logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2962

2 décembre 2011

SOMMAIRE

Archipolis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142149

Architectures Nouvelles et Cuisines  . . . . .

142149

AS Architecture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

142149

Asian and African Assets Corporation S.A.

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142150

Assenagon Asset Management S.A. . . . . . .

142157

Aste Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142150

Atalys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142154

AXA Mezzanine II S.A., SICAR . . . . . . . . . .

142158

AXA Mezzanine I S.A., SICAR  . . . . . . . . . .

142157

Barclays Luxembourg Finance Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142172

Barros-Pereira S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142167

Baulder II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142156

BEB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142167

Bernard-Kauffman S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

142158

Bevis Marks Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

142159

BFW van Hoffs S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142167

Biloba Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

142170

Bominvest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142159

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.  . . . . . .

142170

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.  . . . . . .

142171

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.  . . . . . .

142171

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.  . . . . . .

142171

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.  . . . . . .

142170

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142160

BTS Finance Corporation  . . . . . . . . . . . . . . .

142174

Building Orbis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142175

Calparts S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142175

Cam.Fin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142158

Campus Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142175

Christom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142154

Christophe de Schräiner S. à r.l.  . . . . . . . . .

142176

CNPV Solar Power S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

142176

Columbus III Ventures Investments S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142175

C.V. s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142175

DA Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142160

Epajona S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142160

Eridanus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

142162

Friture Piccola S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142157

Gamaaloth S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142175

GCL Holdings LP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

142143

Gordon Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142167

Kondor Bidco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142130

Luxalloys S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142150

Lyrea Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142149

Oderfin S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142172

OT Luxco 4 Finance & Cy S.C.A.  . . . . . . . .

142151

Profil S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142150

ProLogis France XLVIII S.à r.l.  . . . . . . . . . .

142159

ProLogis France XLVII S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

142154

ProLogis France XV S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

142171

Saipem Maritime Asset Management Lu-

xembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142168

Steelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142176

Sudinvestments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142158

Technical & Data Consulting Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142160

142129

L

U X E M B O U R G

Kondor Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.046.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of September.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

Vista Equity Partners Fund IV, L.P., a company incorporated and existing under the laws of Delaware, having its regis-

tered office at 2711, Centerville road, suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered under
registration number 4987265, duly represented by Carsten Opitz, having his professional address in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 September 2011 in London.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Kondor Bidco S.à r.l.” (the
“Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the City of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

142130

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares - Register of shareholders -

Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1.  The  Company's  share  capital  is  set  at  twelve  thousand  five  hundred  euro  (EUR  12,500)  consisting  of  twelve

thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder. In case of plurality

of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in
the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a
registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6. The Company's shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-

ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

142131

L

U X E M B O U R G

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.

9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in

the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

142132

L

U X E M B O U R G

11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them

to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting

alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his own revocation.

16.3. Any manager shall hold office until his successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive

terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his absence, the

board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum

142133

L

U X E M B O U R G

The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least a majority of its members (ii) including one class

A and one class B managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

18.3. Vote
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including at

least one class A manager and one class B manager. The chairman shall not have a casting vote.

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of a class A manager and a class B manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures
or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers
or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

142134

L

U X E M B O U R G

21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal

reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31

December 2011.

2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) Vista Equity Partners Fund IV, L.P., aforementioned,
paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
Total: twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) paid for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,500.-.

142135

L

U X E M B O U R G

<i>General meeting of shareholders

The incorporating shareholders, representing the Company's entire share capital and considering themselves as duly

convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at two (2).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) James Morril Ford with professional address 2711, Centerville road, suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United

States of America, as class A manager; and

b) Mr. Michel Raffoul, with professional address 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

as class B manager.

3. The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of

shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2011 or
at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.

4. The address of the Company's registered office is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundelf, den einundzwanzigsten September.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, Zivilrechtsnotarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum

Luxemburg.

Sind erschienen:

Vista Equity Partners Fund IV, L.P., eine gemäß dem Recht des Staates Delaware gegründete und existente Gesellschaft

mit eingetragenem Sitz in 2711, Centerville road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika
eingetragen unter Registernummer 4987265, ordnungsgemäß vertreten durch Carsten Opitz, mit beruflicher Adresse in
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 20. September 2011 in London erteilten Vollmacht.

Nachdem die Vollmacht durch den Bevollmächtigten und die unterzeichnete Notarin ne varietur unterzeichnet worden

sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Parteien haben die Notarin ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée

aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma “Kondor
Bidco S.à r.l.” (die “Gesellschaft”).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

142136

L

U X E M B O U R G

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3.  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Transaktionen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  ihrem  Zweck  dienen.

Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis -

Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-

sendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden

Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-
anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen

142137

L

U X E M B O U R G

Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des

Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  “alleiniger  Gesellschafter”  nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
“Gesellschafterversammlung” als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

142138

L

U X E M B O U R G

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse  bei der ersten  Abstimmung wirksam  gefasst,  wenn sie von Gesellschaftern angenommen  werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermöglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-

schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-

142139

L

U X E M B O U R G

schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Geschäftsführer” nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den “Geschäftsführerrat”
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer” gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

18.2. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mit-

glieder an der Sitzung anwesend oder vertreten ist inklusive einem Kategorie A und einem Kategorie B Geschäftsführer.

18.3. Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder

vertretenen  Mitglieder  gefasst,  inklusive  wenigstens  einem  Kategorie  A  Geschäftsführer  und  einem  Kategorie  B  Ge-
schäftsführer. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

142140

L

U X E M B O U R G

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt  im  Protokoll  über  die  betreffende  Transaktion  aufgenommen  werden.  Dieser  Artikel  18.7  ist  nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame

Unterschrift eines Kategorie A Geschäftsführers und eines Kategorie B Geschäftsführers oder durch die Unterschrift des
alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en)
gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer
übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des
Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in
Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-

unddreißigsten Dezember desselben Jahres.

142141

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-

raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-

ßigsten Dezember zweitausendundelf.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
1) Vista Equity Partners Fund IV, L.P, vorbenannt,
zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gegen Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäfts-

anteilen.

Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.
Alle Geschäftsanteile sind ganz in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 1.500 geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ord-

nungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafter-
versammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1) Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf zwei (2) festgesetzt.
2) Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:

142142

L

U X E M B O U R G

a) James Morril Ford, mit beruflicher Adresse 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Ver-

einigte Staaten von Amerika als Kategorie A Geschäftsführer; und

b) Herr Michel Raffoul, mit beruflicher Adresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg als Kategorie B Geschäftsführer.
3) Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterver-

sammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2011 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Gesellschafterversammlung/vom alleinigen
Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.

4) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 19, rue de Bitburg, L-1273 Luxemburg.

Die  unterzeichnete  Notarin,  die  Englisch  versteht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  Urkunde  auf  Anfrage  der

erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben er-
schienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische
Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten

Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-

tigte diese originale Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: C. Opitz et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 septembre 2011. Relation: LAC/2011/42326. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Référence de publication: 2011142710/745.
(110165686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2011.

GCL Holdings LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 51.995,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.208.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND ELEVEN, THE 29 

th

 OF SEPTEMBER,

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GCL Holdings LP S.à r.l. a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 138208
and with a share capital of EUR 47,420 (the Company). The Company was incorporated on 14 April 2008 pursuant to a
deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 1302 of May 28, 2008. The articles of association of the Company (the
Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg,
dated 16 March 2011.

The Meeting is chaired by Mrs Valentina DADDA, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints M Delio CIPOLLETTA, employee, residing professionally in Luxembourg as secretary of the

Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mrs Cristobalina MORON, employee, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the

Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting (the Agenda) is as follows:
1. waiver of the convening notices, where necessary;
2. increase of the Company's share capital by an amount of EUR 4,575 (four thousand five hundred and seventy-five

euros) to raise it from its current amount of EUR 47,420 (forty-seven thousand four hundred and twenty euros) to EUR
51,995 (fifty-five thousand nine hundred and ninety-five euros), by the issuance of 3,660 (three thousand six hundred and
sixty) new shares in registered form, with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) each; corresponding to
a global contribution in cash of Eur 22,073,725 (twenty-two million seventy-three thousand seven hundred and twenty-

142143

L

U X E M B O U R G

five euros) of which EUR 22,069,150 (twenty-two million sixty-nine thousand one hundred and fifty euros) to be allocated
to the relevant share premium accounts;

3. to the extent necessary, acknowledgement of the waiver of the preferential subscription rights of Mrs. Carmela

Bove and Mrs. Gerarda Bove in respect of the new shares to be issued under item 2. above;

4. subscription for, and payment in respect of, the share capital increase specified in item 2 above;
5. the subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company;
6. amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and granting

power and authority to any manager of the Company and any employee of Société Européenne de Banque S.A. to register
on behalf of the Company the newly issued shares in the register of shareholders of the Company and to carry out any
formalities in connection therewith (including, for the avoidance of doubt, the filing and publication of documents with
the relevant Luxembourg authorities); and

7. miscellaneous.
II. The shareholders present or represented at the Meeting (the Shareholders) and the number of shares they hold

are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed "ne varietur"
by the representative(s) of the Shareholders, the undersigned notary and the members of the Bureau (the Attendance
List). The powers of attorney of the Shareholders that are represented at the Meeting, after signature ne varietur by the
proxyholder(s) will also remain attached to the present deed.

III. The Attendance List shows that shareholders holding shares representing the entire issued share capital of the

Company are present or represented at the present Meeting. The Meeting can therefore validly decide on all the items
of the Agenda which has previously been communicated to the Shareholders, each of them expressly declaring to ack-
nowledge the Agenda.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

As the entirety of the share capital of the Company is represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices. The Shareholders consider the Meeting as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 4,575

(four thousand five hundred and seventy-five euros) in order to bring it from its present amount of EUR 47,420 (forty-
seven thousand four hundred and twenty euros), represented by 37,936 (thirty-seven thousand nine hundred and thirty-
six) shares to the amount of EUR 51,995 (fifty-five thousand nine hundred and ninety-five euros), by the issuance of 3,660
(three thousand six hundred and sixty) new shares in registered form, with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-
five cents) each; corresponding to a global contribution in cash of EUR 22,073,725 (twenty-two million seventy-three
thousand seven hundred and twenty-five euros) of which EUR 22,069,150 (twenty-two million sixty-nine thousand one
hundred and fifty euros) is to be allocated to the relevant share premium accounts.

<i>Third resolution

To the extent necessary, the Meeting acknowledges the waiver of the preferential subscription rights, 2 out of 27

shareholders of Mr. Carmela Bove and Mrs. Gerarda Bove in respect of the new shares to be issued under the second
resolution above (the Waiver), so that the other shareholders subscribe on a prorata basis of their actual holding for the
new hares.

The Waiver does not imply a final or explicit waiver of preferential subscription rights for any future increase of capital

which might be decided upon by the Company.

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - Payment

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital increase

by way of a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 22,073,725 (twenty-two million seventy-three thousand
seven hundred and twenty-five euros) which will be contributed as follows:

Subscribers (the Subscribers)

Number of

Shares to be

subscribed

and paid-up

Contribution

in cash

Amount allocated

to the share

capital account

of the Company

DLJ Mojito Luxco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 shares

EUR 156,809.75

EUR 156,777.25

DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,350 shares

EUR

14,173,020.00

EUR

14,170,082.50

Intesa Sanpaolo S.p.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

803 shares EUR 4,842,953.00 EUR 4,841,949.25

142144

L

U X E M B O U R G

SWAN S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 shares EUR 1,025,282.50 EUR 1,025,070.00

Marco Giovannini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 shares

EUR 446,299.00

EUR 446,206.50

Franca Sorgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 shares

EUR 518,672.25

EUR 518,564.75

Francesco Bove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 shares

EUR 241,242.50

EUR 241,192.50

Fabio Bove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 shares

EUR 241,242.50

EUR 241,192.50

Anibal Diaz Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 shares

EUR 24,124.00

EUR 24,119.00

Gianni Roberto Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 shares

EUR 30,155.00

EUR 30,148.75

Paolo Maria Edilio Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 shares

EUR 30,155.00

EUR 30,148.75

Franco Iacoboni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 shares

EUR 42,217.00

EUR 42,208.25

Anna Mancini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 shares

EUR 42,217.00

EUR 42,208.25

Alessandro Bocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Renato Pozzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Fabrizio Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Claudia Banfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Maurizio Mittino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

George S. Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Enrico Perlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

José Luis Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Douglas Arbuckle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Edoardo Albanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 shares

EUR 18,093.00

EUR 18,089.25

Mauro Boano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

EUR 6,031.00

EUR 6,029.75

Orgena Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

EUR 180,932.50

EUR 180,895.00

The Subscribers are all represented by Société Européenne de Banque S.A, a Luxembourg public limited liability com-

pany (société anonyme) with registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 13859 by virtue of powers of attorney
dated September 29, 2011, September 29, 2011, September 26, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, Sep-
tember 23, 2011, September 26, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 23,
2011, September 24, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, Sep-
tember 26, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 26, 2011, September 23,
2011, September 23, 2011, September 23, 2011, September 23, 2011 and September 26, 2011 and September 23..

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders hereby expressly approve and agree to the issuance (including the proportion of shares issued to

each subscriber) of the shares, as set out in the table above. The aggregate subscription amount referred to above, being
an amount of EUR 22,073,725 (twenty-two million seventy-three thousand seven hundred and twenty-five euros), (evi-
dence of which has been given to the undersigned notary), is to be allocated as follows:

(i) EUR 4,575 (four thousand five hundred and seventy-five euros) to the nominal share capital account of the Company.;

and

(ii) EUR 22,069,150 (twenty-two million sixty-nine thousand one hundred and fifty euros) to the share premium account

of the Company.

Further to the increase in share capital, the Meeting resolves to take unanimously the following resolutions:

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article five of the

Articles in respect of the Company's share capital in order to reflect the above changes and resolves that such article
shall henceforth read as follows:

"  5.1.  The  Company's  share  capital  is  set  at  EUR  51,995  (fifty-five  thousand  nine  hundred  and  ninety-five  euros),

represented by 41,596 (forty-one thousand five hundred and ninety-six) shares in registered form, having a par value of
EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Sixth resolution

Thereupon, the Meeting having acknowledged the waiver by the Shareholders of their preferential subscription rights,

decides to accept the said subscriptions and payments by the Subscribers and resolves to allot the shares to the said
Subscribers as indicated hereabove.

As a consequence, the Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the

above changes with power and authority given to any manager of the Company and any employee of Société Européenne
de Banque S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares and cancelled shares

142145

L

U X E M B O U R G

in the register of shareholders of the Company and to see any formalities in connection therewith (including for the
avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at EUR 6.531,05.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE,
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Atter, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GCL Holdings LP S.à r.l., une société

à responsabilité limitée ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138208 et ayant un capital social de EUR
47.420,- (la Société). La Société a été constituée le 14 avril 2008, suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
° - 1302 du 28 mai 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 mars 2011.

L'Assemblée est présidée par Mme Valentina DADDA, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg

(le Président).

Le Président nomme M Delio CIPOLLETTA, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme

secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Mme Cristobalina MORON, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme

scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation, le cas échéant;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 4.575,00 (quatre mille cinq cent soixante-cinq

euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 47.420,- (quarante-sept mille quatre cent vingt euros) à EUR
51.995.00 (cinquante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros), par l'émission de 3.660 (trois mille six cent soixan-
te) nouvelles parts sociales enregistrées sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-
cinq centimes d'euro) chacune, correspondant à un apport total en liquide de EUR 22.073.725,00 (vingt-deux millions
soixante-trois mille sept cent vingt-cinq euros) desquels EUR 22.069.150,00 (vingt-deux millions soixante-neuf mille cent
cinquante euros) seront alloués aux comptes de prime d´émission spécifiques.

3. dans la mesure nécessaire, reconnaissance de la renonciation à des droits préférentiels de souscription de Mme

Carmela Bove et de Mme Gerarda Bové à l'égard des actions nouvelles à émettre au titre du point 2. ci-dessus;

4. Souscription et paiement de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2 ci-dessus.
5. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts de la Société;
6. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donné à tout gérant de la Société et à tout employé de la Société Européenne de Banque S.A. afin de procéder
pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de
la Société et d'accomplir toutes les formalités y afférentes (en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication
des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes); et

7. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée (l'Assemblée) et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont

indiqués sur un registre de présence, qui restera annexé au présent acte après avoir été signé "ne varietur" par le(s)
représentant(s)  des  Actionnaires,  le  notaire  instrumentant  et  les  membres  du  Bureau  (le  registre  de  présence).  Les
procurations des actionnaires qui sont représentés à la Réunion, après signature ne varietur par les mandataire(s) res-
teront également annexés au présent acte.

III. Le registre de présence montre que les actionnaires détenant des actions représentant la totalité du capital émis

de la Société sont présents ou représentés à la présente Assemblée. La Réunion peut donc valablement délibérer sur

142146

L

U X E M B O U R G

tous les points de l'ordre du jour qui a été préalablement communiqué aux actionnaires, chacun d'entre eux déclarant
expressément reconnaître l'ordre du jour.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation. Les

Associés considèrent l'Assemblée comme étant dûment convoquée et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et par la présente augmente le capital social de la Société d'un montant de EUR

4.575,00 (quatre mille cinq cent soixante-cinq euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 47.420,- (quarante-
sept  mille  quatre  cent  vingt  euros)  à  EUR  51.995.00  (cinquante-et-un  mille  neuf  cent  quatre-vingt-quinze  euros),par
l'émission de 3.660 (trois mille six cent soixante) nouvelles parts sociales enregistrées, correspondant à un apport total
en  liquide  de  EUR  22.073.725,00  (vingt-deux  millions  soixante-trois  mille  sept  cent  vingt-cinq  euros)  desquels  EUR
22.069.150,00 (vingt-deux millions soixante-neuf mille cent cinquante euros) seront alloués aux comptes de prime d
´émissions spécifiques.

<i>Troisième résolution

Le cas échéant, l'Assemblée reconnaît la renonciation de deux sur 27 associés, Madame Carmela Bove et Madame

Gerarda Bove de leurs droits de souscription préférentiels respectifs (la Renonciation) au regard des nouvelles actions
devant être émises conformément à la seconde résolution ci-dessus, de sorte que les autres actionnaires abonnent au
prorata de leur participation réelle les nouvelles soucriptions.

La Renonciation n'implique pas une renonciation définitive ou explicite à leurs droits de souscription pour toute future

augmentation de capital pouvant être décidée par la Société.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription – Paiement

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et les paiements de l'augmentation de capital

social par apport en liquide d´un montant total de EUR 22.073.725,00 (vingt-deux millions soixante-trois mille sept cent
vingt-cinq euros) qui sera alloué comme suit:

Souscripteurs (les Souscripteurs)

Nombre

de parts

souscrites

et libérées

Apport en liquide Montant alloué au

compte de capital

social de la Société

DLJ Mojito Luxco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 actions

EUR 156.809,75

EUR 156.777,25

DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.350 actions

EUR

14.173.020,00

EUR

14.170.082,50

Intesa Sanpaolo S.p.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

803 actions EUR 4.842.953,00 EUR 4.841.949,25

SWAN S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 actions EUR 1.025.282,50 EUR 1.025.070,00

Marco Giovannini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 actions

EUR 446.299,00

EUR 446.206,50

Franca Sorgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 actions

EUR 518.672,25

EUR 518.564,75

Francesco Bove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 actions

EUR 241.242,50

EUR 241.192,50

Fabio Bove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 actions

EUR 241.242,50

EUR 241.192,50

Anibal Diaz Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 actions

EUR 24.124,00

EUR 24.119,00

Gianni Roberto Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 actions

EUR 30.155,00

EUR 30.148,75

Paolo Maria Edilio Ferrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 actions

EUR 30.155,00

EUR 30.148,75

Franco Iacoboni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 actions

EUR 42.217,00

EUR 42.208,25

Anna Mancini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 actions

EUR 42.217,00

EUR 42.208,25

Alessandro Bocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Renato Pozzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Fabrizio Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Claudia Banfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Maurizio Mittino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

George S, Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Enrico Perlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

José Luis Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Douglas Arbuckle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

142147

L

U X E M B O U R G

Edoardo Albanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 actions

EUR 18.093,00

EUR 18.089,25

Mauro Boano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

EUR 6.031,00

EUR 6.029,75

Orgena Holding BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 actions

EUR 180.932,50

EUR 180.895,00

Les Souscripteurs sont dûment représentés par la Société Européenne de Banque S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13859 en vertu de procurations datées du 29
septembre 2011, 29 septembre 2011 et 26 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011,
26 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 24 septembre
2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 26 septembre 2011, 23 septembre
2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 26 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre 2011, 23 septembre
2011, 23 septembre 2011, et 26 septembre 2011 et 23 septembre 2011.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire représentant les parties com-

parantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les associés autorisent expressément et acceptent l'émission des actions (y compris la proportion des actions émises

allouée à chaque souscripteur), comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Le montant total des souscriptions visées ci-
dessus, soit un montant de EUR 22.073.725,00 (vingt-deux millions soixante-trois mille sept cent vingt-cinq euros), (dont
la preuve a été donnée au notaire instrumentant) sera par conséquent alloué comme suit:

(i) EUR 4.575,00 (quatre mille cinq cent soixante-cinq euros) alloués au compte de capital social de la société; et
(ii) EUR 22.069.150,00 (vingt-deux millions soixante-neuf mille cent cinquante euros) alloués au compte de prime

d'émission de la société;

Suite à l'augmentation du capital social, l'Assemblée décide de prendre à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article cinq

des Statuts relatif au capital social de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et décide que cet article aura
désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à EUR 51.995.00 (cinquante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-quinze

euros), représenté par 41.596 (quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-seize) parts sociales enregistrées, d'une valeur
nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes d'euro) chacune, toutes souscrites et entièrement payées.»

<i>Sixième résolution

L'Assemblée, après avoir pris connaissance de la renonciation par les Associés à leurs droits de souscription préfé-

rentiels, décide d'accepter lesdites souscriptions et paiements par les Souscripteurs et décide d'attribuer les nouvelles
parts sociales auxdits Souscripteurs comme indiqué ci-dessus.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifi-

cations ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société et à tout employé de Société Européenne
de Banque S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises
et des parts sociales annulées dans le registre des associés de la Société et d'entreprendre toutes les formalités afférentes
(en ce compris, en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises
compétentes).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 6.531,05.

Le notaire soussignée qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes mentionnées

ci-dessus le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties
comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: V. DADDA, D. CIPOLLETTA, C. MORON, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert le 05 octobre 2011. Relation: RED/2011/2067. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

142148

L

U X E M B O U R G

Redange-sur-Attert, le 17 octobre 2011.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2011142659/306.
(110165769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Lyrea Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 47.118.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 20 octobre 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs
conclusions,

a déclaré closes pour absence d'actifs les opérations de liquidation de la société anonyme:
LYREA HOLDING S.A., avec siège social au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, dénoncé en date du 15

décembre 2004.

Pour extrait conforme
Me Anthony BRAESCH
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2011146844/18.
(110170445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Archipolis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 35.887.

Le bilan et le compte Pertes &amp; Profits au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25.10.2011.

Signature.

Référence de publication: 2011146583/11.
(110170300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Architectures Nouvelles et Cuisines, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 123, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 41.023.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 25/10/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011146584/10.
(110170641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

AS Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 73.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AS ARCHITECTURE S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146585/12.
(110170350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

142149

L

U X E M B O U R G

Luxalloys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 469, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 51.275.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la société, tenue le 28 mars 2011, que:
1. Monsieur Bruno Boghun, demeurant au no. 154, Hochfeldstrasse, D - 47239 Duisburg, est démis de ses fonctions

d'administrateur, avec effet au 31/03/2011, par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés.

2. Les mandats d'administrateur de Monsieur Guy Konsbruck en tant qu'administrateur-délégué, de Madame Dina E.

Aune, de Monsieur Thorstein Abrahamsen et de Monsieur Rainer Fiehl en tant qu'administrateurs sont prolongés pour
une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2012.

De plus, il résulte des décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, tenue le 20 septembre 2011,

que Pricewaterhousecoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, et immatriculée au
registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 65.477, a été nommée en tant que Réviseur
d’entreprises en remplacement de GSL REVISION SARL, jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2011147464/21.
(110171424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Asian and African Assets Corporation S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 67.494.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2011146587/11.
(110170126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Aste Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 134.865.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011146588/11.
(110170129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Profil S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 24.318.

<i>Auszug aus dem Beschluss der Hauptversammlung Abgehalten am 20. Oktober 2011

<i>Verwaltungsrat

Die Hauptversammlung beschließt die Mandate aller Mitglieder des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung für eine

zusätzliche Dauer von sechs Jahren zu erneuern.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
- Herr Nico HANSEN, geboren in Differdange am 31. März 1969 mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxemburg

55-57, Avenue Pasteur,

142150

L

U X E M B O U R G

- Herr Alain BARTHOLME, geboren in Ettelbrück am 22. August 1972 mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxemburg

55-57, Avenue Pasteur, und

- Frau Sophie BATARDY, geboren in Lille (France), am 23. Januar 1963 mit geschäftlicher Adresse in L-2311 Luxemburg

55-57, Avenue Pasteur.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung vom 2017, die

über das Geschäftsergebnis per 2016 beschließt.

<i>Rechnungskommissar

Die Hauptversammlung beschließt das Mandat der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MGI FISOGEST S. à r.l., mit

Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, Avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
unter der Nummer B.20.114 als Rechnungskommissar mit sofortiger Wirkung für eine zusätzliche Dauer von sechs Jahren
zu erneuern.

Das Mandat des Rechnungskommissars endet mit der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung vom 2017, die über

das Geschäftsergebnis per 2016 beschließt.

<i>Auszug aus dem Beschluss der Verwaltungsratssitzung Abgehalten am 20. Oktober 2011

Der Verwaltungsrat beschließt das Mandat Herrn Nico Hansen als Vorsitzenden des Verwaltungsrats mit sofortiger

Wirkung für eine zusätzliche Dauer von sechs Jahren zu erneuern.

Das Mandat des Vorsitzenden des Verwaltungsrats endet mit der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung vom

2017, die über das Geschäftsergebnis per 2016 beschließt.

Référence de publication: 2011147542/32.
(110171315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

OT Luxco 4 Finance &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.958.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in re-

placement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “OT Luxco 4 Finance &amp; Cy S.C.A.” (the “Company”),

a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 162.958, incorporated pursuant to a notarial deed dated 1 

st

 August

2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the
Company have not been amended since.

The meeting is presided by Mr. Brendan KLAPP, employee, with professional address at Belvaux, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Nadia WEYRICH, employee, with professional address at Belvaux, who is also elected

as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To amend the article 5.7 of the articles of incorporation of the Company (French version only).
2. To amend the article 5.13 of the articles of incorporation of the Company.
3. To amend the article 7.2 of the articles of incorporation of the Company.
4. To amend the article 12 of the articles of incorporation of the Company.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

142151

L

U X E M B O U R G

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting of the Shareholders resolves to amend the French version of the article 5.7 of the articles of incorporation

of the Company which shall read as follows:

“ 5.7. Toutes les Actions seront émises sous forme nominative ou au porteur.”

<i>Second resolution

The meeting of the Shareholders resolves to amend the article 5.13 which shall read as follows:

“ 5.13. The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned, joint co-owners

have to appoint a single attorney to represent such share(s) towards the Company.”

<i>Third resolution

The meeting of the Shareholders resolves to amend the article 7.2 which shall read as follows:

“ 7.2. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as

Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
(as defined below) as provided for in Article 8.1 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to
effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall
convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance
with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager.”

<i>Fourth resolution

The meeting of the Shareholders resolves to amend the article 12 which shall read as follows:

“ 12. Amendments of the articles.
12.1 Subject to the approval of the Manager, these articles may be amended from time to time by a general meeting

of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.

12.2 The decision to remove the Manager of the Company and the subsequent decision to amend these articles of

association shall be taken in accordance with the provisions of this article 12, except for the approval of the Manager
which shall not be required provided that a new manager be appointed in replacement of the Manager.”

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant

en remplacement de son collègue empêché Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «OT Luxco

4 Finance &amp; Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.958, ayant son siège social au
2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 1 

er

 août

2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n'ont pas été
modifiés depuis.

L'Assemblée est sous la présidence de Monsieur Brendan KLAPP, employé privé, demeurant professionnellement à

Belvaux,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionnellement à Belvaux,

qui est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'article 5.7 des statuts de la Société.

142152

L

U X E M B O U R G

2. Modification de l'article 5.13 des statuts de la Société
3. Modification de l'article 7.2 des statuts de la Société.
4. Modification de l'article 12 des statuts de la Société.
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la traduction française de l'article 5.7 des statuts de la Société qui a désormais

la teneur suivante:

« 5.7. Toutes les Actions seront émises sous forme nominative ou au porteur.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5.13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.13. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont conjointement

détenues, les détenteurs conjoints devront alors désigner un mandataire unique pour représenter l'Action à l'égard de
la Société.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7.2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 7.2. En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Gérant d'exercer

ses fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil
de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l'article 8.1, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être ac-
tionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu'à ce que se tienne une assemblée
générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette
assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de
majorité requises pour la modification des statuts.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui a désormais la teneur suivante:

« 12. Modifications des statuts.
12.1  Les  présents  statuts  pourront  être  modifiés,  sous  condition  de  l'approbation  du  Gérant,  par  une  assemblée

générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

12.2 La décision de démissionner le Gérant et la décision subséquente devant modifier les statuts seront prises en

conformité avec les dispositions de cet article 12, à l'exception de l'accord du Gérant qui ne sera par requis et pour autant
qu'un nouveau gérant soit nommer en remplacement du Gérant.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. KLAPP, N. WEYRICH, M. SCHAEFFER.

142153

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 septembre 2011. Relation: EAC/2011/12897. Reçu soixante-quinze Euros

(75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011146247/142.
(110170036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

ProLogis France XLVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 94.597.

à modifier: Suite à un contrat daté du 21 octobre 2011 une (1) part sociale part sociale détenue dans la Société par

son actionnaire à savoir, ProLogis European Holdings VII Sàrl a été transféré à ProLogis European Finance VII Sàrl, ayant
son siège social à L-I930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B90148. Cette cession de part sociale a été approuvé au nom et pour compte
de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance VII Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Le 24 octobre 2011.

ProLogis Dorectorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011147155/20.
(110170331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Atalys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 110, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 103.525.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011146590/10.
(110170644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Christom S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 164.247.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à LUXEMBOURG

A comparu:

Monsieur THOMAS Christophe Jean-Louis, entrepreneur, né à Metz (F) le 6 avril 1979, demeurant à 17, chemin de la

citadelle F-57140 PLESNOIS.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les

dispositions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la vente de bijoux fantaisie et accessoires de mode.

142154

L

U X E M B O U R G

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de «CHRISTOM S.à r.l.», Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Toutes ces parts ont été souscrites par Monsieur Christophe THOMAS, demeurant à PLESNOIS, 17, chemin de la

citadelle.

Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq  cents  Euros  se  trouve  dès  maintenant  à  la  libre  disposition  de  la  société,  ainsi  qu'il  en  a  été  justifié  au  notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Titre II. Administration - Assemblée Générale

Art. 7. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique ou,

selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Art. 8. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. En cas de pluralité d'associés, chaque

associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède
des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal  ou  établis  par  écrit,  Cette  disposition  n'est  applicable  aux  opérations  courantes  conclues  dans  les  conditions
normales.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 12. L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et

du bilan.

Art. 13. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 14. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 15. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

142155

L

U X E M B O U R G

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme
de huit cents euros (800.- EUR).

<i>Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée:
Monsieur THOMAS Christophe Jean-Louis, entrepreneur, né à Metz (F) le 6 avril 1979, demeurant à 17, chemin de la

citadelle F-57140 PLESNOIS.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. THOMAS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46193. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011147300/98.
(110171301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Baulder II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 828.925,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 122.980.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société du 16 août 2010

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 16 août 2010, BAULDER S.à r.l. a transféré la totalité de ses parts

détenues dans la Société de la manière suivante:

- 6.236 parts sociales de catégorie A (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund A, L.P., avec effet immédiat.
- 7.798 parts sociales de catégorie B (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund A, L.P., avec effet immédiat.
- 6.236 parts sociales de catégorie A (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund B, L.P., avec effet immédiat.
- 7.798 parts sociales de catégorie B (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund B, L.P., avec effet immédiat.
- 6.236 parts sociales de catégorie A (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund C, L.P., avec effet immédiat.
- 7.798 parts sociales de catégorie B (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund C, L.P., avec effet immédiat.
- 6.236 parts sociales de catégorie A (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund D, L.P., avec effet immédiat.
- 7.798 parts sociales de catégorie B (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund D, L.P., avec effet immédiat.
- 6.236 parts sociales de catégorie A (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund E, L.P., avec effet immédiat.
- 7.798 parts sociales de catégorie B (en indivision) à SISU Capital Private Equity Fund E, L.P., avec effet immédiat.

142156

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Manager

Référence de publication: 2011147731/25.
(110171178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Assenagon Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 129.914.

<i>Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren vom 6. Oktober 2011

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließt in Anwendung des Art. 8 letzter Absatz der Satzung der Assenagon

Asset Management S.A. (die "Gesellschaft") Folgendes:

Auf Basis der CSSF-Genehmigung vom 4. Oktober 2011, bestellt der Verwaltungsrat Herrn Dr. Robert Wendt (Be-

rufsadresse: Theresienhöhe 13 a, 80339 München) mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die entsprechende Eintragung im Registre de Commerce ist zu veranlassen.
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Luxemburg, den 6. Oktober 2011.

Assenagon Asset Management S.A.
Ulrich Binninger / Hans Günther Bonk / Vassilios Pappas

Référence de publication: 2011147036/17.
(110170804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

AXA Mezzanine I S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital

à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.403.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146591/11.
(110170495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Friture Piccola S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9457 Landscheid, 3A, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 147.889.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le cinq octobre.
Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch,

A comparu:

Mademoiselle Laura BERARDI, ouvrière, née à Luxembourg le 19 avril 1983, matricule n° 1983 04 19 163, demeurant

à L-7462 Landscheid, 3A, Haaptstrooss.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "Friture

Piccola S.à.r.l.", avec siège social à L-9457 Landscheid, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 20 août
2009, publié au Mémorial C, le 24 septembre 2009, numéro 1847, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B147889,

a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
1) Elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
2) Elle déclare prendre à sa charge tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à leur profit.
3) Elle se trouve donc investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif

social.

142157

L

U X E M B O U R G

4) Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de Madame Laura

Berardi.

Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude date qu'en tête.
Et après lecture faite et interpétation donnée à la comparante, connue du notaire par noms prénom usuel, état et

demeure, a signé avec le notaire le présent acte. / signé / Berardi, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2011. Relation: DIE/2011 /9578. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société.

Diekirch, le 18 octobre 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011147775/32.
(110171013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

AXA Mezzanine II S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital

à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.458.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146592/11.
(110170506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Bernard-Kauffman S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 150.792.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Bernard-Kauffman S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146593/12.
(110170326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Cam.Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.489.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011146628/13.
(110170637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Sudinvestments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 114.793.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 21/10/2011 à Luxembourg

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs supplémentaires:

142158

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Mario BRERO, administrateur de société, né le 29 mars 1946 à Lausanne (Suisse), demeurant 36, rue de

Montchoisy, CH-1207, Genève (Suisse)

- Monsieur Joël MARECHAL, comptable, né à Arlon le 12 septembre 1968, demeurant professionnellement au 29,

avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

Leur mandat se terminera le 3 mars 2016
Le nombre des administrateurs passe de 1 à 3 et conformément à l'article 14 des statuts, la société sera engagée par

la signature conjointe de deux administrateurs.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011146958/19.
(110170197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Bevis Marks Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 161.666.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146594/10.
(110170512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Bominvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.014.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146599/10.
(110170418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

ProLogis France XLVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 96.547.

à modifier: Suite à un contrat daté du 21 octobre 2011 une (1) part sociale part sociale détenue dans la Société par

son actionnaire à savoir, ProLogis European Holdings IX Sàrl a été transféré à ProLogis European Finance IX Sàrl, ayant
son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B97192. Cette cession de part sociale a été approuvé au nom et pour compte
de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance IX Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales

Le 24 octobre 2011.

ProLogis Dorectorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011147156/20.
(110170333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

142159

L

U X E M B O U R G

DA Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.051.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil de gérance en date du 26 septembre 2011

En date du 26 septembre 2011, le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société DA Partners

du 46, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 1 

er

 avril 2011.

Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DA Partners
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2011146647/14.
(110170460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.334.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146600/10.
(110170310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Epajona S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 158.010.

<i>Extrait de la décision prise par la gérante unique en date du 29 septembre 2011

Le siège social a été transféré de L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte Croix à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte

Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Epajona S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011146663/14.
(110170288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Technical &amp; Data Consulting Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 157.481.

L'an deux mil onze, le vingt-et-un octobre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Didier VANDER BRUGGHEN, ingénieur civil mécanicien, demeurant à B-1560 Hoeilaart, 10, Guldenspo-

renlaan.

Lequel comparant, agissant en qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social de la société à res-

ponsabilité limitée "Technical &amp; Data Consulting Luxembourg " avec siège social à L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre

2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 296 du 12 février 2011,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 157481.
Lequel associé unique a exposé au notaire qu'il a acquis l'intégralité des parts suivant cessions de parts du 10 octobre

2011 et du 12 octobre 2011 de la part de Technical &amp; Data Consulting, en abrégé T &amp; D Consulting, quarante-huit parts
sociales ainsi que de Madame Dominique RAEMDONCK vingt-huit parts sociales.

142160

L

U X E M B O U R G

Ceci exposé, Monsieur Didier VANDER BRUGGHEN a accepté en qualité de gérant unique les prédites cessions de

parts conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et a déclaré qu'il n'a entre ses mains aucune
opposition ni empêchement qui puissent en arrêter l'effet.

L'associé unique a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conséquence des cessions de parts ci-avant l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

« Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Didier VANDER BRUGGHEN.»

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de compléter l'objet social de la société en ajoutant un paragraphe supplémentaire et modifie

en conséquence l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objets tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- le conseil en ingénierie mécanique, notamment la mise en oeuvre de moyens et de compétences pour la réalisation

d'études, d'expertises, d'audits permettant d'optimiser les installations techniques des entreprises, la coordination et le
suivi de l'exécution de travaux techniques pour des projets immobiliers, l'assistance et le conseil lors des contrôles de la
maintenance des installations techniques d'immeubles, et également toutes les activités en relation avec l'organisation et
l'exploitation d'un bureau d'étude;

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu'elle  possédera,
l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société s'interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d'intérêts et porter atteinte à l'indépendance

professionnelle de l'activité libérale d'ingénieur-conseil et elle s'engage à respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles est soumise l'activité réglementée en question.»

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions de parts précédentes et en considérant le fait que la société n'aura désormais qu'un seul associé,

l'associé unique décide de modifier les articles 6, 7 et 10 des statuts:

« Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à un non-

associé que de l'accord du ou des associés restants. En cas de refus les associés restants s'obligent eux-mêmes à reprendre
les parts.

Les valeurs de l'actif net des 3 derniers bilans approuvés serviront de base pour la détermination de la valeur des parts

à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l'associé unique ou les associés,

qui désignent leurs pouvoirs. La gérance peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité de l'associé unique ou d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux bilans et comptes de profits et pertes de la société et aux décisions des
associés.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement à 850.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant présent acte.

Signé: D. VANDER BRUGGHEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46861. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

142161

L

U X E M B O U R G

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011147606/75.
(110171102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Eridanus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 104.239.

In the year two thousand eleven, the twenty-seventh day of September,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of ERIDANUS INVESTMENTS S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 2, rue Joseph
Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
104.239 and having a share capital of EUR 12,700 (the Company). The Company was incorporated on November 16,
2004 pursuant to a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on February 2, 2005 under number 94. The articles of association
of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, on September 7, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on
October 4, 2006 under number 1861.

THERE APPEARED

Pepsi-Cola (Bermuda) Limited, a limited company incorporated and existing under the laws of Bermuda, having its

registered office at 2, Clarendon House, Church Street, HM 11 Hamilton, Bermuda, registered under number 270 (the
Sole Shareholder),

represented by Nicolas Marchand, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Introduction of the United States Dollar (USD) as official and accounting currency of the Company with retroactive

effect as of January 1, 2011;

2. Conversion of the share capital currency from Euro (EUR) to United States Dollars (USD) effective at the exchange

rate published by the European Central Bank on September 26, 2011, according to which EUR 1 equals USD 1.3500;

3. Setting of the nominal value of the shares of the Company at one United States Dollar (USD 1) each and conversion

of the existing shares into shares with a nominal value of one United States Dollars (USD 1) each;

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand eight hundred fifty-five United States

Dollars (USD 2,855) in order to bring it from its present amount of seventeen thousand one hundred forty-five United
States Dollars (USD 17,145) represented by seventeen thousand one hundred forty-five (17,145) shares in registered
form, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, to twenty thousand United States Dollars (USD
20,000) by way of the issuance of two thousand eight hundred fifty-five (2,855) new shares of the Company, with a nominal
value of one United States Dollar (USD 1) each, with the same rights and obligations as the existing shares;

5. Subscription to and payment of the share capital increase specified under item 4. above;
6. Subsequent amendment to article 5 of the articles of association (the Articles) in order to reflect the conversion of

the currency of the share capital and the share capital increase adopted under items 2. and 4. above;

7. Amendment to the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority  to  any  manager  of  the  Company  and/or  any  employee  of  Equity  Trust  Co  (Luxembourg)  S.A.  to  proceed
individually, on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant books and registers of
the Company; and

8. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to introduce the United States Dollar (USD) currency as official and accounting currency

of the Company with retroactive effect as of January 1, 2011.

142162

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the United States Dollar (USD) as the currency of its share

capital at the exchange rate published by the European Central Bank on September 26, 2011 and according to which EUR
1 equals USD 1.3500, so that the share capital of the Company now amounts to seventeen thousand one hundred forty-
five United States Dollars (USD 17,145) which will be allocated to the share capital account of the Company.

Proof of the above exchange rate has been given to the notary through a financial publication that will remain attached

to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxyholder representing the Sole Shareholder and the
notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to set the nominal value of the shares at one United States Dollar (USD 1) each.
The Sole Shareholder resolves to set the number of shares at seventeen thousand one hundred forty-five (17,145)

with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, in exchange and replacement of the existing one hundred
and twenty-seven (127) shares having a nominal value of one hundred Euros (EUR 100) each.

The Sole Shareholder resolves to convert all accounts in the books of the Company from Euro to United States Dollars

using the abovementioned exchange rate and resolves to authorize and empower any employee of Equity Trust Co
(Luxembourg) S.A. acting individually on behalf of the Company to proceed with the registration of the conversion of all
accounts in the books of the Company from Euro to United States Dollars.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand eight

hundred fifty-five United States Dollars (USD 2,855) in order to bring it from its present amount of seventeen thousand
one hundred forty-five United States Dollars (USD 17,145) represented by seventeen thousand one hundred forty-five
(17,145) shares in registered form, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, to twenty thousand
United States Dollars (USD 20,000) by way of the issuance of two thousand eight hundred fifty-five (2,855) new shares
of the Company, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, with the same rights and obligations as
the existing shares.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription – Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for the two

thousand eight hundred fifty-five (2,855) new shares of the Company, having a nominal value of one United States Dollar
(USD 1) and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of all the membership interests (the Shares)
it holds in Quaker Mexico Holdings LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware,
having its office address at 555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, United States of America (QMHLLC), such
Shares having an aggregate value of one hundred sixty-one million five hundred thousand United States dollars (USD
161,500,000).

The contribution in kind of the Shares in an aggregate amount of one hundred sixty-one million five hundred thousand

United States dollars (USD 161,500,000) from the Sole Shareholder to the Company shall be allocated as follows:

(i) an amount of two thousand eight hundred fifty-five United States Dollars (USD 2,855) to the nominal share capital

account of the Company; and

(ii) the remaining amount to the share premium reserve account of the Company.
The Sole Shareholder acknowledges (i) the balance sheet dated as of September 26, 2011 signed for approval by the

management of the Sole Shareholder and (ii) that the value of the contribution of the Shares to the Company has been
certified by a certificate dated September 26, 2011 issued by the management of the Sole Shareholder and of QMHLLC
and acknowledged and approved by the management of the Company which states in essence that

“1. The Sole Shareholder is the owner of the Shares, representing one hundred per cent (100%) of the membership

interests of QMHLLC.

2. The Shares are fully paid-up.
3. The Sole Shareholder is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares.
4. None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment.

5. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him.

6. The Shares are freely transferrable.

142163

L

U X E M B O U R G

7. Based on generally accepted accounting principles, the value of the Shares is equal to one hundred sixty-one million

five hundred thousand United States dollars (USD 161,500,000) and since the valuation was made no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

8. All formalities required under the laws of Luxembourg and the laws of the State of Delaware subsequent to the

contribution in kind of the Shares to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed
documenting the said contribution in kind.“

Such  balance  sheet  and certificate,  after  signature  ne  varietur by the  proxyholder  of  the  appearing party  and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles, so

that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. The Company's capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) represented by twenty

thousand (20,000) shares of one United States Dollar (USD 1) each.

(…).”

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Equity Trust Co (Luxembourg) S.A.
to proceed individually, on behalf of the Company, with the registration of the above changes in the relevant books and
registers of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (7,000.-EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour de septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de ERIDANUS INVESTMENTS S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 2, rue Joseph Hackin, L-1746
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 104.239 et au capital social de EUR 12.700 (la Société). La Société a été constituée le 16 novembre
2004, suivant un acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 2 février 2005, numéro 94 (les Statuts). Les Statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 septembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 octobre 2006, numéro 1861.

A COMPARU:

Pepsi-Cola (Bermuda) Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Bermudes, dont le

siège social est situé à 2, Clarendon House, Church Street, HM 11 Hamilton, les Bermudes, immatriculée sous le numéro
270 (l'Associé Unique),

représentée par Nicolas Marchand, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Introduction du dollar américain (USD) comme la devise officielle et comptable de la Société avec effet rétroactif

au 1 janvier 2011;

2. Conversion de la devise du capital social de l'euro (EUR) en dollars américains (USD) au taux de change publié par

la Banque Centrale Européenne le 26 septembre 2011 selon lequel EUR 1 équivaut à USD 1.3500;

142164

L

U X E M B O U R G

3. Fixation de la valeur nominale des parts sociales de la Société à un dollar américain (USD 1) chacune et conversion

des parts sociales existantes en parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune;

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux mille huit cent cinquante-cinq dollars américains

(USD 2.855) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cent quarante-cinq dollars américains (USD 17.145)
représenté par dix-sept mille cent quarante-cinq (17.145) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD
1) chacune, à vingt mille dollars américains (USD 20.000) par l'émission de deux mille huit cent cinquante-cinq (2.855)
parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes;

5. Souscription et libération de l'augmentation du capital social déterminée au point 4. ci-dessus;
6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter la conversion de la devise

du capital social et l'augmentation de capital social adoptées aux points 2. et 4. ci-dessus;

7. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société et/ou employé de Equity Trust Co (Luxembourg) S.A., pour procéder individuellement
au nom de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres concernés de la Société; et

8. Divers.
III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'introduire le dollar américain (USD) comme la devise officielle et comptable de la Société

avec effet rétroactif au 1 janvier 2011.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société adopte le dollar américain (USD) comme la devise de son capital social au taux

de change publié par la Banque Centrale Européenne le 26 septembre 2011 selon lequel EUR 1 équivaut à USD 1.3500,
de sorte que le capital social s'élève désormais à dix-sept mille cent quarante-cinq dollars américains (USD 17.145) qui
sera affecté au compte de capital social de la Société.

La preuve du taux de change ci-dessus a été donnée au notaire par une publication financière qui restera annexée au

présent acte, après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à un dollar américain (USD 1) chacune.
L'Associé Unique décide de fixer le nombre de parts sociales à dix-sept mille cent quarante-cinq (17.145) d'une valeur

d'un dollar américain (USD 1) chacune en échange et remplacement des cent vingt-sept (127) parts sociales existantes
d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

L'Associé Unique décide de convertir tous les comptes dans les livres de la Société de l'euro en dollar américain en

utilisant le taux de change susmentionné et décide de donner pouvoir et autorité à tout employé d'Equity trust Co
(Luxembourg) S.A., agissant individuellement pour le compte de la Société, pour procéder à l'inscription de la conversion
de tous les comptes dans les livres de la Société de l'Euro en dollar américain.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille huit cent cinquante-

cinq dollars américains (USD 2.855) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cent quarante-cinq dollars
américains (USD 17.145) représenté par dix-sept mille cent quarante-cinq (17.145) parts sociales d'une valeur nominale
d'un dollar américain (USD 1) chacune, à vingt mille dollars américains (USD 20.000) par l'émission de deux mille huit
cent cinquante-cinq (2.855) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1), ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et l'entière libération de l'augmentation

de capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à deux mille huit cent

cinquante-cinq (2.855) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) et les
libérer par un apport en nature se composant de toutes les parts sociales (les Parts) qu'il possède dans Quaker Mexico
Holdings LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social se situe au
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, Etats-Unis d'Amérique (QMHLLC), lesquelles Parts ayant une valeur
totale de cent soixante et un millions cinq cent mille dollars américains (USD 161.500.000) dollars américains.

L'apport en nature des Parts de l'Associé Unique à la Société, d'un montant total de cent soixante et un millions cinq

cent mille dollars américains (USD 161.500.000) sera affecté de la manière suivante:

142165

L

U X E M B O U R G

(i) un montant de deux mille huit cent cinquante-cinq dollars américains (USD 2.855) au compte capital social de la

Société; et

(ii) le montant restant au compte de réserve de prime d'émission de la Société.
L'Associé Unique prend acte du (i) bilan daté du 26 septembre 2011 signé pour approbation par la gérance de l'Associé

Unique et (ii) que la valeur de l'apport des Parts à la Société a été certifiée par un certificat émis le 26 septembre 2011
émis par la gérance de l'Associé Unique et de QMHLLC et reconnu et approuvé par la gérance de la Société dont le
contenu est le suivant:

1. "L'Associé Unique est le propriétaire des Parts qui représentent cent pour cent (100%) du capital social de QMHLLC.
2. Les Parts sont entièrement libérées.
3. L'Associé Unique est le seul titulaire des Parts et possède le droit d'en disposer.
4. Aucune des Parts n'est grevée d'un nantissement ou d'un usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement

ou un usufruit sur les Parts et aucune des Parts n'est sujette à une servitude.

5. Il n'existe aucun droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne serait autorisée à demander

qu'une ou plusieurs Parts lui soient cédées.

6. Les Parts sont librement cessibles.
7. Sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur des Parts est de cent soixante et un millions cinq

cent mille dollars américains (USD 161.500.000) et depuis cette évaluation, il n'y a pas eu de changement matériel qui
aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société.

8. Toutes les formalités requises au regard du droit luxembourgeois ou de l'Etat du Delaware consécutives à l'apport

en nature des Parts à la Société seront effectuées dès réception de l'acte notarié documentant ledit apport en nature.

Le bilan et le certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de sorte qu'il

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000) représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.

(…)»

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou employé de Equity Trust Co (Luxembourg) S.A., pour
procéder individuellement au nom de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres
concernés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes sortes, incombant à la Société en raison du présent

acte est estimé approximativement à la somme de sept mille Euros (EUR 7,000.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire le présent

acte original.

Signé: N. MARCHAND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 octobre 2011. Relation: LAC/2011/44011. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME  délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144721/264.
(110168470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2011.

142166

L

U X E M B O U R G

Barros-Pereira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9071 Ettelbruck, 72, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 137.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BARROS-PEREIRA SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146603/12.
(110170330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

BEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3390 Peppange, 33, rue de Crauthem.

R.C.S. Luxembourg B 97.675.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 26 octobre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011146604/10.
(110170435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

BFW van Hoffs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

R.C.S. Luxembourg B 117.379.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BFW van Hoffs S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146605/12.
(110170323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Gordon Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.456.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2011.

L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-

sionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement

au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg

L’Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer trois administrateurs, à savoir:
- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié

professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

- Monsieur Moreno Ampelio BERTA, administrateur, né le 17 octobre 1953 à Lugano (Suisse), domicilié profession-

nellement au 4, Via della Posta CH-6900 Lugano (Suisse).

Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2017.
Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue

de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

142167

L

U X E M B O U R G

La société Zimmer &amp; Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société

Anonyme.

La société Zimmer &amp; Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.
Référence de publication: 2011147401/26.
(110171527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Saipem Maritime Asset Management Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 378.000,00.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 141.486.

<i>Rectificatif de l'acte déposé le 5 octobre 2011

<i>N° de dépôt: L110158854

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of September; Before us Maître Martine SCHAEFFER,

civil law notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

SAIPEM S.p.A., a “societa per azioni” governed by the laws of Italy, and having its registered office at Via Martiri di

Cefalonia 67, San Donato Milanese – Milano, Italy,

here represented by Roberto Stranieri professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 Sep-

tember 2011, which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, shall
remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such  appearing  party  is  the  sole  member  of  SAIPEM  MARITIME  ASSET  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.àr.l.,a

société à responsabilité limitée, having its registered office at 19/21, route d' Arlon, 8009 Strassen -Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 141486, incorporated pursuant to a deed of Me
Aloyse BIEL, notary residing in Esch-sur-Alzette, on August 21, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of September 27, 2008, number 2369. The Articles have been amended for the last time pursuant to a
deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on August 4, 2010, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of August 28, 2010, number 1760 (hereafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to state that the agenda

of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 63,000 (sixty-three thousand USD),
In order to bring it from its current amount of three hundred and fifteen thousand USD (USD 315,000) to USD 378,000

(three hundred and seventy-eight thousand USD), without issuance of new capital units but by the sole increase of the
nominal value of the existing 6,300 (six thousand three hundred) capital units up to USD 60 (sixty USD) each, together
with a total share premium of USD 384,937,000 (three hundred and eighty four million nine hundred and thirty-seven
thousand USD), fully paid in by a payment in cash by the sole shareholder;

2. Subsequent amendment of Article 5 of the articles of association of the Company.
3. Miscellaneous
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution:

The sole member resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 63,000 (sixty-three

thousand USD). In order to bring it from its current amount of three hundred and fifteen thousand USD (USD 315,000)
to USD 378,000 (three hundred and seventy-eight thousand USD), without issuance of new capital units but by the sole
increase of the nominal value of the existing 6,300 (six thousand three hundred) capital units up to USD 60 (sixty USD)
each, together with a total share premium of USD 384,937,000 (three hundred and eighty-four million nine hundred and
thirty-seven thousand USD); fully paid up in cash by the sole shareholder, so that the total amount of USD 385,000,000
(three hundred and eighty-five million USD) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned
notary.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, Article 5 of the articles of association of the Company is amended and shall

read as follows:

Art. 5. The corporate capital is set at USD 378,000 (three hundred and seventy-eight thousand USD), divided into

6,300 (six thousand three hundred) capital units with a nominal value of USD 60 (sixty USD) each.”

142168

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document, are estimated at approximately EUR 6500.

Thereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing person, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the notary, such person

signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-deux septembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg,

A comparu:

SAIPEM S.p.A., une “societa per azioni” de droit italien ayant son siège social à Via Martiri di Cefalonia 67 – 20097 San

Donato Milanese – Milano, Italie,

ici représentée par Roberto Stranieri, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 16 septembre 2011 à Luxembourg,

laquelle procuration, signée "ne varietur" par le comparant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera

soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant  en  sa  qualité  d'associé  unique  de  SAIPEM  MARITIME  ASSET  MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.à  r.l.  (la

«Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19/21, route d'Arlon,
L-8009 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 141.486,
constituée en date du 21 août 2008 par acte du notaire Aloyse BIEL, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 2369 du 27 septembre 2008. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire Joseph ELVINGER, de residence à Luxembourg, en date du 4 août 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1760 du 28 août 2010.

L'associé unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter que l'ordre du jour

des présentes est le suivant::

1. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence d'un montant de USD 63.000 (soixante-trois

mille US dollars),

afin de le porter de son montant actuel de USD 315.000 (trois cent quinze mille US dollars) à USD 378.000 (trios cent

soixante-dix-huit mille US dollars),

sans émission de parts socials nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 6.300 (six mille trois

cents) parts sociales existantes à USD 60 (soixante US dollars) par part sociale, ensemble avec une prime d'émission
totale de USD 384.937.000 (trois cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent trente-sept mille US dollars).

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts
3. Divers.
Ensuite l'associé unique à pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence d'un montant de USD 63.000

(soixante-trois mille US dollars),

afin de le porter de son montant actuel de USD 315.000 (trois cent quinze mille US dollars) à USD 378.000 (trois cent

soixante-dix-huit mille US dollars),

sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 6.300 (six mille trois

cents) parts socials existantes à USD 60 (soixante US dollars) par part sociale, ensemble avec une prime d'émission totale
de USD 384.937.000 (trois cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent trente-sept mille US dollars),

laquelle augmentation avec prime d'émission a été entièrement libéré par l'associé unique moyennant en numéraire

d'un montant total de USD 385.000.000 (trois cent quatre-vingt-cinq millions de US dollars), de sorte que ce montant se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à USD 378.000 (trois cent soixante-dix-huit mille US dollars), représenté

par 6.300 (six mille trois cents) parts socials d'une valeur nominale de USD 60 (soixante US dollars) chacune»

142169

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont

évalués approximativement à 6.500.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Stranieri et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2011. LAC/2011/43241. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146325/120.
(110169377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Biloba Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 155.827.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146606/10.
(110170589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 59.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOULANGERIE PATISSERIE FLICK S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146607/12.
(110170278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 59.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOULANGERIE PATISSERIE FLICK S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146608/12.
(110170280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

142170

L

U X E M B O U R G

ProLogis France XV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.782.

à modifier: Suite à un contrat daté du 21 octobre 2011 une (1) part sociale part sociale détenue dans la Société par

son actionnaire à savoir, ProLogis European Holdings II Sàrl a été transféré à ProLogis European Finance II Sàrl, ayant son
siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B77445. Cette cession de parts sociales a été approuvé au nom et pour compte de la
Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:

ProLogis European Finance II Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Le 24 octobre 2011.

ProLogis Dorectorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011147157/20.
(110170296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 59.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOULANGERIE PATISSERIE FLICK S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146609/12.
(110170285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 59.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOULANGERIE PATISSERIE FLICK S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146610/12.
(110170289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 59.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOULANGERIE PATISSERIE FLICK S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146611/12.
(110170293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

142171

L

U X E M B O U R G

Oderfin S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.701.

<i>Extrait de rassemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 octobre 2011

L'assemblée prend acte de la démission du gérant unique M. Mirko LEO, employé privé, demeurant à Strada Statale

11, I-20063 Cernusco sul Naviglio (Italie), formulée en date du 10 octobre 2011, et décide de nommer comme nouveau
gérant unique Monsieur Elio Quartararo, demeurant Via Lazzaretto 14, 1-20124 Milan (Italie), pour la période expirant
à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011146879/18.
(110170379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 446.249,76.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.421.

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth of October;
Before Us, M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED

ZINC HOLDINGS LIMITED, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, registered with

the Cayman Islands Registrar of Companies under number MC-160163 and registered with the UK Companies House
under number FC026491, whose registered office is at Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman KY1-1104, Cayman
Islands,

here represented by Me Anneleen HOFKENS, Avocat Liste II, with professional address at 2-4, place de Paris, L-2314

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on 17 October 2011; and

SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED, a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having

its registered office at 1 Churchill Place, London E14 5HP, England and registered with the UK Companies House under
number 02793078,

here represented by Me Anneleen HOFKENS, prenamed, by virtue of a proxy given on 17 October 2011.
The said proxies, signed “ne varietur” by the proxy-holders of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  parties  are  the  shareholders  (the  "Shareholders")  of  "Barclays  Luxembourg  Finance  Holdings  S.à

r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 125.421, incorporated pursuant to a deed of the notary
Me Paul FRIEDERS, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 March 2007, whose
articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 24
May 2007, number 961, page 46087. The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary, dated 6 October 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders decide to increase the issued share capital of the Company by an amount of two hundred and twenty-

two thousand thirty-three point sixty-eight British Pounds (GBP 222,033.68) so as to bring it from its current amount of
two hundred and twenty-four thousand two hundred and sixteen point zero eight British Pounds (GBP 224,216.08) to
four hundred and forty-six thousand two hundred and forty-nine point seventy-six British Pounds (GBP 446,249.76), by
creating and issuing two hundred and fifty-two thousand three hundred and eleven (252,311) new B Ordinary Shares with
a nominal value of zero point eighty-eight British Pounds (GBP 0.88) each (the "New Shares").

142172

L

U X E M B O U R G

The New Shares are all subscribed by SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED and are entirely paid up by a contribution

in cash of an amount of two billion seven hundred and seventy-five million four hundred and twenty-one thousand British
Pounds (GBP 2,775,421,000.-). The global contribution of two billion seven hundred and seventy-five million four hundred
and twenty-one thousand British Pounds (GBP 2,775,421,000.-) is allocated as follows: two hundred and twenty-two
thousand thirtythree point sixty-eight British Pounds (GBP 222,033.68) are allocated to the share capital of the Company
and two billion seven hundred and seventy-five million one hundred and ninety-eight thousand nine hundred and sixty-
six point thirty-two British Pounds (GBP 2,775,198,966.32) are allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence of the contribution has been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 6 of the Articles of the Company,

which shall henceforth read as follows:

Art. 6. The share capital of the company is fixed at four hundred and forty-six thousand two hundred and forty-nine

point seventy-six British Pounds (GBP 446,249.76) represented by (i) two (2) A ordinary shares (the "A Ordinary Shares")
and (ii) five hundred and seven thousand one hundred (507,100) B ordinary shares (the "B Ordinary Shares", and together
with the A Ordinary Shares, the "shares"), having a nominal value of zero point eighty-eight British Pounds (GBP 0.88)
each, entirely subscribed and fully paid up.

In addition to the share capital, the company may have share premium or other reserve accounts, into which any

premium paid on any share or class of shares or reserve is transferred and the balance of which is freely distributable
and at the disposal of the company."

<i>Costs and Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately six thousand six hundred and
fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
parties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated in the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le dix-huit octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

ONT COMPARU

ZINC HOLDINGS LIMITED, une limited company constituée sous l'empire du droit des Iles Cayman, immatriculée

auprès du Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro MC-160163 et immatriculée auprès du UK Companies
House sous le numéro FC026491, dont le siège social sis au Ugland House, PO Box 309, Grand Cayman KY1-1104,
Cayman Islands,

ici représentée par Maître Anneleen HOFKENS, Avocat Liste II, avec adresse professionnelle au 2-4, place de Paris,

L-2314 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 octobre 2011; et

SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED, une limited company constituée sous l'empire du droit du Royaume-Uni,

ayant son siège social à 1 Churchill Place, London E14 5HP, Royaume-Uni et immatriculée au UK Companies House sous
le numéro 02793078,

ici représentée par Maître Anneleen HOFKENS, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 17 octobre 2011.
Lesdites procurations, signées “ne varietur” par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés (les "Associés") de "Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l." (la

"Société"), une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.421, constituée suivant un acte reçu par Maître Paul FRIEDERS,
notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 Mars 2007, dont les statuts (les "Statuts")
ont été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 24 Mai 2007, numéro 961, page 46087. Les
Statuts de la Société ont été modifies pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, le 6 octobre
2011, non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

142173

L

U X E M B O U R G

Les parties comparantes représentant la totalité du capital social, requièrent le notaire de prendre acte des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent vingt-deux mille trente-

trois virgule soixante-huit Livres Sterling (GBP 222.033,68) de manière à le porter de son montant actuel de deux cent
vingt-quatre mille deux cent seize virgule zéro huit Livres Sterling (GBP 224.216,08) à quatre cent quarante-six mille deux
cent quarante-neuf virgule soixante-seize Livres Sterling (GBP 446.249,76), par la création et l'émission deux cent cin-
quante-deux mille trois cent onze (252.311) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B ayant une valeur nominale de zéro
virgule quatre-vingt-huit Livres Sterling (GBP 0,88) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales").

Les Nouvelles Parts Sociales sont toutes souscrites par SWAN LANE INVESTMENTS LIMITED et sont entièrement

souscrites et libérées par un apport en numéraire d'un montant de deux milliards sept cent soixante-quinze millions
quatre cent vingt-et-un mille Livres Sterling (GBP 2.775.421.000,-). L'apport global de deux milliards sept cent soixante-
quinze millions quatre cent vingt-et-un mille Livres Sterling (GBP 2.775.421.000,-) est alloué comme suit: deux cent vingt-
deux mille trente-trois virgule soixante-huit Livres Sterling (GBP 222.033,68) sont alloués au capital social de la Société
et deux milliards sept cent soixante-quinze millions cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante six virgule trente-
deux Livres Sterling (GBP 2.775.198.966,32) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société.

La preuve de l'apport a été produite devant le notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de la Société,

lequel aura dorénavant la teneur qui suit:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quarante-six mille deux cent quarante-neuf virgule soixante-

seize Livres Sterling (GBP 446.249,76) représenté par (i) deux (2) parts sociales ordinaires A (les "Parts Sociales Ordinaires
A") et (ii) cinq cent sept mille cent (507.100) parts sociales ordinaires B (les "Parts Sociales Ordinaires B", et ensemble
avec les Parts Sociales Ordinaires A, les "parts sociales"), ayants une valeur nominale de zéro virgule quatre-vingt-huit
Livres Sterling (GBP 0.88) chacune, entièrement souscrites et libérées.

En plus de son capital social, la Société peut posséder des comptes de prime d'émission ou d'autres comptes de réserve,

dans lesquels toute prime payée sur toute part sociale ou classe de parts sociales ou réserve est transférée et dont les
soldes sont librement distribuables et à la disposition de la Société."

<i>Coûts et Dépenses

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six mille six cent
cinquante euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. HOFKENS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 octobre 2011. LAC/2011/46063. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Référence de publication: 2011147246/138.
(110171213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

BTS Finance Corporation, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 110.998.

La société Luxembourg Finance House SA a dénoncé le siège de la société BTS Finance Corporation sis au 22-24,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au RCS sous Je numéro B110998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

142174

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 octobre 2011.

Luxembourg Finance House SA
Signature

Référence de publication: 2011146615/12.
(110170281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Building Orbis S.A., Société Anonyme,

(anc. Gamaaloth S.A.).

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 136.428.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146616/11.
(110170546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

C.V. s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 44, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 144.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011146620/10.
(110170616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Columbus III Ventures Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 137.371.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011146623/11.
(110170591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Campus Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 127.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011146629/10.
(110170538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Calparts S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg.

R.C.S. Luxembourg B 131.061.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

142175

L

U X E M B O U R G

<i>Pour CALPARTS S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146626/12.
(110170277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Christophe de Schräiner S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7565 Mersch, 29, rue Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 102.912.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CHRISTOPHE DE SCHRÄINER S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2011146632/12.
(110170272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

CNPV Solar Power S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 139.925.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146633/10.
(110170420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Steelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Est.

R.C.S. Luxembourg B 71.311.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 mai 2011

Il a été décidé, entre autres,
de renouveler pour un nouveau terme de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire, leur mandat prenant

fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2017, soit:

- Monsieur Spartacus SPERANDIO, administrateur de société, demeurant à F-57100 THIONVILLE, 10, rue du Pays

Haut, administrateur, administrateur-délégué et Président du Conseil d'administration;

- Monsieur Thierry WEBER, employé privé, demeurant à F-57970 YUTZ, 240, rue Roosevelt, administrateur;
- Monsieur Joffrey SPERANDIO, employé privé, demeurant à F-57100 THIONVILLE, 8, rue du Pays Haut, adminis-

trateur.

- la société à responsabilité limitée FN-SERVICES S.à r.l., avec siège social au 61, Gruuss-Strooss, à L - 9991 WEIS-

WAMPACH, commissaire.

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix et le présent procès-verbal est signé par tous les membres du Conseil

d'Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 20 octobre 2011.

<i>Pour STEELUX S.A.
Société Anonyme
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2011148513/28.
(110171953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

142176


Document Outline

Archipolis S.A.

Architectures Nouvelles et Cuisines

AS Architecture S.à r.l.

Asian and African Assets Corporation S.A. SPF

Assenagon Asset Management S.A.

Aste Real Estate S.A.

Atalys S.à r.l.

AXA Mezzanine II S.A., SICAR

AXA Mezzanine I S.A., SICAR

Barclays Luxembourg Finance Holdings S.à r.l.

Barros-Pereira S.à r.l.

Baulder II S.à r.l.

BEB S.A.

Bernard-Kauffman S.à r.l.

Bevis Marks Holding S.à r.l.

BFW van Hoffs S.à r.l.

Biloba Investissement S.A.

Bominvest S.à r.l.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.

Boulangerie Pâtisserie Flick S.à r.l.

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à r.l.

BTS Finance Corporation

Building Orbis S.A.

Calparts S.à r.l.

Cam.Fin S.A.

Campus Invest S.A.

Christom S.à r.l.

Christophe de Schräiner S. à r.l.

CNPV Solar Power S.A.

Columbus III Ventures Investments S.A.

C.V. s.àr.l.

DA Partners

Epajona S.àr.l.

Eridanus Investments S.à r.l.

Friture Piccola S.à.r.l.

Gamaaloth S.A.

GCL Holdings LP S.à r.l.

Gordon Finance S.A.

Kondor Bidco S.à r.l.

Luxalloys S.A.

Lyrea Holding S.A.

Oderfin S.àr.l.

OT Luxco 4 Finance &amp; Cy S.C.A.

Profil S.A. Holding

ProLogis France XLVIII S.à r.l.

ProLogis France XLVII S.à r.l.

ProLogis France XV S.àr.l.

Saipem Maritime Asset Management Luxembourg S.àr.l.

Steelux S.A.

Sudinvestments S.A.

Technical &amp; Data Consulting Luxembourg