logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2950

2 décembre 2011

SOMMAIRE

Aprima Smart Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141568

ARIA Structured Investments SICAV-SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141554

Azure Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141582

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141592

Carlson Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141580

Coal Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141556

C.R.G. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141561

DBSAM Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141569

Delta Lloyd L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141555

Digital Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141558

Dippecher Dachsen, Eclaireurs et Eclaireu-

ses de la Commune de Dippach  . . . . . . . .

141576

DNB Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141580

DnB NOR Part II Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . .

141581

DnB NOR Specialised Investment Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141581

DNB Part II Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141581

DNB Specialised Investment Fund  . . . . . . .

141581

E&G Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141568

Eggborough HoldCo 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

141589

Euring S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141556

FFP Capital Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

141561

Harsco Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

141592

JML Ingénieur Concept SA  . . . . . . . . . . . . . .

141580

JML Ingénieur Concept SA  . . . . . . . . . . . . . .

141580

JPMorgan Series II Funds  . . . . . . . . . . . . . . .

141555

J.P. Morgan Specialist Funds  . . . . . . . . . . . .

141554

Kamari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141560

Lux-Croissance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141560

MARRIE Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141568

MI-FONDS (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141599

Mozina S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141600

Multi-Strategy Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . .

141590

Ness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141588

Norbord (Ontario) Inc., Luxembourg

Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141573

Patrinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141560

RP XIX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141581

RP X S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141581

RP XV S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141581

San Martin Participations  . . . . . . . . . . . . . . .

141589

Scalfi Esfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141559

Silpat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141589

Sirtes S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141590

Soccerworld Europe S. à r. l.  . . . . . . . . . . . .

141590

Spotify Technology S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

141591

Staples Canada Luxco II S.A.  . . . . . . . . . . . .

141589

Sud Immo Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141591

Surexpo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141591

Surexpo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141599

TecCo S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141598

TecCo S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141599

Texhold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141599

Transincom A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141599

Tritax Polska N°1 Investments Company

Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141591

141553

L

U X E M B O U R G

ARIA Structured Investments SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SI-

CAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.369.

The meeting convened on 28 

th

 October 2011 was not quorate, as only 164,660.2433 shares out of 11,302,954.7390

were present or represented.

The board of directors of the Company has now the pleasure to invite you to the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of ARIA STRUCTURED INVESTMENTS SICAV-SIF which will be held at its registered office at 6, rue

Philippe II, L-2340 Luxembourg at 14.00 hours (Luxembourg time) on <i> 13 

<i>th

<i> January 2012 

 (the "Meeting").

The Meeting will be held for the same purposes as the meeting on the 28 

th

 October 2011, which was to consider and

vote upon amendments of the Company's articles of incorporation (the "Articles") as set-out in the following agenda.

<i>Agenda:

Approval of amendments of the Articles as detailed below:

1. Amendment of article 4 of the Articles so as to change the registered office of the Company from Luxembourg

City to Bertrange.

2. Amendment of article 24 of the Articles so as to provide that general meetings of shareholders shall be convened

in accordance with the requirements set-out in the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended.

3. Amendment of article 30 of the Articles to clarify that distributions shall be paid in the base currency of a class of

shares.

Voting:

Resolutions on the agenda of the Extraordinary General Meeting will not require a quorum but a majority of two thirds

(2/3) of the votes cast at the Meeting. Each share entitles to one vote. You may act at the Meeting by way of proxy.

<i>By order of the board of directors.

Référence de publication: 2011163660/27.

J.P. Morgan Specialist Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 151.450.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of  Shareholders  (the  "Meeting")  of  J.P.  Morgan  Specialist  Funds  (the  "Company")  will  be  held  on  Wednesday,  <i>21

<i>December 2011 at 14.00 (CET), at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended June 30, 2011.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended June 30, 2011.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended June 30, 2011.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended June 30,

2011.

5. Approval of Directors' Fees.
6. Re-election of Mr Jacques Elvinger, Mr Trevor Ash, Mr Nicolas Deblauwe, Mr Jean Frijns and Mr Peter Schwicht

to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial
Statements for the accounting year ending on June 30, 2012.

7. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors of the Company until the Annual General

Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on June 30, 2012.

8. Allocation of the results as per the Audited Annual Report for the accounting year ended June 30, 2011.
9. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

<i>VOTING

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.

141554

L

U X E M B O U R G

<i>VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. Com-

pleted Forms of Proxy must be received by no later than the close of business in Luxembourg on Monday, 19 December
2011 at the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011164167/755/33.

Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.964.

As the quorum has not been reached at the Extraordinary General Meeting held on 30 November 2011, the Board

of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV on <i>4 January 2012 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

- Amendment of the articles of association of the SICAV with regards to the Luxembourg law of 17 December 2010

relating to undertakings for collective investment and implementing the Directive 2009/65/EC.

- Rewriting of the articles of association of the SICAV.

Shareholders are advised that no quorum is required for the Meeting and that decisions will be taken by a majority of

two thirds of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. Shareholders who wish to attend
the Meeting must inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days
before the Meeting.

Shareholders may consult the draft updated prospectus and articles of association with the registered office of the

SICAV or Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg).

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011164165/755/21.

JPMorgan Series II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 39.252.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Series II Funds (the "Company") will be held on Wednesday, <i>21 December

<i>2011 at 15.00 (CET), at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended July 31, 2011.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended July 31, 2011.
3. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended July 31, 2011.
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended July 31,

2011.

5. Approval of Directors' Fees.
6. Confirmation of the appointment of Mr James Broderick, co-opted by the Board of Directors on March 31, 2011,

in replacement of Ms Andrea Hazen, and his election to serve as a Director of the Company until the Annual
General Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on July 31,
2012.

7. Re-election of Mr Iain Saunders, Mr Jacques Elvinger, Mr Pierre Jaans, Mr Jean Frijns, Mr Robert Van Der Meer and

Mr Berndt May. to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving
the Financial Statements for the accounting year ending on July 31, 2012.

8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors of the Company until the Annual General

Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on July 31, 2012.

9. Allocation of the results as per the Audited Annual Report for the accounting year ended July 31, 2011.

10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

141555

L

U X E M B O U R G

<i>VOTING

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes

expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.

<i>VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. Com-

pleted Forms of Proxy must be received by no later than the close of business in Luxembourg on Monday, 19 December
2011 at the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011164168/755/36.

Euring S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 68.121.

The shareholders are hereby convened to

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on Thursday, the <i>22th of December 2011 at 10.00 a.m. at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the supervisory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2010.
3. Appropriation of results as of December 31, 2010.
4. Discharge to the directors and to the supervisory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Ratification of the co-option of Mr. Philippe TOUSSAINT as director decided on August 12, 2010 by a decision of

the remaining directors and appointment of Mr. Philippe TOUSSAINT as director until the end of the statutory
general shareholders' meeting of 2015.

6. Sundry.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2011164166/29/21.

Coal Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.144.

Following a decision of the board of directors of Coal Energy S.A. (the "Company"), an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "EGM") followed by the annual general meeting of shareholders of the Company

(the "AGM", and together with the EGM the "Meetings") will be held on <i>14 December 2011 at 2.00 p.m. (Central European
Time) at the offices of the Company, 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment to article 15.4 of the articles of association of the Company to provide that the annual general meeting

of shareholders is held each year on the 12 

th

 day of December at 11.00 a.m.

The board of directors proposes that the annual general meeting of shareholders shall be held each year on the 12

th

 day of December at 11.00 a.m. and that the article 15.4 of the articles of association will be subsequently amended

as follows:
"15.4 The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the 12 

th

 day of December,

at 11.00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on
the following Business Day in Luxembourg."

ANNUAL GENERAL MEETING

<i>Agenda:

1. Approval of the stand-alone financial statements as of 31 December 2010 and of the management report for the

period covered by these financial statements

141556

L

U X E M B O U R G

The board of directors proposes that the meeting approves the stand-alone financial statements as of 31 December
2010 and the management report for the period covered by these financial statements.

2. Allocation of the net result from the financial year ended on 31 December 2010

The board of directors proposes that the meeting acknowledges the net loss for the financial year ended on 31
December 2010, and amounting to ninety-four thousand four hundred eighty-seven Euro twenty-nine cents (EUR
94,487.29), and to carry forward this net loss.

3. Approval of the stand-alone financial statements as of 30 June 2011 and of the management report for the period

covered by these financial statements
The board of directors proposes that the meeting approves the stand-alone financial statements as of 30 June 2011
and the management report for the period covered by these financial statements.

4. Allocation of the net result from the financial year ended on 30 June 2011

The board of directors proposes that the meeting acknowledges the net loss for the financial year ended on 30
June 2011, and amounting to one hundred eighty-six thousand nine hundred eighty-five United States Dollar fifty-
three cents (USD 186,985.53), and to carry forward this net loss.

5. Approval of the consolidated financial statements for the company as of 30 June 2011 and of the management report

for the period covered by these financial statements
The board of directors proposes that the meeting approves the consolidated financial statements as of 30 June
2011 and the management report for the period covered by these financial statements.

6. Acknowledgement of the resignation of Andrey Bolshakov from his position as director A of the Company

The board of directors proposes that the meeting acknowledges the resignation of Andrey Bolshakov as director
A of the Company with effect as of 21 September 2011.

7. Discharge of the directors of the company for the performance of their duties from the formation of the company

on 17 June 2010 until 30 June 2011
The  board  of  directors  proposes  that  the  meeting  discharges  the  directors  that  have  been  in  office  since  the
formation of the company on 17 June 2010 (Viktor Vyshnevetskyy, Andrey Bolshakov, Mykhail Zolotarov, Olek-
sandr Reznyk, Arthur David Johnson, Joost Anton Mees, Gwenaëlle, Bernadette, Andrée, Dominique Cousin, Jacob
Mudde) from their liability for the performance of their duties as directors of the Company until 30 June 2011.

8. Discharge of Interaudit S.à r.l. as statutory auditor of the Company for the performance of its duties from the

formation of the company on 17 June 2010 until 30 June 2011
The board of directors proposes that the meeting discharges Interaudit S.à r.l. from their liability for the perform-
ance of their duties as statutory auditor of the Company from the formation of the company on 17 June 2010 until
30 June 2011.

9. Acknowledgement of the termination of the mandate of Interaudit S.à r.l. as statutory auditor of the company

The board of directors proposes that the meeting acknowledges the termination of the mandate of Interaudit S.à
r.l. as statutory auditor (commissaire) of the Company.

10. Appointment of Interaudit S.à r.l. as independant auditor of the Company

The board of directors proposes that the meeting approves the appointment of Interaudit S.à r.l. as independent
auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for a period ending with the general meeting of shareholders
that will be held in 2016.

Voting Recommendation:
The Board of Directors of the Company unanimously recommends that shareholders vote in favour of the resolutions

which will be proposed and considered at the Meeting.

Action Required by the Shareholders:
Participation at the Meetings is reserved to shareholders of the Company, whose shareholding is determined on the

fourteenth day at 24.00 (Central European Time) prior to Meetings, and who give notice of their intention to attend the
Meetings per mail, email or fax, to the following address: 46A avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg / Fax: + 352 42 19 61; Email: ProjectLavaLux@et.tmf-group.com, so that the notice shall be received not
later than 30 November 2011, 24.00 (Central European Time). The certificate of ownership of shares in the Company
shall be sent to the above-mentioned address and received by the Company no later than 7 December 2011 5.00 p.m.
(Central European Time); shareholders who deliver the certificate after that date may not be granted access to the
Meetings.

The documents relating to the Meetings are available at the registered office of the Company and on the website of

the Company (http://coalenergy.com.ua/) from the date of first publication of this convening notice, and until closing of
the Meetings. These documents include in particular:

(i) the form of proxy
(ii) draft of the shareholders resolutions to be taken during the Meetings;
(iii) the stand-alone financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2010, and the

management report and the auditor's report for the period covered by these financial statements;

(iv) the stand-alone financial statements of the Company for the financial year ended on 30 June 2011, and the man-

agement report and the auditor's report for the period covered by these financial statements; and

141557

L

U X E M B O U R G

(v) the consolidated financial statements of the Company as of 30 June 2011.
An attendance list will be established at the Meetings recording the shareholder(s) of the Company attending the

Meetings in person or by proxy. To be recorded in such a list, a natural or a legal person will have to prove his/her/its
quality of shareholder of the Company. In case of a natural person he/she will have to prove his/her identity. In case of a
legal person, its representative will have to prove that he/she is a duly authorized representative empowered to bind the
legal person.

Important notices:
* The Meetings shall be conducted in conformity with the voting requirements of the Luxembourg law on commercial

companies dated 10 August 1915 as amended and the Company's articles of association:

- EGM: the approval of resolutions of the EGM require a quorum of half of the Company's issued share capital, and

affirmative vote of 2/3 of the voting rights present or represented and expressed at the EGM.

- AGM: the approval of resolutions of the AGM require the affirmative vote of the majority of the voting rights present

or represented and expressed at the AGM.

* On the date of the present convening notice the Company has issued 45,011,120 (forty-five million eleven thousand

one hundred twenty) shares having each a voting right.

* One or several shareholders representing at least 5% (five percent) of the issued share capital of the Company (i)

have the right to put items on the agenda of the Meetings, provided that each such item is accompanied by a justification
or a draft resolution to be adopted in the Meetings; and (ii) have the right to table draft resolutions for items included
or to be included on the agenda of the Meetings.

Requests made in accordance with (i) and (ii) above must be sent in writing per email or mail to the Company no later

than the 22 

nd

 (twenty-second day) preceding the Meetings to the following address: Attn.: Marija Prechtlein - email:

ProjectLavaLux@et.tmf-group.com - address 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - Fax: + 352 42 19 61. The
Company will publish these requests in accordance with applicable legal requirements.

Further Information:
If you require further information or clarification on the above, please contact Marija Prechtlein (tel.: + 352 42 71 71-1,

email: ProjectLavaLux@et.tmf-group.com).

Luxembourg, November 2011.

Coal Energy S.A.
<i>The board of directors

Référence de publication: 2011151550/683/114.

Digital Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.323.

The shareholders of DIGITAL FUNDS (the "Sicav") are hereby informed that the First Extraordinary General Meeting

of the Sicav (the "First Meeting") held on 9 November 2011 was not quorate and did not validly deliberate on the proposed
Agenda items. The shareholders of the Sicav are hereby convened to attend a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Sicav (the "Second Meeting"), which will be held at the registered office of the Sicav at 33A avenue J.F. Kennedy,

Luxembourg on <i>20 December 2011 at 02:30 p.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

With effect as of 20 December 2011:

<i>Agenda:

1. To submit the Company, which was governed until 1 July 2011 by the provisions of Part I of the law of 20 December

2002 on undertakings for collective investment, to the provisions of Part I of the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the
Council of 13 July 2009, and to amend a series of Articles of the Company's articles of incorporation (the "Articles
of Incorporation"), in particular (not exhaustive summary):
- To replace any reference to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references
to the law of 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
- To amend Article 4 "Corporate Object" (formerly "Purpose") of the Articles of Incorporation so as to read as
follows:
"The exclusive purpose of the Company is to invest the assets available to it in transferable securities and other
assets permitted by law, in accordance with the principle of risk diversification and with the objective to provide
the shareholders with the income from and the results of the management of its assets.

141558

L

U X E M B O U R G

The Company may take any measures or carry out any transactions that it considers appropriate to achieve and
promote this purpose and will do this in the broadest possible sense in accordance with Part I of the law dated 17
December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law")."
- To insert in Articles 11, 17 and 25 (formerly 24) of the Articles of Incorporation specific rules for sub-funds
established as a master/feeder structure;
- To insert a new paragraph in Article 17 of the Articles of Incorporation in order to provide the Company with
the authority to perform cross-sub-fund investments;
- To amend Articles 25 (formerly 24) of the Articles of Incorporation in order to adjust mergers and liquidations
of sub-funds to the rules of the 2010 Law.

2. To adjust a series of Articles of the Company's Articles of Incorporation to meet UBS standards, in particular (not

exhaustive summary):
- To allow pooling and co-management of assets of two or more sub-funds and to amend Article 5 Articles of
Incorporation accordingly.
- To amend Article 10 of the Articles of Incorporation in order to allow the adjustments to the net asset value of
share classes if on any trading day the total number of subscription and redemption applications for all share classes
in a sub-fund leads to a net cash in- or outflow (so-called "swing-pricing").
- To insert a new paragraph in Article 14 of the Articles of Incorporation in order to mention the authority of the
Company's board of directors to appoint a designated management company for the Company.

3. To change the date of the annual general meeting and consequently to adapt Article 23 of the Articles of Incor-

poration.

4. To delete the French translation of the Articles of Incorporation and to draw up the Articles of Incorporation or

any amendment thereto henceforth only in English without any translation enclosed.

5. To restate the Articles of Incorporation as a whole in order to reflect the foregoing.
6. Miscellaneous.

The full text of the revised Articles of Incorporation is available to shareholders upon request at the registered office

of the Company 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

These resolutions require a majority of 2/3 of the votes cast in order to pass the resolution.
At the extraordinary shareholders' meeting, each share entitles to one vote.
Holders of bearer shares may, where applicable, vote at the meeting: in person by producing at the meeting a certificate

of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A, which will be issued to them against deposit of their
share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (Luxembourg) S.A. at the latest on 15 December
2011.

In order to be admitted to the meeting, please send a notice in this respect by fax at least five (5) business days in

advance of the extraordinary general meeting to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 - 44 10 10 -
6249.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS

Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, by fax followed by mail until 15 December
2011, fax number +352 - 44 10 10 - 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011154762/755/65.

Scalfi Esfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 61.525.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>22 décembre 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011164169/534/16.

141559

L

U X E M B O U R G

Patrinvest, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 69.080.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 décembre 2011 à 16 heures devant le notaire Elvinger au 15 Côte D'Eich, L-1450 Luxembourg, avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'Article 9 des statuts;
2. Divers.
Une première assemblée extraordinaire ayant été tenue en date du 07 novembre 2011, et n'ayant pas pu délibérer

considérant que la moitié au moins du capital n'était pas représentée ; conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, cette deuxième assemblée pourra être tenue et pourra délibérer sur les
points de l'agenda quelle que soit la proportion du capital représentée.

Référence de publication: 2011154037/17.

Kamari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 149.357.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Kamari S.A., welche am <i>12. Dezember 2011 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden

Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2010
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2011156184/17.

Lux-Croissance, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 38.527.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le

lundi <i>12 décembre 2011 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30

septembre 2011.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2011; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg:

141560

L

U X E M B O U R G

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Pour l'Allemagne:
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011158592/755/32.

C.R.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 58.493.

ASSEMBLEE ORDINAIRE

au siège social le <i>12/12/2011 à 18 h.

<i>Ordre du jour:

- Rapport du C.A.
- Approbation comptes annuels.
- Affectation résultats.
- Décharge administrateurs.
- Nominations.
- Divers.

Référence de publication: 2011157258/15.

FFP Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.040.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fist day of September.
Before, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

FFAM Inc., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at 33 porter

Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, registered with the trade and companies' register of Road Town
under the number 1568779;

here represented by Nicolas Papavoine, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under

a private seal.

The said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration
authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the Articles), which is hereby
incorporated.

1. Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of

"FFP Capital Partners S.à r.l." (the Company).

2. Art. 2. Corporate object.
2.1 The Company may act as general partner of, and take general partner interests in FFP Capital S.C.A., SICAV-FIS,

an investment company organised as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SIF)
subject to the Luxembourg act of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended.

2.2 The Company may carry out any activities which are directly or indirectly connected with its corporate purpose

or which may favour its development.

141561

L

U X E M B O U R G

3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

4. Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a
resolution of the board of managers of the Company.

4.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

5. Art. 5. Share capital. The Company's share capital is fixed at fifteen thousand euro (EUR 15,000) represented by

one hundred and fifty (150) shares (the Shares, and each individually a Share), each Share having a nominal value of one
hundred euro (EUR 100).

6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of the Articles.

7. Art. 7. Distribution. Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of Shares in existence.

8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per

Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

9. Art. 9. Transfer of shares.
9.1 In case the Company has only one shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
9.2 In case the Company has several shareholders, any transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised

by the general meeting of shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of Shares among shareholders.

9.3 Any transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

9.4 The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,

as amended (the 1915 Act) will apply to the transfer of Shares.

10. Art. 10. Redemption of shares.
10.1 The Company shall have the power to acquire Shares in its own share capital, provided that the Company has

sufficient distributable reserves to that effect.

10.2 The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting
of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply in
accordance with article 15 of these Articles.

11. Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of

civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

12. Art. 12. Management.
12.1 The Company is managed by at least four managers forming a board of managers. Each manager shall be assigned

either an A or a B signatory power. The managers need not be shareholders. The managers are appointed, revoked with
or without cause and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders repre-
senting more than half of the share capital of the Company.

12.2 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects, provided
the terms of this article 12 have been complied with.

12.3 All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the

powers of the board of managers.

12.4 The Company shall be bound by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with

a B signatory power.

12.5 A manager may sub-delegate his/her powers for a specific task to one or several ad hoc agents. The delegating

managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency.

12.6 The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members and at least one manager
with an A signatory power and one manager with a B signatory power are present or represented at the relevant meeting.

12.7 A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed at any board meeting by the board of

managers by vote of the majority of the managers present or represented at the relevant meeting. The chairman, if one
is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed.

141562

L

U X E M B O U R G

12.8 Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or

electronic mail (e-mail), at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emer-
gency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers
are present or represented at the relevant meeting, and if they state that they have been informed on the agenda of the
meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places previously approved by a
resolution of the board of managers.

12.9 A manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic

mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company.

12.10 The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the

Company and to be signed by the chairman pro tempore of the relevant meeting, if one has been appointed or by any
manager. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing, in which

case the minutes shall consist of one or several documents setting forth the resolutions and signed by each manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature of a manager. Such circular resolutions are deemed
to be passed in the Grand Duchy of Luxembourg.

13. Art. 13. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name and on behalf of the Company.

14. Art. 14. General meetings of the shareholders.
14.1 An annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

14.2 Other general meetings of the shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholders can be

passed in writing by all the shareholders instead of being passed at general meetings. In this case, each shareholder shall
be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter
or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

15. Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions regardless of the

number of Shares, which it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share
capital of the Company.

15.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders

owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed
by unanimous vote, subject to the provisions of the 1915 Act.

16. Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

17. Art. 17. Financial statements.
17.1 Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case

of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.

17.2 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

18. Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
on a pro rata basis in proportion of to his (their) share holding in the Company. The board of managers may decide to
pay interim dividends.

19. Art. 19. Liquidation. At the time of liquidation of the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine his (their) powers and remune-
ration.

20. Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the 1915 Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to

141563

L

U X E M B O U R G

be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

21. Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for

which no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been established and all the Shares have been subscribed as follows:
FFAM Inc., precited: one hundred and fifty (150) Shares.
All these Shares have been fully paid-up in cash, therefore the amount of fifteen thousand euro (EUR15,000) is now

at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1. the shareholder resolves that the number of managers of the Company is set at four (4) and the following persons

are appointed as managers of the Company, each for an unlimited period of time:

- Jonathan Lepage, born on 27 August 1975 in Namur, Belgium, and with professional address at 65, Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg (Luxembourg), with an A signatory power;

- Olivier Wolf, born on 1 April 1974 in Bendorf am Rhein, Germany, and with professional address at 65, Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Luxembourg), with an A signatory power;

- Yury Emelin, born on 14 May 1980 in Saint Petersburg (Russia) and with professional address at 4, Romanov pereulok,

Moscow 125009 (Russia); with a B signatory power;

- Iseev Rustam, born on 18 December 1981 in Jukovsky (Russia) and with professional address at 4, Romanov pereulok,

Moscow 125009 (Russia); with a B signatory power.

2. the registered office is established at 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

FFAM Inc., une société constituée en vertu du droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au 33 porter

Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola et enregistrée auprès de trade and companies' register of Road
Town sous le numéro 1568779;

représenté par Nicolas Papavoine, avocat, résidant au Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing

privé.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée (les Statuts) qu'elle déclare constituer.

1. Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "FFP Capital Partners S.à

r.l." (ci-après, la Société).

141564

L

U X E M B O U R G

2. Art. 2. Objet social.
2.1 La Société peut agir en tant qu'actionnaire commandité de, et prendre des intérêts d'actionnaire commandité dans

FFP Partners S.C.A., SICAV-FIS, une société d'investissements organisée sous la forme de société d'investissement à capital
variable - fonds d'investissement spécialisé (FIS) soumise à la loi modifiée luxembourgeoise du 13 février 2007 relative au
fonds d'investissement spécialisé.

2.2  La  Société  peut  accomplir  toutes  activités  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou

susceptibles de favoriser son développement.

3. Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4. Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée

générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil de
gérance de la Société.

4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi

qu'à l'étranger.

5. Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze mille euros (15.000 EUR) représenté

par cent cinquante (150) parts sociales (les Parts, et individuellement une Part) d'une valeur nominale de cent euros (100
EUR) chacune.

6. Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de

l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des Statuts.

7. Art. 7. Distributions. Chaque Part donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des Parts existantes, de

l'actif social ainsi que des bénéfices.

8. Art. 8. Parts indivisibles.
Les Parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les

copropriétaires indivis de Parts sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

9. Art. 9. Transfert de parts.
9.1 Lorsque la Société n'a qu'un associé unique, toutes cessions de Parts détenues par l'associé unique sont libres.
9.2  En  cas  de  pluralité  d'associés,  la  cession  de  Parts  inter  vivos  à  des  tiers  non-associés  doit  être  autorisée  par

l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de Parts entre associés.

9.3 La cession de Parts mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois

quarts des droits appartenant aux survivants.

9.4 Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la Loi sur les Sociétés) doivent être respectées en ce qui concerne le transfert de Parts.

10. Art. 10. Rachat de parts.
10.1 La Société pourra acquérir ses propres Parts pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables

suffisants.

10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de Parts détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux termes et conditions qui seront décidés par l'associé unique/
une assemblée générale des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts
en vertu de l'article 15 des présents Statuts sont d'application.

11. Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture

de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

12. Art. 12. Gérance.
12.1 La Société est gérée par au moins quatre (4) gérants qui formeront un conseil de gérance. Les gérants se verront

attribuer un pouvoir de signature A ou B. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués
avec ou sans cause et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés
représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

12.2 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société
et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

12.3 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont

de la compétence du conseil de gérance.

141565

L

U X E M B O U R G

12.4 La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant avec un pouvoir de signature A et d'un gérant avec

un pouvoir de signature B.

12.5 Un gérant peut déléguer ses compétences pour une opération spécifique à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Les gérants déléguant détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la
durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

12.6 Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le

conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou
représentée et que un gérant avec un pouvoir de signature A et un gérant avec un pouvoir de signature B est présent
lors de la réunion concernée.

12.7 Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion

du conseil de gérance par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion concernée. Le président,
si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné.

12.8 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel

(e-mail), au moins vingt quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du
conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont
présents ou représentés à la réunion concernée et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

12.9 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence télé-
phonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui
prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance
par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social.

12.10 Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social

de la Société et signé par le président pro tempore de la réunion concernée, si un président a été désigné ou par tout
gérant. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par

voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents décrivant les résolutions et signés par tous les gérants. La
date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature d'un gérant. Une décision prise par voie circulaire
sera considérée comme ayant été passée au Grand-Duché de Luxembourg.

13. Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom et pour le compte de la Société.

14. Art. 14. Assemblée générale des associés.
14.1 Une assemblée générale annuelle des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de

la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

14.2 D'autres assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.
14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés pourront, au lieu d'être

prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite
de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces
votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

15. Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité.
15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre

de Parts lui appartenant. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de Parts qu'il possède ou représente. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social.

15.3 Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés.

16. Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de

chaque année.

17. Art. 17. Comptes annuels.
17.1 Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou, en cas de pluralité des

gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

141566

L

U X E M B O U R G

18. Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,

déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. Le solde du bénéfice net sera distribué aux associés sur base proportionnelle de leurs détentions de Parts
dans la Société. Le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

19. Art. 19. Liquidation. Lors de la liquidation de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associé(s) ou non, nommés par le(s) associé(s) qui fixera (fixeront) leurs pouvoirs et leurs émoluments.

20. Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la

Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un
réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas appli-
cable.

21. Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts, les associés s'en réfèrent

aux dispositions légales de la Loi sur les Sociétés.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été établis et toutes les Parts ont été souscrites comme suit:
FFAM Inc., prénommée: cent cinquante (150) Parts.
Toutes les Parts sont entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille euros

(15.000 EUR), est désormais à la libre disposition de la Société; preuve ayant été donné au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.

<i>Frais

Les coûts, dépenses, salaires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui puisse être engagés ou mis à la charge de

la Société en conséquence de sa constitution est évalué approximativement à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution, l'associé représentant l'entièreté du capital souscrit de la Société a adopté les

résolutions suivantes:

(1) L'associé décide que le nombre de gérants de la Société est fixé à quatre (4) et les personnes suivantes sont

nommées gérants de la Société, chacune pour une durée indéterminée:

- Jonathan Lepage, né le 27 août 1975 à Namur (Belgique) et avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Luxembourg), avec un pouvoir de signature A;

- Olivier Wolf, né le 1 

er

 avril 1974 à Bendorf am Rhein (Allemagne) et avec adresse professionnelle au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Luxembourg), avec un pouvoir de signature A;

- Yury Emelin, né le 14 mai 1980 à Saint Petersburg (Russie) et avec adresse professionnelle au 4, Romanov pereulok,

Moscou 125009 (Russie), avec un pouvoir de signature B;

- Iseev Rustam, né le 18 décembre 1981 à Jukovsky (Russie) et avec adresse professionnelle au 4, Romanov pereulok,

Moscou 125009 (Russie), avec un pouvoir de signature B.

(2) le siège social est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est établi en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de cette même partie comparante, et
en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par le nom, prénom usuel, état civil et résidence, la partie

comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Papavoine, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 septembre 2011. Relation: EAC/2011/13010. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011142641/352.
(110165825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2011.

141567

L

U X E M B O U R G

E&amp;G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Am <i>12. Dezember 2011 findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Investmentgesellschaft E&amp;G FONDS um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, rue Gabriel Lipp-

mann, L-5365 Munsbach, Luxemburg, statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr zum 30. September 2011.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2012.

6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2012.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung
der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im November 2011.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011159137/2501/24.

MARRIE Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.798.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>13.12.2011 à 11.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 30.09.2011;
- Affectation du résultat au 30.09.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l'Assemblée au Siège Social.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011158593/18.

Aprima Smart Invest, Fonds Commun de Placement.

Hiermit werden die Anleger der Aprima Smart Invest ("Fonds") darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft

in Übereinstimmung mit Artikel 9 des Verwaltungsreglement beschlossen hat die Rücknahmen per 28. November 2011
einzustellen. Darüber hinaus wurde in Übereinstimmung mit Artikel 16 durch die Verwaltungsgesellschaft beschlossen,
dass der genannte Fonds zum 30. November 2011 (Liquidationsdatum) liquidiert wird.

Hintergrund der Liquidation ist, dass für den genannten Fonds eine erhebliche Anteilscheinrücknahme angekündigt

worden ist. Um diese Rücknahme bedienen zu können ist es notwendig, dass zunächst, über den Verkauf der im Fonds
befindlichen Vermögensgegenstände, eine ausreichende Liquidität sichergestellt wird.

Um die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile

des Fonds ab dem 28. November 2011 ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zum Liquidationsdatum weiterhin
täglich berechnet und veröffentlicht.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Fonds getragen.

141568

L

U X E M B O U R G

Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des

Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen,
wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, im November 2011.

IPConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2011164170/755/19.

DBSAM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.979.

In the year two thousand eleven, on the twenty-ninth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Was held:

an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of shareholders of DBSAM FUNDS (the "Company"),a société

d'investissement à capital variable, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg
B 94.979), incorporated pursuant to a notarial deed of 24 July 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of 4 September 2003, number 907. The articles of incorporation have been amended accordingly by a
notarial deed dated 13, February, 2004, published in the Mémorial number 274, on 9 March, 2004.

The Meeting was opened at 4.00 p.m. with Manfred Hoffmann, lawyer, professionally residing in Luxembourg, in the

chair, who appointed as secretary Corinne Prinz, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Elena Esch, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record:
I. - That the Meeting is held with the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the references, throughout the Articles of Incorporation of the Company (the “Articles”), to the

law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, and subsequent amendment of Article 4 second paragraph, Article 5 third para-
graph, Article 18 first paragraph, Article 21 second paragraph, Article 27 second paragraph and Article 32 of the Articles;

2. Amendment of the last paragraph of Article 7 of the Articles and of the first paragraph of Article 21 of the Articles

by introducing the term “authorised” into the references to the auditor of the Company, and deleting the term “inde-
pendent”, if applicable;

3. Insertion of a new character h) in Article 12 of the Articles in order to allow a temporarily suspension of the

determination of the net asset value per share in case that a sub-fund of the Company acts as a feeder and the calculation
of net asset value per share/unit, issue, redemption and/or conversion of the relevant master has been suspended;

4. Amendment of Article 18 paragraph 2 of the Articles, which should be read as follows:
“In compliance with the requirements set forth by the Law dated 17 December 2010 and detailed in the Prospectus,

in particular as to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the
counterparty, each Sub-Fund may invest in:

(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other UCIs, including shares or units of a master fund qualified as a undertaking for collective

investment in transferable securities (“UCITS”);

(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivative instruments;
(v) shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company under the conditions provided for by the Law of

17 December 2010.”

5. Replacement of the words “one fifth” by “one tenth” in Article 22 third paragraph of the Articles;
6. Deletion of the provisions in relation to merger of sub-funds in Article 24 of the Articles and clarification that (i)

assets which may not be distributed after dissolution of a sub-fund of the Company should be deposited directly with the
Caisse de Consignation, (ii) the liquidation of the last subfund of the Company will result in the liquidation of the Company
and (iii) resolutions of the general meeting of shareholders in respect of a dissolution of a sub-fund shall be taken by
simple majority of the shares present or represented and voting;

7. Insertion of a new Article 25 in the Articles which governs the rules concerning the merger of the Company or of

a sub-fund of the Company. The new Article 25 should be read as follows:

“ Art. 25. Mergers. Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged

to the Company nor to its shareholders.

141569

L

U X E M B O U R G

a) Mergers decided by the board of directors
aa) Company
The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010)

of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company concerned as shares of this New UCITS, or of the

relevant sub-fund thereof as applicable.

In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 17 December

2010), solely the board of directors will decide on the merger and effective date thereof.

In the case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 17 December

2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders, rather than the board of directors, has to
approve, and decide on the effective date of such merger by a resolution adopted with no quorum requirement at a
simple majority of the votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

bb) Sub-Funds
The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010)

of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Company or another subfund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

b) Mergers decided by the shareholders
aa) Company
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding section, a merger (within the

meaning of the Law of 17 December 2010) of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof,
may be decided by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum requirement and which

will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority of the votes validly cast
at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

bb) Sub-Funds
The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the Law of

17 December 2010) of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund.
by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.”;

8. Adjustment of the numbering of the articles and characters within the Articles as well as any references to articles

in the Articles due to the modifications mentioned in item 3, 6 and 7 of the agenda;

9. Restatement of the new Article 30 (formerly Article 29) of the Articles which should be read as follows:
“Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed

by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of 17 December 2010. Such law specifies the steps to be
taken to enable the shareholders to participate in the distribution(s) of the liquidation proceeds and provides for a deposit
in escrow at the Caisse de Consignation at the time of the close of the liquidation. Liquidation proceeds available for
distribution to shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by shareholders at the close of the
liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg, where for a period of 30 years they will be held
at the disposal of the shareholders entitled thereto.”;

10. Miscellaneous.

141570

L

U X E M B O U R G

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies given shall be initialled «ne varietur» by the members of the board of
the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves the amendment of the references, throughout the Articles, to the law of 20 December 2002 on

undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment, and subsequent amendment of Article 4 second paragraph, Article 5 third paragraph, Article 18 first paragraph,
Article 21 second paragraph, Article 27 second paragraph and Article 32 of the Articles.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend the last paragraph of Article 7 of the Articles, which should be read as follows:
“The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with

the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the authorised
auditor of the Company (réviseur d'entreprises agréé) and provided that such securities comply with the investment
policy and restrictions of the relevant Sub-Fund as described in the sales documents for the shares. Any costs incurred
in connection with a contribution in kind of securities shall be borne by the relevant shareholders.”

and to amend the first paragraph of Article 21 of the Articles, which should be read as follows:
“The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an authorised auditor (réviseur

d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.“

<i>Third resolution

The Meeting resolves to insert a new character h) in Article 12 of the Articles which shall be read as follows:
“h) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or the

conversion at the level of a master fund in which the Sub-Fund invests in its quality as feeder fund of such master fund”.

<i>Forth resolution

The Meeting resolves the amendment of Article 18 paragraph 2 of the Articles, which should hence be read as follows:
“In compliance with the requirements set forth by the Law dated 17 December 2010 and detailed in the Prospectus,

in particular as to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the
counterparty, each Sub-Fund may invest in:

(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other UCIs, including shares or units of a master fund qualified as a undertaking for collective

investment in transferable securities (“UCITS”);

(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are

maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivative instruments;
(v) shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company under the conditions provided for by the Law of

17 December 2010.”

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves that the third paragraph of Article 22 should be read as follows:
“It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.”

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the title of Article 24 of the Articles as well as its content as follows:

“ Art. 24. Dissolution of Sub-Funds. In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund has

decreased to an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund to be operated
in an economically efficient manner, or if a change in the economical or political situation relating to the Sub-Fund con-
cerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund or in order to proceed to an
economic rationalization, the board of directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the relevant class

141571

L

U X E M B O U R G

or classes issued in such Sub-Fund at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of in-
vestments and realization expenses), calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company
shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares at least thirty days prior to the effective date
for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of the redemption operations:
registered holders shall be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice
in newspapers to be determined by the board of directors. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep
equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund concerned may continue to request re-
demption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments
and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of

shareholders of the class or classes of shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal from the board of directors,
redeem all the shares of the relevant class or classes issued in such Sub-Fund and refund to the shareholders the net asset
value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on
the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general
meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the shares present or represented
and voting.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited

with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.
The liquidation of the last Sub-Fund of the Company will result in the liquidation of the Company under the conditions

of the Law of 17 December 2010.”

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to insert a new Article 25 in the Articles which governs the rules concerning the merger of the

Company or of a sub-fund of the Company. The new Article 25 should be read as follows:

“ Art. 25. Mergers. Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged

to the Company nor to its shareholders.

a) Mergers decided by the board of directors
aa) Company
The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010)

of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company concerned as shares of this New UCITS, or of the

relevant sub-fund thereof as applicable.

In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 17 December

2010), solely the board of directors will decide on the merger and effective date thereof.

In the case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 17 December

2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders, rather than the board of directors, has to
approve, and decide on the effective date of such merger by a resolution adopted with no quorum requirement at a
simple majority of the votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

bb) Sub-Funds
The board of directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010)

of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Company or another subfund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New

Sub-Fund as applicable.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

b) Mergers decided by the shareholders
aa) Company
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding section, a merger (within the

meaning of the Law of 17 December 2010) of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- a New UCITS; or

141572

L

U X E M B O U R G

- a sub-fund thereof,
may be decided by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum requirement and which

will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority of the votes validly cast
at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

bb) Sub-Funds
The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the Law of

17 December 2010) of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund.
by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular

concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.”

<i>Eigths resolution

The Meeting resolves as a consequence of the resolutions three, six and seven to adjust the numbering of the articles

and characters within the Articles as well as any references to articles in the Articles.

<i>Ninth resolution

The Meeting resolves to restate the new Article 30 (formerly Article 29) of the Articles which should be read as

follows:

“Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed

by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of 17 December 2010. Such law specifies the steps to be
taken to enable the shareholders to participate in the distribution(s) of the liquidation proceeds and provides for a deposit
in escrow at the Caisse de Consignation at the time of the close of the liquidation.

Liquidation proceeds available for distribution to shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by

shareholders at the close of the liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg, where for a period
of 30 years they will be held at the disposal of the shareholders entitled thereto.”;

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English and the French version of the Articles of Incorporation is abrogated.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Signé: M. HOFFMANN, C. PRINZ, E. ESCH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43532. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME  délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143356/257.
(110166693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Norbord (Ontario) Inc., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 164.173.

ARTICLES OF AMENDMENT

STATUTS DE MODIFICATION

Form 3 Business Corporations Act
Formule 3 Loi sur les sociétés par actions
1. The name of the corporation is: (Set out In BLOCK CAPITAL LETTERS)
Dénomination sociale actuelle de la société (écrire en LETTRES MAJUSCULES SEULEMENT):
2122221 ONTARIO INC.
2. The name of the corporation is changed to (if applicable): (Set out in BLOCK CAPITAL LETTERS)

141573

L

U X E M B O U R G

Nouvelle dénomination sociale de la société (s'il y a lieu) (écrire en LETTRES MAJUSCULES SEULEMENT):
NORBORD (ONTARIO) INC.
3. Date of incorporation/amalgamation:
Date de la constitution ou de la fusion:
2006-12-15
4. Complete only if there is a change in the number of directors or the minimum / maximum number of directors,
Il faut remplir cette partie seulement si le nombre d'administrateurs ou si le nombre minimal ou maximal d'adminis-

trateurs a changé.

Number of directors is/are: or minimum and maximum number of directors is/are:
Nombre d'administrateurs: ou nombres minimum et maximum d'administrateurs:
Number or minimum and maximum
Nombre ou minimum et maximum
5. The articles of the corporation are amended as follows:
Les statuts de la société sont modifiés de la façon suivante:
To change the name of the corporation to NORBORD (ONTARIO) INC.
6. The amendment has been duly authorized as required by sections 168 and 170 (as applicable) of the Business

Corporations Act

La modification a été dûment autorisée conformément aux articles 168 et 170 (selon le cas) de la Loi sur les sociétés

par actions.

7. The resolution authorizing the amendment was approved by the shareholders/directors (as applicable) of the cor-

poration on

Les actionnaires ou les administrateurs (selon le cas) de la société ont approuvé la résolution autorisant la modification

le

2007-Jan-19
These articles are signed in duplicate.
Les présents statuts sont signés en double exemplaire.
2122221 ONTARIO INC.

John Tremayne
<i>President

<i>Certificate of Incorporation

<i>Certificat de constitution

This is to certify that

Ceci certifie que

2122221 ONTARIO INC.
Ontario Corporation No.

Numéro matricule de la personne morale en Ontario

002122221
is a corporation incorporated,
under the laws of the Province of Ontario.

est une société constituée aux termes des lois de la province
de l'Ontario.

These articles of incorporation
are effective on

Les présents statuts constitutifs entrent en vigueur le

DECEMBER

15 DÉCEMBRE, 2006

Business Corporations Act / Loi sur les sociétés par actions
Signature
<i>Director / Directrice

FORM 1
BUSINESS CORPORATIONS ACT

FORMULE NUMERO 1
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

ARTICLES OF INCORPORATION

STATUTS CONSTITUTIFS

1. The name of the corporation is:

Dénomination sociale de la compagnie:

2122221 ONTARIO INC.
2. The address of the registered office is:

Adresse du siège social:

C/O NOKBORD INC.
1 TORONTO STREET

Suite 600

TORONTO
ONTARIO

CANADA
M5C 2W4

141574

L

U X E M B O U R G

3. Number (or minimum and maximum number)
of directors is:

Nombre (ou nombres minimal et maximal)
d'administrateurs:

Minimum 1

Maximum 10

4. The first director(s) is/are:

Premier(s) administrateur(s):

First name, initials and surname

Prénom, Initiales et nom de famille

Resident Canadian State Yes or No

Résident Canadien Oui/Non

Address for service, giving Street &amp; No. or R.R. No.,
Municipality and Postal Code

Domicile élu, y compris la rue et le numéro, le numéro de
la R.R., ou le nom de la municipalité et le code postal

* JOHN TREMAYNE

YES

61 WENDOVER ROAD
TORONTO ONTARIO
CANADA M8X 2L2
4. The first director(s) is/are:

Premier(s) administrateur(s):

First name, initials and surname

Prénom, initiales et et nom de famille

Resident Canadian State Yes or No

Résident Canadien Oui / Non

Address for service, giving street &amp; No. or R.R. No.,
Municipality and Postal Code

Domicile élu, y compris la rue et le numéro, le numéro de
la R.R., ou le nom de la municipalité et le code postal

* ROBIN LAMPARD

YES

70 ALCINA AVENUE
TORONTO ONTARIO
CANADA M6G 2E8

5. Restrictions, if any, on business the corporation may carry on or on powers the corporation may exercise.
Limites, s'il y a lieu, imposées aux activités commerciales ou aux pouvoir de la compagnie.
None
5. The classes and any maximum number of shares that the corporation la authorised to issue:
Catégories et nombre maximal, s'il y a lieu, d'actions que la compagnie est autorisée a émettre;
An unlimited number of common shares.
7. Rights, privileges, restrictions and conditions (if any) attaching to each class of shares and directors authority with

respect to any class of shares which may be issued in series: Droits, privilèges, restrictions et conditions, s'il y a lieu,
rattachés à chaque catégorie d'actions et pouvoirs des administrateurs relatifs à chaque catégorie d'actions que peut être
émisse en série:

The rights, privileges, restrictions and conditions attaching to the common shares are as follows:
(a) Payment of Dividends: The holders of the common shares will be entitled to receive dividends if, as and when

declared by the board of directors of the Corporation out of the assets of the Corporation properly applicable to the
payment of dividends in such amounts and payable in such manner as the board of directors may from time to time
determine. Subject to the rights of the holders of any other class of shares of the Corporation entitled to receive dividends
in priority to or concurrently with the holders of the common shares, the board of directors may in its sole discretion
declare dividends on the common shares to the exclusion of any other class of shares of the Corporation.

(b) Participation upon Liquidation, Dissolution or Winding Up: In the event of the liquidation, dissolution or winding

up of the Corporation or other distribution of assets of the Corporation among its shareholders for the purpose of
winding up its affairs, the holders of the common shares will, subject to the rights of the holders of any other class of
shares of the Corporation entitled to receive assets of the Corporation upon such a distribution in priority to or con-
currently with the holders of the common shares, be entitled to participate in the distribution. Such distribution will be
made in equal amounts per share on all the common shares at the time outstanding without preference or distinction.

(c) Voting Rights: The holders of the common shares will be entitled to receive notice of and to attend all annual and

special meetings of the shareholders of the Corporation and to one vote in respect of each common share held at all
such meetings.

8. The issue, transfer or ownership of shares is/is not restricted and the restrictions (if any) are as follows:
L'émission, le transfert ou la propriété d'actions est/n'est pas restreinte. Les restrictions, s'il y a lieu, sont les suivantes;
No share of the Corporation may be transferred unless its transfer complies with the restriction on the transfer of

securities set out in section 9 hereof.

9. Other provisions, (if any, are):
Autres dispositions, s'il y a lieu:
No security of the Corporation, other than a non-convertible debt security, may be transferred without the consent

of:

(a) the board of directors of the Corporation, expressed by a resolution duly passed at a meeting of the directors;

141575

L

U X E M B O U R G

(b) a majority of the directors of the Corporation, expressed by an instrument or instruments in writing signed by

such directors;

(c) the holders of the voting shares of the Corporation, expressed by a resolution duly passed at a meeting of the

holders of voting shares; or

(d) the holders of the voting shares of the Corporation representing a majority of the votes attached to all the voting

shares, expressed by an instrument or instruments in writing signed by such holders.

10. The names and addresses of the incorporators are
Nom et adresse des fondateurs

First name, initials and last name or corporate name

Prénom, initiale et nom de famille ou dénomination sociale

Full address for service or address of registered office or of principal place of business giving street &amp; No. or R.R. No.,

municipality and postal code

Domicile élu, adresse du siège social ou adresse de l'établissement principal, y compris la rue et le numéro, le numéro

de la R.R., le nom de la municipalité et le code postal

- DARYL E. MCLEAN

66 WELLINGTON STREET WEST
TORONTO DOMINION BANK TOWER
TORONTO ONTARIO
CANADA M5K 1E6

Suite 4700

Référence de publication: 2011145526/143.
(110169146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Dippecher Dachsen, Eclaireurs et Eclaireuses de la Commune de Dippach, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 30, rue Tajel.

R.C.S. Luxembourg F 8.892.

STATUTS

L'an deux mille onze, le 12 octobre
Entre les soussignés:

Prénom

Nom

Profession

Domicile

Nationalité

Norbert

AREND

employé privé en
retraite

149, route de Luxembourg L-4973 Dippach

Luxembourgeoise

Monique

BOSS

indépendante

4, rue Belle-Vue L-4974 Dippach

Luxembourgeoise

Ginette

ENGEL

Employée privée

7, rue des Romains L-4974 Dippach

Luxembourgeoise

Christoph DEDERICHS employé de l'Etat

1, place de Roedgen L-2432 Luxembourg

Luxembourgeoise

René

GROSBUSCH gérant administratif 64, rue Haard L-4970 Bettange/Mess

Luxembourgeoise

Robert

GRUN

employé privé

28, rue de Bettange L-4974 Dippach

Luxembourgeoise

Julien

KONSBRUCK avocat

7, rue Semmelweis L-8033 Strassen

Luxembourgeoise

Aloyse

MARSON

salarié

54, rue de Bascharage L-4995 Schouweiler

Luxembourgeoise

Yves

MONVILLE

fonctionnaire

47, rue Kremer L-4999 Schouweiler

Luxembourgeoise

Nico

PELTIER

agriculture

46, rue Centrale L-4996 Schouweiler

Luxembourgeoise

Serge

TANSON

fonctionnaire

23, rue de la Chapelle L-4998 Sprinkange

Luxembourgeoise

Benoît

THEISEN

juriste

15, rue des Romains L-4974 Dippach

Luxembourgeoise

Marc

THEISEN

avocat

15, rue des Romains L-4974 Dippach

Luxembourgeoise

et tous ceux qui par la suite en deviennent membres, il est constitué une association sans but lucratif répondant aux

dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée
par la suite, aux statuts de la FNEL et aux présents statuts.

Chapitre I 

er

 - Dénomination, Siège, Objet, Durée, Affiliation

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination "DIPPECHER DACHSEN, ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DE LA

COMMUNE DE DIPPACH", en abrégé "DIPPECHER DACHEN".

Art. 2. L'association est affiliée à la FEDERATION NATIONALE DES ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DU LUXEM-

BOURG (FNEL) dont elle constitue un groupe conformément aux statuts de cette dernière.

Art. 3. Le siège de l'association est établi sur le territoire de la commune de Dippach.

Art. 4. L'objet de l'association consiste à promouvoir et développer le mouvement scout et guide, conformément aux

statuts de la FNEL et selon les principes établis par Lord Baden Powell of Gilwell.

141576

L

U X E M B O U R G

En vue de la réalisation de son objet l'association peut acquérir, prendre en location et gérer des biens meubles et

immeubles.

Art. 5. L'association est indépendante du point de vue politique, confessionnel ou philosophique.

Art. 6. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. - Composition, Admission, Cotisation, Démission, Exclusion

Art. 7. L'association se compose:
- de membres actifs composant le groupe conformément à l'article 23 ci-dessous,
- d'un comité,
- d'une amicale d'anciens et d'anciennes et de sympathisants du scoutisme.

Art. 8. Peuvent devenir membres actifs les personnes physiques qui adhèrent aux principes du scoutisme défendus par

la FNEL et qui sont disposées à contribuer à la réalisation de l'objet de l'association, quelle que soit leur religion, race,
conviction philosophique, opinion politique ou classe sociale.

Art. 9. Toute personne physique ou morale s'intéressant au scoutisme peut devenir membre d'honneur, moyennant

paiement d'une cotisation annuelle à fixer par le comité.

Art. 10. La cotisation des membres actifs est fixée annuellement par l'assemblée générale, sur proposition du comité.
Le montant de la cotisation ne peut pas être inférieur à la cotisation per capita que l'association doit annuellement

verser à la FNEL et ne peut pas être supérieur à 10 fois le montant minimum.

Dans des cas particuliers le comité peut, par décision individuelle, adapter la cotisation à supporter par un ou plusieurs

des membres actifs de l'association.

Art. 11. La qualité de membre actif ou d'honneur se perd:
- de plein droit par non règlement de la cotisation annuelle endéans un délai de trois mois, à compter de l'échéance

fixée pour son paiement,

- par démission, moyennant une simple lettre à adresser au comité,
- par exclusion pour des manquements graves ou répétés aux intérêts de l'association.

Chapitre III. - Administration

Art. 12. Le comité (conseil d'administration) est composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus.

Le nombre des membres du comité est fixé par l'assemblée générale.

Pendant la durée de leurs fonctions le chef de groupe, le(s) chef(s) de groupe adjoint(s) et les chefs de branche, ainsi

que le responsable de l'amicale ou son représentant, assistent aux réunions du comité avec voix délibérative.

Pendant la durée de leurs fonctions les chefs de branche adjoints sont en droit d'assister avec voix consultative aux

réunions du comité.

Art. 13. Peuvent devenir membres du comité (conseil d'administration) les personnes physiques âgées d'au moins 18

ans, ayant la garde juridique d'un enfant membre du groupe, d'anciens scouts/guides et d'amis du scoutisme.

Art. 14. Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale ordinaire.
Les candidatures pour le comité sont à adresser au président avant l'ouverture des opérations de vote.
Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Le mandat des membres du comité est de deux ans, les membres sortants étant rééligibles.

Art. 15. Le comité peut coopter jusqu'à 1/3 des membres élus, et ceci jusqu'à concurrence de 15 membres, afin

d'assurer  une  bonne  gestion  de  l'association.  Le  mandat  des  membres  cooptés  dure  jusqu'à  la  prochaine  assemblée
générale.

Art. 16. Le comité procède à la répartition des charges en son sein en élisant chaque année parmi ses membres un

président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

L'élection se fait à la majorité des voix.

Art. 17. Le comité se réunit chaque fois qu'il le juge utile, sur convocation de son président ou du secrétaire ou à la

demande d'au moins un tiers de ses membres. Toute réunion du comité est convoquée au moins 8 jours avant sa tenue,
sauf urgence.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas d'égalité des voix, celle

du président est prépondérante.

Art. 18. Le comité peut établir des règlements intérieurs relatifs à l'administration interne de l'association ou à l'utili-

sation de ses locaux.

141577

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Le président préside les débats du comité et des assemblées et veille à la sauvegarde des statuts. En cas

d'empêchement il est remplacé par le vice-président ou à défaut, il sera désigné un remplaçant pour cette occasion par
les membres du comité présents.

Art. 20. Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité. Il veille à la rentrée des recettes et au paiement

des dépenses.

Il établit pour chaque exercice le compte des recettes et des dépenses, lequel est soumis aux fins de vérification à

deux réviseurs de caisse, qui ne font pas partie du comité, désignés par l'assemblée générale. Cette commission de révision
en fait le rapport à l'assemblée générale qui, en cas d'approbation, donne décharge au trésorier et au comité.

Art. 21. Le secrétaire rend compte des délibérations du comité et rédige les procès verbaux des assemblées. Il tient

un registre y afférent et il a la charge de la correspondance. En cas d'empêchement du secrétaire, le comité désigne un
remplaçant.

Art. 22. Le comité gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le comité soutient le groupe et en assure la gestion financière et administrative.

Art. 23. Le président signe conjointement avec le secrétaire ou, en son absence, un autre membre du comité, toutes

les pièces qui engagent l'association. En cas d'absence du président, il sera remplacé par le vice-président ou, à son défaut,
par le secrétaire.

Art. 24. Le comité peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres, à un membre actif de

l'association ou à un tiers.

Chapitre IV. - Groupe

Art. 25. Le groupe se compose d'une ou de plusieurs des branches suivantes: colonie de beavers, meute de louveteaux,

troupe de scouts et guides, unité d'explorers et clan de rovers.

Art. 26. Le groupe est dirigé par le chef de groupe qui le représente vis-à-vis de la FNEL.
Dans le cadre de sa mission, le chef de groupe peut être assisté d'un ou de plusieurs chef(s) de groupe adjoint(s).
Le chef de groupe et ses adjoints sont désignés par le comité sur proposition du conseil des gradés.

Art. 27. A la tête de chaque branche se trouve un chef, responsable envers le chef de groupe, du bon fonctionnement

et de la discipline de sa branche.

Les chefs de branche sont nommés par le chef de groupe avec l'accord du comité.
Les assistants du chef de branche sont nommés par le chef de branche avec l'accord du chef de groupe.
Toute nomination est signalée au comité lors de la première réunion qui suit la nomination.

Art. 28. Le conseil des gradés se compose du chef de groupe qui le préside, de son ou ses adjoints, ainsi que des chefs

de branche du groupe et de leurs assistants.

Le conseil des gradés délibère sur les activités du groupe. Il assure la direction des activités du groupe sous l'autorité

du chef de groupe.

Art. 29. Le chef de groupe assure la liaison entre le comité et le conseil des gradés. Il tient au courant le comité des

activités et des projets du groupe. Il dirige l'établissement annuel du relevé nominatif du groupe, de concert avec le conseil
des gradés.

Chapitre V. - Amicale

Art. 30. Le responsable de l'amicale assure la liaison entre le comité et les membres de l'amicale. Il tient le comité au

courant des activités et projets de l'amicale. Il dirige l'établissement annuel du relevé nominatif de l'amicale.

Art. 31. Le conseil de l'amicale se compose du responsable de l'amicale, d'un secrétaire et d'un trésorier. Le conseil

de l'amicale délibère sur les activités de l'amicale et assure la direction de ces activités sous l'autorité du responsable de
l'amicale.

Art. 32. Le conseil de l'amicale tient à jour un fichier nominatif renseignant sur l'identité de ses membres et un livre

de caisse pour autant que l'amicale soit autorisée par le comité à gérer une caisse autonome. Le cas échéant, un rapport
annuel est à faire au trésorier du comité et au chef de groupe.

Chapitre V. - Exercice social

Art. 33. L'année sociale court à partir du 1 

er

 septembre, jusqu'au 31 août.

Chapitre VI. - Assemblée générale

Art. 34. L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association. Elle délibère sur toutes les questions qui relèvent

de l'intérêt de l'association, et elle exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi et les présents statuts.

141578

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale peut être convoquée comme assemblée générale ordinaire ou extraordinaire par le comité quinze

jours francs au moins avant la date de sa réunion par courrier simple. L'ordre du jour est fixé par le comité et est joint
à la convocation.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui a lieu endéans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice

social, porte obligatoirement sur l'approbation du rapport d'activités ainsi que sur la désignation de deux réviseurs de
caisse, élus pour deux ans. Une délibération de l'assemblée générale est en outre obligatoire pour les objets suivants:
modification des statuts, nomination et révocation des membres du comité, approbation des budgets et des comptes,
dissolution de l'association, fixation de la cotisation annuelle.

Chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les mêmes

formes que l'assemblée générale ordinaire, soit sur l'initiative du comité, soit à la demande d'un cinquième des membres
actifs de l'association.

Art. 35. L'assemblée générale se compose des membres actifs, des membres du comité et de l'amicale. Le droit de

vote est réservé à ces derniers. Les membres mineurs sont représentés par leur représentant légal.

L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises

à la majorité des voix exprimées, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi.

Chaque membre ayant droit de vote dispose d'une voix. Le vote par procuration est possible; la procuration se fait

sous forme écrite, à raison d'une seule procuration par membre prenant part aux délibérations.

Les résolutions et décisions des assemblées générales sont portées à la connaissance des membres et des tiers par

insertion dans un bulletin de l'association ou par voie de circulaire.

Chapitre VII. - Ressources

Art. 36. Les ressources de l'association se composent notamment:
a) de cotisation de ses membres;
b) de subsides;
c) de dons ou legs en sa faveur;
d) des intérêts des fonds placés;
e) des recettes des fêtes organisées par l'association.
Cette liste n'est pas limitative.

Art. 37. Toute recette de l'association est à faire au compte de l'association. Les caisses des branches, le cas échéant,

sont alimentées par le trésorier sur demande du chef de groupe, sur présentation de justificatifs appropriés, dans les
limites fixées par le comité.

Chapitre VIII. - Modification des statuts

Art. 38. Toute modification des statuts doit être effectuée conformément aux prescriptions de la loi.

Chapitre IX. - Dissolution, Liquidation

Art. 39. La dissolution de l'association ne peut être prononcée que conformément aux prescriptions de la loi. L'as-

semblée générale peut désigner à la même occasion une ou plusieurs personnes chargées de la liquidation.

Art. 40. En cas de dissolution de l'association, le fonds social est mis sous garde de la FNEL, conformément aux statuts

de celle-ci. Il peut cependant être dérogé à ce principe par voie contractuelle et sous condition d'approbation par l'as-
semblée générale.

Chapitre X. - Publications

Art. 41. Le comité fera les diligences nécessaires pour que les publications prescrites par la loi soient observées.

Chapitre XI. - Dispositions générales

Art. 42. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, tel

qu'elle a été modifiée par la suite, sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.

Tous les cas non prévus par la loi, les statuts, un règlement interne ou les statuts de la FNEL sont tranchés par le

comité.

Fait et passé à Schouweiler, date qu'en tête des présentes.

Norbert AREND / Monique BOSS / Ginette ENGEL / Christoph DEDERICHS / René GROSBUSCH /
Robert GRUN / Julien KONSBRUCK / Aloyse MARSON / Yves MONVILE / Nico PELTIER / Serge TANSON /
Benoît THEISEN / Marc THEISEN
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2011147757/186.
(110171180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

141579

L

U X E M B O U R G

JML Ingénieur Concept SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 80.329.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 18 novembre 2011.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2011159597/14.
(110184838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.

JML Ingénieur Concept SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 80.329.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2011

Il a été décidé, entre autres,
de renouveler pour un terme de six ans les mandats des administrateurs et du Commissaire, leurs mandats prenant

fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2017, à savoir:

- Monsieur Jean-Marie LACASSE, ingénieur de génie rural, demeurant à B-4990 Lierneux, Thier del Preux 1, adminis-

trateur, administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration;

- Madame Marie-Anne MONFORT, assistante sociale, demeurant à B-4990 Lierneux, Thier del Preux 1, administrateur;
- Monsieur Thomas LACASSE, ingénieur industriel, demeurant à B-4990 Lierneux, Petit Sart, 24/1, administrateur;
- La société à responsabilité limitée FN-SERVICES S.à r.l., avec siège social au 61, Gruuss-Strooss à L-9991 Weiswam-

pach, Commissaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 18 novembre 2011.

<i>Pour JML INGENIEUR CONCEPT S.A.
Société Anonyme
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss
L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2011162856/25.
(110188321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2011.

DNB Fund, Fonds Commun de Placement,

(anc. Carlson Fund).

Le règlement de gestion consolidé de DNB Fund (anciennement Carlson Fund), signé en date du 11 novembre 2011,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2011.

CACEIS Bank Luxembourg
<i>Agent administratif de DNB Fund
Signatures

Référence de publication: 2011163581/13.
(110189214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2011.

141580

L

U X E M B O U R G

DNB Specialised Investment Fund, Fonds Commun de Placement,

(anc. DnB NOR Specialised Investment Fund).

Le règlement de gestion consolidé de DNB Specialised Investment Fund (anciennement DnB NOR Specialised Invest-

ment Fund), signé en date du 11 novembre 2011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2011.

CACEIS Bank Luxembourg
<i>Agent administratif de DNB Specialised Investment Fund
Signatures

Référence de publication: 2011163582/13.
(110189298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2011.

DNB Part II Fund, Fonds Commun de Placement,

(anc. DnB NOR Part II Fund).

Le règlement de gestion consolidé de DNB PART II FUND (anciennement DnB NOR Part II Fund), signé en date du

11 novembre 2011, enregistré à Luxembourg a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2011.

CACEIS Bank Luxembourg
<i>Agent administratif de DNB PART II FUND

Référence de publication: 2011164523/12.
(110190938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2011.

RP X S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.155.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011147568/10.
(110171734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

RP XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 134.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011147569/10.
(110170996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

RP XV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.223.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011147570/10.
(110170981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

141581

L

U X E M B O U R G

Azure Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.054.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fifth day of October,
before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Wal-Mart International Holdings, Inc., a company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,

U.S.A., having its registered office at 702 SW 8 

th

 Street, Bentonville, Arkansas, U.S.A., and registered with the Office of

the Secretary of State of the State of Delaware under number 3072593,

duly represented by Ms Yan Yang, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Bentonville,

Arkansas, on 21 September 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as stated above, has required the officiating notary to enact the deed of incorpo-

ration  of  a  private  limited  company  (société  à  responsabilité  limitée)  which  it  declares  organised  and  the  articles  of
incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and all those who may become

shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the “Company”) which shall be governed by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including

bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and
conditions of the law.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of “Azure Holdings S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000) represented by two hundred

(200) shares with a nominal value of one hundred US dollars (USD 100) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

141582

L

U X E M B O U R G

Art. 8. The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by shareholders representing three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided

by law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not

cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. The managers

may be divided into A managers and B managers.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In the case of a sole manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one A manager

and one B manager. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any A manager
together with any B manager.

The sole manager, the board of managers and the Company may grant special powers by authentic proxy or power

of attorney by private instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers may choose from among its members a chairman, and may

choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No
notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of
such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conferencecall or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, including at least one

A manager and one B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority vote of all the managers present or represented at such meeting; in case of a

tied vote, the chairman shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by any two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by any two managers.

141583

L

U X E M B O U R G

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as shares he holds or represents.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous
consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii)
representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on 1 January of each year and ends on the 31 December of the same year.

Art. 20. Each year on 31 December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Each year, five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 22. The sole manager or the board of managers, as the case may be, or the general meeting of shareholders may

proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing
that sufficient funds are available and (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end
of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums
drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant
to the requirements of the law or of these articles of association.

Art. 23. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder

(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal
reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

All of the two hundred (200) shares are subscribed by Wal-Mart International Holdings, Inc., prenamed, represented

as stated above.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31 December

2011.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

141584

L

U X E M B O U R G

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above named party, represented as stated above, representing

the entirety of the subscribed capital passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. The following person is appointed as A manager of the Company for an unlimited period:
- Mr Gordon Young Allison, attorney, born on 19 December 1959 in Pine Bluff, Arkansas, United States of America,

with personal address at 2162 E. Revere Place, Fayetteville, Arkansas, United States of America;

3. The following persons are appointed as B managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Michael Robert Kidd, chartered accountant, born on 18 April 1960 in Basingstoke, England, with personal address

at 28, rue Puert, L-5433, Niederdonven; and

- Mr Martin Timothy Brown, director, born on 30 October 1954 in Oxford, United Kingdom, with professional address

at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le cinq octobre,
par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Wal-Mart International Holdings, Inc., une société constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, U.S.A., ayant

son siège social à 702 SW 8 

th

 Street, Bentonville, Arkansas, U.S.A., et immatriculée à l'Office of the Secretary of State

of the State of Delaware sous le numéro 3072593,

ici représentée par Madame Yan Yang, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Bentonville, Arkansas, le 21 septembre 2011.

Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront devenir des

associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts sous quelque forme que ce soit ou en

émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute
autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, sous réserve des dispositions de la loi.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Azure Holdings S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Le siège social peut être transféré au sein de
la même municipalité par simple résolution du gérant ou du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

141585

L

U X E M B O U R G

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège
social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être provisoirement
transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille dollars US (USD 20.000) représenté par deux cents (200)

parts sociales, d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100) chacune.

Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord (i) de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales nommeront un seul représentant pour les représenter auprès de la
Société.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément pour un tel transfert donné par les autres associés en assemblée générale à une majorité des trois
quarts du capital social. Un tel accord n'est cependant pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants
ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40), sauf dispositions légales

contraires.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la

dissolution de la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants peuvent

être divisés en gérants A et gérants B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants

sont librement et à tout moment révocables.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance composé d'au moins un gérant A et

d'un gérant B. Dans ce cas, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l'un des gérants
A avec l'un des gérants B.

Le gérant unique, le conseil de gérance et la Société peuvent également conférer tous mandats spéciaux par procuration

authentique ou sous seing privé.

Art. 12. En cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir

parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'assemblée générale d'actionnaires.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les transactions relatives à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président, ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence le conseil de gérance pourra

désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les
gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont ap-
prouvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

141586

L

U X E M B O U R G

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, y compris au

moins un gérant A et un gérant B, est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion; en cas d'égalité

des voix, le président a voix prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de l'adoption de la décision.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de votes égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la
Société. Toute autre modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Art. 18. Si la Société n'a qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par

les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 19. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 20. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 22. Le gérant unique, ou le conseil de gérance, ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distri-

bution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment
de fonds disponibles et (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du
dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes
reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la
réserve conformément aux dispositions de la loi ou des statuts présents.

Art. 23. La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable à l'associé/aux associés par une résolution des

associés/de l'associé ou du/des gérant(s), sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital
social et de la réserve légale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues par eux

dans la Société.

Art. 25. Tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la loi du 10 août 1915,

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

141587

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et Libération

Toutes les deux cents (200) parts sociales sont souscrites par Wal-Mart International Holdings, Inc., prénommée,

représentée comme indiqué ci-dessus.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille dollars

US (USD 20.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt, la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée gérant A de la Société pour une durée illimitée:
- Monsieur Gordon Young Allison, avocat, né le 19 décembre 1959 à Pine Bluff, Arkansas, Etats-Unis d'Amérique,

ayant son adresse personnelle au 2162 E. Revere Place à Fayetteville, Arkansas, Etats-Unis d'Amérique.

3. Les personnes suivantes sont nommées gérants B de la Société pour une durée illimitée:
- Monsieur Michael Robert Kidd, expert comptable, né le 18 avril 1960 à Basingstoke, Angleterre, ayant son adresse

personnelle au 28, rue Puert à L-5433, Niederdonven; et

- Monsieur Martin Timothy Brown, administrateur, Global Stewardship, né le 30 octobre 1954 à Oxford, Angleterre,

ayant son adresse personnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Y. YANG et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 octobre 2011. Relation: LAC/2011/45298. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME  délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143247/358.
(110166013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Ness, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.497.

<i>Extraits des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 mai 2009.

Les mandats d’administrateurs de Monsieur Pascal VANHOVE, demeurant à Wavre (Belgique), avenue de la Mousson,

4  et  de  BLUE  STAR  INTERNATIONAL  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  Belize  City  (Belize),  Coney  Drive  4792  et  de
ROSETTA FINANCE Ltd, ayant son siège social à Road Town (Tortola, BVI), Pasea Estate étant arrivés à échéance,
l’Assemblée décide de les reconduire pour un nouveau terme de six ans.

Monsieur Pascal VANHOVE, demeurant à Wavre (Belgique), avenue de la Mousson, 4 est reconduit dans ses fonctions

d’administrateur-délégué pour un terme de six ans.

Le mandat de commissaire aux comptes d’EUROFIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social à Luxembourg étant arrivé

à échéance, l’Assemblée décide de le reconduire pour un nouveau terme de six ans.

Les mandats des administrateurs et de commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an

2015.

141588

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011147502/20.
(110171167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Staples Canada Luxco II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 156.121.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62857 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011146942/10.
(110170853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

San Martin Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.487.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26 septembre 2011

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée accepte les démissions Madame Maria De Fusco et RAPTOR LIMITED de leur poste d’administrateur
2. L’assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’administrateur Monsieur Pascal Hennuy demeurant

professionnellement à 241, Route de Longwy L-1941 Luxembourg et Monsieur François DIFFERDANGE, demeurant
professionnellement à 241, Route de Longwy L-1941 Luxembourg.

Leur mandat est ainsi attribué jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011146944/16.
(110170139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Silpat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 70.140.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011146946/10.
(110170484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Eggborough HoldCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.986,90.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 152.042.

<i>Extrait relatif aux décisions à l'associé unique de la Société

En date du 18 août 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Johanna Dirkje Martina van Oort en tant que gérant B de la Société avec effet au 1 

er

février 2011;

- de nommer Virginia Jennifer Stielen, né le 30 mai 1977 à Bergish Gladbach, Allemagne, ayant pour adresse profes-

sionnelle, 15 rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg, en tant que gérant B de la Société, avec effet au 15 juillet 2011
et pour une durée indéterminée;

141589

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 octobre 2011.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011147769/18.
(110171485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Sirtes S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 43.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011146948/10.
(110170588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Soccerworld Europe S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 103.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 134.769.

En date du 26 septembre 2011, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 67, rue Ermesinde

L-1469 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

L'associé unique constate qu'Alan Dundon, Gérant et Géraldine Schmit, Gérant, ont également transféré leur adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146950/14.
(110170712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Multi-Strategy Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 73.332.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2011

<i>Conseil d'Administration

- Démission de Monsieur David Eckert en date du 1 

er

 Janvier 2011.

- Ratification de la cooptation avec effet au 1 

er

 Janvier 2011 de Monsieur Dirk Buggenhout, 65 Schenkkade, 2595 AS

The Hague, The Netherlands.

- Nomination de Monsieur Monsieur Dirk Buggenhout, 65 Schenkkade, 2595 AS The Hague, The Netherlands.
Confirmation du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Michel Van Elk, 65 Schenkkade, 2595 AS The Hague, The Netherlands
- Madame Maaike van Meer, 81/F, International Commerce Centre, Austin Road West 1, Kowloon, Hong Kong.
- Madame Edith Magyarics, 3 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
- Monsieur Georges Wolff, 3 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
- Monsieur David Suetens, 65 Schenkkade, 2595 AS The Hague, The Netherlands
- Monsieur Jan Straatman, 65 Schenkkade, 2595 AS The Hague, The Netherlands
Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuvera les

comptes pour l'exercice clos en 2012.

<i>Réviseur

Reconduction de mandat de la société Ernst &amp; Young, 7 parc d'activités Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période

d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

141590

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 11 octobre 2011.

ING Investment Management Luxembourg S.A.
Par délégation
Signatures

Référence de publication: 2011148509/30.
(110172485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Tritax Polska N°1 Investments Company Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 125.485.

Les  comptes  annuels  de  la  Société  au  5  avril  2011  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2011.

M. Robert Kimmels
<i>Gérant

Référence de publication: 2011146978/13.
(110170692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Spotify Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 123.052.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146952/10.
(110170859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Surexpo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.828.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011146959/10.
(110170140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Sud Immo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.455.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 octobre 2011

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 3 octobre 2011 que:
L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à L-1330 Luxembourg, 48, Bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

141591

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 3 octobre 2011.

SUD IMMO INVEST S.A.
Hugues Beluche
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011146957/16.
(110170568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Harsco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 107.447,00.

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 132.255.

Il résulte des résolutions écrites des associés (les Associés) de la Société datées du 10 octobre 2011, que les Associés:
1. ont accepté la démission de Monsieur Stéphane Navarra, né le 23 août 1966, à Lyon (France) de sa fonction en tant

que gérant de la Société avec effet au 30 septembre 2011;

2. ont nommé Monsieur Kirk Steven Franklin, né le 29 décembre 1963, à Colorado (États Unis d'Amérique), demeurant

professionnellement à 350 Poplar Church Road, Camp Hill, PA 17011, États Unis d'Amérique, en tant que gérant de la
Société avec effet au 30 septembre 2011 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Harsco Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011147804/18.
(110171495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.003,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.334.

In the year two thousand and eleven, on the seventh of September,
before us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Bridgepoint Europe IV (Nominees) Limited, having its registered office at 30 Warwick Street, London W1B 5AL, United

Kingdom, registered with the Companies House under number 6492046;

European Bijoutier S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital

of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph ELVINGER of 7 March 2011,
published in the Mémorial C – N°1 315 on June 17, 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 159.617 (“EB”);

European Clinics S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital

of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Joseph ELVINGER of 7 March 2011,
published in the Mémorial C – N°1 315 on June 17, 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 159.615 (“EC”); and

European Property Services S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a

share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), with registered office at 2 avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX of 8 June
2011, yet to be published and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
161.859 (“EPS”)

(collectively referred to as the “Shareholders”).
All hereby represented by Mr Gianpiero SADDI, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxies given

on 31 August 2011, which proxies after having being signed “ne variatur” by the proxyholder and the undersigned notary,
shall be annexed to the present deed.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the holders of the entire

share capital of Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of

141592

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, having a share capital of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), with registered office at 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri
HELLINCKX of 2 March 2011, published in the Mémorial C – N°11 23 on May 26, 2011, and registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.334 (the "Company").

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To decrease the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-) so

as to reduce it from its current amount of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) divided into two thousand five
hundred (2,500) class A shares, two thousand five hundred (2,500) class B shares, two thousand five hundred (2,500)
class C shares, two thousand five hundred (2,500) class D shares, two thousand five hundred (2,500) class E shares, two
thousand five hundred (2,500) class F shares, two thousand five hundred (2,500) class G shares, two thousand five hundred
(2,500) class H shares, two thousand five hundred (2,500) class I shares and two thousand five hundred (2,500) class J
shares  with  a  par  value  of  one  euro  (EUR  1.-)  each  to  twenty-two  thousand  five  hundred  euros  (EUR  22,500.-)  by
cancellation of two thousand five hundred (2,500) class J shares.

2 To set the amount of the Company's subscribed capital at twenty-two thousand five hundred euros (EUR 22,500.-)

represented by two thousand five hundred (2,500) class A shares, two thousand five hundred (2,500) class B shares, two
thousand five hundred (2,500) class C shares, two thousand five hundred (2,500) class D shares, two thousand five hundred
(2,500) class E shares, two thousand five hundred (2,500) class F shares, two thousand five hundred (2,500) class G shares,
two thousand five hundred (2,500) class H shares and two thousand five hundred (2,500) class I shares with a par value
of one euro (EUR 1.-) each.

3 To increase the corporate capital of the Company by an amount of three euros (EUR 3.-) so as to raise it from its

present amount twenty-two thousand five hundred euros (EUR 22,500.-) to twenty-two thousand five hundred and three
euros (EUR 22,503.-).

4 To issue one (1) new class A share with a nominal value of one euro (EUR 1.), having the same rights and privileges

as the existing class A shares, to issue one (1) new class B share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the
same rights and privileges as the existing class B shares and issue one (1) new class C share with a nominal value of one
euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing class C shares.

5 To accept subscription for these new class A, class B and class C shares, with payment of a share premium in an

amount of two hundred and forty-eight million nine hundred and eleven thousand one hundred and four euros (EUR
248,911,104.) by EC, EB and EPS and to accept full payment for these new class A, class B and class C shares by contribution
in kind,

6 To set the amount of the Company's subscribed capital at twenty-two thousand five hundred and three euros (EUR

22,503.-) represented by two thousand five hundred and one (2,501) class A shares, two thousand five hundred and one
(2,501) class B shares, two thousand five hundred and one (2,501) class C shares, two thousand five hundred (2,500) class
D shares, two thousand five hundred (2,500) class E shares, two thousand five hundred (2,500) class F shares, two thousand
five hundred (2,500) class G shares, two thousand five hundred (2,500) class H shares and two thousand five hundred
(2,500) class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

7 To amend article 7.1 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the above resolutions.
8 To confer power to the board of managers to implement the above resolutions.
9 Miscellaneous.
Have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred

euros (EUR 2,500.-)

so as to reduce it from its current amount of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) divided into two thousand

five hundred (2,500) class A shares, two thousand five hundred (2,500) class B shares, two thousand five hundred (2,500)
class C shares, two thousand five hundred (2,500) class D shares, two thousand five hundred (2,500) class E shares, two
thousand five hundred (2,500) class F shares, two thousand five hundred (2,500) class G shares, two thousand five hundred
(2,500) class H shares, two thousand five hundred (2,500) class I shares and two thousand five hundred (2,500) class J
shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each

to twenty-two thousand five hundred euros (EUR 22,500.-)
by cancellation of two thousand five hundred (2,500) class J shares and to pay Bridgepoint Europe IV (Nominees)

Limited an amount of two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-) in cash.

<i>Second resolution

The Shareholders resolved to set the amount of the Company's subscribed capital at twenty-two thousand five hundred

euros (EUR 22,500.-) represented by two thousand five hundred (2,500) class A shares, two thousand five hundred (2,500)

141593

L

U X E M B O U R G

class B shares, two thousand five hundred (2,500) class C shares, two thousand five hundred (2,500) class D shares, two
thousand five hundred (2,500) class E shares, two thousand five hundred (2,500) class F shares, two thousand five hundred
(2,500) class G shares, two thousand five hundred (2,500) class H shares and two thousand five hundred (2,500) class I
shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of three euros (EUR 3.-)

so as to raise it from its present amount of twenty-two thousand five hundred euros (EUR 22,500.-) to twenty-two
thousand five hundred and three euros (EUR 22,503.-).

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolved to issue one (1) new class A share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the

same rights and privileges as the existing class A shares, to issue one (1) new class B share with a nominal value of one
euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing class B shares and to issue one (1) new class C share
with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing class C shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared EB represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 August

2011 in Luxembourg, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

EB declared to subscribe for one (1) new class A share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), with payment of

a share premium in a total amount of ninetytwo million two hundred and one thousand three hundred and seventeen
euros (EUR 92,201,317.-) and to fully pay such class A share by a contribution in kind consisting in the contribution by
EB to the Company of an unquestioned receivable it has against the Company for a total amount of ninety-two million
two hundred and one thousand three hundred and eighteen euros (EUR 92,201,318.-). The share premium shall be
allocated to the share premium reserve account corresponding to the class A shares in accordance with the articles of
incorporation of the Company.

EC represented by Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 August 2011in Luxembourg, which

proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

EC declared to subscribe for one (1) new class B share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), with payment of

a share premium in a total amount of sixty-five million one hundred and thirty-four thousand three hundred and forty-
four euros (EUR 65,134,344.-) and to fully pay such class B share by a contribution in kind consisting in the contribution
by EC to the Company of an unquestioned receivable it has against the Company for a total amount of sixty-five million
one hundred and thirty-four thousand three hundred and forty-five euros (EUR 65,134,345.-). The share premium shall
be allocated to the share premium reserve account corresponding to the class B shares in accordance with the articles
of incorporation of the Company; and

EPS represented by Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given on 31 August 2011 in Luxembourg, which

proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

EPS declared to subscribe for one (1) new class C share with a nominal value of one euro (EUR 1.-), with payment of

a share premium in a total amount of ninetyone million five hundred and seventy-five thousand four hundred and forty-
three euros (EUR 91,575,443.-) and to fully pay such class C share by a contribution in kind consisting in the contribution
by EPS to the Company of an unquestioned receivable it has against the Company for a total amount of ninety-one million
five hundred and seventy-five thousand four hundred and forty-four euros (EUR 91,575,444.-). The share premium shall
be allocated to the share premium reserve account corresponding to the class C shares in accordance with the articles
of incorporation of the Company (collectively referred to as the “Subscribers”)

Evidence of the contributions and their value have been given to the notary by a copy of a valuation report which

shows that the managers of the Company have confirmed that the value of the contributions made by the Subscribers is
at least equal to the nominal value plus premium of the new class A, class B and class C shares. The copy of the valuation
report shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the new class A, class B and class C

shares according to the above mentioned subscription.

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolved to set the amount of the Company's subscribed capital at twenty-two thousand five hundred

and three euros (EUR 22,503.-) represented by two thousand five hundred and one (2,501) class A shares, two thousand
five hundred and one (2,501) class B shares, two thousand five hundred and one (2,501) class C shares, two thousand
five hundred (2,500) class D shares, two thousand five hundred (2,500) class E shares, two thousand five hundred (2,500)

141594

L

U X E M B O U R G

class F shares, two thousand five hundred (2,500) class G shares, two thousand five hundred (2,500) class H shares and
two thousand five hundred (2,500) class I shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolved to amend article 7.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect

the above resolutions. This article will from now read as follows:

“ 7.1. The issued share capital of the Company is set at twenty-two thousand five hundred and three euros (EUR

22,503.-) represented by two thousand five hundred and one (2,501) class A shares (the “Class A Shares”), two thousand
five hundred and one (2,501) class B shares (the “Class B Shares”), two thousand five hundred and one (2,501) class C
shares (the “Class C Shares”), two thousand five hundred (2,500) class D shares (the “Class D Shares”), two thousand
five hundred (2,500) class E shares (the “Class E Shares”), two thousand five hundred (2,500) class F shares (the “Class
F Shares”), two thousand five hundred (2,500) class G shares (the “Class G Shares”), two thousand five hundred (2,500)
class H shares (the “Class H Shares”) and two thousand five hundred (2,500) class I shares (the “Class I Shares”), each
having a par value of one Euro (EUR 1.-).

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares,

the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares shall be together referred to as the “Shares”.”

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolved to confer power to the board of managers to give effect to the previous resolutions. The

board of managers is entitled and authorised to do all things necessary and useful in relation to such capital increase.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at EUR 7000.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le sept septembre,
Par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

Bridgepoint Europe IV (Nominees) Limited, ayant son siège social au 30 Warwick Street, London W1B 5AL, Royaume-

Uni, immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 6492046;

European Bijoutier S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, en date du 7 mars 2011, publié
au Mémorial C, N°1 315 du 17 juin 2011 et enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous
le numéro B 159.617 («EB»);

European Clinics S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, en date du 7 mars 2011, publié
au Mémorial C, N°1 315 du 17 juin 2011 et enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous
le numéro B 159.615 («EC»); et

European Property Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un

capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, en date du 8
juin 2011, en attente de publication et enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le
numéro B 161.859 («EPS») (collectivement définis comme les «Associés»),

Toutes ici représentées aux fins des présentes par Mr Gianpiero SADDI, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg, aux termes de procurations en date du 31 août 2011 lesquelles procurations après avoir été signées «ne variatur»
par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés détiennent l'ensemble du capital social de

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant
un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), dont le siège social est au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

141595

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, en date du 2 mars
2011, publié au Mémorial C, N°1123 du 26 mai 2011 et enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Lu-
xembourg sous le numéro B 159.334 (la «Société»).

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des déci-

sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) afin de le porter

de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de
catégorie A, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie B, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de
catégorie C, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie D, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de
catégorie E, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de
catégorie G, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de
catégorie I et deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-)
chacune à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) par annulation de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales
de catégorie J.

2 Fixation du capital social de la Société à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) divisé en deux mille cinq

cents (2.500) parts sociales de catégorie A, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie B, deux mille cinq
cents (2.500) parts sociales de catégorie C, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie D, deux mille cinq
cents (2.500) parts sociales de catégorie E, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F, deux mille cinq
cents (2.500) parts sociales de catégorie G, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H et deux mille cinq
cents (2.500) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

3 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de trois euros (EUR 3,-) pour le porter de son montant

actuel de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) à vingt-deux mille cinq cent et trois euros (EUR 22.503,-).

4 Émission de une (1) nouvelle part sociale de catégorie A d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes

droits et privilèges que les parts sociales de catégorie A existantes, émission de une (1) nouvelle part sociale de catégorie
B d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales de catégorie B
existantes et émission de une (1) nouvelle part sociale de catégorie C d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), ayant
les mêmes droits et privilèges que les parts sociales de catégorie C existantes

5 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C, avec

paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux cent quarante-huit million neuf cent onze mille cent quatre
euros (EUR 248.911.104,-) par EC, EB et EPS à libérer intégralement par apport en nature.

6 Fixation du capital social de la Société à vingt-deux mille cinq cent et trois euros (EUR 22,503,-) divisé en deux mille

cinq cent et une (2.501) parts sociales de catégorie A, deux mille cinq cent et une (2.501) parts sociales de catégorie B,
deux mille cinq cent et une (2.501) parts sociales de catégorie C, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie
D, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie E, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F,
deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie G, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H et
deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

7 Modification de l'article 7.1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
8 Délégation de pouvoirs au conseil de gérance pour mettre en oeuvre les décisions ci-dessus.
9 Divers.
Ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés ont décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux mille cinq cents euros (EUR

2.500,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) divisé en deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales de catégorie A, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie B, deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales de catégorie C, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie D, deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales de catégorie E, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F, deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales de catégorie G, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H, deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales de catégorie I et deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) par annulation de deux mille cinq cents
(2.500) parts sociales de catégorie J et de payer à Bridgepoint Europe IV (Nominees) Limited un montant de deux mille
cinq cents euros (EUR 2.500,-) en espèce.

<i>Deuxième résolution

Les Associés ont décidé de fixer le capital social de la Société à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) divisé

en en deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie A, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie
B, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie C, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie
D, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie E, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F,

141596

L

U X E M B O U R G

deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie G, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H et
deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois euros (EUR 3,-) pour le

porter de son montant actuel de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) à vingt-deux mille cinq cent et trois
euros (EUR 22.503,-).

<i>Quatrième résolution

Les Associés ont décidé d'émettre une (1) nouvelle part sociale de catégorie A d'une valeur nominale de un Euro (EUR

1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales de catégorie A existantes, d'émettre une (1) nouvelle part
sociale de catégorie B d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts
sociales de catégorie B existantes et d'émettre une (1) nouvelle part sociale de catégorie C d'une valeur nominale de un
Euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales de catégorie C existantes

<i>Souscription - Paiement

Ensuite ont comparus EB, représentée par Mr Gianpiero SADDI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le

31 août 2011, à Luxembourg, qui après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

EB a déclaré souscrire une (1) nouvelle part sociale de catégorie A d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) avec

paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-douze million deux cent et un mille trois cent dix-
sept euros (EUR 92.201.317,-) et libérer intégralement cette nouvelle part sociale de catégorie A par un apport en nature
consistant en l'apport par EB de l'intégralité d'une créance envers la Société suite à un Loan Note signé entre EB et la
Société en date du 31 août 2011pour un montant total de un quatre-vingt-douze million deux cent et un mille trois cent
dix-huit euros (EUR 92.201.318,-). La prime démission sera allouée au compte prime démission correspondant aux parts
sociales de catégorie A en conformité avec les statuts de la Société.

EC, représentée par Mr Gianpiero SADDI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 31 août 2011 à Luxem-

bourg, qui après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

EC a déclaré souscrire une (1) nouvelle part sociale de catégorie B d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) avec

paiement d'une prime d'émission d'un montant total de soixante-cinq million cent trente-quatre mille trois cent quarante-
quatre euros (EUR 65.134.344,-) et libérer intégralement cette nouvelle part sociale de catégorie B par un apport en
nature consistant en l'apport par EC de l'intégralité d'une créance envers la Société suite à un Loan Note signé entre EC
et la Société en date du 13 avril 2011 pour un montant total de soixante-cinq million cent trente-quatre mille trois cent
quarante-cinq euros (EUR 65.134.345,-). La prime démission sera allouée au compte prime démission correspondant aux
parts sociales de catégorie B en conformité avec les statuts de la Société; et

EPS, représentée par Mr Gianpiero SADDI, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 31 août 2011, à Lu-

xembourg, qui après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

EPS a déclaré souscrire une (1) nouvelle part sociale de catégorie C d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) avec

paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-onze million cinq cent soixante-quinze mille quatre
cent quarante-trois euros (EUR 91.575.443,-) et libérer intégralement cette nouvelle part sociale de catégorie C par un
apport en nature consistant en l'apport par EPS de l'intégralité d'une créance envers la Société suite à un Loan Note signé
entre EPS et la Société en date du 31 août 2011 pour un montant total de quatre-vingt-onze million cinq cent soixante-
quinze mille quatre cent quarante-quatre euros (EUR 91.575.444,-). La prime démission sera allouée au compte prime
démission correspondant aux parts sociales de catégorie C en conformité avec les statuts de la Société.

<i>Cinquième résolution

Les Associés ont décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre ces nouvelles parts sociales de

catégorie A, de catégorie B et de catégorie C conformément aux souscriptions ci-dessus mentionnées.

<i>Sixième résolution

Les Associés ont décidé de fixer le capital social de la Société à vingt-deux mille cinq cent et trois euros (EUR 22.503,-)

divisé en en deux mille cinq cent et une (2.501) parts sociales de catégorie A, deux mille cinq cent et une (2.501) parts
sociales de catégorie B, deux mille cinq cent et une (2.501) parts sociales de catégorie C, deux mille cinq cents (2.500)
parts sociales de catégorie D, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie E, deux mille cinq cents (2.500)
parts sociales de catégorie F, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie G, deux mille cinq cents (2.500)
parts sociales de catégorie H et deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale de
un euro (EUR 1,) chacune.

141597

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

Les Associés ont décidé de modifier l'article 7.1. des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit

article sera dorénavant rédigé comme suit:

7.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille cinq cent et trois euros (EUR 22.503,-) divisé en deux

mille cinq cent et une (2.501) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), deux mille cinq cent et
une (2.501) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), deux mille cinq cent et une (2.501) parts
sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie D
(les «Parts Sociales de Catégorie D»), deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de
Catégorie E»), deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), deux mille
cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), deux mille cinq cents (2.500) parts
sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H») et deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie
I (les «Parts Sociales de Catégorie I») chacune ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) entièrement libérée.

Les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales

de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G,
les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I seront collectivement désignées comme les «Parts
Sociales»."

<i>Huitième résolution

Les Associés ont décidé de conférer tous pouvoirs au conseil de gérance pour donner effet aux résolutions ci-dessus.

Le conseil de gérance est autorisé et mandaté à prendre toute mesure nécessaire et utile en relation avec l'augmentation
du capital social.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à EUR 7000.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 septembre 2011. Relation: LAC/2011/40358. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143276/349.
(110166160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

TecCo S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.706.

EXTRAIT

Il  resulte  des  résolutions  de  l’associés  unique  prises  en  date  du  24  octobre  2011  qu’il  a  été  décidé  d’accepter  la

démission de Monsieur Dennis E. Justus de son mandat de gérant de la société avec effet au 13 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2011.

<i>Pour TecCo S.à r.l.
Mandataire

Référence de publication: 2011146963/15.
(110170596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

141598

L

U X E M B O U R G

Transincom A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 121.101.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011146987/9.
(110170247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Surexpo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 62.828.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011146960/10.
(110170446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

TecCo S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 114.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011146964/10.
(110170597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

MI-FONDS (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.264.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 24 Octobre 2011:

Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de 2012:
- M. Peter LÄMMLI, Vice-Président du Conseil d'Administration, 12, Seidengasse, CH - 8023, Zürich
- M. Markus WATTINGER, Membre du conseil d'administration, 12, Seidengasse, CH - 8023, Zürich
- M. Günter LUTGEN, Membre du conseil d'administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
- M. Markus Werner MAAG, Président du Conseil d'Administration, 80, Max-Högger-Strasse, CH-8048, Zürich, Suisse

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MI-FONDS (Lux)
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Benjamin Wacker / Mathias Welter
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2011147836/18.
(110171190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Texhold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 26.648.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

141599

L

U X E M B O U R G

Extrait sincère et conforme
Texhold S.A.
Signature

Référence de publication: 2011146984/12.

(110170254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Mozina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 59, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 103.948.

Im Jahre zweitausend und elf, am siebzehnten Tag des Monats Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Rambrouch.

Ist erschienen:

Herr Sacha MOZINA, Alteisenhändler, wohnhaft in L-9964 Huldange, 59, Duarrefstrooss.

Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MOZINA S.à r.l.", mit Sitz in L-9964 Huldange, 59, Duarrefstrooss,

wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Fernand UNSEN, mit dem Amtssitz in Diekirch, am
10. Januar 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 120 vom 9. März 1996,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 103.948. Die Satzung der
Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde unter Privatschrift, aufgenommen am 26. Juni 2002 und veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1284 vom 5. September 2002.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500) An-

teile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), alle dem Herrn Sacha Mozina, vorbenannt, zugeteilt.

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

III.- Alsdann ersuchte der alleinige Anteilhaber den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse, zu beurkunden, wie

folgt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft MOZINA S.à r.l. und ihre Liquidierung.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt Herrn Sacha MOZINA, vorbenannt, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernen-

nen.

Der Liquidator ist mit den weitgehendsten durch das Gesetz und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 über das

Handelsgesellschaftsgesetz vorgesehenen Vollmachten ausgestattet, sogar ohne vorherige Ermächtigung durch die Ge-
neralversammlung im Falle wo diese Ermächtigung normalerweise erfordert wäre.

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-

fähr tausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Heinerscheid, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S Mozina, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert le 19 octobre 2011. Relation: RED/2011/2187. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Rambrouch, den 19. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011148275/42.

(110171783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

141600


Document Outline

Aprima Smart Invest

ARIA Structured Investments SICAV-SIF

Azure Holdings S.à r.l.

Bridgepoint Europe IV Investments (2) S.à r.l.

Carlson Fund

Coal Energy S.A.

C.R.G. S.A.

DBSAM Funds

Delta Lloyd L

Digital Funds

Dippecher Dachsen, Eclaireurs et Eclaireuses de la Commune de Dippach

DNB Fund

DnB NOR Part II Fund

DnB NOR Specialised Investment Fund

DNB Part II Fund

DNB Specialised Investment Fund

E&amp;G Fonds

Eggborough HoldCo 2 S.à r.l.

Euring S.A.

FFP Capital Partners S.à r.l.

Harsco Luxembourg S.à r.l.

JML Ingénieur Concept SA

JML Ingénieur Concept SA

JPMorgan Series II Funds

J.P. Morgan Specialist Funds

Kamari S.A.

Lux-Croissance

MARRIE Spf S.A.

MI-FONDS (Lux)

Mozina S.à r.l.

Multi-Strategy Portfolio

Ness

Norbord (Ontario) Inc., Luxembourg Branch

Patrinvest

RP XIX S.à r.l.

RP X S.àr.l.

RP XV S.àr.l.

San Martin Participations

Scalfi Esfin S.A.

Silpat S.A.

Sirtes S.A., SPF

Soccerworld Europe S. à r. l.

Spotify Technology S.A.

Staples Canada Luxco II S.A.

Sud Immo Invest S.A.

Surexpo S.A.

Surexpo S.A.

TecCo S. à r. l.

TecCo S. à r. l.

Texhold S.A.

Transincom A.G.

Tritax Polska N°1 Investments Company Sàrl