This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2924
30 novembre 2011
SOMMAIRE
70Watt Capital S.C.A. SICAV-SIF . . . . . . .
140336
AAM Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
140338
Admiral Participations (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140347
Apollo 3C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140349
Aqua European Technologists S.A. . . . . . .
140338
Axxion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140338
Bioptone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140339
Bioptone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140340
Blue Gem Luxembourg 1B S.à r.l. . . . . . . .
140339
BM 17 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140338
BM 17 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140340
Bureau d'Expertises Wagner & Chiesa S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140345
Caspian Grill s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140340
Caspian Grill s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140341
Centre d'Isolation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140340
Claront S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140341
CMH Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
140342
CMH Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
140342
Compagnie Luxembourgeoise des Audi-
teurs Réunis (CLAR) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
140343
CompAM FUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140306
Cross Media Publishing S.à r.l. . . . . . . . . . . .
140343
Dellmont S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140347
Digital Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140339
Distillerie Othon Schmitt S.à r.l. . . . . . . . . .
140347
Dollar Tree International, S.à r.l. . . . . . . . .
140348
Double Ace S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140347
EP Anjou 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140330
EP Anjou 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140330
EP Latitude 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140333
EP Latitude 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140333
European Solar Opportunities II . . . . . . . . .
140342
FAURECIA AST Luxembourg S.A. . . . . . .
140346
Fidco Fishing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140348
I C T C S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140348
Ingenieurbüro Thomas DEFFNER sàrl . . .
140350
International Overseas Holding S.A. . . . . .
140349
Island Immo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140349
Jager Financement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140349
Job Networks Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
140351
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l. . . . . . .
140351
Luxembourg CFA Society . . . . . . . . . . . . . .
140325
Luxembourg Hydro Power . . . . . . . . . . . . . .
140326
Luxembourg Real Estate Company . . . . . .
140352
Ourakan International S.A. . . . . . . . . . . . . .
140323
Sermelux aluminium S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
140343
SGG-FFW S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140328
SGG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140328
Sifobuci S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140343
Société d'Industrie Mécanique S.A. . . . . . .
140323
THL GCO Investments III, S.à r.l. . . . . . . .
140352
T.I.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140341
Tivolex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140352
Todoka Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140352
Wyse Investments Luxembourg S.A. . . . .
140352
140305
L
U X E M B O U R G
CompAM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 92.095.
In the year two thousand eleven, on the ninth of November.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CompAM FUND (the "Company"), a société anonyme
qualifying as a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 8, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the trade and companies' register in Luxembourg under
section B number 92095, incorporated on 28 February 2003 for an unlimited duration pursuant to a deed of the notary
Henri Hellinckx, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil de Commerce
et des Sociétés on 4 April 2003, number 366.
The meeting is opened at 2 p.m., and and Mrs. Cecile Leroy, residing professionally in Luxembourg, is elected chairman
of the meeting.
Mr. Silvano Del Rosso, residing professionally in Luxembourg, is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs. Louise Chiappalone, residing professionally in Luxembourg, is ap-
pointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following :
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list, which
is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance
list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company convened for October 3, 2011 could not
validly deliberate on the agenda for lack of quorum, and the present Meeting has been reconvened by notices containing
the agenda published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Luxemburger Wort and the Tageblatt
on October 6 and 21, 2011. As a result of the foregoing, the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and
decide on all the items of the agenda.
III. That the agenda is as follows:
<i>Agendai>
1. Amendment of the Company's purpose as follows:
“ 4.1. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in Transferable Securities and other
liquid financial assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the
results of the management of its assets.
4.2. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment
and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the Law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "UCI Law").”
2. Change of the law applicable to the Company to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment.
3. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company and complete recasting of the articles of
incorporation of the Company to (i) take into account certain legal and regulatory updates and to (ii) ameliorate the
formulation.
4. Appointment of new directors.
5. Deletion of the French translation of the Articles of Incorporation.
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to amend the Article 4 of the Company's articles of incorporation on the Company's
purpose, which shall henceforth read as follows:
“ 4.1. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in Transferable Securities and other
liquid financial assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the
results of the management of its assets.
4.2. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment
and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the Law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "UCI Law").”
140306
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to approve the submission of the Company (which was previously subject to the Lu-
xembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment) to the Luxembourg law of 17 December
2010 on undertakings for collective investment, and to take this opportunity to update the articles of incorporation.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to subsequently amend the Company's articles of incorporation and to completely recast
the articles of incorporation of the Company to (i) take into account certain legal and regulatory updates and to (ii)
ameliorate the formulation, the Company's articles of incorporation which shall henceforth read as follows:
“Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose - Definitions
Art. 1. Name. There exists among the existing Shareholders and those who may become owners of Shares in the
future, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital
("société d'investissement à capital variable") under the name of "CompAM FUND" (hereinafter the "Company").
Art. 2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the Board of Directors. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these Articles of Incorporation.
The Board of Directors may decide to transfer the registered office of the Company within the same municipality, or
from a municipality to another municipality within the Grand-Duchy of Luxembourg, if and to the extent permitted by
Luxembourg law and practice relating to commercial companies.
2.3 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
(but not, in any event in the United States of America, its territories or possessions) by resolution of the Board of
Directors.
2.4 In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, military or social
developments have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of Shareholders, adopted
in the manner required for an amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 4. Purpose.
4.1 The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in Transferable Securities and other
liquid financial assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the
results of the management of its assets.
4.2 The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment
and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the Law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "UCI Law").
Art. 5. Definitions. “Articles” means these Articles of Incorporation of the Company, as amended from time to time.
“Board of Directors” means the board of directors of the Company from time to time.
“Business Day” means any day when the banks in Luxembourg are fully open for business in Luxembourg and/or such
other place or places and such other day or days as the Directors may determine and notify to Shareholders in advance
“Class” / “Class of Shares” is a class of Shares of a Sub-Fund.
“Company” means "CompAM FUND ".
“Depositary” means any depositary bank as defined under Article 29.1 hereof.
“Designated Person” means any person to whom a transfer of Shares (legally or beneficially) or by whom a holding of
Shares (legally or beneficially) would or, in the opinion of the Directors, might: be in breach of the law or the requirements
of any country or governmental authority or result in the Company incurring any liability or taxation or suffering any
other disadvantage which the Company may not otherwise have incurred or suffered.
“Director(s)” means the member(s) of the Board of Directors.
"EU" means the European Union.
“EUR” or “Euro” means the legal currency of the European Monetary Union.
140307
L
U X E M B O U R G
“Member State” means a member state of the European Union. The states that are contracting parties to the agreement
creating the European Economic Area other than the member states of the European Union, within the limits set forth
by this agreement and related acts are considered as equivalent to member states of the European Union.
“Money Market Instruments” means instruments normally dealt in on the money market which are liquid, and have a
value which can be accurately determined at any time.
“Net Asset Value" means in relation to each Class of Share of any Sub-Fund, the value per Share determined in
accordance with the provisions set out in the section headed “Calculation of the Net Asset Value per Share” below.
“Prospectus” means the document(s) whereby Shares in the Company are offered to investors and any supplemental
or replacement documentation having similar effect.
“Regulated Market” means a regulated market as defined in the EC Parliament and Council Directive 2004/39/EC of
21 April 2004 on markets in financial instruments as amended (“Directive 2004/39/EC”).
"Share" means each share within any Class of a Sub-Fund of the Company issued and outstanding from time to time
“Shareholder” means a person recorded as a holder of Shares in the Company's register of Shareholders.
“Sub-Fund” or “Compartment” means a specific portfolio of assets, held within the Company, which is invested in
accordance with a particular investment objective.
“Time”: all references to time throughout these Articles shall be references to Luxembourg time, unless otherwise
indicated.
Transferable Security” means (i) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies (“shares”),
(ii) bonds and other forms of securities debt (“debt securities”), and/or (iii) any other negotiable securities which carry
the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchange. For the purposes of this definition, the
techniques and instruments do not constitute transferable securities.
"UCI(s)" means undertaking(s) for collective investment.
"UCI Law" means the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be
amended from time to time.
"UCITS Directive" means EC Council Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 on the co-ordination of laws, regulations
and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in Transferable Securities (“UCITS”), as
may be amended from time to time.
"U.S. Person" has the meaning as disclosed in the Prospectus.
“US-Dollar” or “USD” means the legal currency of the United States of America.
“Valuation Day” means a Business Day as of which the Net Asset Value per Share of each Sub-Fund is determined, as
provided for in the Prospectus.
Words importing a masculine gender also include the feminine gender, words importing a singular also include the
plural, and words importing persons or Shareholders also include corporations, partnerships associations and any other
organised group of persons whether incorporated or not.
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 6. Share Capital - Classes of Shares.
6.1 The share capital of the Company shall be represented by fully paid up Shares of no par value and shall at any time
be equal to the total net assets of the Company calculated pursuant to Article 12 hereof. The minimum capital shall be
as provided by the UCI Law, i.e. the equivalent in any currency of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR
1,250,000.-). The initial issued Share capital of the Company was thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-).
6.2 The Shares of a Sub-Fund to be issued pursuant to Articles 7 and 8 hereof may, as the Board of Directors shall
determine, be of different Classes. The proceeds of the issue of each Share shall be invested in Transferable Securities of
any kind and any other liquid financial assets permitted by the UCI Law and Luxembourg regulations pursuant to the
investment policy determined by the Board of Directors for a Sub-Fund established in respect of the relevant Shares,
subject to the investment restrictions provided by the UCI Law and Luxembourg regulations or determined by the Board
of Directors.
6.3 The Board of Directors shall establish a portfolio of assets constituting a Sub-Fund within the meaning of Article
181 of the UCI Law for each Class of Shares or for two or more Classes of Shares in the manner described in Article
12.2 III hereof. Each portfolio of assets shall be, as between shareholders thereof, invested for the exclusive benefit of
the relevant Sub-Fund. With regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall
be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.
6.4 The Board of Directors may create each Sub-Fund or Class of Shares for an unlimited or limited period of time;
in the latter case, the Board of Directors may, at the expiry of the initial period of time, prorogate the duration of the
relevant Sub-Fund or Class of Shares once or several times. At expiry of the duration of the Sub-Fund or Class of Shares,
the Company shall redeem all the Shares in the relevant Class(es) of Shares, in accordance with the provisions of Article
9 below. At each prorogation of a Sub-Fund or Class of Shares, the Shareholders shall be duly notified.
140308
L
U X E M B O U R G
6.5 The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the
Prospectus of the Company, that all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed.
6.6 For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund
shall, if not expressed in euro, be converted into euro and the capital shall be the total aggregate of the net assets of each
Sub-Fund.
Art. 7. Form of Shares.
7.1 The Board of Directors shall determine whether the Company shall issue Shares in bearer and/or in registered
form. If bearer Share certificates are to be issued, they will be issued in such denominations as the Board of Directors
shall prescribe and shall provide on their face that they may not be transferred to any U.S. Person, resident, citizen of
the United States of America or entity organized by or for a U.S. Person.
All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by
the Company or by any entity designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each
owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of registered
Shares held by him.
The inscription of the Shareholder's name in the register of Shareholders evidences his right of ownership on such
registered Shares. Evidence of such inscription shall be delivered upon request to the Shareholder.
If bearer Shares are issued, registered Shares may be converted into bearer Shares and bearer Shares may be converted
into registered Shares at the request of the holder of such Shares. A conversion of registered Shares into bearer Shares
will be effected by cancellation of the registered Share certificate, if any, representation that the transferee is not a U.S.
Person and issuance of one or more bearer Share certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the register
of Shareholders to evidence such cancellation. A conversion of bearer Shares into registered Shares will be effected by
cancellation of the bearer Share certificate, and, if applicable, by issuance of a registered Share certificate in lieu thereof,
and an entry shall be made in the register of Shareholders to evidence such issuance. At the option of the Board of
Directors, the costs of any such conversion may be charged to the Shareholder requesting it.
Before Shares are issued in bearer form and before registered Shares shall be converted into bearer Shares, the
Company may require assurances satisfactory to the Board of Directors that such issuance or conversion shall not result
in such Shares being held by a U.S. Person.
The Share certificates shall be signed by two Directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.
The certificates will remain valid even if the list of authorized signatures of the Company is modified. However, one of
such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the Board of Directors; in the latter case, it shall
be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board of Directors may determine.
7.2 If bearer Shares are issued, transfer of bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant Share certificates.
Transfer of registered Shares shall be effected (i) if Share certificates have been issued, upon delivering the certificate or
certificates representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Com-
pany and (ii) if no Share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register
of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act therefore. Any transfer of registered Shares shall be entered into the register of Shareholders; such entry shall be
signed by one or more Directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto
by the Board of Directors.
7.3 Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his address as
entered into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
7.4 If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, mutilated
or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees,
including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance
of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in replacement
of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated Share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the Shareholder the costs of a duplicate or of a new Share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original Share certificate.
7.5 The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the
ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney
140309
L
U X E M B O U R G
to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights
attached to such Share(s).
7.6 The Company may decide to issue fractional Shares. Such fractional Shares shall not be entitled to vote, unless the
number is so that they represent an entire Share in which case they confer a voting right, but shall be entitled to participate
in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis. In the case of bearer Shares, only certificates
evidencing full Shares will be issued.
Art. 8. Issue of Shares.
8.1 The Board of Directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully paid up Shares at any
time without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued.
8.2 The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Sub-Fund
or Class of Shares. The Board of Directors may, in particular, decide that Shares of any Sub-Fund or Class of Shares shall
only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the Prospectus.
8.3 Furthermore, the Board of Directors may impose restrictions in relation to the minimum amount of the aggregate
Net Asset Value of Shares to be initially subscribed, the minimum amount of any additional investments and the minimum
of any holding of Shares.
8.4 Whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered after
the initial offer period as described in the Prospectus shall be the Net Asset Value per Share of the relevant Sub-Fund as
determined in compliance with Article 12 hereof as of such Valuation Day as may be determined in accordance with such
policy as the Board of Directors may from time to time determine, after the swing pricing adjustment (if any) mechanism
is applied. Unless otherwise provided for in the Prospectus, such price may be increased by a percentage estimate of
costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales
commissions, as approved from time to time by the Board of Directors.
8.5
8.5.1 The issue price per Share so determined shall be payable within a period as determined by the Board of Directors
which shall not exceed ten (10) Business Days from the relevant Valuation Day.
8.5.2 Where an applicant for Shares fails to pay issue price on subscription, the Board of Directors may cancel the
allotment or, if applicable, redeem the Shares. In this case the applicant may be required to indemnify the Company against
any and all losses, costs or expenses incurred (as conclusively determined by the Board of Directors in its discretion)
directly or indirectly as a result of the applicant's failure to make timely payment. In computing such loss, account shall
be taken, where appropriate, of any movement in the price of the Shares concerned between allotment and cancellation
or redemption and the costs incurred by the Company in taking proceedings against the applicant.
8.5.3 No request for conversion or redemption of a Share shall be dealt with unless the issue price for such Share has
been paid and any confirmation delivered in accordance with this Article.
8.6 The Board of Directors may delegate to any Director, manager, officer or other duly authorised agent the power
to accept subscriptions, to receive payment of the price of Shares to be issued and to deliver them.
8.7 The Company may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance
with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation, if applicable, to deliver a valuation report
from the authorised auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé"). The securities to be delivered by way of a
contribution in kind must correspond to the investment policy and restrictions of the Sub-Fund to which they are con-
tributed. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of securities shall be borne by the relevant
Shareholders.
8.8 The Company may issue Shares within the framework of regular savings plans.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 Under the terms and procedures set forth by the Board of Directors in the Prospectus and within the limits
provided by law and these Articles any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares in the Company.
9.2 Subject to the provisions of Article 13 hereof, the redemption price per Share shall be paid within such period as
may be determined by the Board of Directors in its discretion from time to time, but which shall not, in any event, exceed
ten (10) Business Days from the Valuation Day which next follows receipt of such redemption request, provided that the
Share certificates (if any) and such instruments for redemption as may be required by the Board of Directors have been
received, and are in a form which is satisfactory to the Company.
9.3 The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the relevant Class within the relevant
Sub-Fund, as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof, less such charges and commissions (if
any) at the rate provided for in the Prospectus and after the swing pricing adjustment (if any) mechanism is applied. Unless
otherwise provided for in the Prospectus, such price may be decreased by a percentage estimate of costs and expenses
to be incurred by the Company when disposing of assets in order to pay the redemption proceeds to redeeming Share-
holders. Furthermore, the redemption price may be rounded up or down to the nearest five decimal places, or such
number of decimal places as the Board of Directors shall determine in its discretion.
140310
L
U X E M B O U R G
9.4 If as a result of any request for redemption, the number, the minimum subscription amount or the aggregate Net
Asset Value of the Shares held by any Shareholder in any Class of the relevant Sub-Fund would fall below these thresholds
as determined by the Board of Directors in its discretion from time to time, then the Company may decide that this
request be treated as a request for redemption for the full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class.
9.5 The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, and with the express consent of the
relevant Shareholder, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder in specie by allocating to the Sha-
reholder investments from the portfolio of assets in such Class or Classes of Shares equal in value (as calculated in the
manner described in Article 12 hereof) as of the Valuation Day on which the redemption price is determined to the value
of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair
and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the Class or Classes of Shares
and the valuation used shall be confirmed, as applicable, by a special report of the authorised auditor of the Company.
The costs of any such transfers shall be borne by the Shareholder.
9.6 All redeemed Shares may be cancelled.
Art. 10. Conversion of Shares.
10.1 Unless otherwise determined by the Board of Directors for certain Classes of Shares or Sub-Funds, any Share-
holder is entitled to request the conversion of whole or part of his Shares in one Sub-Fund into Shares of another Sub-
Fund or in one Share Class into another Share Class of the same Sub-Fund, provided that the Board of Directors may (i)
at its absolute discretion reject any request for the conversion of Shares in whole or in part, (ii) set restrictions, terms
and conditions as to the right to and frequency of conversions between certain Sub-Funds and Share Classes and (iii)
subject to the payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine (unless otherwise
provided for in the Prospectus).
10.2 The price for the conversion of Shares shall be computed by reference to the respective Net Asset Values per
Share of the two Sub-Funds or the two Share Classes concerned, determined as of the same Valuation Day.
10.3 If as a result of any request for conversion the number or the aggregate Net Asset Value of the Shares held by
any Shareholder in any Sub-Fund or Class of Shares would fall below such minimum number or value as determined by
the Board of Directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the
full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class or Sub-Fund.
10.4 The Shares which have been converted into Shares of another Sub-Fund or of another Share Class within the
same Sub-Fund may be cancelled.
Art. 11. Restrictions on Ownership of Shares.
11.1 The Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate
body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of
any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become subject to
laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws).
11.2 Specifically, but without limitation, the Company may restrict the ownership of Shares in the Company by any
U.S. Person or any Designated Person, and for such purposes the Company may:
11.2.1. decline to issue any Shares and decline to register any transfer of Shares, where it appears to it that such
registration or transfer would or might result in the legal or beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person or by
any Designated Person; and
11.2.2. at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of
Shares on the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider
necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a
U.S. Person or any Designated Person, or whether such entry in the register will result in the beneficial ownership of
such Shares by a U.S. Person or any Designated Person; and
11.2.3. decline to accept the vote of any U.S. Person or any Designated Person at any meeting of Shareholders of the
Company.
11.3 Where it appears to the Company that (i) any U.S. Person or any Designated Person either alone or in conjunction
with any other person is a beneficial owner of Shares or that (ii) the aggregate Net Asset Value of Shares or the number
of Shares held by a Shareholder falls below such value or number of Shares respectively as determined by the Board of
Directors of the Company, or (iii) where in exceptional circumstances the Board of Directors determines that a com-
pulsory redemption is in the interest of the other Shareholders, the Company may compulsorily redeem or cause to be
redeemed from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:
11.3.1 The Company shall serve a notice (the "purchase notice") upon the Shareholder holding such Shares or appearing
in the register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased, the
manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
11.3.2 Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said Share-
140311
L
U X E M B O U R G
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if any)
representing the Shares specified in the purchase notice.
11.3.3 Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such Shareholder shall cease
to be the owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the register of Shareholders.
11.3.4 The price at which each such Share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the
Net Asset Value per Share of the relevant Class as of the Valuation Day next succeeding the date of the purchase notice
or next succeeding the surrender of the Share certificate or certificates (if any) representing the Shares specified in such
notice, all as determined by the Board of Directors, less any service charge provided therein.
11.3.5 Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares normally in the
currency set by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the Shares of the relevant Class and
will be (i) deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere; or (ii) paid
by a check sent to the last known address on the Company's books (as specified in the purchase notice) upon final
determination of the purchase price following surrender of the Share certificate or certificates (if any) specified in such
notice and unmatured dividend coupons attached thereto.
11.3.6 Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Shares
or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase
price (without interest) from such bank following effective surrender of the Share certificate or certificates (if any) as
aforesaid. Any funds receivable by a Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years
from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund relating
to the relevant Class or Classes of Shares. The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps
necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.
11.3.7 The exercise by the Company of the power conferred by Article 11 hereof shall not be questioned or invalidated
in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true
ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in
such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
Art. 12. Calculation of the Net Asset Value per Share.
12.1 The Net Asset Value per Share of each Sub-Fund or Class of Shares as the case may be shall be expressed in the
reference currency (as defined in the Prospectus) of the relevant Sub-Fund or Class of Shares concerned and shall be
determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each Sub-Fund, being the
value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Sub-Fund, as of any such Valuation Day,
by the total number of Shares in the relevant Sub-Fund then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth
below. The Net Asset Value per Share may be rounded up or down to the third decimal or such number of decimal
places as the Board of Directors shall determine. If, since the time of determination of the Net Asset Value, there has
been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to
a Sub-Fund are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the
Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation. In such a case, instructions for subscription, re-
demption or conversion of Shares shall be executed on the basis of the second valuation.
On any Valuation Day, the Board of Directors may determine to apply an alternative Net Asset Value calculation
method to the Net Asset Value per Share, to include such reasonable factors as they see fit (swing pricing). This method
of valuation is intended to pass the estimated costs of underlying investment activity of the Company to the active
Shareholders by adjusting the Net Asset Value of the relevant Share and thus to protect the Company's long-term
Shareholders from costs associated with ongoing subscription and redemption activity. This alternative Net Asset Value
calculation method may take account of trading spreads on the Company's investments, the value of any duties and charges
incurred as a result of trading and may include an allowance for market impact. Where the Board of Directors, based on
the prevailing market conditions and the level of subscriptions or redemptions requested by Shareholders or potential
Shareholders in relation to the size of the relevant Sub-Fund, has determined for a particular Sub-Fund to apply an
alternative Net Asset Value calculation method, the Sub-Fund may be valued either on a bid or offer basis (which would
include the factors referenced in the present paragraph).
12.2 The valuation of the Net Asset Value of each Sub-Fund shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants, options and other securities, financial instruments, and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
140312
L
U X E M B O U R G
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset;
6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The valuation of assets of each Sub-Fund of the Company shall be calculated in the following manner:
(a) The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after
making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
(b) The value of assets which are listed or dealt in on any stock exchange is based on the last available price on the
stock exchange which is normally the principal market for such assets.
(c) The value of assets dealt in on any other Regulated Market (as defined in Article 5 thereof) is based on the last
available price.
(d) In the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or
if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or other Regulated Market as aforesaid, the price as
determined pursuant to sub-paragraph (b) or (c) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the
value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
(e) The liquidating value of options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their
net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors, on a basis consistently
applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on
exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on
exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Com-
pany; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which
net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the
Board of Directors may deem fair and reasonable.
(f) The value of Money Market Instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market
and with remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof,
increased by any interest accrued thereon. Money Market Instruments with a remaining maturity of 90 days or less will
be valued by the amortized cost method, which approximates market value.
(g) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rate
curve.
(h) Units or shares of open-ended UCI will be valued at their last determined and available net asset value or, if such
price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the Board of
Directors on a fair and equitable basis. Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock
market value.
(i) All other securities and other assets will be valued at fair market value, as determined in good faith pursuant to
procedures established by the Board of Directors or a committee appointed to that effect by the Board of Directors.
The Board of Directors may adjust the value of any investment if having regard to its currency, marketability, applicable
interest rates, anticipated rates of dividend, maturity, liquidity or any other relevant consideration, they consider that
such adjustment is required to reflect the fair value thereof.
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the
reference currency of such Sub-Fund at the rate of exchange ruling in Luxembourg on the relevant Valuation Day. If such
quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established
by the Board of Directors.
Where the value of any investment is not ascertainable as described above, the value shall be the probable realisation
value estimated by the Board of Directors with care and in good faith or by a competent person.
To the extent that the Board of Directors considers that it is in the best interests of the Company, given the prevailing
market conditions and the level of subscriptions or redemptions requested by Shareholders in relation to the size of any
Sub-Fund, an adjustment, as determined by the Board of Directors at its discretion, may be reflected in the Net Asset
Value of the Sub-Fund for such sum as may represent the percentage estimate of costs and expenses which may be
incurred by the relevant Sub-Fund under such conditions.
The Board of Directors may, in its discretion, permit any other method of valuation to be used if it considers that
such method of valuation better reflects the fair value of any asset of the Company generally or in particular markets or
market conditions and is in accordance with the good practice.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
140313
L
U X E M B O U R G
3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive fees, cus-
todian fees, and corporate agents' fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company ;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the Board of Directors, as well as
such amount (if any) as the Board of Directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent
liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the
Company.
In determining the amount of such other liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise promotion, printing, formation expenses, fees payable to its investment manager or
adviser, including performance fees, fees and expenses payable to its auditors and accountants, Depositary and its cor-
respondents, domiciliary and corporate agent, registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any permanent
representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration of the
directors (if any) and their reasonable out-ofpocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in
connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and expenses involved in
registering and maintaining the registration of the Company with any governmental agencies or stock exchanges in the
Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing,
translating, printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, Company documentation, pe-
riodical reports or registration statements, and the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental
and similar charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges
and brokerage, postage, telephone, facsimile and other electronic means of communication.
The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure
for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund or Class will be converted
into the reference currency of such Sub-Fund or Class at the rate of exchange determined as of the relevant Valuation
Day in good faith by or under procedures established by the Board of Directors.
The Board of Directors, in its absolute discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers
that such valuation better reflects the fair value of any asset and / or liability of the Company.
III. The assets shall be allocated as follows:
The Board of Directors shall establish a Sub-Fund in respect of each Class of Shares and may establish a Sub-Fund in
respect of two or more Classes of Shares in the following manner:
a) if two or more Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such Classes shall be commonly
invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned. Within a Sub-Fund, Classes of Shares may
be defined from time to time by the Board of Directors so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such as
entitling to distributions ("distribution Shares") or not entitling to distributions ("capitalisation Shares"); and/or (ii) a
specific sales and redemption charge structure; and/or (iii) a specific management or advisory fee structure; and/or (iv) a
specific assignment of distribution, Shareholder services or other fees; and/or (v) a specific currency; and/or (vi) a specific
type of investor; and/or (vii) the use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency of the
relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term mo-
vements of their currency of quotation; and/or (viii) any other specific features applicable to one Class of Shares. The
Board of Directors may, at its discretion, decide to change the characteristics of any Class as described in the Prospectus
in accordance with the procedures determined by the Board of Directors from time to time;
b) the proceeds to be received from the issue of Shares of a Class shall be applied in the books of the Company to
the Sub-Fund corresponding to that Class of Shares, provided that if several Classes of Shares are outstanding in such
Sub-Fund, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the Class
of Shares to be issued;
c) the assets and liabilities and the income and expenditure applied to a Sub-Fund shall be attributable to the Class or
Classes of Shares corresponding to such Sub-Fund;
d) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company
to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease
in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
e) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in
connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;
f) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the Net Asset Value of the relevant
Classes of Shares or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith. Each Sub-Fund
shall only be responsible for the liabilities which are attributable to such Sub-Fund; and
140314
L
U X E M B O U R G
g) upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the Net Asset Value of such Class of Shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of fraud, bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value
taken by the Board of Directors or by any bank, company or other organisation which the Board of Directors may appoint
for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
Shareholders, subject to Article 12.1 hereof.
IV. For the purpose of this Article:
1) Shares of the Company to be redeemed under Article 9 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board of Directors as of the Valuation Day on which such redemption
is made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the
Company;
2) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of
Directors as of the Valuation Day on which such issue is made and from such time and until received by the Company.
The price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the
relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the rates of exchange as determined by the Board of Directors
for determination of the Net Asset Value of Shares; and
4) where as of any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known as of such
Valuation Day, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 13. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Conversion of Shares.
13.1 With respect to each Sub-Fund or Class of Shares, the Net Asset Value per Share and the price for the issue,
redemption and conversion of Shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the Board of Directors and determined
in the Prospectus, such date or time of determination being the Valuation Day.
13.2 The Company may suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any particular Sub-Fund and
the issue and redemption of its Shares to and from its Shareholders as well as the conversion from and to Shares of each
Sub-Fund:
13.2.1 during the whole or part of any period (other than for ordinary holidays or customary weekends) when any of
the Regulated Markets on which the Company's investments are quoted, listed, traded or dealt are closed or during which
dealings therein are restricted or suspended or trading is suspended or restricted; or
13.2.2 during the whole or part of any period when circumstances outside the control of the Directors exist as a result
of which any disposal or valuation by the Company of investments of the Sub-Fund is not reasonably practicable or would
be detrimental to the interests of Shareholders or it is not possible to transfer monies involved in the acquisition or
disposition of investments to or from the relevant account of the Company; or
13.2.3 during the whole or part of any period when any breakdown occurs in the means of communication network
normally employed in determining the price or value of any of any of the Company's investments of the relevant Sub-
Fund; or
13.2.4 during the whole or any part of any period when for any other reason the price or value of any of the Company's
investments cannot be reasonably, promptly or accurately ascertained; or
13.2.5 during the whole or any part of any period when subscription proceeds cannot be transmitted to or from the
account of the Company or the Sub-Fund being unable to repatriate funds required for making redemption payments or
when such payments cannot, in the opinion of the Directors, be carried out at normal rates of exchange; or
13.2.6 following a possible decision to merge, liquidate or dissolve the Company or, if applicable, one or several Sub-
Funds; or
13.2.7 following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, the redemption and/
or the conversion of the shares/units issued within a master fund in which the Sub-Fund invests in its quality as a feeder
fund of such master fund;
13.2.8 if any other reason makes it impossible or impracticable to determine the value of a portion of the investments
of the Company or any Sub-Fund; or
140315
L
U X E M B O U R G
13.2.9 if, in exceptional circumstances, the Directors determine that suspension of the determination of Net Asset
Value is in the interest of Shareholders (or Shareholders in that Sub-Fund as appropriate).
13.2.10 during a period where the relevant indices underlying the derivative instruments which may be entered into
by the Sub-Funds of the Company are not compiled or published; or
13.2.11 during any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company, in particular
the derivative instruments and repurchase transactions which may be entered into by the Company in respect of any
Sub-Fund, cannot promptly or accurately be ascertained.
13.3 Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and may be notified to Shareholders
having made an application for subscription, redemption or conversion of Shares for which the calculation of the Net
Asset Value has been suspended.
13.4 Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share, the
issue, redemption and conversion of Shares of any other Sub-Fund if the assets within such other Sub-Fund are not affected
to the same extent by the same circumstances.
13.5 Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension
of the calculation of the Net Asset Value per Share.
Title III. Administration and Supervision
Art. 14. Board of Directors.
14.1 The Company shall be managed by the Board of Directors composed of not less than three members, who need
not be Shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. They may be re-elected.
The Directors shall be elected by the Shareholders at a general meeting of Shareholders; in particular by the Shareholders
at their annual general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors
are elected and qualified, provided however that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at
any time by resolution adopted by the Shareholders. The general meeting of Shareholders shall also determine the number
of Directors, their remuneration and the term of their office.
14.2 In the event an elected Director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be desi-
gnated as member of the Board of Directors. Such individual is submitted to the same obligations than the other Directors.
Such individual may only be revoked upon appointment of a replacement individual.
14.3 Directors shall be elected by the majority of the votes of the Shares validly cast and shall be subject to the approval
of the Luxembourg regulatory authorities.
14.4 Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the
general meeting.
14.5 In the event of a vacancy in the office of Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy. The
Shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 15. Board Meetings.
15.1 The Board of Directors shall choose from among its members a chairman and may choose one or more vice-
chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary (who need not be a Director) who shall write and keep
the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the Shareholders. Either the chairman or any two Directors
may at any time summon a meeting of the Directors by notice in writing to every Director which notice shall set forth
the general nature of the business to be considered and the place at which the meeting is to be convened.
15.2 Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours
prior to the date set for such meeting, except in circumstances of an emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by mail, e-mail,
facsimile or any other similar means of communication, or when all Directors are present or represented at the meeting.
Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of
Directors.
15.3 The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the Shareholders. In his absence, the Share-
holders or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in the case of a Shareholders' meeting,
that any other person shall be in the chair of such meetings.
15.4 The Board of Directors may from time to time and at any time by powers of attorney appoint any company, firm,
person or body of persons, with full power of substitution, to be the attorney or attorneys of the Company for such
purpose and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Board
of Directors under these Articles) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such
powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such
attorneys as the Board of Directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the
powers, authorities and discretions vested in him.
15.5 Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by mail, e-mail or facsimile or any other similar
means of communication another Director as his proxy. A Director may represent several of his colleagues.
140316
L
U X E M B O U R G
15.6 The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind
the Company by their individual signatures, except if specifically authorised thereto by resolution of the Board of Direc-
tors.
15.7 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors are present or
represented.
15.8 Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies
of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed where they are
signed by the chairman of the meeting or any two Directors.
15.9 Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any meeting
the numbers of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
15.10 Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at
the Board of Directors' meetings. Each Director shall approve such resolution in writing, by mail, facsimile or any other
similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that
proves that such decision has been taken.
15.11 Members of the Board of Directors or of any committee thereof may participate in a meeting of the Board of
Directors or of such committee by means of conference telephone, videoconference, or similar communications equip-
ment by means of which all persons participating in the meeting can hear each other and participation in a meeting pursuant
to this provision shall constitute presence in person at such meeting.
Art. 16. Powers of the Board of Directors.
16.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration
within the Company's purpose, in compliance with the investment policies as determined in Article 19 hereof.
16.2 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of
Shareholders are in the competence of the Board of Directors.
Art. 17. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
Directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority
has been delegated by the Board of Directors.
Art. 18. Delegation of Powers.
18.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
(including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of
the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members
of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board
of Directors so authorises, sub-delegate their powers.
18.2 In particular, the Company may enter into an investment management agreement with an investment manager
(the "Investment Manager") or an investment advisory agreement with an investment adviser (the "Investment
Adviser"),pursuant to which the Investment Manager, the Investment Adviser or any other company first approved by it
will supply the Company with recommendations and advice with respect to the Company's investment policy pursuant
to Article 19 hereof and pursuant to which the Investment Manager may, on a day-to-day basis and subject to the overall
control and responsibility of the board of directors of the Company, have actual discretion to purchase and sell securities
and other assets of the Company pursuant to the terms of a written agreement. Subject to the approval of the Board of
Directors of the Company, the Investment Manager may delegate its powers to third parties at its own cost.
18.3 The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 19. Investment Policies and Restrictions.
19.1 The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment
policies and strategies to be applied in respect of each Sub-Fund and the course of conduct of the management and
business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with
applicable laws and regulations.
19.2 Within those restrictions, the Board of Directors may decide that investments be made in:
a) Transferable Securities or Money Market Instruments;
b) shares or units of other UCI, including shares or units of a master fund qualified as a UCITS; c) deposits with credit
institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are maturing in no more than
twelve (12) months;
d) financial derivative instruments;
e) Shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company, under the conditions provided for by the UCI
Law.
19.3 The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities
recognized by the Luxembourg supervisory authority.
140317
L
U X E M B O U R G
19.4 The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any Regulated Market of a state of
Europe, being or not a Member State, a state of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.
19.5 The Company may also invest in recently issued Transferable Securities and Money Market Instruments, provided
that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated
Market and that such admission be secured within one year of issue.
19.6 In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net
assets attributable to each Sub-Fund in Transferable Securities or Money Market Instruments issued or guaranteed by an
EU member state, its local authorities, another member state of the OECD, such non-member state(s) of the OECD as
set out in the Prospectus, or public international bodies of which one or more member states of the EU are members
being provided that if the Company uses the possibility described above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund,
securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one issue can not exceed 30% of the total
net assets attributable to that Sub-Fund.
19.7 The Board of Directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the
Prospectus, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis
with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their sub-funds;
or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds of the Company be co-managed amongst themselves on a
segregated or on a pooled basis.
19.8 Investments of each Sub-Fund of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned
subsidiaries, as the Board of Directors may from time to time decide and as described in the Prospectus. Reference in
these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially
held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.
19.9 The Company is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to Transferable Securities and
Money Market Instruments provided that such techniques and instruments may be used for hedging purposes, for the
purpose of efficient portfolio management or for investment purposes and (ii) to employ techniques and instruments
intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.
Art. 20. Conflict of Interest.
20.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Board of Directors or officers of the Company is interested in, or is
a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who
serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
20.2 In the event that any Director or officer of the Company may have an interest in any transaction of the Company
which conflicts with the interests of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors
such conflict of interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's
or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of Shareholders.
20.3 Such conflict of interest as referred to in this Article, shall not include any relationship with or without interest
in any matter, position or transaction involving any affiliated or associated company of the Investment Manager, or such
other person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.
Art. 21. Indemnification of Directors. Every Director, agent, auditor, or officer of the Company and his personal
representatives shall be indemnified and secured harmless out of the assets of the relevant Sub-Fund(s) against all actions,
proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities (“Losses”) incurred or sustained by him in or about
the conduct of the Company business or affairs or in the execution or discharge of his duties, powers, authorities or
discretions, including Losses incurred by him in defending (whether successfully or otherwise) any civil proceedings con-
cerning the Company in any court whether in Luxembourg or elsewhere. No such person shall be liable (i) for the acts,
receipts, neglects, defaults or omissions of any other such person or (ii) by reason of his having joined in any receipt for
money not received by him personally or (iii) for any loss on account of defect of title to any property of the Company
or (iv) on account of the insufficiency of any security in or upon which any money of the Company shall be invested or
(v) for any loss incurred through any bank, broker or other agent or (vi) for any loss, damage or misfortune whatsoever
which may happen in or arise from the execution or discharge of the duties, powers, authorities, or discretions of his
office or in relation thereto, unless the same shall happen through his own gross negligence or wilful misconduct against
the Company.
Art. 22. Auditors.
22.1 The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an authorised auditor
("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.
22.2 The auditor shall fulfil all duties prescribed by the UCI Law.
140318
L
U X E M B O U R G
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 23. General Meetings of Shareholders of the Company.
23.1 The general meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the
Company. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Class of Shares held by them. It shall
have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
23.2 The general meeting of Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.
23.3 It may also be called upon the request of Shareholders representing at least one tenth of the share capital of the
Company.
23.4 The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law in Luxembourg-City at a place
specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of the month of May at 11.00 a.m. (Luxembourg time).
23.5 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
Business Day.
23.6 Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
23.7 The Board of Directors may convene a general meeting of Shareholders pursuant to a notice setting forth the
agenda published to the extent and in the manner required by Luxembourg law and/or sent at least eight (8) days prior
to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders or at such
other address indicated by the relevant Shareholder. No evidence of the giving of such notice to registered Shareholders
is required by the meeting. The agenda shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the
meeting is called on the written demand of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a
supplementary agenda.
Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items
to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company
by registered mail five days at the latest before the relevant meeting.
If bearer Shares are issued, the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the
Board of Directors may decide.
23.8 If all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to Shareholders may be mailed by
registered mail only.
23.9 If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of
the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The holders of bearer Shares are obliged, in order to be admitted to the general meetings, to deposit their Share
certificates with an institution specified in the convening notice at least five days prior to the date of the meeting.
23.10 The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to
attend any meeting of Shareholders.
23.11 The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the
agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
23.12 Each Share of whatever Class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A
Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by mail or by
facsimile transmission, who need not be a Shareholder and who may be a Director.
23.13 Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders are passed by
a simple majority vote of the Shareholders validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and
nihil vote shall not be taken into account.
23.14 Each Shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail,
facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the
convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place,
date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well
as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each
proposed resolution by ticking the appropriate box.
23.15 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into
account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.
Art. 24. General Meetings of Shareholders of Sub-Funds or of Classes of Shares.
24.1 The Shareholders of the Class or Classes issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings
to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund.
24.2 In addition, the Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings to decide on any
matters which relate exclusively to such Class.
140319
L
U X E M B O U R G
24.3 The provisions of Article 23, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 shall apply to such general meetings
of Shareholders.
24.4 Each Share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act
either in person or by giving a proxy in writing, by mail or by facsimile transmission to another person who need not be
a Shareholder and may be a Director.
24.5 Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of Shareholders of a Sub-Fund
or of a Class are passed by a simple majority of the validly cast votes.
Art. 25. Closure of Sub-Funds and/or Classes.
25.1 In the event that for any reason the value of the assets in any Sub-Fund or Class has decreased to an amount
determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund or Class to be operated in an econo-
mically efficient manner, or if a change in the economical, political or monetary situation relating to the Sub-Fund or Class
concerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund or if the range of products
offered to investors is rationalised, the Board of Directors may decide to compulsorily redeem all the Shares of the
relevant Class or Classes issued in such Sub-Fund or the relevant Class at the Net Asset Value per Share (taking into
account actual realisation prices of investments and realisation expenses), determined as of the Valuation Day at which
such decision shall take effect and therefore close the relevant Sub-Fund or Class. The Company shall serve a notice to
the Shareholders of the relevant Class(es) or Sub-Fund(s) prior to the effective date for the compulsory redemption,
which will indicate the reasons for, and the procedure of, the redemption operations. Unless it is otherwise decided in
the interests of, or to keep equal treatment between, the Shareholders, the Shareholders of the Sub-Fund or Class
concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares free of charge (but taking into account
actual realisation prices of investments and realisation expenses) prior to the effective date of the compulsory redemption.
25.2 Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by paragraph 25.1 of this Article, the general
meeting of Shareholders of any Sub-Fund or Class within any Sub-Fund may, upon a proposal from the Board of Directors,
redeem all the Shares of the relevant Class within the relevant Sub-Fund and refund to the Shareholders the Net Asset
Value of their Shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) determined
as of the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general
meeting of Shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and
voting.
25.3 Assets which may not be distributed to the relevant beneficiaries upon the implementation of the redemption
will be deposited with the Depositary for the period required by Luxembourg law; after such period, the assets will be
deposited with the “Caisse de Consignation” on behalf of the persons entitled thereto.
25.4 All redeemed Shares may be cancelled.
25.5 The liquidation of the last remaining Sub-Fund of the Company will result in the liquidation of the Company under
the conditions of the UCI Law.
Art. 26. Mergers.
26.1 Mergers decided by the Board of Directors
The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the UCI Law) of the Company
or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and procedures
imposed by the UCI Law, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the Share-
holders, as follows:
26.1.1. Company
The Board of Directors may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS,
with:
- another Luxembourg or foreign UCITS (the “New UCITS”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Company concerned as Shares of this New UCITS, or of the
relevant sub-fund thereof as applicable.
In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the UCI Law), solely the
Board of Directors will decide on the merger and effective date thereof.
In the case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the UCI Law), and hence
ceases to exist, the general meeting of the Shareholders has to approve, and decide on the effective date of such merger
by a resolution adopted with (a) a presence quorum requirement of at least 50% of the share capital of the Company;
and (b) a majority requirement of at least two-third (2/3) of the shareholders present or represented.
26.1.2. Sub-Funds
The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the UCI Law) of any Sub-Fund,
either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the “New Sub-Fund”); or
140320
L
U X E M B O U R G
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Sub-Fund concerned as Shares of the New UCITS, or of the New
Sub-Fund as applicable.
26.2. Mergers decided by the Shareholders
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors under the preceding section, the general meeting
of Shareholders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the UCI Law) of the Company or of one
of the SubFunds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and procedures imposed
by the UCI Law, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the Shareholders, as
follows:
26.2.1. Company
The general meeting of the Shareholders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the UCI Law)
of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:
- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof.
The decision shall be adopted by a general meeting of the Shareholders for which there shall be (a) a presence quorum
requirement of at least 50% of the share capital of the Company; and (b) a majority requirement of at least two-third
(2/3) of the shareholders present or represented.
26.2.2. Sub-Funds
The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the UCI Law)
of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund
by a resolution adopted with (a) a presence quorum requirement of at least 50% of the share capital of the Company;
and (b) a majority requirement of at least two-third (2/3) of the shareholders present or represented.
26.3. General
Shareholders will in any case be entitled to request, without any charge other than those retained by the Company
or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their Shares, or, where possible, to
convert them into units or shares of another UCITS pursuing a similar investment policy and managed by a company with
which the Company is linked by common management or control, or by substantial direct or indirect holding, in accor-
dance with the provisions of the UCI Law.
Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged to the Company
nor its Shareholders.
Art. 27. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Distributions.
28.1 The general meeting of Shareholders of the Class or Classes issued in respect of any Sub-Fund shall, upon proposal
from the Board of Directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Sub-Fund shall be
disposed of, and may from time to time declare, or authorise the Board of Directors to declare, distributions.
28.2 For any Class or Classes of Shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim
dividends in the frequency and amounts determined by the Board of Directors in compliance with the conditions set
forth by law.
28.3 Payments of distributions to holders of registered Shares shall be made to such Shareholders at their addresses
in the register of Shareholders. Payments of distributions to any holders of bearer Shares shall be made upon presentation
of the dividend coupon to the agent or agents therefore designated by the Company.
28.4 Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall in its
discretion determine from time to time.
28.5. For each Sub-Fund or Class of Shares, the Board of Directors may decide on the payment of interim dividends
in compliance with legal requirements.
28.6 The Board of Directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and
conditions as may be set forth by the Board of Directors.
28.7 Any distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to
the Sub-Fund relating to the relevant Class or Classes of Shares.
28.8 No interest shall be payable by the Company on a dividend which has not been claimed by a Shareholder.
140321
L
U X E M B O U R G
Title V. Final provisions
Art. 29. Depositary.
29.1 To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or savings
institution - a depositary (the “Depositary”) as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector.
29.2 The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the UCI Law.
29.3 If the Depositary wishes to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor
Depositary within two (2) months of the effectiveness of such retirement. The Board of Directors may terminate the
appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary shall have
been appointed to act in the place thereof.
Art. 30. Dissolution of the Company.
30.1 The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders subject to the
quorum and majority requirements referred to in Article 32 hereof.
30.2 Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 6 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of Shareholders by the Board of Directors.
The general meeting of Shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the validly
cast votes.
30.3 The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of Shareholders
whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital set by Article 6 hereof; in such an event, the
general meeting of Shareholders shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by
Shareholders holding one quarter of the votes of the Shares represented and validly cast at the meeting.
30.4 The general meeting of Shareholders must be convened so that it is held within a period of forty days from
ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one quarter of the legal minimum, as
the case may be.
Art. 31. Liquidation of the Company.
31.1 Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities,
appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compensation.
31.2 Should the Company be voluntarily or compulsorily liquidated, its liquidation will be carried out in accordance
with the provisions of the UCI Law. Such law specifies the steps to be taken to enable the Shareholders to participate in
the distribution(s) of the liquidation proceeds and provides for a deposit in escrow at the Caisse de Consignation at the
time of the close of the liquidation. Liquidation proceeds available for distribution to Shareholders in the course of the
liquidation that are not claimed by Shareholders at the close of the liquidation be deposited at the Caisse de Consignation
in Luxembourg, where for a period of 30 years they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto.
Art. 32. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by a general
meeting of Shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended from time to time.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time and the UCI Law, as amended
from time to time.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting acknowledges the resignations of Mr. Corrado Capacci as member of the Board of Directors of
the Company with effect to June 30, 2011 and the resignations of Mr. Enzo Tricerri and Mr. Alessandro Mangione, as
members of the Board of Directors of the Company, with effect to November 10, 2011.
The general meeting ratify the decision of the board of directors to co-opt Mr. Lamberto CONTE, born in Roma
(Italy), on March 25, 1967, with professional address in Via San Gottardo, 61 - CH-6900 Lugano (Switzerland) as Director
of the Company as of June 23, 2011.
The general meeting resolves to appoint as new members of the Company's Board of Directors with effect to No-
vember 10, 2011:
- Mr. Gabriele SPROCATI, born in Ferrary (Italy), on March 30, 1954, with professional address in 6, boulevard Joseph
II, L-1840 Luxembourg.
- Mr. Alberto CAVADINI, born in Como (Italy), on October 4, 1969, with professional address in 6, boulevard Joseph
II, L-1840 Luxembourg.
The appointment of Mr. Lamberto CONTE, Mr. Gabriele SPROCATI and Mr Alberto CAVADINI shall expire at the
close of the annual general meeting of shareholders which shall deliberate on the annual accounts of the Company as at
31 December 2011.
140322
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to delete the French translation of the Articles of Incorporation, in accordance with
article 26 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: C. LEROY, S. DEL ROSSO, L. CHIAPPALONE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50689. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 novembre 2011.
Référence de publication: 2011158849/975.
(110185267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2011.
Société d'Industrie Mécanique S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 150.340.
Ourakan International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 83.990.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille onze, le quinze novembre.
Pardevant Maître Joelle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de sa consoeur dûment em-
pêchée, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle dernière restera dépositaire du présent
acte.
A comparu:
M. Ferdinando CAVALLI, employé privé, demeurant professionnellement 7 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lu-
xembourg
agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée Société d'Industrie Mécanique S.A, avec siège social à Luxembourg, 4 rue Jean-Pierre Probst, inscrite au R.C.S.
Luxembourg sous la section B et le numéro 150340
constituée par acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
décembre 2009,
publié au Mémorial C 201 du 30 janvier 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même
notaire en date du 17 mars 2010, publié au Mémorial c n° 986 du 11 mai 2010,
avec un capital social actuel de EUR 3.050.000 (trois millions cinquante mille euros), représenté par 305.000 (trois
cent cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,
M. Ferdinando CAVALLI, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en
date du 10 novembre 2011
dénommée ci-après «la société absorbante», d'une part.
ET,
M. Ferdinando CAVALLI, employé privé, demeurant professionnellement 7 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lu-
xembourg
en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée
Ourakan International S.A. avec siège social à Luxembourg, 38 rue de la Faïancerie, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous
la section B et le numéro 83990 constituée par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg Ville, en date
du 28 septembre 2001, publié au Mémorial c n° 260 du 15 février 2002,
et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 13 décembre 2001, publié
au Mémorial c n° 584 du 15 avril 2002,
140323
L
U X E M B O U R G
avec un capital social actuel de EUR 746.000 (sept cent quarante-six mille euros), représenté par 74.600 (soixante-
quatorze mille six cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) par action, toutes entièrement souscrites
et libérées,
M. Ferdinando CAVALLI, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en
date du 10 novembre 2011
dénommée ci-après «la société absorbée», d'autre part,
ces deux sociétés, soumises à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,
Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:
PROJET DE FUSION
1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée Société d'Industrie Mécanique S.A, avec siège social à
Luxembourg, 4 rue Jean-Pierre Probst, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 150340
constituée par acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
décembre 2009,
publié au Mémorial C 201 du 30 janvier 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même
notaire en date du 17 mars 2010, publié au Mémorial c n° 986 du 11 mai 2010,
avec un capital social actuel de EUR 3.050.000 (trois millions cinquante mille euros), représenté par 305.000 (trois
cent cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,
détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme de droit luxem-
bourgeois Ourakan International S.A., et s'élèvant à EUR 746.000 (sept cent quarante-six mille euros), représenté par
74.600 (soixante-quatorze mille six cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, toutes entiè-
rement souscrites et libérées et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois Ourakan
International S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 38 rue de la Faïancerie, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la
section B et le numéro 83990, constituée par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg Ville, en date
du 28 septembre 2001, publié au Mémorial c n° 260 du 15 février 2002, et les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par acte du même notaire en date du 13 décembre 2001, publié au Mémorial c n° 584 du 15 avril 2002, avec un capital
social actuel de EUR 746.000 (sept cent quarante-six mille euros), représenté par 74.600 (soixante-quatorze mille six
cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) par action, toutes entièrement souscrites et libérées,
aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées
(encore appelées sociétés fusionnantes).
1) La société anonyme «Société d'Industrie Mécanique S.A.» (encore appelée la société absorbante) entend fusionner
conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les
textes subséquentes, avec la société anonyme «Ourakan International S.A.» (encore appelée la société absorbée) par
absorption de cette dernière.
2) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au premier janvier 2012.
3) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.
4) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
5) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour-cent) des actions du
capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.
7) A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,
comme indiqué ci-avant au point 4) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
8) Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les
déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des
apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
9) La présente opération est réalisée en parfaite neutralité fiscale.
10) Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
11) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
<i>Formalitési>
La société absorbante:
140324
L
U X E M B O U R G
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
<i>Remise de titresi>
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie....), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs
aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et Droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour
toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 278 de la loi sur les sociétés.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en une langue d'eux connue, les comparants, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Cavalli et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50671. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce. Luxembourg, le 21 novembre 2011.
Signé par Maître Joseph ELVINGER, Notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d'un mandat verbal en
remplacement de sa collègue Maître Martine Schaeffer, Notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2011159979/128.
(110185659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Luxembourg CFA Society, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7317 Steinsel, 14A, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg F 7.
L'assemblée générale a approuvé les modifications de statuts suivantes:
1.1. Dénomination. Le nom de l'association est «Luxembourg CFA Society» (ci-après dénommé «Society»).
1.2. Siège. Le siège principal de la Society est localisé à l'adresse du secrétaire: 14A Rue Paul Eyschen, 7317 Steinsel
3.3. Membre affilié. Afin de devenir membre affilié de l'association, le professionnel doit:
(a) se soumettre et signer le «Member's Agreement» et le «Professional Conduct Statement"; et
(b) remplir toutes les autres conditions que l'association peut imposer et qui sont en accord avec les conditions établies
par CFA Institute
140325
L
U X E M B O U R G
8.3. Cotisations. Le comité peut fixer et changer le montant des cotisations annuelles de l'association dans les devises
USD ou EUR. Pour les membres réguliers et affiliés, les cotisations se comprennent en supplément à celles de CFA
Institute. Le Comité fixe le niveau des cotisations et leur classification par type de membre.
Philippe Bernard.
Référence de publication: 2011161327/18.
(050077670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.
Luxembourg Hydro Power, Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 156.923.
L'an deux mil onze, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Luxembourg Hydro Power», avec siège
social à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2010, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2864 du 30 décembre 2010,
statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange agissant en rem-
placement du notaire instrumentant, en date du 29 juillet 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2368 du 4 octobre 2011,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 156923.
L'assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg. La Présidente élit Mademoiselle Estelle
MATERA, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, comme se-
crétaire.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Delphine GOERGEN, employée privée, demeurant professionnelle-
ment 10, rue Pierre d'Aspelt, L1142 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du conseil d'administration de la Société sur le projet de fusion impliquant la Société en tant que société
absorbante et Financière Saint Merri S.A. en tant que société absorbée (la «Fusion») et approbation du projet commun
de Fusion.
2.- Décision d'augmentation du capital social à concurrence d'une somme de 2.054.828 EUR avec émission de 1.027.414
actions de 2 EUR chacune dont 765.000 actions de catégorie A et 262.414 actions de catégorie B suivie d'une réduction
du capital social à concurrence d'une somme de 31.000 EUR par voie d'annulation des 15.500 actions apportées par la
société absorbée dans le cadre de ladite Fusion.
3.-Modification corrélative de l'article 6 §1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital social de la
société est fixé à la somme de deux millions cinquante-quatre mille huit cent vingt-huit euros (2.054.828 EUR) représenté
par un million vingt-sept mille quatre cent quatorze (1.027.414) actions de deux euros (2 EUR) chacune dont sept cent
soixante-cinq mille (765.000) actions de catégorie A et deux cent soixante-deux mille quatre cent quatorze (262.414)
actions de catégorie B».
4.- Constatation de la réalisation définitive de la Fusion ainsi que de la dissolution de la société absorbée.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
140326
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée entend le rapport du conseil d'administration de la Société sur le projet commun de fusion transfrontalière
du 31 août 2011 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 2147 du 14 septembre 2011, entre
Financière Saint Merri SA, société anonyme de droit français, au capital de deux millions cinquante-quatre mille huit cent
vingt-huit euros (2.054.828 EUR) dont le siège social est sis au 75, boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée sous
le numéro 420 456 709 au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS, société absorbée, et Luxembourg Hydro
Power, société anonyme, au capital de 31.000 euros dont le siège social est sis au 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxem-
bourg, immatriculée sous le numéro B 156923 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, société
absorbante, en vertu duquel la société Financière Saint Merri SA sera absorbée par Luxembourg Hydro Power SA
moyennant l'apport de l'universalité du patrimoine actif et passif de Financière Saint Merri SA à Luxembourg Hydro Power
SA, sans aucune restriction ni limitation, à charge pour Luxembourg Hydro Power SA (i) d'attribuer aux actionnaires de
la société absorbée, en rémunération de cet apport, un million vingt-sept mille quatre cent quatorze (1.027.414) nouvelles
actions entièrement libérées, d'une valeur nominale de deux (2) euros chacune ayant les mêmes droits et privilèges que
les actions existantes avec application d'un rapport d'échange d'une (1) action de la société absorbée pour une (1) action
de la société absorbante, (ii) de supporter tout le passif de la société absorbée et d'exécuter tous ses engagements et
obligations, et (iii) de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion.
L'assemblée générale décide d'approuver le projet commun de fusion transfrontalière du 31 août 2011 précité en
l'état.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter dans le contexte de la Fusion le capital social de la Société à concurrence
d'une somme de deux millions cinquante-quatre mille huit cent vingt-huit euros (2.054.828 EUR) avec émission de un
million vingt-sept mille quatre cent quatorze (1.027.414) actions de deux (2) EUR chacune dont sept cent soixante-cinq
mille (765.000) actions de catégorie A et deux cent soixante deux mille quatre cent quatorze (262.414) actions de caté-
gorie B. Les actions de catégorie A seront réparties entre Monsieur Antoine Decitre, 4 Quai du Marche Neuf, F-75004
Paris (une (1) action), Monsieur Jean-Luc Rivoire, Rua Henrique Martins, 785 Jardim Paulista, Sao Paulo (Brésil) (une (1)
action), Monsieur Yves Rivoire, 8 rue Albert Thomas, Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) (une (1) action) et Saint Merri
Capital Sàrl, 11 avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, RCS Luxembourg B 158 795 (sept cent soixante quatre mille neuf
cent quatre-vingt-dix-sept (764.997) actions); les actions de catégorie B entre Crédit Agricole Private Equity, 100, bou-
levard de Montparnasse, Paris (une (1) action), Crédit Agricole Capital Investissement et Finance, 100 boulevard de
Montparnasse, Paris (deux cent un mille huit cent cinquante-sept (201.857) actions) et CL Capital Developpement I FCPR,
100 boulevard de Montparnasse, Paris (soixante mille cinq cent cinquante-six (60.556) actions).
Compte tenu du fait que suite à la Fusion, la société absorbante détient l'entièreté de ses propres actions initiales,
l'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de trente et un mille euros (31.000
EUR) par voie d'annulation des quinze mille cinq cents (15.500) actions de la Société d'une valeur nominale de deux euros
(2 EUR) chacune apportées par la société absorbée dans le cadre de la Fusion.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux décisions prises dans le cadre de la seconde résolution, l'article 6 §1 des statuts aura désormais la teneur
suivante: «Le capital social de la société est fixé à la somme de deux millions cinquante-quatre mille huit cent vingt-huit
euros (2.054.828 EUR) représenté par un million vingt-sept mille quatre cent quatorze (1.027.414) actions de deux euros
(2 EUR) chacune dont sept cent soixante-cinq mille (765.000) actions de catégorie A et deux cent soixante-deux mille
quatre cent quatorze (262.414) actions de catégorie B».
<i>Quatrième résolutioni>
La Fusion sera effective et prendra effet à l'égard des tiers après l'approbation du projet de fusion par l'Assemblée
Générale de chacune des sociétés appelées à fusionner, à la date de publication du présent procès-verbal qui sera pos-
térieure à l'accomplissement des contrôles de conformité et de légalité prévus à l'article 271 de la loi fondamentale sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée («LSC»). La radiation de la société absorbée s'effectuera
dès réception par le Registre de Commerce et des Sociétés de Paris de la notification de la prise d'effet de la Fusion par
le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
L'assemblée générale nomme Monsieur Philippe PEDRINI en sa qualité de Président Directeur Général de la Société,
comme mandataire de la Société pour exécuter les résolutions prises lors de la présente assemblée, en vue plus parti-
culièrement d'émettre et de signer la déclaration de régularité et de conformité à déposer au Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris, de réaliser le transfert à Luxembourg Hydro Power de l'universalité du patrimoine actif et passif de
la société absorbée et d'accomplir tous les actes généralement nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été clôturée à 12.45 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 1.500,- EUR.
140327
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. WAUTHIER, E. MATERA, D. GOERGEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 novembre 2011. Relation: LAC/2011/51480. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial. Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Référence de publication: 2011160475/118.
(110186701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2011.
SGG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 65.906.
SGG-FFW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 67.905.
PROJET DE FUSION
L'an deux mille onze, le vingt-deux novembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
ont comparu
1. SGG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à LUXEMBOURG (L-2086) situé au
412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
65.906 (la «Société Absorbante»),
ici représentée par Madame Johanna TENEBAY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte du conseil d'administration de la Société Absorbante,
en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de ladite société en date du 21 novembre
2011, et
2. SGG-FFW S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à LUXEMBOURG (L-2086) situé
au 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
67.905, (la «Société Absorbée»),
ici représentée par Madame Johanna TENEBAY, prénommée,
agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte du conseil d'administration de la Société Absorbée,
en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de ladite société en date du 21 novembre
2011, et
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après collectivement désignées comme les sociétés fusionnantes
(les «Sociétés Fusionnantes»).
CONSIDERANT QUE
1) la Société Absorbante détient trois mille trois cent trentre-quatre (3.334) actions, dans le capital social de la Société
Absorbée représentant l'entièreté du capital social de cette dernière;
2) les Sociétés Fusionnantes ont estimé souhaitable qu'elles procèdent à une fusion (la «Fusion») au sens de la section
XIV des fusions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés
Commerciales);
3) par effet de la Fusion, la Société Absorbante acquerra tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à titre de
transmission universelle et la Société Absorbée cessera d'exister;
4) l'exercice social de chacune des Sociétés Fusionnantes coïncide avec l'année civile;
5) les derniers comptes approuvés par chacune des Sociétés Fusionnantes concernent l'exercice 2010;
6) aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été déclarée en faillite, ne s'est vue accorder une suspension de paiements ou
n'a été dissoute;
les conseils d'administration des Sociétés Fusionnantes ont décidé d'établir le projet de fusion qui suit, conformément
aux dispositions des articles 261 et 278 de la Loi sur les Sociétés Commerciales et
ADOPTENT LE PROJET DE FUSION SUIVANT:
1. Présentation des sociétés fusionnantes.
1.1 La Société Absorbante
140328
L
U X E M B O U R G
SGG S.A. (ci-après encore désignée «Société Absorbante»), société anonyme ayant son siège social à LUXEMBOURG
(L-2086) situé au 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 65.906, constituée par acte de scission reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 31 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 800
en date du 3 novembre 1998 et modifié à plusieurs reprises, la dernière fois en date du 14 décembre 2010.
La Société a un capital de EUR 24.266.243,27 représenté par 115.889 actions sans désignation de valeur nominale.
1.2 La Société Absorbée
SGG-FFW S.A. (ci-après encore désignée «Société Absorbée»), société anonyme ayant son siège social à LUXEM-
BOURG (L-2086) situé au 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la
section B et le numéro 67.905, constituée par acte de scission reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à
Bascharage, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
195 du 23 mars 1999 et modifié à plusieurs reprises, la dernière fois en date du 11 juillet 2011.
La Société a un capital de EUR 1.250.000,00 représenté par 3.334 actions sans désignation de valeur nominale.
2. Eléments de référence sur la fusion.
2.1. Juridique
La Société Absorbante acquerra l'actif et le passif de la Société Absorbée par transmission universelle de l'ensemble
du patrimoine actif et passif suite à la fusion. Les informations financières de la Société Absorbée seront comptabilisées
dans les comptes annuels de la Société Absorbante à partir du 31 décembre 2011.
En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes les actions émises par celle-ci seront
annulées.
Les créances et dettes qui peuvent exister entre les Sociétés Fusionnantes sont annulées suite à la fusion. La fusion ne
modifie pas les relations juridiques entre les Sociétés Fusionnantes et les tiers, étant donné que celles-ci seront considérées
après la fusion comme les relations juridiques entre la Société Absorbante et ces tiers.
2.2. Motifs et Buts de la fusion
La restructuration, objet de cette fusion, aura un caractère purement interne au groupe et aura pour but de simplifier
la structure actuelle du groupe, l'actif et le passif de la Société Absorbée étant transmis à la Société Absorbante.
3. La date à laquelle les droits et Obligations de la Société Absorbée seront inclus dans les comptes de la Société
Absorbante. Le projet de fusion est basé sur les états comptables des Société Absorbante et Absorbée en date du 31
octobre 2011.
La fusion sera effective d'un point de vue comptable en date du 31 décembre 2011, date à partir de laquelle les droits
et obligations de la Société Absorbée seront considérés comptablement comme ayant été transférés à la Société Absor-
bante.
4. Date effective et effets de la fusion. La fusion sera effective entre les parties une fois que le délai d'un mois tel que
prévu à l'article 279 de la Loi sera écoulé, sous réserve de la convocation d'une assemblée générale dans les conditions
prévues au paragraphe (1) alinéa (c) du même article.
En application des dispositions de l'article 273 de la Loi, la fusion sera effective à l'égard des tiers suivant la publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations d'un certificat notarié constatant que les conditions de l'article 279
de la Loi ont été remplies.
La fusion entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 de la Loi, à savoir:
a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'en-
semble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
b) la Société Absorbée cesse d'exister;
c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.
5. Droits spéciaux et Avantages. Aucun droit spécial ne sera conféré par la Société Absorbante ni aux détenteurs
d'actions dotées de droits spéciaux, ni aux obligataires.
6. Avantages spéciaux conférés aux membres du conseil d'administration et aux experts indépendants choisis parmi
les réviseurs d'entreprises qui examinent le projet de fusion. Aucun avantage spécial ne sera conféré ni aux membres du
conseil d'administration ni aux réviseurs des Sociétés Fusionnantes.
7. Salariés. Conformément à la loi, tous les contrats de travail en vigueur à la date de la réalisation définitive de la
Fusion seront transférés à la Société Absorbante. Les informations concernant la date d'effet de la Fusion, les consé-
quences de la Fusion et les mesures envisagées concernant l'emploi après la Fusion seront communiquées aux salariés
dès que possible après la publication du présent projet de fusion.
8. Informations concernant la fusion. Conformément à la loi luxembourgeoise, ce projet de fusion doit être publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet entre les Sociétés
Fusionnantes.
140329
L
U X E M B O U R G
Au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes, les documents suivants seront à la disposition des actionnaires
de la Société Absorbante pour révision un mois avant que la fusion ne prenne effet entre parties:
a. présent projet de fusion;
b. comptes annuels et les rapports de gestion des Sociétés Fusionnantes des trois derniers exercices;
c. états comptables des Société Fusionnantes arrêtés au 31 décembre 2010;
d. rapports des organes d'administration des Sociétés Fusionnantes.
Pendant cette période, un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante disposant d'au moins 5% des actions ou
parts du capital souscrit ont le droit de requérir la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée
à se prononcer sur l'approbation de la fusion.
9. Divers. Décharge sera accordée aux administrateurs de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat pour
l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.
Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société
Absorbante.
Le notaire soussigné déclare attester de l'existence et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents
et formalités incombant aux Société Fusionnantes conformément à la Loi.
10. Pouvoirs pour les formalités. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait
des présentes pour remplir toutes formalités et effectuer toutes déclarations, significations, dépôts et publications qui
pourraient être nécessaires ou utiles.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, le mandataire des comparantes a signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: J. TENEBAY et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 novembre 2011. LAC/2011 /51952. Reçu douze euros €12,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 24 novembre 2011.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2011161440/128.
(110187868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2011.
EP Anjou 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 124.120.
EP Anjou 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 124.123.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and eleven, on the twenty fourth day of November,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared
1. Mr. Charles Kirsch, with professional address in Luxembourg acting in its capacity as attorney of the board of
managers of EP Anjou 1 S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office
at 34 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B
under n° 124120 by virtue of a power of attorney granted by the board of managers attached hereto.
2. Mr. Charles Kirsch, with professional address in Luxembourg acting in its capacity as attorney of the board of
managers of EP Anjou 2 S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office
at 34 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B
under n° 124.123, by virtue of a power of attorney granted by the board of managers attached hereto
The above companies, acting through the above mentioned attorneys have requested the notary to enact the terms
and conditions of the draft terms of merger between them, as follows.
Further to the resolutions adopted by their respective board of directors on November 24
th
, 2011, EP Anjou 1 S.à
r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 34 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n° 124.120 with a
140330
L
U X E M B O U R G
share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) represented by 500 (five hundred) shares having a par
value of EUR 25.- (twenty five euros), each fully paid up, (hereafter the "Absorbing Company"), and
EP Anjou 2 S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 34 avenue
de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°
124.123 with a share capital of EUR 273,650 (two hundred and seventy three thousand six hundred and fifty euros)
represented by 10,946 (ten thousand nine hundred and forty six) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty five
euros) per share, each fully paid up,
(hereafter the "Absorbed Company")
(the Absorbing Company and the Absorbed Company being collectively referred to as the "Merging Companies")
have decided to merge and have agreed on the following draft terms of merger (the "Merger Project"), being beforehand
underlined that:
- the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company and the merger
may thus be operated in accordance with the provisions of articles 278 and following of the law of 10
th
August, 1915 on
commercial companies, as amended (the "Law"); and
- the board of managers of the Merging Companies have resolved that the Absorbed Company shall be merged into
the Absorbing Company and for this purpose the Absorbed Company shall contribute all of its assets and liabilities (the
"Assets and Liabilities") to the Absorbing Company.
1. At the date determined by the board of managers of the Merging Companies, being September 30
th
, 2011 (the
"Effective Date"), the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company
2. The merger is based on the accounting statements of the Merging Companies drawn up as at September 30
th
,
2011 for each of the Merging Companies.
3. As a result of the completion of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue
shall be cancelled.
4. The merger shall further be subject to the following additional terms and conditions:
a) The Absorbing Company shall acquire the assets contributed by the Absorbed Company as is where is, i.e. in the
state in which they are on the Effective Date.
b) The Absorbing Company shall from the Effective Date onwards pay all taxes, including but not limited to, contri-
butions, duties, levies, insurance and other premiums annuities and royalties, whether ordinary or extraordinary, which
are due or may become due with respect to the property of the assets contributed. If necessary, the Absorbing Company
shall pay the taxes due by the Absorbed Company on the capital and the profits, for the fiscal years not yet taxed.
c) The Absorbing Company shall carry out all the agreements and obligations of any kind of the Absorbed Company
such as these agreements and obligations exist on the Effective Date.
d) The Absorbing Company shall, in particular, carry out all agreements existing on the Effective Date which include
but are not limited to, the employment contracts binding on the Absorbed Company to its staff, customers and debtors,
suppliers and creditors and it shall be subrogated to all rights and duties resulting therefrom, at its own risk.
5. For accounting purposes, the merger shall be deemed to be effective from September 30
th
, 2011 (the "Effective
Accounting Date").
6. The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) and c) of the Law (i.e. the Merger Project, the annual
accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years and the financial statements
as at September 30
th
, 2011) will be available for inspection by the shareholders at the registered office of the Merging
Companies.
7. No particular advantage is granted to the members, of the board of managers of the Merging Companies.
8. If the general meeting is not required or if the Merger Project is not rejected by the former, the merger will become
definitive, as stated above under point 1., and will lead by rights to the effects indicated in article 274 of the Law and in
particular its paragraph a).
9. The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end on the Effective date and full discharge
is hereby granted to the directors and to the statutory auditor of the Absorbed Company for the duties performed.
10. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company will be kept for the legal time period at the
registered office of the Absorbing Company.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first names,
civil status and residences, the said persons signed together with Us the notary this original deed.
140331
L
U X E M B O U R G
Suit la version en langue française:
L'an deux mille onze, le vingt quatre novembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu
1. M. Charles Kirsch, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil de
gérance de EP Anjou 1 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 124120, en vertu d'une procuration accordée par le conseil de gérance demeurée annexée aux présentes.
2. M. Charles Kirsch, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil de
gérance de EP Anjou 2 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 124123, en vertu d'une procuration accordée par le conseil de gérance demeurée annexée aux présentes.
Les sociétés mentionnées ci-dessus, agissant par leur mandataire susmentionné, ont demandé au notaire d'acter les
termes et conditions du projet de fusion entre elles comme suit.
Par décision de leur conseil de gérance respectif en date du 24 novembre 2011, EP Anjou 1 S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 124120 au capital social de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-
cinq euros), chacune entièrement libérées,
(ci-après la «Société Absorbante»),
et
EP Anjou 2 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
124123 au capital social de EUR 273.650,- (deux cent soixante treize mille six cent cinquante euros) représenté par 10.946
(dix mille neuf cent quarante six) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), chacune entièrement
libérées.
(ci-après la «Société Absorbée»),
et
(la Société Absorbante et la Société Absorbée étant ensemble collectivement désignées les «Sociétés Fusionnantes»)
ont décidé de procéder à leur fusion et ont convenu du projet de fusion qui va suivre (le «Projet de Fusion»), étant
préalablement souligné que:
- la Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée et la fusion est donc
soumise aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»);
- le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes a décidé que la Société Absorbée sera absorbée par la Société
Absorbante et, pour ce faire; la Société Absorbée fera apport de tout son actif et de tout son passif (l'«Actif et le Passif»)
à la Société Absorbante.
1. A la date déterminée par le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes, en l'occurrence le 30 septembre 2011 (la
«Date d'Effet»), l'Actif et le Passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante.
2. La fusion est basée sur les états financiers des Sociétés Fusionnantes établis au 30 septembre 2011 pour chacune
des Sociétés Fusionnantes.
3. A l'issue du processus de fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et ses actions seront annulées.
4. La fusion sera en outre soumise aux conditions suivantes:
a) La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs de la Société Absorbée dans leur état actuel à la Date d'Effet.
b) La Société Absorbante règlera, à compter de la Date d'Effet, tous les impôts et taxes, y inclus, sans que cette
énumération soit limitative, les droits d'apport, droits de timbre, assurances et toutes autres annuités et redevances,
qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, qui seraient dus ou pourraient être dus, en rapport avec les actifs apportés.
Au besoin, la Société Absorbante règlera les impôts sur le capital et les bénéfices, pour les exercices non encore imposés.
c) La Société Absorbante continuera tous les contrats et obligations de la Société Absorbée en cours à la Date d'Effet;
d) La Société Absorbante continuera en particulier tous les contrats de travail en cours à la Date d'Effet ainsi que les
contrats avec la clientèle, les fournisseurs, les créanciers et les débiteurs de la Société Absorbée et sera subrogée dans
tous ses droits et obligations à cet égard, à ses propres risques.
5. Pour les besoins comptables, la fusion sera effective à compter du 30 septembre 2011, (la «Date d'Effet Comptable»)
6. Les documents mentionnés à l'article 267, par.1 a), b) et c) de la Loi (à savoir, le projet de fusion, les comptes annuels
et les rapports annuels relatifs aux 3 derniers exercices sociaux ainsi que les états financiers arrêtés à la date du 30
septembre 2011) seront à la disposition des associés pour inspection au siège social des Sociétés Fusionnantes.
140332
L
U X E M B O U R G
7. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.
8. Si l'approbation des assemblées générales des associés n'est pas requise ou si le Projet de Fusion est approuvé par
les assemblées des associés des Sociétés Fusionnantes, la Fusion engendrera tous les effets prévus par l'article 274 de la
Loi, en particulier en son paragraphe a), à la date prévue au point 1. ci-dessus.
9. Le mandat des gérants prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière leur sera accordée pour l'exercice
de leur mandat.
10. Tous les documents sociaux, les dossiers et les registres de la Société Absorbée seront conservés pendant la durée
légale au siège de la Société Absorbante. Le notaire soussigné qui a une connaissance personnelle de la langue anglaise
déclare que à la requête des comparants, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une traduction en français, la
version anglaise prévalant en cas de divergences entre les textes français et anglais.
DONT ACTE, en foi de quoi le présent acte a été rédigé à Luxembourg à la date indiquée au début des présentes.
Les documents ayant été lu aux comparants, qui sont connus du notaire de par leur noms, prénoms, statuts civils et
résidences, les comparants ont signé avec Nous notaire l'original de cet acte.
Signé: C. Kirsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52304. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR COPIE conforme à l'original.
Luxembourg, le 28 novembre 2011
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2011162009/155.
(110188950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2011.
EP Latitude 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.523.
EP Latitude 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 131.522.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and eleven, on the twenty fourth day of November,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared
1. Mr. Charles Kirsch, with professional address in Luxembourg acting in its capacity as attorney of the board of
managers of EP Latitude 1 S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office
at 34 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B
under n° 131.523 by virtue of a power of attorney granted by the board of managers attached hereto.
2. Mr. Charles Kirsch, with professional address in Luxembourg, acting in its capacity as attorney of the board of
managers of EP Latitude 2 S.à r.l., a limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office
at 34 avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B
under n° 131.522, by virtue of a power of attorney granted by the board of managers attached hereto.
The above companies, acting through the above mentioned attorneys have requested the notary to enact the terms
and conditions of the draft terms of merger between them, as follows.
Further to the resolutions adopted by their respective board of directors on November 24
th
, 2011, EP Latitude 1
S.à r.l., a limited liability company "société à responsabilité limitée"), having its registered office at 34 avenue de la liberté
L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n° 131.523 with a
share capital of thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro
(EUR 25) each fully paid up,
(hereafter the "Absorbing Company"), and
EP Latitude 2 S.à r.l., a limited liability company "société à responsabilité limitée"), having its registered office at 34
avenue de la liberté L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under
n°131.522 with a share capital of EUR 158,975 (one hundred and fifty eight thousand nine hundred and seventy five euros)
represented by 6,359 (six thousand three hundred and fifty nine) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty five
euros) per share, each fully paid up,
(hereafter the "Absorbed Company")
(the Absorbing Company and the Absorbed Company being collectively referred to as the "Merging Companies")
140333
L
U X E M B O U R G
have decided to merge and have agreed on the following draft terms of merger (the "Merger Project"), being beforehand
underlined that:
- the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of the Absorbed Company and the merger
may thus be operated in accordance with the provisions of articles 278 and following of the law of 10
th
August, 1915 on
commercial companies, as amended (the "Law"); and
- the board of managers of the Merging Companies have resolved that the Absorbed Company shall be merged into
the Absorbing Company and for this purpose the Absorbed Company shall contribute all of its assets and liabilities (the
"Assets and Liabilities") to the Absorbing Company.
1. At the date determined by the board of managers of the Merging Companies, being September 30
th
, 2011 (the
"Effective Date"), the Assets and Liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company
2. The merger is based on the accounting statements of the Merging Companies drawn up as at September 30
th
,
2011 for each of the Merging Companies.
3. As a result of the completion of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue
shall be cancelled.
4. The merger shall further be subject to the following additional terms and conditions:
a) The Absorbing Company shall acquire the assets contributed by the Absorbed Company as is where is, i.e. in the
state in which they are on the Effective Date.
b) The Absorbing Company shall from the Effective Date onwards pay all taxes, including but not limited to, contri-
butions, duties, levies, insurance and other premiums annuities and royalties, whether ordinary or extraordinary, which
are due or may become due with respect to the property of the assets contributed. If necessary, the Absorbing Company
shall pay the taxes due by the Absorbed Company on the capital and the profits, for the fiscal years not yet taxed.
c) The Absorbing Company shall carry out all the agreements and obligations of any kind of the Absorbed Company
such as these agreements and obligations exist on the Effective Date.
d) The Absorbing Company shall, in particular, carry out all agreements existing on the Effective Date which include
but are not limited to, the employment contracts binding on the Absorbed Company to its staff, customers and debtors,
suppliers and creditors and it shall be subrogated to all rights and duties resulting therefrom, at its own risk.
5. For accounting purposes, the merger shall be deemed to be effective from September 30
th
, 2011 (the "Effective
Accounting Date").
6. The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) and c) of the Law (i.e. the Merger Project, the annual
accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years and the financial statements
as at September 30
th
, 2011) will be available for inspection by the shareholders at the registered office of the Merging
Companies.
7. No particular advantage is granted to the members of the board of managers of the Merging Companies.
8. If the general meeting is not required or if the Merger Project is not rejected by the former, the merger will become
definitive, as stated above under point 1., and will lead by rights to the effects indicated in article 274 of the Law and in
particular its paragraph a).
9. The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end on the Effective date and full discharge
is hereby granted to the directors and to the statutory auditor of the Absorbed Company for the duties performed.
10. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company will be kept for the legal time period at the
registered office of the Absorbing Company.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first names,
civil status and residences, the said persons signed together with Us the notary this original deed.
Suit la version en langue française:
L'an deux mille onze, le vingt quatre novembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu
1. Monsieur Charles Kirsch, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du
conseil de gérance de EP Latitude 1 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 131523, en vertu d'une procuration accordée par le conseil de gérance demeurée annexée aux pré-
sentes.
140334
L
U X E M B O U R G
Monsieur Charles Kirsch, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du conseil
de gérance de EP Latitude 2 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 131522 en vertu d'une procuration accordée par le conseil de gérance demeurée annexée aux présentes
Les sociétés mentionnées ci-dessus, agissant par leur mandataire sus mentionné, ont demandé au notaire d'acter les
termes et conditions du projet de fusion entre elles comme suit.
Par décision de leur conseil de gérance respectif en date du 24 novembre 2011, EP Latitude 1 S. à r.l. une société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 131523, au capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune
entièrement libérées,
(ci-après la «Société Absorbante»),
et
EP Latitude 2 S. à r.l. une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 34 avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
131522, au capital social de cent cinquante huit mille neuf cent soixante quinze euros (158.975,-EUR), représenté par six
mille trois cent cinquante neuf (6.359) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune,
entièrement libérées,
(ci-après la «Société Absorbée»),
(la Société Absorbante et la Société Absorbée étant ensemble collectivement désignées les «Sociétés Fusionnantes»)
ont décidé de procéder à leur fusion et ont convenu du projet de fusion qui va suivre (le «Projet de Fusion»), étant
préalablement souligné que:
- la Société Absorbante détient cent pour cent (100%) des parts sociales de la Société Absorbée et la fusion est donc
soumise aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»);
- le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes a décidé que la Société Absorbée sera absorbée par la Société
Absorbante et, pour ce faire; la Société Absorbée fera apport de tout son actif et de tout son passif (l'«Actif et le Passif»)
à la Société Absorbante.
1. A la date déterminée par le conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes, en l'occurrence le 30 septembre 2011 (la
«Date d'Effet»), l'Actif et le Passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante.
2. La fusion est basée sur les états financiers des Sociétés Fusionnantes établis au 30 septembre 2011 pour chacune
des Sociétés Fusionnantes.
3. A l'issue du processus de fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et ses actions seront annulées.
4. La fusion sera en outre soumise aux conditions suivantes:
a) La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs de la Société Absorbée dans leur état actuel à la Date d'Effet.
b) La Société Absorbante règlera, à compter de la Date d'Effet, tous les impôts et taxes, y inclus, sans que cette
énumération soit limitative, les droits d'apport, droits de timbre, assurances et toutes autres annuités et redevances,
qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, qui seraient dus ou pourraient être dus, en rapport avec les actifs apportés.
Au besoin, la Société Absorbante règlera les impôts sur le capital et les bénéfices, pour les exercices non encore imposés.
c) La Société Absorbante continuera tous les contrats et obligations de la Société Absorbée en cours à la Date d'Effet;
d) La Société Absorbante continuera en particulier tous les contrats de travail en cours à la Date d'Effet ainsi que les
contrats avec la clientèle, les fournisseurs, les créanciers et les débiteurs de la Société Absorbée et sera subrogée dans
tous ses droits et obligations à cet égard, à ses propres risques.
5. Pour les besoins comptables, la fusion sera effective à compter du 30 septembre 2011, (la «Date d'Effet Comptable»)
6. Les documents mentionnés à l'article 267, par.1 a), b) et c) de la Loi (à savoir, le projet de fusion, les comptes annuels
et les rapports annuels relatifs aux 3 derniers exercices sociaux ainsi que les états financiers arrêtés à la date du 30
septembre 2011) seront à la disposition des associés pour inspection au siège social des Sociétés Fusionnantes.
7. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.
8. Si l'approbation des assemblées générales des associés n'est pas requise ou si le Projet de Fusion est approuvé par
les assemblées des associés des Sociétés Fusionnantes, la Fusion engendrera tous les effets prévus par l'article 274 de la
Loi, en particulier en son paragraphe a), à la date prévue au point 1. ci-dessus.
9. Le mandat des gérants prendra fin à la Date d'Effet et décharge pleine et entière leur sera accordée pour l'exercice
de leur mandat.
10. Tous les documents sociaux, les dossiers et les registres de la Société Absorbée seront conservés pendant la durée
légale au siège de la Société Absorbante.
Le notaire soussigné qui a une connaissance personnelle de la langue anglaise déclare que à la requête des comparants,
le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une traduction en français, la version anglaise prévalant en cas de divergences
entre les textes français et anglais.
140335
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, en foi de quoi le présent acte a été rédigé à Luxembourg à la date indiquée au début des présentes.
Les documents ayant été lu aux comparants, qui sont connus du notaire de par leur noms, prénoms, statuts civils et
résidences, les comparants ont signé avec Nous notaire l'original de cet acte.
Signé: C. Kirsch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52303. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 28 NOV. 2011.
Joseph ELVINGER.
Référence de publication: 2011162010/159.
(110188944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2011.
70Watt Capital S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 151.555.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of September.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Ms Sabine IGEL, private employee, residing professionally in 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg,
acting in the name and on behalf of 70Watt Capital Management S.à r.l., a company incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg (RCS Luxembourg B 151.476),
by virtue of a proxy given on 5 September 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation 70Watt Capital S.C.A. SICAVSIF, having its principal office in L-1118 Luxembourg, 11, Rue
Aldringen, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on February 10, 2010, published in the
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 714 of April 6, 2010. The Articles of Incorporation have not been
modified since today;
- that the corporation 70Watt Capital S.C.A. SICAVSIF has been incorporated with a subscribed share capital of thirty-
one thousand euro (EUR 31,000) divided into thirty one (31) Shares of no par value, fully paid up;
- that 70Watt Capital Management S.à r.l. prenamed, has become owner of all the shares and declares that it has full
knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company 70Watt Capital S.C.A. SICAV-SIF;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 30 September 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 30 September 2011 being only one information for
all purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's directors and approved statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units and or the shareholders register;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1118 Luxembourg,
11, Rue Aldringen;
- it has been informed that no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the
reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial
companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company
currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.
140336
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at two thousand euros (EUR 2,000).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her
surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente septembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Madame Sabine IGEL, employée privée, demeurant professionnellement à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de 70Watt Capital Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg (RCS Luxembourg B 151.476),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 5 septembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société 70Watt Capital S.C.A. SICAV-SIF, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, Rue Aldringen, a
été constituée suivant acte du notaire soussigné du 10 février 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 714 du 6 avril 2010. Les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour;
- que la société 70Watt Capital S.C.A. SICAV-SIF a été constituée avec un capital social souscrit de trente et un mille
euros (31.000 EUR), représenté par trente et une (31) Actions sans valeur nominale, entièrement libérées;
- que 70Watt Capital Management S.à r.l. précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les actions et qu'elle
déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société 70Watt Capital S.C.A. SICAV-
SIF;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution
anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 30 septembre
2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du
passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 30 septembre 2011 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprise agrée de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1118 Luxembourg,
11, Rue Aldringen.
- il a été informé qu'aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement
à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales)
à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura
exigé la constitution de sûretés.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués à approximativement à deux mille euros (EUR 2.000).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
140337
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses noms,
prénom usuels, état et demeure, ladite comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. IGEL, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43565. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2011.
Référence de publication: 2011146431/108.
(110169591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.
Axxion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 82.112.
<i>Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates abgehalten in Munsbach am 24. Februar 2011i>
<i>Tagesordnungi>
Der Verwaltungsrat der Axxion S.A. bestellt einstimmig mit Wirkung zum 1. Mai 2011
Herrn Pierre Girardet
(wohnhaft in Könenerstr. 85, D-54329 Konz, geboren am 11. Oktober 1973)
zum 3. Geschäftsführer der Axxion S.A.
Martin Stürner / Thomas Amend / Uwe Kristen.
Référence de publication: 2011145732/14.
(110168724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
BM 17 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 132.160.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011145743/9.
(110169231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
AAM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 116.476.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises en date du 20 octobre 2011 que Monsieur Steven Richard KEYES a démissionné en
tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011145733/13.
(110168995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Aqua European Technologists S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 72.533.
Démission de l'administrateur et administrateur délégué:
- Sigma Fin International S.àr.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
140338
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 21-10-2011.
Sigma Fin International Sarl
Signature
Référence de publication: 2011145735/13.
(110168826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Blue Gem Luxembourg 1B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 128.032.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associési>
En date du 29 août 2011 l'assemblée générale des associés a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Sylvie ABTAL-COLA, en tant que gérant de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Johanna Dirkje Martina VAN OORT, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant profes-
sionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2011.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011145737/18.
(110168761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Digital Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 23.503.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de Monsieur Boris SZULZINGER, demeurant 36/1, avenue Général
de Gaulle à B-1050 BRUXELLES, et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la
Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l., ayant son siège
social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011145767/17.
(110168796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Bioptone, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 155.826.
EXTRAIT
Il résulte de la convention de cession de parts sociales conclue en date du 1
er
octobre 2011 à Luxembourg, que:
Madame Joëlle BESSON, consultante, née le 7 avril 1951 à Donaueschingen (Allemagne), demeurant à F-63000 Cler-
mont-Ferrand, 76, boulevard François Mitterrand, cède irrévocablement à Monsieur Robin CHARMANT, employé privé,
né le 24 novembre 1981 à Beaumont (France), demeurant à B-1950 Kraainem, avenue des Séquoias 25, qui accepte et
achète ce à compter de ce jour, les trente et une (31) parts sociales numérotées de 93 à 123 qu'il détient dans la
BIOPTONE.
140339
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2011145741/16.
(110168660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Bioptone, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 155.826.
EXTRAIT
Il résulte de la convention de cession de parts sociales conclue en date du 1
er
octobre 2011 à Luxembourg, que:
Monsieur Alain CHARMANT, gérant de sociétés, né le 17 octobre 1944 à Thiers (France), demeurant à B-1570
Auderghem, Chaussée de Wavre 1160, cède irrévocablement à Monsieur Thomas CHARMANT, employé privé, né le
13 octobre 1978 à Beaumont (France), demeurant à B-1570 Auderghem, Chaussée de Wavre 1160, qui accepte et achète
ce à compter de ce jour, une (1) part sociale numérotée 124 qu'il détient dans la BIOPTONE.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2011145742/15.
(110168660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
BM 17 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 132.160.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011145744/9.
(110169232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Centre d'Isolation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 67.863.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s'est tenue le 21/10/2011 à 9.00 au siègei>
<i>social de la société Centre d'Isolation S.A. à KEHLENi>
Les actionnaires décident d'accepter la démission de l'administrateur SERMELUX S.A. METALSERVICE Luxembourg
avec effet aujourd hui.
Fait à Kehlen, le 21/10/2011.
Certifié sincère et conforme
Monsieur Frank NIMAX
Référence de publication: 2011145745/14.
(110169085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Caspian Grill s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9068 Ettelbruck, 27, rue Michel Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 147.267.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch.
Signature.
Référence de publication: 2011145754/10.
(110168762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
140340
L
U X E M B O U R G
Caspian Grill s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9068 Ettelbruck, 27, rue Michel Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 147.267.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch.
Signature.
Référence de publication: 2011145755/10.
(110168764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
T.I.G., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 159.522.
L'an deux mille onze, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
a comparu:
Monsieur Tanguy RICAILLE, analyste-programmeur, né à Virton (Belgique) le 25 juin 1978 (matricule 1978 06 25 395),
demeurant à B-6747Châtillon, Grand-Rue 105, appartement1.
Le comparant agissant en sa qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social, de la société à res-
ponsabilité limitée «T.I.G. S.à r.l.», avec siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 mars 2011, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1164 du 31 mai 2011,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 159.522.
L'associé unique a ensuite requis le notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'associé unique transfère le siège social de L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon, vers L-8413 Steinfort, 12, rue du
Cimetière et en conséquence décide modifier l'article 2 des statuts comme suit:
« Art. 4. Le siège social de la société est établi dans la commune de Steinfort. Il pourra être transféré en tout autre
lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 750,- €.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Tanguy RICAILLE, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 19 octobre 2011 Relation: DIE/2011/9959. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 25 octobre 2011.
Référence de publication: 2011146962/34.
(110170240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.
Claront S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 9, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 61.991.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/10/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011145756/10.
(110169110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
140341
L
U X E M B O U R G
European Solar Opportunities II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 127.914.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 24 octobre 2011, a pris note du non renouvellement de la candidature de
Monsieur Jean-Claude STOFFEL aux fonctions de gérant de la société.
L'associé unique, dans ses résolutions du 24 octobre 2011, a renouvelé les mandats des autres gérants:
- Monsieur Richard CRAWFORD, gérant de catégorie A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Lon-
dres, Royaume-Uni,
- Monsieur Jonathan ENTRACT, gérant de catégorie A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres,
Royaume-Uni,
- Madame Stéphanie GRISIUS, gérant de catégorie B, M. Phil. Finance B, Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Lu-
xembourg,
- Monsieur Laurent HEILIGER, gérant de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg.
En outre, l'associé unique a nommé un gérant supplémentaire:
- Monsieur Manuel HACK, gérant de catégorie B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2011.
Luxembourg, le 24 octobre 2011.
<i>Pour EUROPEAN SOLAR OPPORTUNITIES II
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2011146003/27.
(110169964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.
CMH Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 110.751.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011145757/10.
(110169086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
CMH Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 110.751.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale annuelle tenue au siège social en date du 8 juillet 2011i>
Les mandats des administrateurs, à savoir Messieurs Jean-Marc FABER, né le 07/04/1966 à Luxembourg, résidant
professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg; Christophe MOUTON, né le 20/11/1971 à Saint-Mard
(Belgique) résidant professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg; Monsieur Manuel Bordignon, né le
03/06/1969 à Esch sur Alzette (Luxembourg) résidant professionnellement au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg
ainsi que celui du Commissaire aux comptes, la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège le 63-65, rue de
Merl à L-2146 Luxembourg, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
CMH PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011145758/19.
(110169089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
140342
L
U X E M B O U R G
Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 150.963.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011145762/11.
(110168634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Sermelux aluminium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 73.525.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui s'est tenue le 21/10/2011 à 10.00 au siègei>
<i>social de la société à KEHLENi>
Les actionnaires décident d'accepter la démission des administrateurs ROBERT SCHINTGEN et LEA BEISSEL avec
effet à ce jour.
Fait à Kehlen, le 21/10/2011.
Certifié sincère et conforme
Monsieur Frank NIMAX
Référence de publication: 2011145808/14.
(110169088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Cross Media Publishing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7220 Walferdange, 42, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 149.815.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/10/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011145763/10.
(110169107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Sifobuci S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 128.100.
L'an deux mille onze, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1.- SIFOLUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 68.623, ici représentée par Monsieur Bruno
MARCHAIS, expert comptable, ayant son adresse professionnelle à L-1270 Luxembourg, 1, Am Bongert, en vertu d'une
procuration lui délivrée.
2.- "G.C.C. S.A.", société anonyme, avec siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 67.216, ici représentée par son adminis-
trateur-délégué en fonction Monsieur Bruno MARCHAIS, préqualifié.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée " Sifobuci S.àr.l. ", avec siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre
Beicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 128.100, a été
140343
L
U X E M B O U R G
constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 4 mai 2007,
publié au Mémorial C numéro 1401 du 9 juillet 2007, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
- Que la comparante sub 1.- est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée
générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, et en présence de la comparante sub 2.-, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quarante-huit mille huit cents euros
(148.800, EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à cent soixante
et un mille deux cents euros (161.200,- EUR), sans émission de parts sociales nouvelles, mais par l'augmentation de la
valeur nominale des parts sociales de son montant actuel de cent euros (100,- EUR) chacune à mille trois cents euros
(1.300,- EUR) chacune.
L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par l'associée
unique, moyennant conversion en capital du "compte courant associé", à concurrence de cent quarante-huit mille huit
cents euros (148.800,- EUR).
Tous pouvoirs sont conférés aux gérants pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
La justification de l'existence dudit "compte courant associé" a été rapportée au notaire instrumentant par des docu-
ments comptables.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de réduire le capital social à concurrence de cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800,-
EUR), pour le ramener de son montant actuel de cent soixante et un mille deux cents euros (161.200,- EUR) à douze
mille quatre cents euros (12.400, EUR).
Cette réduction de capital est réalisée par apurement de pertes pour un montant total de cent quarante-huit mille
huit cents euros (148.800,- EUR), sans annulation de parts sociales, mais par la réduction de la valeur nominale des parts
sociales de son montant actuel de mille trois cents euros (1.300,- EUR) chacune à cent euros (100, EUR) chacune.
Tous pouvoirs sont conférés aux gérants pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quarante-huit mille euros (248.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400, EUR) à deux cent soixante mille
quatre cents euros (260.400,- EUR), par la création et l'émission de deux mille quatre cent quatre-vingts (2.480) parts
sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.
Les nouvelles parts sociales ont été souscrites par "G.C.C. S.A.", société anonyme, avec siège social à L-1226 Luxem-
bourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 67.216, et entièrement libérées par renonciation à une créance certaine, liquide et exigible, que le souscripteur
a à l'encontre de la société.
Tous pouvoirs sont conférés aux gérants pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
La justification de l'existence de la créance a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate que les parts sociales du capital social sont réparties comme suit:
1. SIFOLUX S.A., société anonyme, avec siège social à L1226 Luxembourg,
20, rue Jean-Pierre Beicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 68.623, cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
2. "G.C.C. S.A.", société anonyme, avec siège social à L1226 Luxembourg,
20, rue Jean-Pierre Beicht, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 67.216, deux mille quatre cent quatrevingts parts sociales . . . . . . . . . . . . .
2.480
Total: deux mille six cent quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.604
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article
cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent soixante mille quatre cents euros (260.400,- EUR), représenté par deux
mille six cent quatre (2.604) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
140344
L
U X E M B O U R G
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital
sont évalués à la somme de 2.450,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bruno MARCHAIS, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 octobre 2011. Relation GRE/2011/3663. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 25 octobre 2011.
Référence de publication: 2011146345/85.
(110169877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.
Bureau d'Expertises Wagner & Chiesa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4988 Sanem, 4D, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 67.756.
L'an deux mille onze, le trente septembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
ONT COMPARU
1. Monsieur Fernand Valentin WAGNER, expert en automobiles, né à Esch-sur-Alzette le 6 novembre 1952, demeurant
à L-4989 Sanem, 57, rue Emmanuel Servais;
2. Monsieur Claude Raphaël CHIESA, expert en automobiles, né à Luxembourg le 6 mars 1959, demeurant à L-8284
Kehlen, 1B, rue des Romains;
Ci-après collectivement désignés les «Comparants». Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter
ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «BUREAU D'EXPERTISES
WAGNER & CHIESA S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-4988 Sanem, 4D, rue de la Fontaine, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 67.756, constituée suivant acte reçu par Maître
Edmond SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 10 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 169 du 15 mars 1999 (ci-après la «Société»).
- Qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils s'entendent par ailleurs dûment convoqués
et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société, Monsieur Fernand Valentin WAGNER, pré-qualifié
(ci-après le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les
cas où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
140345
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux Comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et
demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. WAGNER, R. CHIESA, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 2011. Relation: MER/2011/1964. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 25 octobre 2011.
Référence de publication: 2011146617/47.
(110170159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.
FAURECIA AST Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 3.500.000,00.
Siège social: L-9779 Eselborn, 14, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 92.429.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Eselborn le 6 juin 2011i>
L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur José MEMBRILLERA, demeurant à F-08000
Charleville-Mézières.
L'assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a pris les décisions suivantes:
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de prolonger le mandat jusqu'à la prochaine assemblée en l'année 2012 des administrateurs suivants:
Président et administrateur:
Monsieur José MEMBRILLERA
Vice-Président et Administrateur:
SAI Automotive Washington Limited Staithes road, 8-NE38 8NW
WASHINGTON Représenté par Monsieur Christophe SCHMITT
représentant permanent demeurant au 2, rue Hennape - F-92000 NANTERRE
Administrateur:
Faurecia Automotive Industrie 2, Rue Hennape - F 92000 NANTERRE
Représenté par Monsieur Carsten FUHRMAN repésentant permanent
demeurant au 2, rue Hennape, F-92000 NANTERRE
<i>Septième résolutioni>
La personne suivante est nommée Réviseur d'Entreprises pour l'exercice 2011:
ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée entérine la prolongation du mandat de délégués à la gestion journalière des personnes suivante:
Délégué à la gestion journalière et Directeur:
Monsieur Edgard HOUSSINE
7, boulevard Gambetta
F-08000 Charleville-Mezieres
Délégué à la gestion journalière et Contrôleur
de Gestion:
Monsieur Nicolas DELFORGE
4, rue de Marville
L-2119 Luxembourg
Ils sont habilités à engager valablement la société par signatures conjointes deux à deux.
Ces mandats sont valables jusqu'au renouvellement annuel proposé en préalable à la convocation par le conseil de
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée entérine la nommination de Madame Peggy MARCOT comme personne déléguée à la gestion journalière.
Délégué à la gestion journalière et Responsable
des Ressources Humaines:
Madame Peggy MARCOT
113, rue des Hêtres
B-6600 BASTOGNE
Elle est habilitée à engager valablement la société par signatures conjointes deux à deux.
Ce mandat est valable jusqu'au renouvellement annuel proposé par le conseil d'administration, en préalable à la con-
vocation de l'assemblée générale annuelle, qui se tiendra en 2012.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur José MEMBRILLERA lève la séance
à 13.00 heures.
140346
L
U X E M B O U R G
Eselborn, le 6 juin 2011.
Edgard HOUSSINE / Nicolas DELFORGE
<i>Directeur / Contrôleur de Gestioni>
Référence de publication: 2011146708/49.
(110170152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.
Dellmont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 143.921.
<i>Auszug aus der Versammlung des Teilhaber vom 31. August 2011i>
Die Versammlung beschliesst einen neuen Geschäftsführer zu ernennen:
Herrn Marcus Huybreghs, wohnhaft in D-47918 Toenisvorst, 28, Am Schluff, wird ersetzt durch
Herrn Remco Slootweg, IT Service Provider, wohnhaft in NL-2586 HE Den Haag, 25, Berkenbosch Blokstraat.
Der neue Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
Für gleichlautenden Auszug
Fiduplan S.A.
Unterschrift
Référence de publication: 2011145766/15.
(110168649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Distillerie Othon Schmitt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3333 Hellange, 44, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 23.703.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/10/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011145768/10.
(110169156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Double Ace S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1264 Luxembourg, 18, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 75.522.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24/10/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011145770/10.
(110169121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Admiral Participations (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 141.953.
Par résolutions prises en date du 16 septembre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de James Macdonald, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, de son mandat de «Geschäftsführer der Klasse B», avec effet immédiat
2. Acceptation de la démission de Alain Koch, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, de son mandat de «Geschäftsführer der Klasse B», avec effet immédiat
3. Nomination de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de «Geschäftsführer der Klasse B», avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
4. Nomination de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de «Geschäftsführer der Klasse B», avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
140347
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2011.
Référence de publication: 2011145837/19.
(110170053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.
Fidco Fishing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.637.
<i>Extrait rectificatif de l'extrait déposé le 26 août 2010 sous la référence L10013201805i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 octobre 2011 qu'il convient
de corriger le code postal du siège social de la société:
L'adresse correcte du siège social est donc:
- 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg
Luxembourg, le 19 Octobre 2011.
Pour Extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011145774/15.
(110168726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
I C T C S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 53.858.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 octobre 2011, Monsieur Gilles ORBAN,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et Madame Marie-Laurence THILL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
ont été nommés administrateurs au Conseil d'Administration en remplacement des Administrateurs démissionnaires,
Messieurs Guy BAUMANN et Olivier LECLIPTEUR.
Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.
Luxembourg, le 21 octobre 2011.
<i>Pour ICTC S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Caroline Felten
Référence de publication: 2011145778/18.
(110168851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Dollar Tree International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 20.500,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 155.745.
L’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission des personnes suivantes:
- M. David CHAIKIN en tant que gérant de classe A avec effet au 21 octobre 2011.
Depuis cette date le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
<i>Gérant de classe A:i>
M. Philippe van den AVENNE
M. Faruk DURUSU
<i>Gérant de class B:i>
M. Bob SASSER
M. Kevin S. WAMPLER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
140348
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 25 octobre 2011.
Dollar Tree, Inc.
Référence de publication: 2011145956/21.
(110170026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.
International Overseas Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 137.829.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011i>
L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à
r.l., ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011145780/15.
(110168829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Island Immo, Société Anonyme.
Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.
R.C.S. Luxembourg B 102.173.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011145781/9.
(110168607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Jager Financement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 99.502.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Norbert SCHMITZ
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011145782/11.
(110169014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Apollo 3C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 53.196,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.037.
En date du 8 septembre 2011, l'associé Apollo European Real Estate Fund II LP, avec siège social au 2711, Centerville
Road, etage Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis, a transféré 1 part ordinaire à Apollo European Real
Estate Fund II (Euro) LP, avec siège social au Two, Manhattanville Road, NY 10577 Purchase, Etats Unis qui l'acquiert,
avec effet au 18 mars 2011.
En conséquence, les associés sont les suivants:
- 3C Investment LLP, avec siège social au 7-10, Chandos Street, W1G 9DQ Londres, Royaume Uni, avec 10 parts
ordinaires
- Apollo European Real Estate Fund II LP, précité, avec 340 parts ordinaires
- Apollo European Real Estate Fund II (Euro) LP, précité, avec 79 parts ordinaires
140349
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2011.
Référence de publication: 2011145842/19.
(110170056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.
Ingenieurbüro Thomas DEFFNER sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Luxembourg, 13-17, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 164.163.
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend und elf.
Den neunzehnten September.
Vor Uns Christine DOERNER, Notar im Amtssitz zu Bettemburg.
Ist erschienen:
Herr Thomas DEFFNER, Diplomingenieur, geboren zu Heilbronn (Deutschland) am 18. Mai 1969 (No. Matricule
19690518051), zu D-55481 Metzenhausen, 16 Auf der Forst wohnend.
Dieser Erschienene ersuchte den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée unipersonnelle) wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Der vorbenannte Komparent errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeich-
nung „Ingenieurbüro Thomas DEFFNER sàrl".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bettemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung von Energiepässen, Planung, Konstruktion und Überwachung von
Bauvorhaben, Bauleitung, Tätigkeiten als Sicherheits-, und Gesundheitskoordinator, Lehrtätigkeit an Schulen und Uni-
versitäten, Beratung in Baufragen, sowie jede Axt von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt oder denselben fördern kann.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt
das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (Euro 12.500,-) und ist eingeteilt
in EIN HUNDERT (100) Geschäftsanteile zu je EIN HUNDERT FÜNF UND ZWANZIG EURO (Euro 125,-).
Diese Geschäftsanteile werden ganz durch den vorgenannten Gesellschafter gezeichnet.
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von
ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (Euro 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar
nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionnalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der
Gesellschaft.
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von dem Gesellschafter ernannt und abberufen.
Der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls der Gesellschafter nicht anders bestimmt, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Art. 9. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesell-
schaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben des verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 11. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
140350
L
U X E M B O U R G
Der Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- Fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen;
- Der verbleibende Betrag steht dem Gesellschafter zur Verfügung.
Art. 12. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem Gesell-
schafter ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Der Gesellschafter bestimmt über die Befugnisse der Liquidatoren.
Art. 13. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf abgeschätzt auf TAUSEND ZWEI HUNDERT FÜNFZIG (Euro 1.250,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung hat der Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3253 Bettemburg, 13-17, route de Luxembourg.
- Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird ernannt Herr Thomas DEFFNER, vorgenannt, der die Gesellschaft durch
seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: Deffner, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 22 septembre 2011. Relation: EAC/2011/12535. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce
et des Sociétés.
Bettembourg, le 11 octobre 2011.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2011145779/79.
(110168588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Job Networks Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 144.277.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011145783/10.
(110169162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 102.729.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de LaSalle Japan Logistics Fund II L.P., société mère de LaSalle Japan
Logistics (JPY) Sàrl, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011145784/11.
(110169205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
140351
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Real Estate Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 21.126.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 juin 2011 à 14.00 heures à Luxembourgi>
1. L'Assemblée renouvelle pour une période d'un an le mandat du Commissaire sortant jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en 2012.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011145787/13.
(110168793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.
Wyse Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 95.866.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011148477/10.
(110172395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.
Todoka Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 27.408.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2011148450/10.
(110172568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.
THL GCO Investments III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 111.744.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011148447/9.
(110172270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.
Tivolex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.421.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011148449/10.
(110172505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
140352
70Watt Capital S.C.A. SICAV-SIF
AAM Luxembourg S.à r.l.
Admiral Participations (Luxembourg) S.à r.l.
Apollo 3C S.à r.l.
Aqua European Technologists S.A.
Axxion S.A.
Bioptone
Bioptone
Blue Gem Luxembourg 1B S.à r.l.
BM 17 S.A.
BM 17 S.A.
Bureau d'Expertises Wagner & Chiesa S.à r.l.
Caspian Grill s.àr.l.
Caspian Grill s.àr.l.
Centre d'Isolation S.A.
Claront S.A.
CMH Participations S.A.
CMH Participations S.A.
Compagnie Luxembourgeoise des Auditeurs Réunis (CLAR) S.A.
CompAM FUND
Cross Media Publishing S.à r.l.
Dellmont S.à r.l.
Digital Finance S.A.
Distillerie Othon Schmitt S.à r.l.
Dollar Tree International, S.à r.l.
Double Ace S.à r.l.
EP Anjou 1 S.à r.l.
EP Anjou 2 S.à r.l.
EP Latitude 1 S.à r.l.
EP Latitude 2 S.à r.l.
European Solar Opportunities II
FAURECIA AST Luxembourg S.A.
Fidco Fishing S.A.
I C T C S.A.
Ingenieurbüro Thomas DEFFNER sàrl
International Overseas Holding S.A.
Island Immo
Jager Financement S.A.
Job Networks Group S.A.
LaSalle Japan Logistics (JPY) S.à r.l.
Luxembourg CFA Society
Luxembourg Hydro Power
Luxembourg Real Estate Company
Ourakan International S.A.
Sermelux aluminium S.A.
SGG-FFW S.A.
SGG S.A.
Sifobuci S.àr.l.
Société d'Industrie Mécanique S.A.
THL GCO Investments III, S.à r.l.
T.I.G.
Tivolex S.A.
Todoka Holdings S.A.
Wyse Investments Luxembourg S.A.