logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2838

21 novembre 2011

SOMMAIRE

1A Gérances S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136224

Dentsply Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

136197

Dentsply Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

136204

Eneris Wind Italia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136212

Fininfra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136218

Octavian S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136195

Picarus N.V. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136178

Rac Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136195

Racing Experience S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

136195

Ratia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136195

Restclair S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136195

RH-Lorlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136195

RH-Lorlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136196

Richardson Investments (Castel Romano)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136196

Roumaninvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136196

Satul S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136202

Schiff Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136203

Schiff Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136203

Scripto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136203

Sensus Metering Systems (Luxco 5) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136203

Servico S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136203

Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A.  . . . . . . .

136196

Shiraz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136204

SHS Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136204

SIEGEL SCHLEIMER Ingénieurs-conseils

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136210

Simedex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136209

SkillTeam Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

136197

SK-Q8 Pommerlach SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

136209

SK-Q8 Schmëtt SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136209

S. Michele S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136196

Société de Courtage pour l'Europe Centra-

le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136210

Société de Participation Européenne et In-

ternationale S.A. (SPEI S.A.)  . . . . . . . . . . .

136211

Société Générale de Bâtiment  . . . . . . . . . .

136197

Sogecofi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136211

Sogen Finance Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

136211

Sotrap Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136211

Sotrap Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136212

Sotrap Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136212

Spike Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

136212

Stakotra International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

136216

Stefana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136217

St. Modwen Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

136217

Strasbourg Investissement  . . . . . . . . . . . . . .

136217

Sugarloaf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136217

Sugarloaf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136217

Sunfive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136218

SunGem SubSerFinCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

136197

Tasa Finance Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

136221

TBL PG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136222

Team 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136221

TEH REFI 2009 Société Coopérative . . . . .

136221

Threadneedle (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136221

TMGE Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

136224

Topfin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136224

Top Ten International s.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

136224

Toulouse Manager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136221

Transactive Management S.A. . . . . . . . . . . .

136224

Uranus Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136210

136177

L

U X E M B O U R G

Picarus N.V. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 111.407.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of November.
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

1.- "L.I.B. Beheer B.V.", a limited liability company, under the laws of the Netherlands, with registered office in NL-5663

Geldrop, 2, Genoenhuizerweg, registered with the Netherlands Trade Register under number 17157418, with an issued
share capital of eighteen thousand Euro (EUR 18,000.00) represented by one thousand eight hundred (1,800) shares with
a nominal value of ten Euro (EUR 10.00) each (the "Absorbing Company"),

here represented by Mrs Cathy KEMPENEERS, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt,

by virtue of a resolution taken by the director of the Absorbing Company on 7 November 2011 ("Resolution 1"),
2.- "PICARUS N.V. S.A.", a public limited liability company, under the laws of Luxembourg, with registered office in

L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City
under section B and number 111.407, with an issued share capital of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.00)
represented by one hundred twenty-five thousand shares (125,000) shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.00)
each (the "Absorbed Company", together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies"),

here represented by Mrs. Claude KRAUS, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt,

by virtue of a resolution taken by the board of directors of the Absorbed Company on 7 November 2011 ("Resolution

2", together with Resolution 1 referred to as the "Resolutions").

The Resolutions, initialled "ne varietur", will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the

following:

"Common Terms of Cross-Border Merger

In accordance with Section 2:309 and following of the Netherlands Civil Code ("NCC") and Article 261 and following

of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Luxembourg Law"),

(1) the management body of "L.I.B. Beheer B.V.", a limited liability company, under the laws of the Netherlands, with

registered office in NL-5663 Geldrop, 2, Genoenhuizerweg, registered with the Netherlands Trade Register under num-
ber 17157418, with an issued share capital of eighteen thousand Euro (EUR 18,000.00) represented by one thousand
eight hundred (1,800) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.00) each (the "Absorbing Company") and

(2) the board of directors of "PICARUS N.V. S.A.", a public limited liability company, under the laws of Luxembourg,

with  registered  office  in  L-2450  Luxembourg,  15,  boulevard  Roosevelt,  incorporated  by  deed  of  notary  Jean-Paul
HENCKS, then residing in Luxembourg, on 17 October 2005, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C", number 318 of 13 February 2006, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under
section B and number 111.407, with an issued share capital of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.00) re-
presented by one hundred twenty-five thousand shares (125,000) shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.00)
each (the "Absorbed Company", together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies"),

have together established the following common terms of the cross-border merger by absorption of the Absorbed

Company by the Absorbing Company (the "Merger Project") in order to specify the terms and conditions of such merger
and declared that:

- all of the shares of the Merging Companies are held by the sole shareholder, Mr. Ronald Adrianus Maria HORVERS,
- neither of the Merging Companies has a supervisory board,
- neither of the Merging Companies have a Works Council ("ondernemingsraad") or a trade union that has among its

members employees of one of the Merging Companies or any of their subsidiaries,

- neither of the Merging Companies have been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been

declared,

- none of the Merging Companies has any employees,
- the aforementioned merger is motivated by reasons of restructuring and rationalization of the structure and activities

of the Merging Companies, and the group of which they form part, including particularly reduction of the number of group
companies and organizational and administrative simplification. The merger by absorption of the Absorbed Company by

136178

L

U X E M B O U R G

the Dutch Absorbing Company also aims at strengthening the presence and activities of the group of which the Merging
Companies form part, in the Netherlands,

- the details required pursuant to Section 2:333e NCC will be published in the State Gazette of the Netherlands

("Staatscourant"), it will be announced in a nationally distributed newspaper in the Netherlands that the merger documents
have been deposited in accordance with Section 2:314 NCC,

- the Merger Project will be registered with the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City and published in

the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C" in accordance with Articles 262 and 9 of the Luxembourg Law,

- the cross-border merger of the Absorbed Company into the Absorbing Company (the "Merger") shall comply with

both Dutch and Luxembourg legal provisions.

Thereupon, the following has been agreed:

Art. 1. Universal transfer of assets and liabilities. According to notably Section 2:309 and following NCC Article and

261 and following of the Luxembourg Law dealing with merger by acquisition, at the Effective Date (as defined in Art. 4
below) the Absorbing Company will acquire the entirety of the assets and liabilities of the Absorbed Company (known
and unknown), by operation of law, such that at the Effective Date (as defined below):

a) all of the assets of the Absorbed Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter be the

property of the Absorbing Company,

b) the Absorbing Company shall be liable for all the obligations of the Absorbed Company, provided, however, that

notwithstanding the foregoing, amounts owing between the Absorbed Company and the Absorbing Company shall be
cancelled for no consideration,

c) the Absorbed Company will cease to exist,
d) the Absorbed Company shall hand over to the Absorbing Company the originals of all its incorporating documents,

deeds, amendments, contracts/agreements and transaction of any kind, as well as the bookkeeping and related archive
and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any assets, the supporting
documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating
to the assets and rights given at the Effective Date (as defined in Art. 4 below).

Art. 2. Data to be mentioned pursuant to Section 2:312 paragraph 2 and 2:333d NCC and Article 261 of the Luxem-

bourg Law. The following data need to be mentioned pursuant to Sections 2:312 paragraph 2 and 2:333d NCC and Article
261 of the Luxembourg Law:

I. Type of legal entity, name and official seat/registered office of the merging companies (Section 2:312 paragraph 2,

subparagraph a. and Section 2:333d, sub a. NCC as well as Article 261 paragraph 2 a) of the Luxembourg Law).

(i) the private company with limited liability ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"):
"L.I.B. Beheer B.V.", a limited liability company, under the laws of the Netherlands, with registered office in NL-5663

Geldrop, 2, Genoenhuizerweg, registered with the Netherlands Trade Register under number 17157418, with an issued
share capital of eighteen thousand Euro (EUR 18,000.00) represented by one thousand eight hundred (1,800) shares with
a nominal value of ten Euro (EUR 10.00) each,

(ii) the limited company ("société anonyme"):
"PICARUS N.V. S.A.", a public limited liability company, under the laws of Luxembourg, with registered office in L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, incorporated by deed of notary Jean-Paul HENCKS, then residing in Luxembourg,
on 17 October 2005, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 318 of 13 February
2006, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 111.407, with
an issued share capital of two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.00) represented by one hundred twenty-five
thousand shares (125,000) shares with a nominal value of two Euro (EUR 2.00) each.

II. Share or corporate unit exchange ratio and, where appropriate, the amount of any cash payment (Section 3:326

NCC as well as Article 261 paragraph 2 b) of the Luxembourg Law).

The shareholder of the Absorbed Company shall receive two shares, with a nominal value of ten Euro (EUR 10.00)

each, in the capital of the Absorbing Company in exchange for all of his shares in the capital of the Absorbed Company.
There will be no cash payments in connection with this share exchange rate.

III. Terms for the delivery of the shares or corporate units in the Absorbing Company (Section 2:312 paragraph 2,

subparagraph g. NCC as well as Article 261 paragraph 2 c) of the Luxembourg Law).

The shares to be issued pursuant to the share exchange rate are registered shares. After the merger is effected, the

new shares will be registered in the shareholders register of the Absorbing Company, which is a formality only and not
a constitutive requirement for the coming into existence of those shares. The same applies to the registration of this
share capital increase of the Absorbing Company with the Trade Register in the Netherlands.

IV. Date as from which those shares or corporate units shall carry the right to participate in the profits and any special

condition regarding that right (Section 2:326 NCC as well as Article 261 paragraph 2 d) of the Luxembourg Law).

The shares shall participate in the profits of the Absorbing Company as of 1 January 2011. No special conditions apply

to such participation in the profits of the Absorbing Company.

136179

L

U X E M B O U R G

V. Articles of Association of the Absorbing Company (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph b. NCC as well as

Article 261 paragraph 4 a) of the Luxembourg Law).

The articles of association of the Absorbing Company shall not be amended in connection with the Merger.
These articles of association of the Absorbing Company were drawn up by deed of incorporation on 17 July 2003,

executed before a substitute of P.A.L. van der Horst, civil law notary officiating in Eindhoven, the Netherlands and have
not been amended since. The current text of the articles of association, initialled "ne varietur", is attached to this Merger
Project to be filed at the same time with the registration authorities, shall form an integrated part of this Merger Project
and shall be published together with this Merger Project.

VI. Rights given and compensations to be paid, chargeable to the Absorbing Company (Section 2:312, paragraph 2,

subparagraph c. NCC as well as Article 261 paragraph 2 f) of the Luxembourg Law).

As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Absorbed

Company, no special rights will be given to and no compensations will be paid to anyone by the Absorbing Company.

VII. Benefits to be granted to the members of the management board or of the supervisory board of the Merging

Companies or to third parties in connection with the Merger (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph d. NCC as well
as Article 261 paragraph 2 g) of the Luxembourg Law).

None.
VIII. Intentions with regard to the composition of the management board of the Absorbing Company after the Merger

(Section 2:312, paragraph 2, subparagraph e. NCC).

There is no intention to change the composition of the management board of the Absorbing Company after the Merger.
The present composition is as follows:
Management board:
Mr. Ronald Adrianus Maria HORVERS.
IX. Date per which the financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of the

Absorbing Company (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph f. NCC and Article 261 paragraph 2 e) of the Luxembourg
Law).

The financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of the Absorbing Company

with retroactive effect as per January 1, 2011 (the "Accounting Date"). The last financial year of the Absorbed Company
therefore ends on the date immediately preceding the Accounting Date.

X. Proposed measures in connection with the conversion of the shareholdership of the Absorbed Company or in

connection with an allotment of shares (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph g. NCC).

In this cross-border merger of two sister companies, there is no allotment of shares in the Absorbing Company.
XI. Intentions involving continuance or termination of activities (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph h. NCC).
In addition to the legal consequences further to effectiveness of the Merger as stated in Art. 4 below, the activities of

the Absorbed Company will be continued by the Absorbing Company. For the avoidance of doubt, this cross-border
merger will not imply or provoke any termination of activities of the Merging Companies.

XII. Approval of the resolution to effect the Merger (Section 2:312, paragraph 2, subparagraph i. NCC as well as Article

263 and following of the Luxembourg Law).

The  resolutions  to  effect  the  Merger  will  be  taken  by  the  general  meeting  of  the  shareholders  of  the  Absorbing

Company and by the general meeting of shareholders of the Absorbed Company.

XIII. Effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company (Section 2:312,

paragraph 4, final sentence NCC).

There will be no effects of the Merger on the goodwill and the distributable reserves of the Absorbing Company.
XIV. Probable consequences of the Merger for the employment (Section 2:333d, sub b. NCC as well as Article 261

paragraph 4 b) of the Luxembourg Law).

There are no probable consequences of the Merger for employment, as the Merging Companies have no employees.
XV. Procedures for employee participation (Section 2:333d, sub c. NCC as well as Article 261 paragraph 4 c) of the

Luxembourg Law).

As the Merging Companies do not have employees and none of the Merging Companies is subject to regulations dealing

with employee participation, no arrangements with respect to employee participation have to be made.

XVI. Information on the valuation of assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing

Company (Section 2:333d, sub d. NCC as well as Article 261 paragraph 4 d) of the Luxembourg Law).

The valuation of the relevant assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing Company

was done on the basis of the book value in accordance with its interim accounts as at 30 September 2011.

XVII. Date of the most recently adopted annual accounts used to establish the terms of the Merger (Section 2:33d,

sub e. NCC as well as Article 261 paragraph 4 e) of the Luxembourg Law).

136180

L

U X E M B O U R G

The annual accounts of the Absorbing Company and of the Absorbed Company for the financial year having ended as

at 31 December 2010 were adopted on 3 November 2011 for the Absorbing Company and on 20 June 2011 for the
Absorbed Company.

XVIII. Proposal for the level of compensation of shareholders of the Absorbed Company (Section 2:333d, sub f. NCC).
There will be no compensation for shareholders of the Absorbed Company which vote against the Merger, since the

Absorbing Company and the Absorbed Company have the same sole shareholder of the Absorbed Company who will
not vote against this cross-border Merger. In addition, the Absorbed Company hereby waives any claim it may have to
such compensation.

Art. 3. Valuation of assets and liabilities of the Absorbed Company. On the basis of their book value the net assets of

the Absorbed Company amount to eight million eight hundred forty-six thousand six hundred ninety-two Euro and four
cents (EUR 8,846,692.04) according to its interim accounts as at 30 September 2011.

Further to the Merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be booked in the balance sheet of the

Absorbing Company at book value as at the Accounting Date.

Art. 4. Effective Date - Approval of the Absorbing Company. The Merger shall become effective between the Merging

Companies and towards third parties as of the day after the day the notarial deed of merger has been executed before
a Dutch civil law notary (the "Deed of Merger"),

Art. 5. Obligations concerning formalities of the Absorbing Company. The Absorbing Company shall carry out all the

legal formalities required by law and being necessary or useful to achieve the Merger and to have the Absorbing Company
acquire all the assets and liabilities of the Absorbed Company.

Art. 6. Availability of the Merger documentation at registered offices. The documents referred to Section 2:314 pa-

ragraphs 1 and 2 NCC and in Article 267 paragraph 1 a), b), c) and d) of the Luxembourg Law, in particular:

a) the Merger Project,
b) the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years,
c) interim accounts of the Merging Companies as at 30 September 2011,
d) the explanatory reports of the management body of the Absorbing Company and of the board of directors of the

Absorbed Company,

e) where applicable, the reports referred to in Article 266 of the Luxembourg Law,
will be made available as from the date hereof for inspection at the registered offices of the Merging Companies, in

addition to their filing with the Trade Register in the Netherlands.

Art. 7. Creditors' claims. The creditors of the Merging Companies will benefit from all the protections and recourses

as provided for by Dutch law and the Luxembourg Law, i.e.:

a) according to Section 2:316 NCC, each creditor may oppose the Merger Project by a petition to the court specifying

the requested security up to one (1) month after the day, on which the Merging Companies have announced that the
Merger Project and other required documents have been deposited in accordance with the applicable provisions of the
NCC,

b) according to Luxembourg Law, the creditors of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication

of the extraordinary general meeting of the Absorbed Company to be held before a Luxembourg notary approving the
Merger may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two (2) months to the competent court to
obtain  adequate  safeguard  of  collateral  for  any  matured  and  unmatured  debts,  where  the  Merger  would  make  such
protection necessary.

In this respect, the creditors may obtain additional information at the registered offices of the Absorbing Company,

i.e. NL-5663 Geldrop, 2, Genoenhuizerweg, and of the Absorbed Company, i.e. at L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt."

The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the merger plan and of all acts, documents

and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to Luxembourg Law.

The undersigned notary public, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix novembre.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

136181

L

U X E M B O U R G

Ont comparu:

1.- "L.I.B. Beheer B.V.", une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à NL-5663 Geldrop,

2, Genoenhuizerweg, inscrite au Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 17157418, avec un capital social
émis de dix-huit mille euros (EUR 18.000,00), représenté par mille huit cents (1.800) parts d'une valeur nominale de dix
euros (EUR 10,00) chacune (la "Société Absorbante"),

ici représentée par Madame Cathy KEMPENEERS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Lu-

xembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une résolution adoptée par le gérant de la Société Absorbante en date du 7 novembre 2011 ("Résolution

1"),

2.- "PICARUS N.V. S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
111.407, avec un capital social émis de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par cent vingt-cinq
mille (125.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune (la "Société Absorbée", cette société
étant désignée ensemble avec la Société Absorbante les "Sociétés qui fusionnent"),

ici représentée par Madame Claude KRAUS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 7 novembre 2011

("Résolution 2", désignée ci-après ensemble avec la Résolution 1 les "Résolutions").

Les Résolutions, paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à l'enregis-

trement.

Lesdites comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

"Projet de Fusion transfrontalière

Conformément à la Section 2:309 et suivants du Code Civil Néerlandais ("NCC") et à l'Article 261 et suivants de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi Luxembourgeoise"),

(1) l'organe de gestion de "L.I.B. Beheer B.V.", une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social

à NL-5663 Geldrop, 2, Genoenhuizerweg, inscrite au Registre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 17157418,
avec un capital social émis de dix-huit mille euros (EUR 18.000,00), représenté par mille huit cents (1.800) parts d'une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,00) chacune (la "Société Absorbante") et

(2) le conseil d'administration de "PICARUS N.V. S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège

social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 318 du 13 février 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 111.407, avec un capital social émis de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par
cent vingt-cinq mille (125.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune (la "Société Absorbée",
cette société étant désignée ensemble avec la Société Absorbante les "Sociétés qui fusionnent"),

ont établi conjointement les dispositions générales de la fusion transfrontalière moyennant absorption de la Société

Absorbée par la Société Absorbante (le "Projet de Fusion"), en vue de stipuler les termes et conditions de cette fusion,
auxquelles fins ils ont déclaré ce qui suit:

- toutes les actions des Sociétés Fusionnantes sont détenues par l'actionnaire unique M. Ronald Adrianus Maria HOR-

VERS,

- aucune des Sociétés qui fusionnent ne possède un organe de surveillance,
- aucune des Sociétés Fusionnantes ne possède un comité d'entreprise ou un syndicat comptant parmi ses membres

des employés de l'une des Sociétés Fusionnantes ou de l'une quelconque de leurs filiales,

- aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute ou déclarée en faillite, ni n'a fait l'objet d'une déclaration de sursis

de paiement,

- aucune des Sociétés Fusionnantes ne possède d'employés,
- la fusion susmentionnée est motivée par des raisons de restructuration et de rationalisation de la structure et des

activités des Sociétés Fusionnantes et du groupe dont elles font partie, y compris en particulier par des raisons de ré-
duction du nombre des sociétés du groupe et de simplification organisationnelle et administrative. La fusion par absorption
de la Société Absorbée par la Société Absorbante néerlandaise vise également au renforcement de la présence et des
activités du groupe comportant les Sociétés Fusionnantes aux Pays-Bas,

- les détails requis en vertu de la Section 2:333e du NCC seront publiés au Journal Officiel des Pays-Bas ("Staatscou-

rant"), un journal diffusé sur le plan national aux Pays-Bas fera mention du dépôt des documents de la fusion conformément
à la Section 2:314 du NCC,

- le Projet de Fusion sera enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg et publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, conformément aux Articles 262 et 9 de la Loi Luxembourgeoise,

136182

L

U X E M B O U R G

- la fusion transfrontalière de la Société Absorbée avec la Société Absorbante (la "Fusion") sera conforme à la fois aux

dispositions légales néerlandaises et luxembourgeoises.

Sur ce, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1 

er

 . Transfert global des actifs et des passifs.  Conformément notamment à la Section 2:309 et suivants du NCC

et à l'Article 261 et suivants de la Loi Luxembourgeoise, relatifs à la fusion par absorption, la Société Absorbante acquerra
à la Date d'Effet (telle que définie à l'art. 4 ci-après) la totalité des actifs et des passifs de la Société Absorbée (connus et
inconnus) conformément aux dispositions légales, de manière à ce que à la Date d'Effet (telle que définie ci-dessous):

a) tous les actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante, après quoi ils seront la propriété

de la Société Absorbante,

b) la Société Absorbante sera tenue de tous les engagements de la Société Absorbée, étant entendu toutefois que

nonobstant ce qui précède, les dettes réciproques existant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante seront
annulées sans désintéressement,

c) la Société Absorbée cessera d'exister,
d) la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses documents de constitution, actes,

amendements, contrats/conventions et transactions, quels qu'ils soient, de même que les livres comptables et les archives
correspondantes et tous autres documents comptables, titres de propriété ou titres de propriété de quelconque actifs,
les pièces à l'appui des opérations effectuées, les garanties et contrats, les archives, les justificatifs et tous autres documents
relatifs aux actifs et droits transférés à la Date d'Effet (telle que définie à l'art. 4 ci-dessous).

Art. 2. Données à mentionner en vertu de la Section 2:312, paragraphe 2, et 2:333d du NCC et de l'Article 261 de la

Loi Luxembourgeoise. Les données suivantes devront être mentionnées en vertu de la Section 2:312, paragraphe 2, et
2:333d du NCC et de l'Article 261 de la Loi Luxembourgeoise:

I. La forme, dénomination et siège social des sociétés qui fusionnent (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe a.,

et Section 2:333d sub. A. du NCC, de même que l'Article 261, paragraphe 2 a) de la Loi Luxembourgeoise).

(i) la société à responsabilité limitée:
"L.I.B. Beheer B.V.", une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à NL-5663 Geldrop, 2,

Genoenhuizerweg, inscrite au Registre de Commerce Pays-Bas sous le numéro 17157418, avec un capital social émis de
dix-huit mille euros (EUR 18.000,00), représenté par mille huit cents (1.800) parts d'une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,00) chacune,

(ii) la société anonyme:
"PICARUS N.V. S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors de résidence à Luxembourg,
en date du 17 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 318 du 13 février 2006,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 111.407, avec un
capital social émis de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000)
actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,00) chacune.

II. Rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces (Section 3:326

NCC, de même que l'Article 261, paragraphe 2 b) de la Loi Luxembourgeoise).

L'actionnaire de la Société Absorbée recevra deux actions de valeur nominale de dix euros (EUR 10,00) chacune, dans

le capital de la Société Absorbante en échange de toutes ses actions dans le capital de la Société Absorbée. Il n'y aura
aucune soulte en espèces en rapport avec le rapport d'échange des actions.

III. Modalités de remise des actions ou parts de la Société Absorbante (Section 2:312 paragraphe 2, sous-paragraphe

g. NCC, de même que l'Article 261, paragraphe 2 c) de la Loi Luxembourgeoise).

Les actions à émettre conformément au rapport d'échange des des actions sont des actions nominatives. Après que

la fusion est effectuée, les nouvelles actions seront enregistrées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante,
ce qui n'est qu'une formalité et pas une condition de l'existence de ces actions. Il en va de même pour l'enregistrement
de cette augmentation de capital de la Société Absorbante dans le Registre de Commerce des Pays-Bas.

IV. Date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité

particulière relative à ce droit (Section 2:326 NCC, de même que l'Article 261, paragraphe 2 d) de la Loi Luxembour-
geoise).

Les actions participeront aux profits de la Société Absorbante à partir du 1 

er

 janvier 2011. Aucune condition spéciale

ne s'applique à une telle participation dans les profits de la Société Absorbante.

V. Statuts de la Société Absorbante (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe b. du NCC, de même que l'Article

261, paragraphe 4 a) de la Loi Luxembourgeoise).

Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas amendés dans le cadre de la fusion.
Les statuts de la Société Absorbante ont été dressés suivant acte de constitution du 17 juillet 2003, passé par-devant

un remplaçant de P.A.L. van der Horst, notaire de résidence à Eindhoven, Pays-Bas, et n'ont pas subi de modifications

136183

L

U X E M B O U R G

par la suite. Le texte actuel des statuts paraphé "ne varietur", est annexé au Projet de Fusion pour être formalisé avec
celui-ci, dont il fera partie intégrante et avec lequel il sera publié.

VI. Droits consentis et désintéressements à verser par la Société Absorbante (Section 2:312, paragraphe 2, sous-

paragraphe c. du NCC, de même qu'Article 261, paragraphe 2 f) de la Loi Luxembourgeoise).

Etant donné qu'il n'existe aucune personne possédant en une quelconque qualité autre que celle d'actionnaire des

droits particuliers à l'égard de la Société Absorbée, il ne sera conféré aucun droit ni versé aucun désintéressement à qui
que ce soit par la Société Absorbante.

VII.  Avantages  à  consentir  aux  membres  de  l'organe  d'administration  ou  de  l'organe  de  surveillance  des  Sociétés

Fusionanntes ou à des tiers en rapport avec la présente Fusion (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe e. du NCC,
de même que l'Article 261, paragraphe 2 g) de la Loi Luxembourgeoise).

Néant.
VIII. Intentions relatives à la composition de l'Organe de Gestion de la Société Absorbante après la Fusion (Section

2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe a., et Section 2:333d sub. a. du NCC).

Il n'est pas envisagé de modifier la composition de l'organe de gestion de la Société Absorbante après la Fusion.
La composition actuelle se présente comme suit:
Organe de gestion:
Monsieur Ronald Adrianus Maria HORVERS.
IX. Date à laquelle les données comptables de la Société Absorbée seront prises en compte dans les comptes annuels

de la Société Absorbante (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe f. du NCC, et Article 261, paragraphe 2 e) de la
Loi Luxembourgeoise).

Les données comptables de la Société Absorbée seront prises en compte dans les comptes annuels de la Société

Absorbante avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2011 (la "Date d'Arrêté des Comptes"). Le dernier exercice comptable

de la Société Absorbée prendra donc fin à la veille de la Date d'Arrêté des Comptes.

X. Mesures proposées en rapport avec la conversion de l'actionnariat de la Société Absorbée ou en rapport avec une

attribution de parts (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe g. du NCC).

Cette fusion transfrontalière de deux sociétés soeurs ne prévoit pas d'attribution de parts dans la Société Absorbante.
XI. Intentions impliquant la poursuite ou la cessation d'activités (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe h. du

NCC).

A titre additionnel aux conséquences légales de l'efficacité de la Fusion, telles que stipulées à l'Article 4 ci-dessous, les

activités de la Société Absorbée seront poursuivies par la Société Absorbante. Afin d'écarter tout doute, la présente
fusion transfrontalière n'impliquera ni ne provoquera la cessation des activités des Sociétés Fusionnantes.

XII. Approbation de la résolution de Fusion (Section 2:312, paragraphe 2, sous-paragraphe i. du NCC, et Article 263

et suivants de la Loi Luxembourgeoise).

Les résolutions de Fusion seront adoptées par l'assemblée générale des associés de la Société Absorbante et par

l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée.

XIII. Effets de la Fusion sur le "goodwill" et les réserves distribuables de la Société Absorbante (Section 2:312, para-

graphe 4, dernière phrase du NCC).

Il n'y aura aucun effet de la Fusion sur le "goodwill" et les réserves distribuables de la Société Absorbante.
XIV. Conséquences probables de la Fusion sur l'emploi (Section 2:333d, sub. b. du NCC, et Article 261, paragraphe 4

b) de la Loi Luxembourgeoise).

Il n'existe pas de conséquences probables de la Fusion sur l'emploi, alors que les Sociétés Fusionnantes n'ont pas

d'employés.

XV. Procédures en matière d'intéressement des employés (Section 2:333d, sub. c. du NCC, et Article 261, paragraphe

4 c) de la Loi Luxembourgeoise).

Etant donné que les Sociétés Fusionnantes ne possèdent pas d'employés et qu'aucune des Sociétés Fusionnantes n'est

soumise à de quelconques règlementations en matière d'intéressement des employés, il n'y a pas lieu de conclure de
quelconques accords relatifs à un intéressement des employés.

XVI. Information relative à l'évaluation des actifs et des passifs de la Société Absorbée à acquérir par la Société Ab-

sorbante (Section 2:333d, sub. d. du NCC, et Article 261, paragraphe 4 d) de la Loi Luxembourgeoise).

L'évaluation des actifs et passifs en question de la Société Absorbée, à acquérir par la Société Absorbante, a été réalisée

sur la base de la valeur comptable de son bilan intermédiaire au 30 septembre 2011.

XVII. Date des comptes annuels les plus récents, ayant servi de base à la stipulation des termes de la Fusion (Section

2:333d, sub. e. du NCC, et Article 261, paragraphe 4 e) de la Loi Luxembourgeoise).

Les comptes annuels de la Société Absorbante et ceux de la Société Absorbée pour l'exercice comptable clôturé au

31 décembre 2010 ont été adoptés le 3 novembre 2011 pour ce qui est de la Société Absorbante, et le 20 juin 2011 pour
ce qui est de la Société Absorbée.

136184

L

U X E M B O U R G

XVIII. Proposition relative au niveau de désintéressement des actionnaires de la Société Absorbée (Section 2:333d,

sub. f. NCC).

Il n'y aura pas de désintéressement des actionnaires de la Société Absorbée votant contre la Fusion, alors que la Société

Absorbante et la Société Absorbée ont le même actionnaire unique de la Société Absorbée, lequel ne votera pas contre
cette fusion transfrontalière. Par ailleurs, la Société Absorbée renonce par la présente à toute prétention éventuelle à un
tel désintéressement.

Art. 3. Evaluation des actifs et des passifs de la Société Absorbée. Sur la base de leur valeur comptable, les actifs nets

de la Société Absorbée s'élèvent à huit millions huit cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-douze euros et quatre
cents (EUR 8.846.692,04) conformément à son bilan intermédiaire au 30 septembre 2011.

Après la Fusion, les actifs et les passifs de la Société Absorbée seront comptabilisés dans le bilan de la Société Absor-

bante à leur valeur comptable arrêtée à la Date d'Arrêté des Comptes.

Art. 4. Date d'Effet - Approbation de la Société Absorbante. La Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes

et à l'égard des tiers à compter du lendemain de la passation de l'acte notarié de fusion devant un notaire néerlandais
(l'"Acte de Fusion")

Art. 5. Obligations relatives aux formalités à remplir par la Société Absorbante. La Société Absorbante remplira toutes

les formalités légales, nécessaires ou utiles à la réalisation de la Fusion et à l'acquisition par la Société Absorbante de tous
les actifs et passifs de la Société Absorbée.

Art. 6. Disponibilité de la documentation de la Fusion aux sièges sociaux. Les documents stipulés à la Section 2:314,

paragraphes 1 et 2 du NCC et à l'Article 267, paragraphe 1 a), b), c) et d) de la Loi luxembourgeoise, notamment:

a) le Projet de Fusion,
b) les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes portant sur les trois derniers exercices comptables,
c) les bilans intermédiaires des Sociétés Fusionnantes au 30 septembre 2011,
d) les rapports explicatifs de l'organe de gestion de la Société Absorbante et du conseil d'administration de la Société

Absorbée,

e) le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise,
seront mis à disposition dès la date des présentes aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes, parallèlement à leur

inscription au Registre de Commerce aux Pays-Bas.

Art. 7. Revendications des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes bénéficieront de toutes les protections

et de tous les recours prévus par les dispositions légales néerlandaises et luxembourgeoises, à savoir:

a) conformément à la Section 2:316 du NCC, tout créancier pourra s'opposer au Projet de Fusion moyennant une

requête adressée au tribunal, précisant la garantie revendiquée, ce dans le délai d'un (1) mois à compter de la date à
laquelle les Sociétés Fusionnantes auront annoncé le dépôt du Projet de Fusion et des autres documents requis confor-
mément aux dispositions du NCC applicables en la matière,

b) conformément à la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les créances sont anté-

rieures à la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée qui devra
se tenir devant un notaire luxembourgeois et approuvant la Fusion, pourront, sauf stipulation contraire, déposer dans les
deux (2) mois une demande auprès des tribunaux compétents en obtention d'une sûreté adéquate pour toutes créances
échues ou venant à échéance, dans la mesure où la Fusion exigerait une telle protection.

A ce sujet, les créanciers pourront obtenir des renseignements supplémentaires auprès des sièges sociaux de la Société

Absorbante, à savoir NL-5663 Geldrop, 2, Genoenhuizerweg, et de la Société Absorbée, à savoir L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt."

Le notaire instrumentaire certifie par la présente l'existence et la légalité du projet de fusion et de tous les actes,

documents et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes

susmentionnées, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une traduction française; à la demande desdites compa-
rantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux représentantes des comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom, état

civil et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Kempeneers, C. Kraus, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50084. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Suivent les statuts néerlandais:

OPRICHTING/020

136185

L

U X E M B O U R G

Heden zeventien juli tweeduizend drie, verscheen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef Theunissen, hierna te noemen

"notaris", als waarnemer van mr. Peter Antonio Laurentius van der Horst, notaris te Eindhoven: mevrouw Mireille Ma-
thildis Brigitte Timmermans-van Vliet, geboren te Eindhoven op zeventien november negentienhonderd achtenzestig,
werkzaam ten kantore van Marks Wachters Notarissen, Ten Hagestraat 9 te Eindhoven, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van de heer Ronald Adrianus Maria Horvers, geboren te Eindhoven op zestien december negentienhon-
derd achtenzestig, paspoort nummer NC931152, wonende te 5663 PH Geldrop, Genoenhuizerweg 2 en gehuwd.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze op te richten een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende

Statuten

Naam en zetel

Art. 1. De vennootschap draagt de naam:
L.I.B. Beheer B.V. en is gevestigd te Geldrop.

Doel

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
a. het beleggen in, het verwerven vant, het administreren van en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire)

vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in, het voeren van de directie
over, het financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook;

b. het aangaan en uitvoeren van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het uitvoeren van pensioenregelingen in de zin van

de Wet op de Loonbelasting 1964, zulks buiten de werkingssfeer van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf;

c. het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden,

het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke
verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheldsrechten op goederen van de vennootschap voor gelijke
schulden of verplichtingen van derden;

d. het verrichten van al datgene wat met het voorgaande verband houdt of daaruit zou kunnen voortvloeien.
Alle terrnen van dit artikel dienen te worden begrepen in hun ruimste betekenis.

Duur

Art. 3. De duur van de vennootschap is onbepaald.

Kapitaal en aandelen

Art. 4.
1.  Het  maatschappelijk  kapitaal  der  vennootschap bedraagt:  negentigduizend euro  (€  90.000,00) en  is  verdeeld  in

negenduizend (9.000) aandelen, elk aandeel groot nominaal tier euro (€10,00).

2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af; er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. Een besluit tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen - waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het

nemen van aandelen - wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering daarbij
tevens de koers - mits niet beneden parl - en de overige voorwaarden vaststelt.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit als hiervoor ver-

meld, overdragen aan een ander vennootschapsorgaan, en kan deze overdracht herroepen. De uitgifte geschiedt op de
in artikel 14 voorgeschreven wijze.

4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie Vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden

gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot Storfing, behoudens het

bepaalde in artikel 206 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De directie kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek slechts verrichten

met goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

6. Aandeelhouders hebben een recht van voorkeur tot deelneming in de uitgifte in verhouding tot het aantal aandelen,

dat zij reeds bezitten, uit te oefenen op de wijze en binnen de termijn zoals door de algemene vergadering van aandeel-
houders, die tot uitgifte besluit, zal worden bepaald.

Aandeelhouders hebben geen recht van voorkeur bij uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of

van een groepsmaatschappij.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene

vergadering van aandeelhouders.

7. Een recht van voorkeur zoals bedoeld in het vorige lid kan alleen door de aandeelhouders aan wie het ingevolge het

daar bepaalde toekomt, worden uitgeoefend en is mitsdien afzonderlijk niet voor overdracht vatbaar.

136186

L

U X E M B O U R G

8. De vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of

van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk
of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificatea daarvan, mag de

vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het bedrag van de in dit lid genoemde lening(en).
Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd op de in artikel 14 voorgeschreven wijze. Indien bij de vestiging van

het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien
zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de
algemene vergadering van aandeelhouders.

10. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die

door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, Indien bij de vestiging of overdracht van bet vrucht-

gebruik niet anders is bepaald.

11. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd op de in artikel 14 voorgeschreven wijze. Het bepaalde in de

leden 9 en 10 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.

12. Onder certificaathouders worden in deze Statuten verstaan de houders van met medewerking van de verrnoot-

schap  uitgegeven  certifieaten  van  aandelen,  alsmede  de  personen  die  als  gevolg  van  een  op  een  aandeel  gevestigd
vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 9 en 10 bedoelde rechten hebben.

13. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplagtste kapitaal door

intrekking van door haar gehouden aandelen of certificaten daarvan of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging
te verminderen.

Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering

van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Register van aandeelhouders

Art. 5.
1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met

vermelding van de nummers hunner aandelen, van het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop zij de aandelen
hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening.

2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een

pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van
erkenning of betekening, alsmede met de vermelding welke aan de aandelen verbunden rechten hun overeenkomstig de
leden 9, 10 en 11 van artikel 4 toekomen.

3. Voorts worden in een register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de

vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.

4. ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van

de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de ven-
nootschap bekend is.

5. In het register van aandeelhouders, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte opgenomen ieder

verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een

uittreksel ult het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeidt het uittreksel aan wie de in de leden

9, 10 en 11 van artikel 4 bedoelde rechten toekomen.

7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de

vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de leden 9, 10 en 11 van artikel 4 bedoelde rechten toekomen.

De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van

deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

8. Alle kenntsgevingen worden aan de ingeschreven adressen gedaan.

Aandelen in onverdeeldheid

Art. 6.
1. De aandelen zijn onsplitsbaar.
2. Indien een aandeel behoort tot een onverdeelde gemeenschap kunnen de deelgenoten zich slechts door een persoon,

schriftelijk door hen daartoe aangewezen, tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

136187

L

U X E M B O U R G

Zolang die aanwijzing niet is geschied kunnen de aan dat aandeel verbonden rechten door de desbetreffende aandeel-

houders niet worden uitgeoefend.

Inkoop van aandelen

Art. 7.
1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna

volgende bepalingen:

a. het eigen vermögen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van

het kapitaal verrneerderd rnet de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van dete verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen

gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplagtste kapitaal;

c. door de algemene vergadering van aandeelhouders of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan

is machtiging tot de verkrijging verleend.

3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde

balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst
of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar
meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2
niet toegestaan.

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikei zijn certificaten daarvan begrepen.
6. Op vervreemding door de vennootschap van in haar bezit zijnde aandelen in haar kapitaal vindt het in artikei 4 lid

3 bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari mag ge-
schieden.

Blokkeringsregeling

Art. 8.
1. Behoudens het in artikel 10 bepaalde is een aandeelhouder, die een of meer aandelen wenst te vervreemden, verplicht

dit aandeel of deze aandelen eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden door van zijn voornemen tot vervreemding
kenhis te geven aan de directie.

De directie deelt het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving mede aan de andere aandeelhouders.
Indien de vennootschap houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal is zij slechts bevoegd op aandelen te reftecteren,

indien de aanbieder hiermede instemt en met inachtneming van het bepaalde omtrent inkoop van aandelen.

2. Tengevolge van die kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht dit aandeel of deze aandelen te kopen

vooreen prijs, die door de aanbieder en de andere aandeeihouders in onderling overleg wordt vastgesteld.

3. Indien de andere aandeelhouders en de aanbieder aangaande de prijsvaststelling van de aandelen niet tot overeens-

temming komen binnen drie weken na het in lid 1 bedoelde aanbod, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke
deskundige, door de aanbieder en de andere aandeelhouders in onderling overleg te benoemen en indien zij het daarover
niet eens kunnen worden binnen tien dagen na evengemelde termijn van drie weken op verzoek van de meest gerede
belanghebbende aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk rayon de
vennootschap kantoor houdt.

De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschsp en tot het verkrijgen van alle

inlichtingen, waarvan kennisneming voor zijn taxatie dienstig is.

De door de aandeelhouders in onderling overleg of door de deskundige vastgestelde prijs wordt zo spoedig mogelijk

aan de directie medegedeeld.

4. De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de aanbieder indien hij zijn aanbod intrekt; in alle andere gevallen

komen de kosten ten laste van de vennootschap.

5. De directie stelt alle aandeelhouders op de hoogte van de prijs en wel binnen tien dagen nadat de prijs aan de directie

is medegedeeld.

6. De andere aandeelhouders moeten binnen vier weken na de mededeling van de prijs aan de directie opgeven of en

in hoeverre zij van het recht van koop gebruik wensen te maken.

7. Blijkt, dat er door gegadigden tezamen op meer aandelen is gereflecteerd dan aangeboden worden dan zullen de

aangeboden aandelen onder de gegadigden worden verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen, dat ieder reeds bezit
en een voor een zodanige verdeling niet vatbaar aantal of restant daarvan zal worden toegewezen bij loting door de
directie, met dien verstande, dat een gegadigde niet meer dan een aandeel bij loting kan verkrijgen.

Wordt door een gegadigde op minder aandelen gereflecteerd dan bem bij evenredige verdeling krachtens het vorens-

taande zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen onder de overige gegadigden verdeeld op de
wijze, als in de vorige zin is aangegeven.

136188

L

U X E M B O U R G

8. Binnen acht weken nadat zij aan de aandeelhouders mededeling beeft gedaan van de prijs, moet de directie van het

resultaat der aanbieding aan de aanbieder kennisgeven.

9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand na de in het vorige lid

bedoelde kennisgeving.

10. Indien blijkens die kennisgeving niet ten aanzien van alle aangeboden aandelen van het recht van koop gebruik wordt

gemaakt, is de aanbieder gedurende drie maanden na de verzending dezer kennisgeving vrij de door hem aangeboden
aandelen te vervreemden.

Indien  de  aanbieder zijn aandelen  wil  overdragen tegen een lagere  prijs dan  bij de  aanbieding  gold is hij  tot deze

overdracht bevoegd, nadat hij de aandelen opnieuw tegen deze lagere prijs heeft aangeboden aan de overige aandeel-
houders. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat indien
niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen de aanbieder, ook wat de prijs betreft, vrij is in de overdracht.

11. Dit artikel is ook van toepassing indien iemand uit welken hoofde ookde aandelen van een ander wil vervreemden.

Art. 9.
1.  Ingeval  van  faillissement,  verlening  van  surseance  van  betaling  of  schuldsanering,  ingeval  van  overlijden  van  een

aandeelhouder, ingeval van onderbewindstelling van zijn vermogen of ingeval hij door enigerlei andere oorzaak de vrije
beschikking over zijn vermogen verliest, ingeval van overlijden van de echtgenoot van een aandeelhouder, met wie de
overledene was gehuwd in een gemeenschap van goederen waarvan de aandelen deel uitmaakten, ingeval van overlijden
van de geregistreerde partner van een aandeelhouder en de aandelen daarbij deel uitmaakten van een gemeenschap van
goederen, ingeval van ontbinding van zodanige goederengemeenschappen anders dan door overlijden, en ingeval van
ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, bestaat de verplichting tot aanbieding van de aandelen van de desbe-
treffende aandeelhouder aan de andere aandeelhouders binnen een termijn van drie maanden, nadat een der hiervoor
vermelde omstandigheden zich heeft voorgedaan.

Deze verplichting tot aanbieding rust, ingeval van overlijden als hiervoor bedoeld, op de rechtverkrijgenden onder

algemene titel van de overledene, ingeval van ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon op haar vereffenaar(s),
en ingeval van de andere genoemde oorzaken op de aandeelhouder of diens rechtsvertegenwoordiger.

2. Op deze aanbiedingen vindt het in het vorige artikel bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat

de aanbieder niet bevoegd ts zijn aanbod in te trekken en slechts bevoegd is de aandelen te behouden, indien niet alle
aangeboden aandelen worden overgenomen.

3. Indien in de gevallen van overlijden als bedoeld in dit artikel de aan te bieden aandelen tot enige gemeenschap van

goederen behoren, bestaat de verplichting tot aanbieding ten aanzien van die aandelen in hun geheel en derbalve niet
slechts ten aanzien van het tot de nalatenschap van de overledene behorende onverdeelde aandeel daarin.

4. Indien de verpiichting tot aanbieding ontstaat door het overlijden van de echtgenoot of geregistreerd partner van

een houder van aandelen, welke te diens name in het register van aandeelhouders geboekt staan, vervalt die verplichting
indien de desbetreffende aandelen binnen drie maanden na dat overlijden zijn toegedeeld en geleverd aan die aandeel-
houder.

5. Indien de verplichting tot aanbieding ontstaat door ontbinding van een goederengemeenschap anders dan door

overlijden, vervalt die verplichting, indien de desbetreffende aandelen binnen drie maanden na die ontbinding zijn toege-
deeld en geleverd aan die aandeelhouder die de aandelen voor de goederengemeenschap verwierf.

6. Gedurendede in dit artikel voorgeschreven procedure kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten

onverkort worden uitgeoefend, behoudens het in artikel 6 lid 2 bepaalde.

Uitzondering opde artikelen 8 en 9

Art. 10.
Het in de artikelen 8 en 9 bepaalde is niet van toepassing:
a. Indien alle aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van genoemde artikelen in een bepaald geval buiten

toepassing kan blijven, mits een daaruit voortvloeiende overdracht plaatsvindt binnen drie maanden na vorenbedoelde
schriftelijke verklaring;

b. indien de aandelen overgaan door boedelmenging tengevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap;
c. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Levering van aandelen, betaling en aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen

Art. 11.
1. De levering van de ingevolge de artikeien 8 en 9 verkochte aandelen moet geschieden binnen zes weken, nadat de

koop is tot stand gekomen, tenzij de koper(s) en de verkoper(s) anders overeenkomen.

2. De betaling van de koopprijs vindt plaats tegelijkertijd met de levering, tenzij de koper(s) en de verkoper(s) anders

overeenkomen.

3. Na overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop

nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk.

136189

L

U X E M B O U R G

De directie kan de vorige aandeelhouders bij autbentieke of geregistreerde onderhandse akte van verdere aanspra-

kelijkheid ontslaan; in dat geval blijft de aansprakelijkheid niettemin bestaan voor stortingen uitgeschreven binnen een jaar
na de dag waarop de authentieke akte is verleden of de onderhandse is geregistreerd. Indien een vorige aandeelhouder
betaalt, treedt hij in de rechten die de vennootschap tegen latere houders heeft.

Art. 12. Indien een aandeelhouder krachtens het ni de artikelen 8 en 9 bepaalde koper van een aandeel is geworden

en de verkoper ondanks sommatie op een termijn van een maand aar de levering mede te werken te kort is geschoten
terzake van de levering daarvan, alsmede indien aan een verplichting tot aanbieding niet wordt voldaan, is de vennootschap
onherroepelijk gemachtigd tot de desbetreffende levering, respectievelijktot het doen van het aanbod en indien van het
aanbod volledig gebruik gemaakt wordt tot de daaruit voortvloeiende levering en om door ondertekening van de voor
de levering vereiste verklaringen de levering zelf te bewerkstelligen onder verplichting tot voldoening van de koopprijs
aan de verkoper onder aftrek van alle terzake gemaakte kosten.

Wijze van kennisgeving

Art. 13. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge de artikelen 8, 9en 12 te doen, moeten bij aangetekend schrijven

geschieden.

Wijze van uitgifte en levering van (beperkte rechten op) aandelen

Art. 14.
1. Uitgifte en levering van een aandeel geschiedt bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland plaats

van vestiging hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partjj zijn. Onder levering is begrepen vestiging,
levering en afstand van beperkte rechten op aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.

2. De levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden

rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend.

De vennootschap is ook, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar is

geschied, uit eigener beweging bevoegd tot erkenning indien zij kennisdraagt van de levering, welke erkenning geschiedt
door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het register van aandeelhouders en met
inachtneming van de tweede en derde zin van lid 2 van artikel 196a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De erkenning van de levering geschiedt, tenzij op grond van het bepaalde in de derde alinea van lid 2, in de desbe-

treffende akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van die akte.

Bij overlegging van een afschritt of uittreksel wordt op het overgelegde stuk een gedagtekende verklaring geplaatst.
Betekening geschiedt van een notarieei afschrift of uittreksel van de akte.

Bestuur

Benoeming, schorsing, ontslag on bezoldiging

Art. 15.
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestsande uit een door de algemene vergadering van aandeel-

houdsrs te bepalen aantal leden.

2. De leden der directie worden door de algemene vergadering van aandeelbouders benoemd en kunnen door haar

te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

3. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering

van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de directie of aan één of meer
hunner tantième en/of pensioenaanspraken voor henzelf of hnu nabestaanden toekennen.

4. Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden

tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te

verantwoorden; hij kan zich doen bijstaan door een raadsman.

Taak en vertegenwoordiglng

Art. 16.
1. De directie is belast met het besturen van devennootschap. Indien er meerdere directeuren zijn, verdelen zij hun

werkzaamheden onderling.

2. De directie kan een reglement opstellen met betrekklng tot haar beslultvorming en kan een zodanig reglement

wijzigen.

3. Bij staken van stemmen binnen een meerhoofdige directie beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De directie vertegenwoordigt de vennootschap; de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere

directeur.

5. De directie kan aan personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen. De directie kan aan

die personen een titel toekennen die zij verkiest.

136190

L

U X E M B O U R G

Ontstentenis of belet

Art. 17.
1. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur berust het bestuur, indien nog een of meer andere directeuren

in functie zijn, bij laatstgenoemde(n).

2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een door

de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen bestuurder.

3. Indien door de algemene vergadering van aandeelhouders een tijdelijke bestuurder is benoemd, blijft deze benoeming

voor soortgelijke gevallen van kracht en behoeft geen nieuwe benoeming te worden gedaan zolang deze tijdelijke bes-
tuurder er is en de algemene vergadering van aandeelhouders niet besluit een ander tot tijdelijke bestuurder te benoemen.

4. De tijdelijke bestuurder zal ten spoedigste na het ontstaan van de ontstentenis van alle directeuren of de enige

directeur een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, teneinde definitief in het bestuur te doen voorzien.

Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang

Art. 18. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur blijft de desbetreffende directeur

bevoegd tot vertegenwoordiging.

De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te

wijzen.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Art. 19.
1. Vergaderingen vart aandeelhouders worden gehouden ter plaatse waar de vennootschap kantoor houdt. In een

eiders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.

2. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen ver-

tegenwoordrgen.

3. Telkenjare wordt zo spoedig mogelijk nadat de jaarrekening is opgestefd, doch in ieder geval binnen zes maanden

na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

4. In de Jaarlijkse algemene vergadering wordt:
a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het

boekjaar van de rechtspersoon en van de dochter- en groepsmaatschappijen, waarvan de financiële gegevens in haar
jaarrekening ofgroepsjaarrekening zijn opgenomen;

b. de jaarrekening en de winstbesteding vastgesteld, behoudens ingeval van verlenging als bedoeld in artikel 25 lid 2

van deze Statuten;

c. al dan niet decharge verleend aan de directie voor de door haar in het voorafgaande boekjaar verrichte handelingen;
d. voorzien in eventuele vacatures;
e. behandeld hetgeen verder op de agenda is geplaatst.
5. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls een directeur dit nodig

acht.

Bovendien zal een algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, onverminderd het bepaalde in

artikel 220 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zodra één of meer aandeelhouders, tezamen ten minste vijfentwintig
procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan
de directie verzoekt. Indien de directie de vergadering niet bijeenroept zodanig dat deze binnen vier weken na het verzoek
kan worden gehouden, zijn de desbetreffende aandeelhouders zelf tot oproeping bevoegd.

Oproeping

Art. 20.
1. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij aangetekend schrijven aan de adressen

van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze voorkomen in de in artikel 5 bedoeide registers.

2. Bij de oproeping worden de tijd en de plaats der vergadering, alsmedede te behandelen onderwerpen vermeld.

Mededelingen welke krachtens de wet of deze Statuten aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden
gericht, kunnen geschieden door opnerning in de oproepingsbrief.

De termljn van oproeping bedraagt ten minste vijftien dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet mee-

gerekend.

3. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief, met inachtneming

van de voor oproeping gestelde termijn, zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met aige-
mene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

4. Onder de te behandelen onderwerpen zullen ook worden opgenomen die, welke door een of meer houders van

certificaten, gezamenlijk ten minste vijfentwintig procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, bij de directie

136191

L

U X E M B O U R G

schrifielijk zijn ingediend op een zodanig tijdstip, dat ten aanzien daarvan het bepaalde in artikei 224 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek kan worden inachtgenomen.

5. Wanneer in een vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap aan de orde zal

zijn, moet hiervan in de oproeping tot die vergadering melding worden gemaakt terwijl indien het een statutenwijziging
betreft, een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag der oproe-
pingtot de afloop der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage
wordt gelegd.

Indien het betreft een besluit als bedoeld in artikei 208 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal tevens dienen te worden

voldaan aan het bepaalde in lid 5 van dat artikel.

Leiding van de vergadering

Art. 21.
1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de oudste In dienstjaren ter vergadering aanwezige

directeur. Zijn de aanwezige directeuren een gelijk aantal jaren in dienst, dan heeft ieder hunner bij toerbeurt de leiding.
De vergadering is echter steeds bevoegd de leiding op te dragen aan een ander dan de directeur.

2. Is er geen directeur ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. De voorzitter wijst bij de aanvang der vergadering de secretaris aan.
4. Van het verhandele in elke vergadering worden notulen gemaakt, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opge-

maakt.

5. ledere directeur, zomede de voorzitter der vergadering is steeds bevoegd opdracht te geven tot het maken van zulk

een proces-verbaal op kosten der vennootschap.

6.  De  notulen  worden  vastgesteld  door  de  desbetreffende  vergadering  of  een  volgende  vergadering  en  ten  blijke

daarvan getekend door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling geschiedt, als voorzitter en secretaris fun-
geren.

Stemrecht

Art. 22.
1. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
2. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van hen aan wie uit anderen hoofde dan als

aandeelhouders der vennootschap, door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekendof
die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene

vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vrucht-
gebruikers  en  pandhouders  van  aandelen  die  aan  de  vennootschap  en  haar  dochtermaatschappijen  toebehoren,  zijn
evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat hei aandeel
aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij
daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

4. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het

aandetenkapitaal verschaff wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen
stem kan worden uitgebracht.

Art. 23.
1. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze Statuten een

grotere meerderheid is voorgesthreven.

2. Stemming over personen geschiedt metgesloten ongetekende briefjes.
Over zaken wordt mondeling gestemd, een en ander tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van een

der stemgerechtigden een andere wijze van stemming bepaalt.

3. Blanco stemmen engetekende briefjes worden van onwaardebeschouwd en geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten buiten de vergadering

Art. 24.
1. Ook zonder het houden van een vergadering kunnen de aandeelhouders rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle

stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk en met algemene stemmen voor het desbetreffende voorstel hebben
uitgesproken.

Van het besluit wordt door een directeur in het notulenboek der algemene vergadering van aandeelhouders melding

gemaakt, welke vermelding door hem wordt ondertekend en in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders wordt
voorgelezen.

136192

L

U X E M B O U R G

2. Besluiten, betreffende het ontslag van een directeur anders dan op eigen verzoek en die over de punten, welke in

de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden genomen, kunnen slechts genomen worden in
een algemene vergadering van aandeelhouders.

3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal geen toepassing kunnen vinden indien er certificaathouders zijn.

Boekjaar, jaarrekening en publicatie

Art. 25.
1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering

van aandeelhouders met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een
jaarrekening over het afgelopen boekjaar op.

Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over, tenzij artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

voor de vennootschap geldt.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een deskundige, bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, behoudens ingeval de vennootschap hiervoor inge-
volge  de  wet  is  vrijgesteld,  in  welk  geval  de  algemene  vergadering  van  aandeelhouders  voormelde  opdracht  kan
verstrekken.

Zij kan de opdracht aan deze deskundige te allen tijde intrekken.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392, lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

- voorzover op de vennootschap van toepassing - toe te voegen gegevens liggen vanaf de oproeping voor de algemene
vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage
ten kantore van de vennootschap.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.
6. Dedirectie draagt zorg voor de openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag en toebehoren, conform de

artikelen 394 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Winstverdeling

Art. 26.
1. De winst, zoals deze uit de vastgestelde winst- en verliesrekening blijkt, is ter beschikking van de algemene verga-

dering van aandeelhouders.

2. Aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst kunnen slechts uitkeringen

worden gedaan voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van
haar kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden gehouden.

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zijgeoorloofd is. Op aandelen

wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.

3. Bij de berekening van de winstverdeling teilen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet

mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik ofdaarvan met medewerking van de vennootschap certifi-
caten zijn uitgegeven.

4. Tussentijdse uitkeringen kunnen slechts plaatsvinden, indien aan het bepaalde in de eerste zin van lid 2 van dit artikel

is voldaan.

5. Indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening over enig boekjaar verlies geleden is, mag dit verlies slechts

ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves worden gebracht voorzover de wet dat toestaat.

Art. 27.
1. Net dividend wordt veertien dagen na vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders ten kantore

der vennootschap betaalbaar gesteld.

2. De vordering van een aandeelhouder op dividend verjaart door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag waarop

zij betaalbaar is gesteld.

Statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en splitsing

Art. 28. Besluiten tot wijziging der Statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing kunnen slechts worden genomen

in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal is vertegen-
woordigd, met ten minste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in de vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,

te houden binnen een maand na de eerste, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, doch met de hiervoor
bepaalde meerderheid van stemmen, geldige besluiten omtrent het desbetreffende voorstel kunnen worden genomen.

136193

L

U X E M B O U R G

Liquidatie

Art. 29.
1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemene vergadering van aan-

deelhouders anders beslist.

2. Het salaris der door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemde vereffenaar(s) wordt door die ver-

gadering vastgesteld.

3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer Statuten voorzoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van

de wettelijke bepalingen.

4. Van het liquidatiesaldo wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het op de door hen gehouden aandelen

gestorte bedrag tot maximaald e nominale waarde.

Hetgeen alsdan van het liquidatiesaldo resteert wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato van het nominale

bedrag van hun aandelenbezit.

5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende

baten meer aanwezig zijn.

Houdt de vennootschap op te bestaan, dan doet (doen) de vereffenaar(s) daarvan opgaaf aan de registers waarde

vennootschap is ingeschreven.

<i>Slotverklaring

Tot slot verklaarde de comparante, handelend als gemeld:
- dat van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst:
achttienduizend euro (€ 18,000,00), verdeeld in eenduizend achthonderd (1.800) aandelen, genummerd 1 tot en met

1.800, elk aandeel groot nominaal tien euro (€ 10,00);

- dat in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door; de heer Ronald Adrianus Maria Horvers voornoemd voor

eenduizend achthonderd (1.800) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.800;

- dat de aandelen à pari in contanten worden volgestort, welke volstorting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de

aan deze aktete hechten verklaring, als bedoeld in artikel 203a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- dat gemeide storting, voorzover is uitgegaan van een verklaring als bedoeld in lid 1 onder b van genoemd artikel 203a,

door de vennootschap wordt aanvaard;

- dat voor de eerste maal tot directeur der vennootschap wordt benoemd: de heer Ronald Adrianus Maria Horvers

voornoemd;

- dat het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend drie;
- dat de verklaring van geen bezwaar werd verleend bij beschikking van de Minister van Justitie op drieëntwintig juni

tweeduizend drie, nummer B.V.1.246.021, welke aan deze akte zal worden vastgehecht.

<i>Volmacht

Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden gehecht.
De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke

opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden
van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT
21 juli 2003
Signé: C. Kempeneers, C. Kraus, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50084. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2011157255/933.
(110182590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

136194

L

U X E M B O U R G

Octavian S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 72.551.

Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141691/9.
(110164050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Rac Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 76.681.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141766/9.
(110164152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Racing Experience S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 49, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 78.614.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RACING EXPERIENCE S.à r.l.

Référence de publication: 2011141767/10.
(110164000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Restclair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 69.126.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RESTCLAIR S.à r.l.

Référence de publication: 2011141784/10.
(110163999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

RH-Lorlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.728.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141785/10.
(110163810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Ratia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 113.457.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136195

L

U X E M B O U R G

RATIA S.A.
Georges DIEDERICH / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011141769/12.
(110164081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

RH-Lorlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.728.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141786/10.
(110163812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Richardson Investments (Castel Romano) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 84.769.

Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO) S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2011141789/11.
(110163684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Roumaninvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 42.986.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2011141795/11.
(110163748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

S. Michele S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 77.143.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141798/10.
(110163766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 66.186.

Les comptes annuels pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136196

L

U X E M B O U R G

Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2011141801/12.
(110163895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

SkillTeam Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8308 Capellen, 89C, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 90.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 de la maison mère ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2011.

<i>Pour SKILL TEAM Luxembourg
Mr Steve Dierckens
<i>Gérant

Référence de publication: 2011141825/14.
(110164220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Société Générale de Bâtiment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 150.682.

EXTRAIT

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Les membres du conseil de gérance

Référence de publication: 2011141826/12.
(110164020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

SunGem SubSerFinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 145.247.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141827/9.
(110163619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Dentsply Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 23.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 163.262.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of August.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public residing in the city of Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Dentsply Acquisition S.à r.l.", a Luxembourg

"société à responsabilité limitée", having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the
“Company”), incorporated as a "société à responsabilité limitée " by a deed enacted by Maître Jean Seckler on 23 August
2011 awaiting publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Dentsply International Inc., a company incorporated under the laws of Delaware,

registered with the Division of Corporation of Delaware under number 2002951, having its registered office at 221 West
Philadelphia Street, Suite 60W, York Pennsylvania 17405, United States of America (the “Sole Shareholder” or “DII”),

136197

L

U X E M B O U R G

duly represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk residing professionally in at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 30
August 2011.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. – That the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro)

each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>“Agenda

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR into USD;
3. Conversion of all the 12,500 (twelve thousand five hundred) outstanding shares of the Company into 18 (eighteen)

new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, the share capital remaining
unchanged;

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,000 (five thousand United States Dollars) so

as to raise it from its current amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to USD 23,000 (twenty
three thousand United States Dollars) by the issue of 5 (five) new shares of the Company with a nominal value of USD
1,000 (one thousand United States Dollars) each;

5. Subscription and payment by the Sole Shareholder of 5 (five) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one

thousand United States Dollars) by the contribution of 18 (eighteen) shares in Dentsply S.à r.l.;

6. New composition of the shareholding of the Company;
7. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6. of the articles of association of the Company in order to

reflect the new share capital following the increase of the share capital described in resolution 4. above; and

8. Miscellaneous.”
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.

<i>Second resolution

It is resolved to change the currency in which the Company’s share capital is expressed and to convert, with immediate

effect, the currency of the share capital of the Company using the EUR/USD exchange rate applicable as of 26 August
2011 as published on the European Central Bank official website being EUR 1 (one Euro) for USD 1.44 (one United States
Dollar forty four cents) (the “Conversion”).

As a result, the share capital of the Company amounts to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars)

represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of USD 1.44 (one United States
Dollar forty four cents) each.

<i>Third resolution

It is resolved to convert all the 12,500 (twelve thousand five hundred) outstanding shares of the Company into 18

(eighteen) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, the subscribed
capital of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) remaining unchanged.

As a result, the share capital of the Company now amounts to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars)

represented by 18 (eighteen) shares having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars)each.

<i>Fourth resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of 5,000 (five thousand United States Dollars)

so as to raise it from its current amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to USD 23,000 (twenty
three thousand United States Dollars) by the issue of 5 (five) new shares of the Company with a nominal value of USD
1,000  (one  thousand  United  States  Dollars)  each  (the  “New  Shares”),  subject  to  the  payment  of  a  share  premium
amounting to USD 13,000 (thirteen thousand United States Dollars) (the “Share Premium”), out of which an amount of
USD 2,300 (two thousand three hundred United States Dollars) be allocated to the legal reserve, the whole to be fully

136198

L

U X E M B O U R G

paid up through a contribution in kind of all 18 (eighteen) shares that the Sole Shareholder holds in Dentsply S.à r.l., a
Luxembourg “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register (“D Sàrl”), with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each and an aggregate total
value amounting to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to the Company, resulting in the Company
becoming the sole shareholder of D Sàrl (the “Contribution ”).

<i>Fifth resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by DII of the New Shares by means of the Contribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes DII, here represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named by virtue

of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay it up entirely
together with the payment of the Share Premium through the Contribution.

<i>Description of the Contribution

The Contribution made by DII, in exchange for the issuance of the New Shares is composed of all 18 (eighteen) shares

that DII holds in D Sàrl with an aggregate total value amounting to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars).

<i>Valuation

The net value of the Contribution above amounts to a global total of 18,000 USD (eighteen thousand United States

Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 30 August 2011, which shall remain annexed to this deed and be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contributions’ existence

A proof of the Contribution has been given to the Company..

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
a) Mr. Konrad Van der Haegen, B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr. Hugo Froment B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L1331 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

c) Mrs. Valérie Pechon, B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg;

d) Mrs. Deborah Michelle Rasin, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg;

e) Mr. William Edward Reardon, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg; and

f) Mr. Robert john Winters, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement

of contribution value established on August 30 

th

 , 2011.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder is now the holder of 23 (twenty

three) shares.

The notary acts that the 23 (twenty three) shares representing the whole share capital of the Company, are represented

so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions described above having been fully

carried out, it is resolved to amend article 6, paragraph 1 of the Company’s articles of association so that to read as
follows:

“ Art. 6. The corporate capital is set at USD 23,000 (twenty three thousand United States Dollars), represented by

23 (twenty three) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.”

136199

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand five hundred euro (€
1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le trentième jour d’août.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire établit dans la ville de Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de «Dentsply Acquisition S.à r.l.», une société

à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la
«Société»), constituée en société à responsabilité limitée suivant acte notarié par Maître Jean Seckler le 23 août 2011 en
cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il est apparu:

L’associé unique de la société, Dentsply International Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, enregistrée

auprès de la «Division of Corporation of Delaware» sous le numéro 2002951, ayant son siège social au 221 West Phila-
delphia Street, Suite 60W, York Pennsylvania 17405, Etats-Unis d’Amérique, (l’«Associé Unique» ou «DII»), dûment
représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé en date du 30 août 2011.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

L’Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d’enregistrer comme suit:
I.- Que les 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro),

représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l’assemblée peut valablement
se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique a été dûment informé par avance.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la conversion en USD de la devise du capital social de la Société actuellement en EUR;
3.  Conversion de  toutes les 12.500  (douze  mille  cinq  cents) parts sociales  libérées de  la  société  en 18 (dix-huit)

nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1,000 USD (mille Dollars Américains) chacune, le capital social demeu-
rant inchangé;

4. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 5.000 USD (cinq mille Dollars Américains) afin de le

porter de son montant actuel de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) à 23.000 USD (vingt trois mille Dollars
Américains);

5. Souscription et paiement par l’Associé Unique des 5 (cinq) nouvelles parts avec une valeur nominale de 1.000 USD

(mille Dollars Américains) par l’apport de 18 (dix huit) parts sociales dans Dentsply S.à r.l.;

6. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
7. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social de la Société

suivant l’augmentation de capital décrite dans la résolution 4. ci-dessus; et

8. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la

136200

L

U X E M B O U R G

documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de changer la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimé et de convertir, avec effet

immédiat, la devise du capital social de la Société en utilisant le taux de change EUR/USD applicable au 26 août 2011, tel
que publié sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne étant de 1 EUR (Un Euro) pour 1,44 USD (Un Dollars
et quarante quatre cents) (la «Conversion»).

En conséquence, le capital social de la Société d’un montant de 18.000 USD (dixhuit mille dollars américains) représenté

par 12.500 (douze mille cinq cents) parts ayant une valeur nominale de 1,44 USD (un dollar Américain et quarante quatre
cents) chacune.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de convertir toutes les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales libérées de la Société en 18 (dix-

huit) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de 1,000 USD (mille Dollars Américains) chacune, le capital social
souscrit de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) demeurant inchangé.

En conséquence, le capital social de la Société s’élève dorénavant à 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains)

représenté par 18 (dix-huit) parts sociales d’une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune.

<i>Quatrième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 5.000 USD (cinq mille Dollars Américains) afin

de le porter de son montant actuel de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) à 23.000 USD (vingt trois mille
Dollars Américains) par l’émission de 5 (cinq) nouvelles parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1.000
USD (mille Dollars Américains) chacune (les «Nouvelles parts») soumis au paiement d’une prime d’émission d’un montant
de 13.000 USD (treize mille Dollars Américains) (La “Prime d’Emission”) et dont un montant de 2.300 USD (deux mille
trois cents Dollars Américains) alloué à la réserve légale, l’intégralité devant être libéré par un apport en nature toutes
les 18 (Dixhuit) parts sociales que l’Associé Unique possède dans Dentsply S.à r.l.,», une société à responsabilité limitée
luxembourgeoise, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en cours d’enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ( «D Sàrl»), avec une
valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune et une valeur globale de la société s’élevant à 18.000
USD (dix-huit mille Dollars Américains) , ayant pour effet que la Société devienne le seul associé de D Sàrl (l’«Apport»).

<i>Cinquième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par DII des Nouvelles Parts Sociales par le biais de l’Apport.

<i>Intervention – Souscription – Paiement

Intervient ensuite DII, ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommé en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et de les payer
entièrement ensemble avec le versement par l’Apport.

<i>Description de l’apport

L’Apport réalisé par DII, en échange de l’émission des Nouvelles Parts Sociales est composé de toutes les 18 (dix-huit)

parts sociales que DII détient dans D Sàrl avec une valeur globale s’élevant au total à 18.000 USD (dix-huit mille Dollars
Américains).

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport précédemment décrit s’élève à un montant global d’au moins 18.000 USD (dix-huit mille

Dollars Américains).

Une telle évaluation a reçu l’approbation des gérants de la Société aux termes d’une déclaration de valeur de l’Apport

datant du 30 août 2011, qui est annexée au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.

<i>Intervention des gérants

Sont intervenus:
a) M. Konrad Van der Haegen, manager B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

b) M. Hugo Froment, manager B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L1331 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg;

136201

L

U X E M B O U R G

c) Mademoiselle Valérie Pechon, manager B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

d) Mademoiselle Deborah Michelle Rasin, manager A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

f) M. William Edward Reardon, manager A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

g) M. Robert John Winters, manager A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration

de valeur d’apport établie le 30 août 2011.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement responsables de l’Ap-

port comme gérants de la Société, approuvent expressément la description de l’Apport, son évaluation, et confirment la
validité de la souscription et du paiement.

<i>Sixième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’Associé Unique est désormais le propriétaire de 23

(vingt trois) parts sociales.

Le notaire établit que les 23 (vingt trois) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont

représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Septième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et la Conversion décrite ci-dessus ayant été totalement

réalisée, il est décidé de modifier l’article 6, paragraphe 1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d’être lu comme
suit:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 23.000 USD (vingt trois mille Dollars Américains), représenté par 23

(vingt trois) parts sociales d’une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains)».

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l’augmentation de son capital social et le changement de son exercice social, ont été estimés
à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été levée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 septembre 2011. Relation: EAC/2011/11961. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011138720/269.
(110161067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Satul S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141830/10.
(110164265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

136202

L

U X E M B O U R G

Schiff Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 137.229.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011141839/12.
(110164211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Schiff Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 137.229.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011141840/12.
(110164212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Scripto, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 164, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.165.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SCRIPTO S.à r.l.

Référence de publication: 2011141842/10.
(110163998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sensus Metering Systems (Luxco 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 108.513.

Le bilan au 31 mars 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141845/9.
(110164404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Servico S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 14.065.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SERVICO S.A.

Référence de publication: 2011141846/10.
(110163997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

136203

L

U X E M B O U R G

Shiraz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 63.414.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
SHIRAZ S.A.

Référence de publication: 2011141848/11.
(110163974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

SHS Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 87.067.

Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SHS EUROPE S.A.
DIEDERICH Georges / REGGIORI Robert
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011141849/12.
(110164083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Dentsply Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 23.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 163.253.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of August.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public residing in the city of Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Dentsply Holdings S.à r.l.", a Luxembourg "société

à responsabilité limitée", having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the “Com-
pany”), incorporated as a "société à responsabilité limitée " by a deed enacted by Maître Jean Seckler on 23 August 2011
awaiting publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Dentsply International Inc., a company incorporated under the laws of Delaware,

registered with the Division of Corporation of Delaware under number 2002951, having its registered office at 221 West
Philadelphia Street, Suite 60W, York Pennsylvania, 17405, United States of America (the “Sole Shareholder” or “DII”),
duly represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk residing professionally in at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 30
August 2011.

The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. – That the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro)

each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>“Agenda

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR into USD;
3. Conversion of all the 12,500 (twelve thousand five hundred) outstanding shares of the Company into 18 (eighteen)

new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, the share capital remaining
unchanged;

136204

L

U X E M B O U R G

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,000 (five thousand United States Dollars) so

as to raise it from its current amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to USD 23,000 (twenty
three thousand United States Dollars) by the issue of 5 (five) new shares of the Company with a nominal value of USD
1,000 (one thousand United States Dollars) each;

5. Subscription and payment by the Sole Shareholder of 5 (five) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one

thousand United States Dollars) by the contribution of 23 (twenty three) shares in Dentsply Acquisition S.à r.l.;

6. New composition of the shareholding of the Company;
7. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6. of the articles of association of the Company in order to

reflect the new share capital following the increase of the share capital described in resolution 4. above; and

8. Miscellaneous.”
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.

<i>Second resolution

It is resolved to change the currency in which the Company’s share capital is expressed and to convert, with immediate

effect, the currency of the share capital of the Company using the EUR/USD exchange rate applicable as of 26August
2011 as published on the European Central Bank official website being EUR 1 (one Euro) for USD 1.44 (one United States
Dollar forty four cents) (the “Conversion”).

As a result, the share capital of the Company amounts to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars)

represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of USD 1.44 (one United States
Dollar forty four cents) each.

<i>Third resolution

It is resolved to convert all the 12,500 (twelve thousand five hundred) outstanding shares of the Company into 18

(eighteen) new shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, the subscribed
capital of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) remaining unchanged.

As a result, the share capital of the Company now amounts to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars)

represented by 18 (eighteen) shares having a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.

<i>Fourth resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of 5,000 (five thousand United States Dollars)

so as to raise it from its current amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to USD 23,000 (twenty
three thousand United States Dollars) by the issue of 5 (five) new shares of the Company with a nominal value of USD
1,000  (one  thousand  United  States  Dollars)  each  (the  “New  Shares”),  subject  to  the  payment  of  a  share  premium
amounting to USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) (the “Share Premium”), out of which an amount of
USD 2,300 (two thousand three hundred United States Dollars) be allocated to the legal reserve, the whole to be fully
paid up through a contribution in kind of all 23 (twenty three) shares that the Sole Shareholder holds in Dentsply Ac-
quisition S.à r.l., a Luxembourg “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 65, Boulevard Grande-
Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register (“DA Sàrl”), with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars)
each and an aggregate total value amounting to USD 23,000 (twenty three thousand United States Dollars) to the Com-
pany, resulting in the Company becoming the sole shareholder of DA Sàrl (the “Contribution ”).

<i>Fifth resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by DII of the New Share by means of the Contribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes DII, here represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, pre-named by virtue

of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay it up entirely
together with the payment of the Share Premium through the Contribution.

<i>Description of the Contribution

The Contribution made by DII, in exchange for the issuance of the New Shares is composed of all 23 (twenty three)

shares that DII holds in DA Sàrl with an aggregate total value amounting to USD 23,000 (twenty three thousand] United
States Dollars).

136205

L

U X E M B O U R G

<i>Valuation

The net value of the Contribution above amounts to a global total of at least USD 23,000 (twenty three thousand

United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 30 August 2011, which shall remain annexed to this deed and be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contributions’ existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
a) Mr. Konrad Van der Haegen, B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr. Hugo Froment B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L1331 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

c) Mrs. Valérie Pechon, B manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg;

d) Mrs. Deborah Michelle Rasin, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg;

e) Mr. William Edward Reardon, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg; and

f) Mr. Robert J. Winters, A manager, with address at 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg

all represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement

of contribution value established on August 30 

th

 , 2011.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder is now the holder of 23 (twenty

three) shares.

The notary acts that the 23 (twenty three) shares representing the whole share capital of the Company, are represented

so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Seventh resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contributions described above having been fully

carried out, it is resolved to amend article 6, paragraph 1 of the Company’s articles of association so that to read as
follows:

“ Art. 6. The corporate capital is set at USD 23,000 (twenty three thousand United States Dollars), represented by

23 (twenty three) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each.”

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand five hundred euro (€
1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le trentième jour d’août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établit dans la ville de Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

136206

L

U X E M B O U R G

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de «Dentsply Holdings S.à r.l.», une société à

responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la
«Société»), constituée en société à responsabilité limitée suivant acte notarié par Maître Jean Seckler le 23 août 2011 en
cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il est apparu:

L’associé unique de la société, Dentsply International Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, enregistrée

auprès de la «Division of Corporation of Delaware» sous le numéro 2002951, ayant son siège social au 221 West Phila-
delphia Street, Suite 60W, York Pennsylvania 17405, Etats-Unis d’Amérique, (l’«Associé Unique» ou «DII»), dûment
représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé en date du 30 août 2011.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

L’Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d’enregistrer comme suit:
I.- Que les 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de 1 EUR (un Euro),

représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l’assemblée peut valablement
se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique a été dûment informé par avance.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la conversion en USD de la devise du capital social de la Société actuellement en EUR;
3.  Conversion  de  toutes les 12.500 (douze  mille  cinq  cents) parts  sociales  libérées de  la  société  en 18 (dix-huit)

nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1,000 USD (mille Dollars Américains) chacune, le capital social demeu-
rant inchangé;

4. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 5.000 USD (cinq mille Dollars Américains) afin de le

porter de son montant actuel de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) à 23.000 USD (vingt trois mille Dollars
Américains);

5. Souscription et paiement par l’Associé Unique des 5 (cinq) nouvelles parts avec une valeur nominale de 1.000 USD

(mille Dollars Américains) par l’apport de 23 (vingt trois) parts sociales dans Dentsply Acquisition S.à r.l.;

6. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
7. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social de la Société

suivant l’augmentation de capital décrite dans la résolution 4. ci-dessus; et

8. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la
documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de changer la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimé et de convertir, avec effet

immédiat, la devise du capital social de la Société en utilisant le taux de change EUR/USD applicable au 26 août 2011, tel
que publié sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne étant de 1 EUR (Un Euro) pour 1,44 USD (Un Dollars
et quarante quatre cents) (la «Conversion»).

En conséquence, le capital social de la Société d’un montant de 18.000 USD (dixhuit mille dollars américains) représenté

par 12.500 (douze mille cinq cents) parts ayant une valeur nominale de 1,44 USD (un dollar Américain et quarante quatre
cents) chacune.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de convertir toutes les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales libérées de la Société en 18 (dix-

huit) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de 1,000 USD (mille Dollars Américains) chacune, le capital social
souscrit de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) demeurant inchangé.

En conséquence, le capital social de la Société s’élève dorénavant à 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains)

représenté par 18 (dix-huit) parts sociales d’une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune.

136207

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 5.000 USD (cinq mille Dollars Américains) afin

de le porter de son montant actuel de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) à 23.000 USD (vingt trois mille
Dollars Américains) par l’émission de 5 (cinq) nouvelles parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1.000
USD (mille Dollars Américains) chacune (les «Nouvelles parts») soumis au paiement d’une prime d’émission d’un montant
de 13.000 USD (treize mille Dollars Américains) (La “Prime d’Emission”) et dont un montant de 2.300 USD (deux mille
trois cents Dollars Américains) alloué à la réserve légale, l’intégralité devant être libéré par un apport en nature toutes
les 18 (Dixhuit) parts sociales que l’Associé Unique possède dans Dentsply S.à r.l.,», une société à responsabilité limitée
luxembourgeoise, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en cours d’enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ( «D Sàrl»), avec une
valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune et une valeur globale de la société s’élevant à 18.000
USD (dix-huit mille Dollars Américains) , ayant pour effet que la Société devienne le seul associé de D Sàrl (l’«Apport»).

<i>Cinquième résolution

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par DII des Nouvelles Parts Sociales par le biais de l’Apport.

<i>Intervention – Souscription – Paiement

Intervient ensuite DII, ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE prénommé en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et de les payer
entièrement ensemble avec le versement par l’Apport.

<i>Description de l’apport

L’Apport réalisé par DII, en échange de l’émission des Nouvelles Parts Sociales est composé de toutes les 23 (Vingt

trois) parts sociales que DII détient dans DA Sàrl avec une valeur globale s’élevant au total à 23.000 USD (vingt trois mille
Dollars Américains).

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport précédemment décrit s’élève à un montant global d’au moins 23.000 USD (vingt trois mille

Dollars Américains).

Une telle évaluation a reçu l’approbation des gérants de la Société aux termes d’une déclaration de valeur de l’Apport

datant du 30 août 2011, qui est annexée au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.

<i>Intervention des gérants

Sont intervenus:
a) M. Konrad Van der Haegen, manager B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

b) M. Hugo Froment, manager B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L1331 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg;

c) Mademoiselle Valérie Pechon, manager B, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

d) Mademoiselle Deborah Michelle Rasin, manager A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

f) M. William Edward Reardon, manager A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg;

g) M. Robert John Winters, manager A, avec adresse au 65, Boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration

de valeur d’apport établie le 30 août 2011.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement responsables de l’Ap-

port comme gérants de la Société, approuvent expressément la description de l’Apport, son évaluation, et confirment la
validité de la souscription et du paiement.

<i>Sixième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’Associé Unique est désormais le propriétaire de 23

(vingt trois) parts sociales.

Le notaire établit que les 23 (vingt trois) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont

représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

136208

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et la Conversion décrite ci-dessus ayant été totalement

réalisée, il est décidé de modifier l’article 6, paragraphe 1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin d’être lu comme
suit:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 23.000 USD (vingt trois mille Dollars Américains), représenté par 23

(vingt trois) parts sociales d’une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains)».

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec l’augmentation de son capital social et le changement de son exercice social, ont été estimés
à mille cinq cents euros (€ 1.500,-).

Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été levée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 9 septembre 2011. Relation: EAC/2011/11950. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Thoma.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011138721/270.
(110161068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Simedex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 128.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141851/10.
(110163740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

SK-Q8 Pommerlach SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 99.301.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SK-Q8 POMMERLACH SA

Référence de publication: 2011141853/10.
(110164003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

SK-Q8 Schmëtt SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 99.300.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SK-Q8 SCHMËTT SA

Référence de publication: 2011141854/10.
(110164002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

136209

L

U X E M B O U R G

Uranus Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 157.303.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140548/10.
(110162263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

S.C.E.C., Société de Courtage pour l'Europe Centrale, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 43, route Principale.

R.C.S. Luxembourg B 61.932.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141855/10.
(110163736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

SIEGEL SCHLEIMER Ingénieurs-conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4408 Belvaux, 150-159, Waassertrap.

R.C.S. Luxembourg B 155.752.

Im Jahre zweitausendelf, den fünften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1.  Herr  Christian  SIEGEL,  Diplomingenieur,  geboren  in  Luxemburg,  am  19.  November  1977,  wohnhaft  in  L-3918

Monnerich, 2A, rue d'Ehlerange.

2. Herr Markus SCHLEIMER, Diplomingenieur, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 20. März 1974,

wohnhaft in D-54295 Trier, Kettlerstraße 8,

hier vertreten durch Herrn Christian SIEGEL, vorgennant,
auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privateschrift.
3. Herr Winfried HECK, Privatangestellter, geboren in Wittlich (Bundesrepublik Deutschland), am 29. März 1957,

wohnhaft in D-54296 Trier, Andreasstraße 26,

hier vertreten durch Herrn Christian SIEGEL, vorgennant,
auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privateschrift .
Vorgenannten Vollmachten, von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben,

bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit denselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung “SIEGEL SCHLEIMER Ingénieurs-conseils S.à r.l.”, mit Sitz in L-3918

Monnerich, 2A, rue d'Ehlerange, eingetragen in Handels-und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Num-
mer 155752 (die "Gesellschaft"), gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 24.
September 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2395 vom 8. November
2010;

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass sie den amtierenden

Notar ersuchen, den von ihnen in außerordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie
folgt:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Monnerich nach L4408 Beles, 150-159, Waassertrap,

zu verlegen und dementsprechend den ersten Satz von Artikel 4 der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 4. (erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg)."

136210

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

achthundertneunzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe
zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. SIEGEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 octobre 2011. LAC/2011/44309. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Référence de publication: 2011140507/48.
(110162240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2011.

Société de Participation Européenne et Internationale S.A. (SPEI S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.301.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011141856/10.
(110164357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sogecofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 43.567.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2011141858/12.
(110163967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sotrap Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».

R.C.S. Luxembourg B 29.540.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141860/9.
(110163827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sogen Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 13.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136211

L

U X E M B O U R G

SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme en cours de liquidation

Référence de publication: 2011141859/11.
(110164286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sotrap Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».

R.C.S. Luxembourg B 29.540.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141861/9.
(110163830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sotrap Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».

R.C.S. Luxembourg B 29.540.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141862/9.
(110163831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Spike Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 134.223.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011141863/11.
(110164015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Eneris Wind Italia SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.759.

In the year two thousand eleven, on the thirtieth of September.
Before Maître Karine REUTER, notary, residing in Petange, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of
NERIS WIND ITALIA S.A.
a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,
having had its registered office at L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»),
incorporated following a deed of the Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, on April 21

st

 , 2005,

registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg, Section B, under the number B 107.759,
having a subscribed capital of EUR 118,520.- (one hundred eighteen thousand five hundred and twenty euros), divided

into 59,260 (fifty-nine thousand two hundred and sixty) shares with a par value of EUR 2.- (two euros) each

The meeting is presided by Maître Stephan LE GOUEFF residing professionally in Luxembourg, who appoints as se-

cretary Madame Candice DE BONI, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Maître Murielle BAUGNIET, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Verification of the convening notice;

136212

L

U X E M B O U R G

2) Appointment of an Auditor for the accounts 2008 and 2009;
3) Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor, presentation and approval of the annual

accounts as at December 31 

st

 , 2008 and December 31 

st

 , 2009;

4) Transfer of the registered office of the Company to its new adress in L1030 LUXEMBURG, 412F, route d'Esch and

modification of the 1 

st

 paragraph of article 2 of the articles of association;

5) Allocation of the results;
6) Discharge granted to the Board of Directors as well as to the Statutory Auditor for the financial years ending

December 31 

st

 , 2008 and December 31 

st

 , 2009;

7) Resignation of Mr Harry Sykes, director and president of the board of directors;
8) Modification of the number of directors;
9) Renewal of the mandate of three directors;
10) Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on

an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

D) This meeting has been duly convened by notices dated 22 

th

 of September as it appears from the copies presented

to the meeting Closed, the attendance list lets appear that, from the 59,260 (fifty-nine thousand two hundred and sixty)
shares, currently issued, 56.861 (fifty-six thousand eight hundred sixty-one) shares are present or duly represented at
the present extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide
validly on all of the items of the agenda.

E) That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. The

general meeting declares, accepts and recognizes that the present general meeting will have to take the decisions under
the majority conditions of Article 67-1 of the law of 1915 (2/3).

Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting notes that the general meeting has validly been convened by notices within the legal period.

<i>Second resolution

The general meeting notes that the former statutory auditor resigned with effect on the 29 

th

 of December 2009.

Therefore, the general meeting appoints with effect to the 1 

st

 of January 2010, until the general meeting stating on

the annual accounts of the Company as at December 31 

st

 , 2010, Fin-Contrôle S.A., having its registered office in L-1882

Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 42.230.

Furthermore, the general meeting gives special mandat to Fin-Contrôle S.A. in order to audit the annual accounts of

2008, 2009.

<i>Third resolution

After presentation of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor as well as of the annual

accounts as at December 31 

st

 2008 and December 31 

st

 , 2009, the general meeting refuses the annual accounts as at

December 31 

st

 , 2008 and December 31 

st

 2009.

The resolution has been refused by vote:
30.469 for the approbation of accounts,
26.392 against the approbation of accounts.
The shareholder ENERIS S.A. has refused to approuve the accounts 2008 and 2009 because the commissaire aux

comptes has indicated in his report that they are not certain that all documents were made available to them and that
they can not give an opinion about the annual accounts fot 2008 and 2009.

Moreover, ENERIS S.A. questions the paiment of the invoices of 31 

st

 August 2009 of ATMOSCLEAR S.A. for a total

amount 692.400.- euros which paiments were made by the Board of Directors without the knowledge and consent of
Mr Artur DELA in his capacity as director.

<i>Fourth Resolution

The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to its new address in L-2086 Luxemburg,

412F, route d'Esch.

The general meeting resolves to amend consequently the first paragraph of article 2 of the articles of association, as

follows:

136213

L

U X E M B O U R G

«The Corporation has its registered office in the municipality of the City of Luxemburg. The Board of Directors is

authorized to change the address of the Corporation inside the same municipality of the Corporation's corporate seat.»

<i>Fifth Resolution

As a consequence of the 3 

rd

 resolution, the general meeting agrees not to resolve upon the allocation of the results.

<i>Sixth Resolution

The general meeting does not grant discharge to the Board of Directors as well as to the Statutory Auditor for the

financial years ending December 31 

st

 , 2008 and December 31 

st

 , 2009.

The 6 

th

 resolution has been refused by vote:

30.469 for the discharge,
26.392 against the discharge.

<i>Seventh Resolution

The general meeting refuses the resignation of Mister Harry SYKES as director as well as president of the Board of

Directors and does not grant discharge to Mister Harry SYKES:

th

 resolution:

30.469 for the resignation
26.392 against the resignation

<i>Eight Resolution

As a consequence of the 7 

th

 resolution, the general meeting agrees not to resolve upon this point.

<i>Ninth Resolution

The general meeting resolves to renew the mandate of the following Directors until the general meeting stating on

the annual accounts of the Company as at December 31 

st

 , 2010:

- Mister Jerry BROOKS;
- Mister Artur DELA;
- Mister David SURTEES.
While Mr Artur DELA is member of the Board of Directors of the Company, he has neither been informed nor has

participated to the meetings and decisions made by the Board of Directors since his resignation as managing director
(save for the meetings on the 29/07/2011 and 12/08/2011) including the decision to pay the abovementioned invoices of
ATMOSCLEAR.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le trente septembre,
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société
ENERIS WIND ITALIA S.A.
une société anonyme régie par le droit luxembourgeois,
établie et ayant eu son siège social à L-5753 Frisange, 43 Parc Lésigny, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par Maitre Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 avril

2005,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 107.759
dont le capital émis s'élève à la somme de EUR 118.520,- (cent dix-huit mille cinq cent vingt euros), représenté par

59.260 (cinquante-neuf mille deux cent soixante) actions d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stéphan LE GOUEFF demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Candice DE BONI demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Murielle BAUGNIET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

136214

L

U X E M B O U R G

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Vérification des convocations à l'assemblée générale
2) Constatation de la démission du commissaire aux comptes à la date du 29 décembre 2009 et nomination d'un

nouveau commissaire aux comptes

3) Présentation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que du commissaire aux comptes; présentation et ap-

probation des comptes annuels au 31 décembre 2008 ainsi que des comptes annuels au 31 décembre 2009

4)  Transfert  du  siège  social  de  la  société  à  la  nouvelle  adresse  sise  à  L-1030  Luxembourg,  412F,  route  d'Esch  et

modification subséquente du 1 

er

 paragraphe de l'article 2 des statuts

5) Affectation des résultats
6) Décharge accordée aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour les années 2008 et 2009
7) Acceptation de la démission de Monsieur Harry SYKES
8) Diminution du nombre d'administrateurs
9) Renouvellement des mandats des administrateurs
10) Divers
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

D) La présente assemblée a été convoquée par courrier du 22 septembre 2011 ainsi qu'il a été prouvé à l'assemblée

par la présentation des copies.

Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 59.260 (cinquanteneuf mille deux cent soixante) actions,

actuellement émises, 56.861 (cinquante-six mille huit cent soixante-et-une) actions sont présentes ou dûment représen-
tées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à
prendre valable toutes décisions sur les points de l'ordre du jour.

E) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre

du jour. L'assemblée générale déclare, accepte et reconnaît que la présente assemblée générale doit prendre les décisions
dans les conditions de majorité prévues à l'article 67-1 de la loi (2/3).

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée constate que les formalités de convocation des actionnaires ont été respectées et que tous les actionnaires

ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais légaux.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale constate la démission du commissaire aux comptes à la date du 29 décembre 2009.
Par conséquent, l'assemblée générale nomme avec effet au 1 

er

 janvier 2010, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire

devant statuer sur les comptes annuels de l'année 2010 à la fonction de commissaire aux comptes la société anonyme
Fin-Contrôle S.A., établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, inscrit au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 42.230.

Par ailleurs, l'assemblée générale donne mandat spécial à la société Fin-Contrôle S.A. établie et ayant son siège social

à L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 42.230,
afin d'examiner les comptes pour les années 2008, 2009.

<i>Troisième résolution

Après présentation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes, ainsi qu'après présen-

tation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, l'assemblée générale refuse l'approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009.

La résolution a été refusée par vote comme suit:
30.469 pour l'approbation des comptes
26.392 contre l'approbation des comptes
L'actionnaire ENERIS S.A. a refusé d'approuver les comptes 2008 et 2009 alors que le commissaire aux comptes a

indiqué dans son rapport qu'ils ne sont pas certains que tous les documents étaient mis à leur disposition et qu'ils ne
peuvent pas donner une opinion sur les comptes annuels de 2008 et 2009.

136215

L

U X E M B O U R G

En outre, ENERIS S.A. s'interroge sur le paiement des factures du 31 août 2009 d'ATMOSCLEAR S.A. pour un montant

total de 692.400.-euros, ces paiements ayant été effectués par le Conseil d'Administration sans la connaissance et le
consentement de M. Artur DELA en sa qualité d'administrateur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-2086 Luxembourg,

412F, route d'Esch et de modifier en conséquence le 1 

er

 paragraphe de l'article 2 des statuts, comme suit:

«Le siège social est établi dans la Commune de la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à

changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.»

<i>Cinquième résolution

Eu égard à la 3 

e

 résolution, l'assemblée générale décide de ne pas statuer sur l'allocation des résultats.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale refuse de donner décharge au Conseil d'Administration ainsi qu'au commissaire aux comptes

pour l'exercice de leurs fonctions pendant les années sociales se terminant au 31 décembre 2008 et au 31 décembre
2009.

La 6 

e

 résolution a été refusée par vote comme suit:

30.469 pour la décharge
26.392 contre la décharge

<i>Septième résolution

L'assemblée générale refuse la démission de Monsieur Harry SYKES.

e

 résolution:

30.469 pour la résolutoire
26.392 contre la résolutoire

<i>Huitième résolution

Eu égard à la 7 

e

 résolution, l'assemblée générale décide de ne pas statuer sur ce point.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Jerry BROOKS, Monsieur Artur DELA et Monsieur

David SURTEES jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l'année 2010.

Alors que M. Artur DELA est membre du Conseil d'Administration de la société, il n'a été ni informé ni a participé

aux réunions et décisions du Conseil d'Administration depuis se démission comme administrateur-délégué (sauf réunions
des 29 juillet 2011 et 12 août 2011) y inclue la décision de payer les factures préqualifiées d'ATMOSCLEAR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: LEGOUEFF, DEBONI, BAUGNET, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 octobre 2011. Relation: EAC/2011/13171. Reçu soixante-quinze euros.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011138743/222.
(110160832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Stakotra International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 32.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136216

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour compte de Stakotra International S.A.
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2011141866/13.
(110163738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

St. Modwen Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 153.339.

Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141865/10.
(110163692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Strasbourg Investissement, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 110.412.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141868/9.
(110164377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sugarloaf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 116.682.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011141869/11.
(110164093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sugarloaf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 116.682.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011141870/11.
(110164282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Stefana S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 112.953.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136217

L

U X E M B O U R G

Clemency, le 16 septembre 2011.

SV SERVICES S.à r.l.
9, rue basse
L-4963 CLEMENCY
Signature

Référence de publication: 2011141867/14.
(110163704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Sunfive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 137.615.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011141871/10.
(110164263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Fininfra, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 137.745.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-six day of September.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing at Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AXA Infrastructure Partners FCPR,a fonds commun de placement à risque, represented by AXA Investment Managers

Private Equity Europe, a company governed by French law, having its registered office at 20, place Vendôme, 75001 Paris,
France and registered under number 403 201 882 RCS Paris,

hereby represented by Jennifer Ferrand, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23

September 2011.

The appearing is the sole shareholder of Fininfra, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, whose

registered office is at 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 137.745, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph
Wagner of 31 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 7 May 2008, number
1120 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been amended by a deed of the undersigned
notary, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, of 2 March 2011, published in the Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations dated 7 June 2011, number 1222.

The appearing party has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda

1 To increase the corporate capital by an amount of one hundred fiftyone thousand six hundred sixty-seven euro (EUR

151,667.-) so as to raise it from its present amount of one million nine hundred three thousand six hundred eighty-seven
euro (EUR 1,903,687.-) to two million fifty-five thousand three hundred fifty-four euro (EUR 2,055,354.-).

2 To issue one hundred fifty-one thousand six hundred sixty-seven (151,667) new shares with a nominal value of one

euro (EUR 1.-) per share and having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares with payment of a share premium in a total amount of fifty cents (EUR

0.50) by AXA Infrastructure Partners FCPR and to accept payment in full for such new shares by a contribution in cash.

4 To amend article 5 (first paragraph) of the articles of incorporation, in order to reflect the increase of the issued

capital of the Company.

5 Miscellaneous.
The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred fifty-

one thousand six hundred sixtyseven euro (EUR 151,667.-) so as to raise it from its present amount of one million nine
hundred three thousand six hundred eighty-seven euro (EUR 1,903,687.-) to two million fifty-five thousand three hundred
fifty-four euro (EUR 2,055,354.-).

136218

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to issue one hundred fifty-one thousand six hundred sixty-seven (151,667) new shares

with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share and having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared Jennifer Ferrand, prenamed, acting in her capacity as duly authorised attorney-in-fact of AXA

Infrastructure Partners FCPR, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Axa Infrastructure Partners FCPR, for one

hundred fifty-one thousand six hundred sixty-seven (151,667) new shares, each having a nominal value of one euro (EUR
1.-), with payment of a share premium amounting to fifty cents (EUR 0.50) and to make payment for such new shares and
the share premium by a contribution in cash.

The amount of one hundred fifty-one thousand six hundred sixty-seven euro and fifty cents (EUR 151,667.50) is thus

as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the one hundred

fifty-one thousand six hundred sixty-seven (151,667) new shares to AXA Infrastructure Partners FCPR.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles

of incorporation, which will from now on read as follows:

“ Art. 5. Capital (first paragraph). The issued capital of the Company is set at two million fifty-five thousand three

hundred fifty-four euro (EUR 2,055,354.-) divided into two million fiftyfive thousand three hundred fifty-four (2,055,354)
shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which have been fully paid-in.´

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at

one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing party, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known by the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-sixième jour de septembre.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AXA Infrastructure Partners FCPR, un fonds commun de placement à risque, représenté par AXA Investment Mana-

gers Private Equity Europe, une société de droit français, ayant son siège social à 20, place Vendôme, 75001 Paris, France
et enregistrée sous le numéro 403 201 882 RCS Paris,

représentée aux fins des présentes par Jennifer Ferrand, employé privée, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une

procuration donnée le 23 septembre 2011.

Le comparant est l'associé unique de Fininfra, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège

social à 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.745, constituée suivant acte notarié de
Maître Jean-Joseph Wagner en date du 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date
du 7 mai 2008, numéro 1120 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte
du notaire soussigné, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch en date du 2 mars 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 juin 2011, numéro 1222.

Le comparant a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la société d'un montant de cent cinquante et un mille six cent soixante-sept euros

(EUR 151.667,-) pour le porter de son montant actuel de un million neuf cent trois mille six cent quatre-vingt sept euros
(EUR 1.903.687,-) à deux millions cinquante-cinq mille trois cent cinquante-quatre euros (EUR 2.055.354,-).

2 Emission de cent cinquante et un mille six cent soixante-sept (151.667) actions nouvelles d'une valeur nominale de

un euro (EUR 1,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

136219

L

U X E M B O U R G

3 Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total

de cinquante centimes (EUR 0,50) par AXA Infrastructure Partners FCPR et acceptation de la libération intégrale de ces
actions nouvelles par apport en espèces.

4 Modification de l'article 5 (premier alinéa) des statuts de manière à refléter l'augmentation du capital social de la

Société.

5 Divers.
L'associé unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la société d'un montant de cent cinquante et un mille six

cent soixante-sept euros (EUR 151.667,-) pour le porter de son montant actuel de un million neuf cent trois mille six
cent quatre-vingt sept euros (EUR 1.903.687,-) à deux millions cinquante-cinq mille trois cent cinquante-quatre euros
(EUR 2.055.354,-).

<i>Deuxième résolution

L'associé unique a décidé d'émettre cent cinquante et un mille six cent soixante-sept (151.667) actions nouvelles d'une

valeur nominale de un euro (EUR 1,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

S'est  ensuite  présentée  Jennifer  Ferrand,  précitée,  agissant  en  sa  qualité  de  mandataire  dûment  autorisé  de  AXA

Infrastructure Partners FCPR, précitée, en vertu de la prédite procuration.

Le comparant a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de AXA Infrastructure Partners FCPR, à cent cinquante

et un mille six cent soixante-sept (151.667) actions nouvelles chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-),
avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de cinquante centimes (EUR 0,50) et de libérer intégralement ces
actions nouvelles et la prime d'émission par un apport en espèces.

Le montant de cent cinquante et un mille six cent soixante-sept euros et cinquante centimes (EUR 151.667,50) est à

partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite, l'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les cent cinquante et

un mille six cent soixante-sept (151.667) actions nouvelles à AXA Infrastructure Partners FCPR.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'associé unique a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article

5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital social. (Alinéa premier). Le capital social de la Société est fixé à deux millions cinquante-cinq mille

trois cent cinquante-quatre euros (EUR 2.055.354,-) divisé en deux millions cinquante-cinq mille trois cent cinquante-
quatre (2.055.354) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la même com-
parante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture  du  présent  acte  faite  et  interprétation  donnée  au  mandataire  de  la  partie  comparante,  connu  du  notaire

instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Ferrand, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 septembre 2011. Relation: RED/2011/2001. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 28 septembre 2011.

Référence de publication: 2011138773/141.
(110160621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

136220

L

U X E M B O U R G

Threadneedle (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.216.

Le bilan au 31 mars 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour THREADNEEDLE (Lux)
SICAV
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2011141873/14.
(110164295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Toulouse Manager, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.807.

Les comptes annuels au 31 janvier 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141876/9.
(110163700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Tasa Finance Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.439.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011141878/13.
(110164360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Team 31, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 31, rue d'Oradour.

R.C.S. Luxembourg B 74.741.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011141879/11.
(110163755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

TEH REFI 2009 Société Coopérative, Société Coopérative.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 156.335.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

136221

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2011141880/12.
(110163968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

TBL PG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.966.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

First Marine Finance Corporation N.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands Antilles, having

its registered office at Van Engelenweg 23, Willemstad, Curacao, registered with The Netherlands Antilles trade and
company registry under number 9818,

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on September 2,

2011.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- First Marine Finance Corporation N.V is the sole shareholder of "TBL PG S.àr.l.", a société à responsabilité limitée

having its registered office at 30, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.966. The Company was incorporated on June 18,
2010 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations -N°1571 of August 2, 2010.

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by one

thousand two hundred and fifty (1,250) shares having a nominal value of ten euros (EUR 10) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company decides to change the article 18 of the Company's articles of association, which

will henceforth read as follows:

“ 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after de-

duction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%)
of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company's nominal share capital.

Profits accrued by the Company shall result in an immediate and irrevocable commitment, booked as a deductible item

in accordance with article 46 (14) of the Luxembourg act dated 4 December 1967 on income tax (the Luxembourg Income
Tax Law 1967), to the Shareholder(s) regardless of the actual date of payment of dividends out of these profits, in any
form, or the accounting of such profits into a reserve account.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to distribute interim dividends at

any time under the following conditions:

- Interim accounts are established by the sole manager/board of managers,
- These accounts show a profit including profits carried forward,
- The decision to pay interim dividends is taken by the sole manager/the board of managers,
The payment is made once the company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the company

are not threatened.”

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

136222

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The

document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille onze, le treizième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

First Marine Finance Corporation N.V., une société constituée sous le droit des Antilles Néerlandaises, ayant son siège

social à Van Engelenweg 23, Willemstad, Curacao, immatriculée auprès du Registre de Commerce des Antilles Néerlan-
daises sous le numéro 9818,

ici représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2

septembre 2011,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- First Marine Finance Corporation N.V. est l'associé unique de «TBL PG S.àr.l.», une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 30, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.966. La Société a été constituée le 18 juin 2010 suivant
acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1571 du 2 août 2010.

- le capital social de la Société est actuellement de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) parts sociales de dix euros (EUR 10) chacune.

Ceci ayant été exposé, la partie comparante, agissant par son mandataire a requis le notaire soussigné d'acter ce qui

suit:

<i>Première résolution

L'associé unique de la Société a décidé de modifier l'article 18 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:

18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction

faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq
pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social.

Les bénéfices accumulés par la Société résultent en un engagement immédiat et irrévocable, comptabilisé dans un poste

déductible conformément à l'article 46 (14) de la loi luxembourgeoise du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu
(la Loi de l'Impôt sur le Revenu 1967) au profit des Associé(s) sans prise en compte de la date réelle du paiement des
dividendes provenant des bénéfices, quels qu'ils soient, ou de la comptabilisation de ces bénéfices dans un compte de
réserve.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de distribuer des dividendes intér-

imaires à tout moment selon les conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires ont été établis par le gérant unique/conseil de gérance,
- Ces comptes montrent un profit incluant les profits reportés,
- La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par le gérant unique/conseil de gérance.
Le paiement sera effectué lorsque la société aura la garantie que les droits des créanciers de la société ne sont pas

menacés.

Dont acte
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie par les présentes qu'à la demande de la partie com-

parante, le présent acte a été rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé en date qu'en tête des présentes à Luxembourg. Le document ayant été lu au mandataire des

parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2011. Relation: LAC/2011/42110. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

136223

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Référence de publication: 2011139055/105.
(110160940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

TMGE Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.173.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 28/9/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011141885/10.
(110163826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Top Ten International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 29, Marbuergerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Référence de publication: 2011141886/10.
(110164230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Topfin Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 63.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141887/9.
(110164010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Transactive Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 86.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011141891/9.
(110164319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

1A Gérances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 69.229.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ACA - Atelier Comptable &amp; Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2011141924/12.
(110163962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

136224


Document Outline

1A Gérances S.à r.l.

Dentsply Acquisition S.à r.l.

Dentsply Holdings S.à r.l.

Eneris Wind Italia SA

Fininfra

Octavian S.à.r.l.

Picarus N.V. S.A.

Rac Europe S.A.

Racing Experience S.à r.l.

Ratia S.A.

Restclair S.à r.l.

RH-Lorlux S.A.

RH-Lorlux S.A.

Richardson Investments (Castel Romano) S.à r.l.

Roumaninvest S.A.

Satul S.A.

Schiff Invest S.A.

Schiff Invest S.A.

Scripto

Sensus Metering Systems (Luxco 5) S.à r.l.

Servico S.A.

Shell Gas (LPG) Luxembourg S.A.

Shiraz S.A.

SHS Europe S.A.

SIEGEL SCHLEIMER Ingénieurs-conseils S.à r.l.

Simedex S.A.

SkillTeam Luxembourg

SK-Q8 Pommerlach SA

SK-Q8 Schmëtt SA

S. Michele S.A.

Société de Courtage pour l'Europe Centrale

Société de Participation Européenne et Internationale S.A. (SPEI S.A.)

Société Générale de Bâtiment

Sogecofi S.A.

Sogen Finance Luxembourg S.A.

Sotrap Sàrl

Sotrap Sàrl

Sotrap Sàrl

Spike Investments S.A.

Stakotra International S.A.

Stefana S.A.

St. Modwen Properties S.à r.l.

Strasbourg Investissement

Sugarloaf S.A.

Sugarloaf S.A.

Sunfive S.A.

SunGem SubSerFinCo S.à r.l.

Tasa Finance Lux S.àr.l.

TBL PG S.à r.l.

Team 31

TEH REFI 2009 Société Coopérative

Threadneedle (Lux)

TMGE Investments S.A.

Topfin Holding S.A.

Top Ten International s.à r.l.

Toulouse Manager

Transactive Management S.A.

Uranus Capital S.A.