This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2689
4 novembre 2011
SOMMAIRE
AGC & Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129034
Agri Ventures International S.A. . . . . . . . .
129034
Alfa Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129035
Alphabet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129035
Alphemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129033
Altice VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129027
Auberge THILLSMILLEN S.à r.l. . . . . . . . .
129033
Auto Seikel Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
129033
Autos-Métaux-Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
129035
Beaufort Lotissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .
129036
Bétons Feidt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129035
Budget Travel Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
129034
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129036
Cadogan Joseph II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
129037
Cadogan Joseph II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
129037
Cap Sud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129037
Carrières Feidt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129037
Carts & Kiosks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129036
Castel (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
129035
Castlement Management S.à r.l. . . . . . . . . .
129036
Cinven (Luxco 1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
129061
Circles Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129038
City-Image S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129038
Clover Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
129037
CMT SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129038
Cofima I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129038
ConvaTec Healthcare E S.A. . . . . . . . . . . . .
129037
Cosma Finance International S.A. . . . . . . .
129039
DAGNY GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129050
Décoman 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129039
Décoman 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129039
DH New Investment XI S.à r.l. . . . . . . . . . .
129040
DH Udine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129060
Diorasis International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
129060
Donneaux Conseils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
129060
Doralcapital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129069
Doranda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129039
Editions Plus S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129072
Elysion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129069
Energie & Environnement Ingénieurs-con-
seils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129072
Eni Algeria Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129070
Eni Pakistan (M) Limited . . . . . . . . . . . . . . . .
129070
Eni South China Sea Limited . . . . . . . . . . . .
129070
Entertainment Concepts S.A. . . . . . . . . . . .
129070
EOI Fire S.à rl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129072
Equidem S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129071
EREA Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .
129072
Eventsys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129072
Extensa Participations II S.àr.l. . . . . . . . . . .
129071
Extensa Participations II S.àr.l. . . . . . . . . . .
129071
Financière Daunou 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
129071
Finsteel Energy Investment S.A. . . . . . . . . .
129061
First London European Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129036
FLE SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129038
Freiburg Capital Development S.A. . . . . . .
129034
GKS Prop Co. B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129050
Green Flash S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129039
Green S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129061
Harbour LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129027
Hippo Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129040
IC Invest HOLDINGS S.A. . . . . . . . . . . . . . .
129061
Marinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
129026
Pegaso Marine Research S.A. . . . . . . . . . . . .
129026
Sampan Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
129070
Triton III LuxCo A 10 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
129027
129025
L
U X E M B O U R G
Marinvest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 28.612.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 septembre 2011i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011:
- Monsieur Salvatore MONACO, administrateur de sociétés, demeurant à Via Contrada Facolnara SNC, 96017 Noto
(SR), Italie, Président;
- Monsieur Arsène KRONSHAGEN, demeurant au 22, rue Marie Adélaïde, L - 2128 Luxembourg
- Monsieur Anacleto PROIETTI, retraité, demeurant à Via dei Levii, 29, 00174 Rome, Italie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2011.
Référence de publication: 2011133477/19.
(110153787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2011.
Pegaso Marine Research S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.290.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique et par le conseil d’administration en date du 4 août 2011i>
1. Le siège social de la société a été transféré de L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. La société à responsabilité limitée INTEGRAL MARITIME SOLUTIONS (IMS) S.àr.l. a démissionné de ses mandats
d’administrateur et d’administrateur-délégué.
3. M. André HARPES a démissionné de son mandat de commissaire.
4. M. Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né le 3 septembre 1971 à Bassano del Grappa (Italie), demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.
5. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 (trois) à 4 (quatre).
6. M. Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.
7. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58 545, avec siège social à L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme commissaire jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2012.
8. M. Alexander James FLEMMING a été nommé comme président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale statutaire de 2012.
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PEGASO MARINE RESEARCH S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011130484/29.
(110150214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2011.
129026
L
U X E M B O U R G
Altice VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.832.835,10.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 143.725.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du le 21 janvier 2011i>
L’associé unique a décidé de renouveler la mandat de gérant de Monsieur Laurent GODINEAU jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2011 en vue de l’approbation des comptes de la Société pour l’exercice
social clos au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131332/14.
(110151758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Harbour LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Triton III LuxCo A 10 S.à r.l.).
Capital social: USD 18.024,13.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.677.
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of August.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replace-
ment of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain the
depositary of the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Triton III LuxCo A 10 S.à r.l., a société à respon-
sabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the
"Company"), having been incorporated following a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch (Grand
Duchy of Luxembourg), dated 21 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1321 of 17 June 2011, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
159.677. The articles of incorporation have not yet been amended.
The meeting is declared open at 14:50 by Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, lawyer, with professional address in
Luxembourg, in the chair, who appointed, Mrs Monique DRAUTH, private employee, with professional address in Ram-
brouch, as secretary.
The meeting elected Me Marc FRANTZ, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman called upon the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1 To amend the financial year of the Company.
2 To change the currency of the subscribed capital of the Company from euro to dollars of the United States of
America by applying the exchange rate EUR 1.-= USD 1.4417.
3 To convert the existing subscribed capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) into eighteen thou-
sand twenty-one point twenty-five dollars of the United States of America (USD 18,021.25) divided into six hundred
twenty-five thousand (625,000) class A shares and six hundred twenty-five thousand (625,000) class B shares, each having
a nominal value of zero point zero one four four one seven dollars of the United states of America (USD 0.014417).
4 To increase the share capital of the Company by an amount of two point eighty-eight dollars of the United states of
America (USD 2.88) so as to raise it from its present amount of eighteen thousand twenty-one point twenty-five dollars
of the United States of America (USD 18,021.25) to an amount of eighteen thousand twenty-four point thirteen dollars
of the United states of America (USD 18,024.13).
5 To issue one hundred (100) new class A shares and one hundred (100) new class B shares with a nominal value of
zero point zero one four four one seven dollars of the United states of America (USD 0.014417) per share, having
respectively the same rights and privileges as the existing class A shares and class B shares.
6 To accept subscription for these new class A shares by TFF III Limited acting as general partner of Triton Fund III
F&F L.P. and these new class B shares by TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l. with a total share premium of forty-three
million two hundred fifty thousand nine hundred ninety-eight point fifty-six dollars of the United states of America (USD
43,250,998.56), and to accept full payment in cash for these new class A shares and new class B shares.
129027
L
U X E M B O U R G
7 To change the name of the Company to “Harbour LuxCo S.à r.l.”.
8 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the
capital increase.
9 To amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the name
change.
10 To amend and restate article 22 and article 23 of the articles of incorporation of the Company.
11 Miscellaneous.
(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) The entire share capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or represented
declaring that due notice had been given and that they had knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
(v) The present meeting is consequently properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, resolved unanimously that:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to close the current financial year that started on 21 March 2011 on the date hereof.
As a result, a new financial year shall start on the date hereof and end on 31 December 2011.
The general meeting further resolved to confirm that the Company's financial year for any subsequent year shall start
on the first day of January and end on the last day of December of the same year.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to change the currency of the subscribed capital of the Company from euro to dollars
of the United States of America by applying the exchange rate EUR 1.-= USD 1.4417.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to convert the existing subscribed capital of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) into eighteen thousand twenty-one point twenty-five dollars of the United States of America (USD 18,021.25)
divided into six hundred twenty-five thousand (625,000) class A shares and six hundred twenty-five thousand (625,000)
class B shares, each having a nominal value of zero point zero one four four one seven dollars of the United states of
America (USD 0.014417).
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of two point eighty-eight
dollars of the United states of America (USD 2.88) so as to raise it from its present amount of eighteen thousand twenty-
one point twenty-five dollars of the United States of America (USD 18,021.25) to an amount of eighteen thousand twenty-
four point thirteen dollars of the United states of America (USD 18,024.13).
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolved to issue one hundred (100) new class A shares and one hundred (100) new class B shares
with a nominal value of zero point zero one four four one seven dollars of the United states of America (USD 0.014417)
per share, having respectively the same rights and privileges as the existing class A shares and class B shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
1. TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.926 (“TRITON MAS-
TERLUXCO 3”), represented by Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, aforementioned, by virtue of a proxy given on 19
th
August 2011, which, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
TRITON MASTERLUXCO 3 declared to subscribe for one hundred (100) new class B shares with a nominal value of
zero point zero one four four one seven dollars of the United states of America (USD 0.014417) per share, and to fully
pay for such new class B shares together with a total share premium of forty-three million two hundred fifty thousand
nine hundred ninety-eight point fifty-six dollars of the United states of America (USD 43,250,998.56), by way of a con-
tribution in cash.
129028
L
U X E M B O U R G
2. TFF III Limited, a limited liability company governed by the laws of Jersey, having its registered office at 29 Esplanade
(1st Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Companies Registry at Jersey Financial Services
Commission under number 101339, acting as general partner of Triton Fund III F&F L.P., a limited partnership governed
by the laws of Jersey, with registered office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, and
registered with the Jersey Registrar of Limited Partnerships under number 1079 (“Triton Fund III F&F”), represented by
Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, aforementioned, by virtue of a proxy given on 19
th
August 2011, which, signed by
the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
Triton Fund III F&F declared to subscribe for one hundred (100) new class A shares with a nominal value of zero point
zero one four four one seven dollars of the United states of America (USD 0.014417) per share, and to fully pay for such
new class A shares by a contribution in cash.
The amount of forty-three million two hundred fifty-one thousand one point forty-four dollars of the United states of
America (USD 43,251,001.44) was forthwith at the disposal of the Company, evidence of which has been submitted to
the undersigned notary.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolved to accept said subscriptions and payments and to allot the new shares according to the
above mentioned subscriptions.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting resolved to change the Company's name to “Harbour LuxCo S.à r.l.”.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company
in order to reflect the above resolutions. Aforementioned paragraph will forthwith read as follows:
“The issued capital of the Company is set at eighteen thousand twenty-four point thirteen dollars of the United states
of America (USD 18,024.13) divided into six hundred twenty-five thousand one hundred (625,100) class A shares (the
“Class A shares”) and six hundred twenty-five thousand one hundred (625,100) class B shares (the “Class B shares”),
altogether referred to as the “shares”, each having a nominal value of zero point zero one four four one seven dollars of
the United states of America (USD 0.014417), fully paid up.”
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting resolved to amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation, which shall
forthwith read as follows:
“The Company will exist under the name of “Harbour LuxCo S.à r.l.”.
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting resolved to amend and restate article 22 and article 23 of the articles of incorporation of the
Company, which shall forthwith read as follows:
“ Art. 22. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated
to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to
ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
Subject to the following, the single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to
a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend.
In the event of a payment of a dividend, such dividends will be apportioned to the holders of the Class A Shares and
the holders of the Class B Shares as follows:
(a) first, each holder of Class A Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend (the “Preferred
Dividend”) in an amount of twenty (20) percent of the sum of its total contribution made to the Company to subscribe
for the shares held by it (including any share premium paid);
(b) second, the holders of Class B Shares shall be entitled to receive the remainder if the sums available for distribution.
Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the
case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance
payment.”
“ Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a
decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in article 19 of these
Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.
129029
L
U X E M B O U R G
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
After the payment of all debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall
be apportioned to the holders of the Class A Shares and the holders of the Class B Shares as follows: after repayment
of each shareholders' capital contribution (including any share premium paid), the net liquidation proceeds will be ap-
portioned to the holders of the Class A Shares and the holders of the Class B Shares according to the rules of priority
and proportions set out in article 22.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind payable by the Company by reason of this deed are estimated at six
thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).
There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 15:10.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of inconsistencies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-neuf août.
Par-devant nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant
en remplacement de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg), lequel
dernier nommé restera dépositaire de la minute.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de Triton III LuxCo A 10 S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-), avec siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
(la «Société») constituée par acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-duché de
Luxembourg), en date du 21 Mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1321 en
date du 17 juin 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.677.
Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 14:50 heures sous la présidence de Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, avocat,
demeurant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Madame Monique DRAUTH, employée
privée, demeurant professionnellement à Rambrouch.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Marc FRANTZ avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification de l'exercice social de la Société.
2 Changement de la devise du capital souscrit de la Société de l'euro au dollar des Etats-Unis d'Amérique par application
du taux de conversion EUR 1,-= USD 1,4417.
3 Conversion du capital souscrit existant d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) en dix-huit
mille vingt et un virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.021,25) représenté par six cent vingt-cinq
mille (625.000) parts sociales de catégorie A et six cent vingt-cinq mille (625.000) parts sociales de catégorie B, chacune
ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un quatre quatre un sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
0,014417).
4 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux virgule quatre-vingt-huit dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 2,88) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille vingt et un virgule vingt-cinq dollars des
Etats-Unis d'Amérique (USD 18.021,25) à dix-huit mille vingt-quatre virgule treize dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 18.024,13).
5 Émission de cent (100) nouvelles parts sociales de catégorie A et cent (100) nouvelles parts sociales de catégorie B,
d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un quatre quatre un sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 0,014417)
chacune, ayant respectivement les mêmes droits et privilèges que les parts sociales de catégorie A et les parts sociales
de catégorie B existantes.
6 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales de catégorie A par TFF III Limited agissant en tant que
general partner de Triton Fund III F&F L.P. et de ces nouvelles parts sociales de catégorie B, avec paiement d'une prime
129030
L
U X E M B O U R G
d'émission totale de quarante-trois millions deux cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit virgule cinquante-
six dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 43.250.998,56) par TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., à libérer intégrale-
ment en espèces.
7 Changement de dénomination sociale en «Harbour LuxCo S.à r.l.».
8 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.
9 Modification du troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter le changement de dénomination.
10 Modification et refonte des articles 22 et 23 des statuts de la Société.
11 Divers.
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils dé-
tiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.
(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale, et, les associés présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.
(v) La présente assemblée générale est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points
portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de clôturer à la date des présentes l'exercice social en cours débuté le 21 mars 2011.
Par conséquent, un nouvel exercice social débutera à la date des présentes et se clôturera au 31 décembre 2011.
L'assemblée générale a décidé en outre décidé de confirmer que l'exercice social de la Société pour les années à venir
débutera le premier jour du mois de janvier et finira le dernier jour du mois de décembre de la même année.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de changer la devise du capital souscrit de la Société de l'euro au dollar des Etats-Unis
d'Amérique par application du taux de conversion EUR 1,-= USD 1,4417.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de convertir le capital souscrit existant d'un montant de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) en dix-huit mille vingt et un virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.021,25) repré-
senté par six cent vingt-cinq mille (625.000) parts sociales de catégorie A et six cent vingt-cinq mille (625.000) parts
sociales de catégorie B, chacune ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un quatre quatre un sept dollars des
Etats-Unis d'Amérique (USD 0,014417).
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux virgule quatre-vingt-
huit dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2,88) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille vingt et un
virgule vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.021,25) à dix-huit mille vingt-quatre virgule treize dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 18.024,13).
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'émettre cent (100) nouvelles parts sociales de catégorie A et cent (100) nouvelles
parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un quatre quatre un sept dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 0,014417) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite ont comparu:
1. TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, avec siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926 («TRITON MASTER-
LUXCO 3»), représentée par Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 19
août 2011, qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.
TRITON MASTERLUXCO 3 a déclaré souscrire les cent (100) nouvelles parts sociales de catégorie B d'une valeur
nominale de zéro virgule zéro un quatre quatre un sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 0,014417) par part
sociale, et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales de catégorie B avec paiement d'une prime d'émission totale
de quarante-trois millions deux cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit virgule cinquante-six dollars des Etats-
Unis d'Amérique (USD 43.250.998,56) par un apport en espèces.
129031
L
U X E M B O U R G
2. TFF III Limited, une société à responsabilité limitée régie par les lois de Jersey, avec son siège social au 29 Esplanade
(1
er
étage), St Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE2 3QA, et inscrite auprès du Registre des Sociétés de la Com-
mission des Services Financiers de Jersey sous le numéro 101339, agissant en sa qualité de commandité pour le compte
de Triton Fund III F&F L.P., une société en commandite, régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 29 Esplanade
(1
er
étage), St Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes, JE2 3QA, et inscrite auprès du Registre des Sociétés en Commandite
de Jersey sous le numéro 1079 («Triton Fund III F&F»), représentée par Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, préqualifié,
en vertu d'une procuration donnée le 19 août 2011, qui, après avoir été signée par le mandataire et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte.
Triton Fund III F&F a déclaré souscrire les cent (100) nouvelles parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale
de zéro virgule zéro un quatre quatre un sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 0,014417) par part sociale, et
libérer intégralement ces nouvelles parts sociales de catégorie A par un apport en espèces.
Le montant de quarante-trois millions deux cent cinquante et un mille un virgule quarante-quatre dollars des Etats-
Unis d'Amérique (USD 43.251.001,44) a dès lors été mis à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve
ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'allouer les nouvelles parts
sociales conformément aux souscriptions ci-dessus mentionnées.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en «Harbour LuxCo S.à r.l.».
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les
résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société s'élève à dix-huit mille vingt-quatre virgule treize dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique (USD 18.024,13) représenté par six cent vingt-cinq mille cent (625.100) parts sociales de catégorie A (les «Parts
Sociales de Catégorie A») et six cent vingt-cinq mille cent (625.100) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de
Catégorie B»), ensemble les «parts sociales», chacune ayant une valeur nominale de zéro virgule zéro un quatre quatre
un sept dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 0,014417), et est entièrement libérée.»
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée générale a décide de modifier le troisième alinéa de l'article 1 des statuts de la Société qui alinéa sera
dorénavant rédigé comme suit:
«La Société adopte la dénomination “Harbour LuxCo S.à r.l.”.».
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier les articles 22 et 23 des statuts de la Société pour refléter les résolutions
ci-dessus. Lesdites articles seront dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets selon les conditions
suivantes. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le
reporter à nouveau ou de le distribuer comme dividendes.
En cas de paiement de dividendes, ces dividendes seront répartis entre les associés de la façon suivante:
(a) premièrement, chaque détenteur de Parts Sociales de Catégorie A aura droit à recevoir un dividende préférentiel
cumulatif (le «Dividende Préférentiel») d'un montant, pour chaque année sociale, égal à vingt pour cent (20%) de la somme
de son apport total fait à la Société pour souscrire les parts sociales détenues par celui-ci (incluant toute prime d'émission
payée) ,
(b) deuxièmement, les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront droit au restant des sommes disponibles
pour distribution.
Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes
aux associés dans les conditions établies par la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le ou les Gérant(s)
ou, selon le cas, le Conseil de Gérance déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes.»
« Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article 19 des
Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
129032
L
U X E M B O U R G
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net est réparti
entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B de la manière
suivante: après le remboursement de la contribution de chaque associé au capital (y compris les primes d'émission payées),
le produit net de la liquidation sera reparti entre les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A et les détenteurs de
Parts Sociales de Catégorie B selon les règles de priorité et de proportions énoncées à l'article 22.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15:10 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: M. Bertomeu-Savalle, M. Drauth, M. Frantz, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 23 août 2011. Relation: RED/2011/1765. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 23 août 2011
Référence de publication: 2011130094/338.
(110149805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2011.
Alphemi, Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1-3, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 76.523.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALPHEMI SA
Référence de publication: 2011131295/10.
(110151753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Auberge THILLSMILLEN S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8212 Mamer, 30, rue Baerendall.
R.C.S. Luxembourg B 26.383.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 17 août 2011i>
L’assemblée prend acte de la démission de Madame Françoise Loschetter avec effet au 31 août 2011.
Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131306/10.
(110151786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Auto Seikel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 136.398.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131307/10.
(110152142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129033
L
U X E M B O U R G
Budget Travel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 161.998.
Par résolutions prises en date du 19 juillet 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Fabio M. Giuseppetti, avec adresse au 33, King Street, SWIY 6RJ Londres, Royaume
Uni, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
2. Nomination d'Anthony Luzzatto Gardner, avec adresse au 124, Coleherne Court, Old Brompton Road, SW5 0EB,
Londres, Royaume Uni, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2011.
Référence de publication: 2011131347/15.
(110151573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Freiburg Capital Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 74.389.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement en date du 8 septembre 2011:i>
L'assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Madame Sabrina COLLETTE, avec adresse professionnelle au
18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, de Madame Séverine FEITLER, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l.,
ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011131880/17.
(110152119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
AGC & Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 83.183.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011131315/11.
(110152159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Agri Ventures International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 51.714.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AGRI VENTURES INTERNATIONAL S.A.
i>Cédric Barrington BLACKER / LARGO MANAGEMENT S.A.
- / Signature
<i>Administrateur-délégué / Administrateur Représentée par M. Joris Gyssaerti>
Référence de publication: 2011131316/13.
(110152106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129034
L
U X E M B O U R G
Alfa Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.706.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALFA INVEST S.A.
Référence de publication: 2011131324/10.
(110151790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Alphabet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 133.414.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131328/10.
(110151663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Autos-Métaux-Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4742 Pétange, 97, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 46.414.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131340/10.
(110151700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Bétons Feidt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1-3, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 8.804.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BÉTONS FEIDT SA
Référence de publication: 2011131341/10.
(110151754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Castel (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 127.676.
EXTRAIT
La société RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES, agissant en sa qualité de domiciliataire de la société anonyme CASTEL
(LUXEMBOURG) Sàrl (RCS Luxembourg B 127.676), dénonce le siège social de ladite société situé au 6 rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, avec effet au 22 septembre 2011, suite à la résiliation du contrat de domiciliation en date du 22 juin
2011.
Luxembourg, le 22 septembre 2011.
RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2011131358/14.
(110151718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129035
L
U X E M B O U R G
Beaufort Lotissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5201 Sandweiler, Z.I. Rôlach.
R.C.S. Luxembourg B 138.087.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011131343/10.
(110151793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 137.222.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131348/10.
(110151589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Carts & Kiosks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.062.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Carts & Kiosks S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011131357/11.
(110151880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
First London European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 122.193.
<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle des associés de la société tenue à Luxembourg en date du 13 septembre 2011.i>
Les actionnaires de la Société décide de renouveler le mandat de Monsieur François BROUXEL demeurant L-2320
Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, en qualité de gérant unique de la Société jusqu’à la tenue de l’assemblée
générale de la Société en relation avec l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011131440/13.
(110151864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Castlement Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 106.976.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011131359/11.
(110151474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129036
L
U X E M B O U R G
Clover Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 8.750,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 129.901.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131363/11.
(110151941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Cap Sud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.353.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CAP SUD S.A.
Référence de publication: 2011131370/10.
(110151885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
ConvaTec Healthcare E S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.248.
Les comptes annuels pour la période du 23 août 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131364/11.
(110151536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Cadogan Joseph II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.874.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011131366/9.
(110151798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Cadogan Joseph II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.874.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011131367/9.
(110151799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Carrières Feidt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1-3, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 11.760.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
129037
L
U X E M B O U R G
CARRIERES FEIDT SA
Référence de publication: 2011131372/10.
(110151752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
FLE SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 141.600.
<i>Extrait de la décision prise par l’associé gérant commandité en date du 22 septembre 2011i>
Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte à L-1420 Luxembourg,
7, avenue Gaston Diderich.
Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLE SICAV-FIS
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2011131441/15.
(110151638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Circles Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 115.423.
L’adresse du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est désormais la suivante:
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131376/11.
(110152034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
City-Image S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3370 Leudelange, 8, Z.I. Grasbusch.
R.C.S. Luxembourg B 60.050.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131377/10.
(110152045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
CMT SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3726 Rumelange, 7, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 149.241.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011131378/10.
(110152118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Cofima I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.302.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
129038
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131379/10.
(110152053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Green Flash S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.431.
Lors de l'assemblée générale annuelle reportée des actionnaires tenue en date du 29 juillet 2011, les actionnaires ont
décidé de renouveler le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS, avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471
Luxembourg, en tant que Commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2011.
Référence de publication: 2011131449/13.
(110151685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Cosma Finance International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 66.035.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2011131381/11.
(110151835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Décoman 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.174.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131385/10.
(110151690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Décoman 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.175.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131386/10.
(110151689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Doranda S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
129039
L
U X E M B O U R G
DORANDA S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011131389/12.
(110151847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
DH New Investment XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2448 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.296.
Les comptes annuels pour la période du 13 juillet 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131394/12.
(110151533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Hippo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 163.461.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twelfth of September;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
1) PARTNERS & PARTNERS S.à r.l., a private limited liability company, existing under the law of Luxembourg, having
its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
here represented by Mr. François LANNERS, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August
1
st
, 2011;
2) Mr. Niels BAKKER, born on January 26, 1973 in 's-Gravenhage (the Netherlands), with professional address c/o
ECO GROUP ASIA LIMITED, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong Kong,
here represented by Mr. François LANNERS, prenamed, by virtue of a proxy given on July 27
th
, 2011;
3) Mr. Jaap Derk BUMA, born on August 27, 1972 in 's-Gravenhage (the Netherlands), with professional address c/o
ECO GROUP ASIA LIMITED, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong Kong,
here represented by Mr. François LANNERS, prenamed, by virtue of a proxy given on August 1
st
, 2011.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
HIPPO HOLDING S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
129040
L
U X E M B O U R G
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests
in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for a period of fifty (50) years from incorporation.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Partners' Agreement
Art. 5. Partners' Agreement.
5.1 The partners are bound by a partners' agreement dated September 12
th
, 2011, as amended from time to time;
III. Capital - Shares
Art. 6 Capital.
6.1 The Company's corporate capital is fixed at ONE MILLION FIVE HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND EIGHT
HUNDRED US DOLLARS (USD 1,570,800.-), represented by ONE MILLION FIVE HUNDRED AND SEVENTY THOU-
SAND EIGHT HUNDRED (1,570,800) shares in registered form with a par value of ONE US DOLLAR (USD 1.-) each,
all subscribed and fully paid-up.
6.2 The Board of Managers is authorized to increase the initial corporate capital by THREE MILLION FOUR HUN-
DRED TWENTY-NINE THOUSAND AND TWO HUNDRED US DOLLARS (USD 3,429,200.-) in order to raise it from
ONE MILLION FIVE HUNDRED AND SEVENTY THOUSAND EIGHT HUNDRED US DOLLARS (USD 1,570,800.-)
to FIVE MILLION US DOLLARS (5,000,000.-) as the case may be by the issue of THREE MILLION FOUR HUNDRED
TWENTY-NINE THOUSAND AND TWO HUNDRED (3,429,200) shares of a par value of ONE US DOLLAR (USD
1.-) each, having the same rights as the existing shares.
6.3 The Board of Managers is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new partners, finally to fix all
other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution, to
have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of capital
and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized and duly
documented increase of capital, in accordance with the law of August 10
th
, 1915 and especially under the condition that
the authorization has to be renewed every five years.
129041
L
U X E M B O U R G
6.4 Moreover, the Board of Managers is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered form, with
any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of
the authorized capital.
6.5 The Board of Managers shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reim-
bursement and any other conditions which may be related to such bond issue.
6.6 A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
6.7 With respect to the conditions set forth hereinbefore, the Board of Managers is authorized to increase the cor-
porate capital even by incorporation of free reserves.
6.8 The Board of Managers is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase
of capital within the limits of the authorized capital.
6.9 The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general
meeting of partners deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The Company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Art. 7. Shares.
7.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
7.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
7.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
IV. Management - Representation
Art. 8. Board of managers.
8.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
8.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated “Category A Managers” and
“Category B Managers”.
8.3 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
9.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 10. Procedure.
10.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
10.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
10.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
10.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
10.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
129042
L
U X E M B O U R G
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
10.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
10.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 11. Representation.
11.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and
by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.
11.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the
Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.
11.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.
Art. 12. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
V. General meetings of partners
Art. 13. Powers and Voting rights.
13.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
13.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
13.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 14. Form - Quorum - Majority.
14.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
14.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
14.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
VI. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 15. Accounting Year.
15.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
15.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
15.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
16.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the
Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholders.
129043
L
U X E M B O U R G
VII. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VIII. General provision
Art. 18. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2011.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of the Company thus having been established, the one million five hundred and seventy thousand eight
hundred (1,570,800) shares have been subscribed as follows:
1) The company PARTNERS & PARTNERS S.à r.l., prenamed, twenty-five thousand shares, . . . . . . . . . .
25,000
2) Mr. Niels BAKKER, prenamed, one million ten thousand two hundred shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,010,200
3) Mr. Jaap Derk BUMA, prenamed, five hundred thirty-five thousand six hundred shares, . . . . . . . . . . .
535,600
Total: one million five hundred seventy thousand eight hundred shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,570,800
All the share quotas have been fully paid up by the aforesaid subscribers by a contribution in kind of:
- for the subscriber sub 1), by payment in cash up to the amount of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000.-),
so that the said sum is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary
by a bank certificate, who states it expressly;
- for the subscriber sub 2), by a contribution in kind of five thousand and fifty-one (5,051) shares, representing 25.25%
of the share capital of the limited liability company governed by the laws of Hong Kong “Eco Group Asia Limited”,
established and having its registered office in 1601 Hollywood Centre, Central Hong Kong, registered with the Hong
Kong Companies Registry under the number 1421972 (the "Contribution 1"); and
- for the subscriber sub c), by a contribution in kind of two thousand six hundred and seventy-eight (2,678) shares,
representing 13.39% of the share capital of the company “Eco Group Asia Limited”, prenamed, (the "Contribution 2");
(the Contribution 1 and the Contribution 2 are hereinafter referred to as the "Contribution");
<i>Valuation of the contributioni>
The Contribution is valued at least at one million five hundred forty-five thousand eight hundred US Dollars (1,545,800.-
USD), pursuant to a valuation report (the "Report") established and issued by Concordia Capital LC, Doha, Qatar.
The Report, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, will be annexed
to the present deed for the purpose of registration.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The aforesaid subscribers declare:
- that all the shares are fully paid up;
- that there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to acquire
one or several shares;
- that such shares are legally and conventionally freely transferable;
- that they are, in their quality as contributor, the sole owners of the shares brought in;
- that all formalities shall be carried out in Hong Kong in order to formalise the transfer and to render them effective
anywhere and towards any third party.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand six hundred Euros (EUR 2,600.-).
129044
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share
capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- H.E Sheikh Khalifa JABOR M.J. AL-THANI, passport number S013267, born on January 1
st
, 1964, in Doha (Qatar),
residing Al-Jabor Building, C-Ring Road, Al Mansoura Area, PO Box 24024, Doha, Qatar;
- Mr. Niels BAKKER, passport number BN37B7F58, born on January 1, 1973 in 's-Gravenhage (the Netherlands), with
professional address c/o Eco Group Asia Limited, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong
Kong;
- Mr. Jaap Derk BUMA, passport number BX0B3D7J1, born on August 27, 1972 in 's-Gravenhage (the Netherlands),
with professional address c/o Eco Group Asia Limited, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong
Kong;
- Mr. Philippe JOUARD, passport number 08CX07103, born on September 14, 1961 in Aix-en-Provence (France),
with professional address Qatar Financial Centre (Tower 1), 7
th
Floor, Suite 703, Doha, Qatar.
2. The registered office of the Company is set at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le douze septembre;
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) PARTNERS & PARTNERS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur François LANNERS, employée, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 1
er
août 2011.
2) Monsieur Niels BAKKER, né le 26 janvier 1973 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle c/o
ECO GROUP ASIA LIMITED, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong Kong,
ici représenté par Monsieur François LANNERS, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 27 juillet 2011.
3) Monsieur Jaap Derk BUMA, né le 27 août 1972 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle c/o
ECO GROUP ASIA LIMITED, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong Kong,
ici représenté par Monsieur François LANNERS, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 1
er
août 2011.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et
le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d'une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination HIPPO HOLDING S.à
r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
129045
L
U X E M B O U R G
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une période de cinquante (50) ans à partir de sa constitution.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Pacte d'associés
Art. 5. Pacte d'associés.
5.1 Les associés sont liés par un pacte d'associés daté du 12 septembre 2011, comme modifié de temps à autre.
III. Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital.
6.1 Le capital social est fixé à UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENTS DOLLARS US (USD
1.570.800,-), représenté par UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENTS (1.570.800) parts sociales
sous forme nominative d'une valeur nominale d'UN DOLLAR US (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
6.2 Le conseil de gérance est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de TROIS MILLIONS QUATRE
CENT VINGT-NEUF MILLE DEUX CENTS DOLLARS US (USD 3.429.200,-) pour le porter de son montant actuel de
UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENTS DOLLARS US (USD 1.570.800,-) à CINQ MILLIONS
DE DOLLARS US (USD 5.000.000,-), le cas échéant par l'émission de quatre millions neuf cent soixante-neuf mille deux
cent quatre-vingt-douze (4.969.292) parts sociales nouvelles d'US DOLLAR US (USD 1,-) chacune, jouissant des mêmes
droits que les parts sociales existantes.
6.3 En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les nouvelles parts
sociales éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux associés, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des nouvelles
parts sociales, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec
les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
129046
L
U X E M B O U R G
6.4 De même, le conseil de gérance est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que
toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
6.5 Le conseil de gérance déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait.
6.6 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
6.7 Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le Conseil de gérance est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres.
6.8 Le Conseil de gérance a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être
augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de
modifications des statuts.
6.9 La société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la loi.
Art. 7. Parts sociales.
7.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
7.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
7.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
7.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
IV. Gestion - Représentation
Art. 8. Conseil de gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.
8.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement “Gérants de
catégorie A” et “Gérants de catégorie B”.
8.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
9.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
Art. 10. Procédure.
10.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
10.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
10.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
10.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
10.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
129047
L
U X E M B O U R G
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
10.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
10.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 11. Représentation.
11.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
11.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.
11.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 9.2. des Statuts.
Art. 12. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements
sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
V. Assemblée Générale des associés
Art. 13. Pouvoirs et Droits de vote.
13.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
13.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
13.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.
14.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
14.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
14.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
VI. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 15. Exercice social.
15.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
15.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
16.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
129048
L
U X E M B O U R G
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.
VII. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VIII. Disposition générale
Art. 18. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2011.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les un million cinq cent soixante-dix mille huit cents (1.570.800) parts
sociales ont été souscrites comme suit:
1) La société PARTNERS & PARTNERS S.à r.l., prédésignée, vingt-cinq mille parts sociales, . . . . . . . . . .
25.000
2) Monsieur Niels BAKKER, préqualifié, un million dix mille deux cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . 1.010.200
3) Monsieur Jaap Derk BUMA, préqualifié, cinq cent trente-cinq mille six cents parts sociales, . . . . . . . .
535.600
Total: un million cinq cent soixante-dix mille huit cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.570.800
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par les souscripteurs prédits moyennant apport en nature de:
- pour le souscripteur 1), moyennant un versement à hauteur d'un montant de vingt-cinq mille dollars US (USD
25.000,-), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé
au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément;
- pour le souscripteur 2), moyennant un apport en nature de cinq mille et cinquante et une (5.051) parts sociales,
représentant 25,25% du capital social de la société à responsabilité limitée régie par les lois de Hong Kong “Eco Group
Asia Limited”, établie et ayant son siège social à 1601 Hollywood Centre, Central Hong Kong, inscrite au "Hong Kong
Companies Registry" sous le numéro 1421972 (l'"Apport 1"); et
- pour le souscripteur 3), moyennant un apport en nature de deux mille six cent soixante-dix-huit (2.678) parts sociales,
représentant 13,39% du capital social de la société “Eco Group Asia Limited”, prédésignée, (l'"Apport 2");
(l'Apport 1 et l'Apport 2 sont ci-après désignées ci-après l'"Apport")
<i>Evaluation de l'apporti>
L'Apport est estimé à au moins un million cinq cent soixante-dix mille huit cents US Dollars (1.570.800,- USD), en
vertu d'un rapport d'évaluation dressé et émis par Concordia Capital LC, Doha, Qatar (le "Rapport").
Le Rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux
présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Les souscripteurs prédits déclarent:
- que toutes parts sociales sont entièrement libérées;
- qu'il n'existe ni de droit de préemption, ni d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit
d'en acquérir une ou plusieurs parts sociales;
- que lesdites parts sociales légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- qu'ils sont, en leurs qualités d'apporteurs, les seuls propriétaires des parts sociales apportées;
- que toutes formalités seront réalisées à Hong Kong aux fins de formaliser les transferts et de les rendre effectifs
partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille six cents euros
(EUR 2.600,-).
129049
L
U X E M B O U R G
<i>Décision des associési>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- H.E Sheikh Khalifa JABOR M.J. AL-THANI, passeport numéro S013267, né le 1
er
janvier 1964 à Doha (Qatar),
demeurant au Al-Jabor Building, C-Ring Road, Al Mansoura Area, PO Box 24024, Doha, Qatar;
- Monsieur Niels BAKKER, passeport numéro BN37B7F58, né le 26 janvier 1973 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), avec
adresse professionnelle c/o Eco Group Asia Limited, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong
Kong;
- Monsieur Jaap Derk BUMA, passeport numéro BX0B3D7J1, né le 27 août 1972 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), avec
adresse professionnelle c/o Eco Group Asia Limited, RM 1601, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, Hong
Kong;
- Monsieur Philippe JOUARD, passeport numéro08CX07103, né le 14 septembre 1961 à Aix-en-Provence (France),
demeurant au Qatar Financial Centre (Tower 1), 7
th
Floor, Suite 703, Doha, Qatar.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. LANNERS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 septembre 2011. LAC/2011/40644. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
Référence de publication: 2011130380/550.
(110150210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2011.
DAGNY GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 99.410.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011131392/9.
(110151637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
GKS Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 163.357.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirty first day of August.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 158.362,
here represented by José María Ortiz, Director, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 21 July 2011.
129050
L
U X E M B O U R G
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "GKS Prop Co. B S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
129051
L
U X E M B O U R G
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing
three-quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board
are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(VII) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers.
The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by
them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the
manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
129052
L
U X E M B O U R G
10.2. Notices, Quorum, Majority and Voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement
such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of ECE Real Estate Partners S.a
r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel investment
agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further parties and
such consent shall be documented in writing:
(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.
(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.
(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion
of the Company's ownership) real estate financings.
(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the
proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
129053
L
U X E M B O U R G
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.a r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Dr. Yves Marie Edmee Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg; and
129054
L
U X E M B O U R G
b. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19,
rue des Lilas, L-8035 Strassen; and
c. Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond
Reuter, L-5326 Contern.
2. The registered office of the Company is established at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present
deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Contern by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am einunddreißigsten Tag des Monats August im Jahre zweitausendelf.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxem-
burg.
ERSCHIENEN:
Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reu-
ter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 158.362,
hier vertreten durch José Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, mit Geschäftsadresse in 17, rue Edmond Reuter,
L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 21 Juli 2011 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „GKS Prop Co. B S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann
durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
129055
L
U X E M B O U R G
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte
Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Gesellschafts-
anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
129056
L
U X E M B O U R G
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse
des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern un-
terzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-
bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
129057
L
U X E M B O U R G
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-
plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.ä r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:
(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.
(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.
(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.
(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
129058
L
U X E M B O U R G
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflosung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-
beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.ä r.l., wie
vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem
Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,-).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend euros (EUR 1.000,-) betragen.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-
neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Dr. Yves Marie Edmee Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg; und
129059
L
U X E M B O U R G
b. Ulrich Binninger, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland,
geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen; und
c. Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Contern aufge-
nommen wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, dem
Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit
dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J.M. Ortiz, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert le 6 septembre 2011. Relation: RED/2011/1853. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): KIRSCH.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Rambrouch, den 12. September 2011.
Référence de publication: 2011127699/531.
(110146828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2011.
DH Udine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.802.
Les comptes annuels pour la période du 13 octobre 2009 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131395/12.
(110151534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Diorasis International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 153.091.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131396/10.
(110151967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Donneaux Conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 75.515.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131397/10.
(110151894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129060
L
U X E M B O U R G
Green S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 41.363.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011131462/13.
(110152033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
IC Invest HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 64.169.
Madame Fentje Stefanie JUNGEN demeurant au Tsingtauer Str. 84, D-81827 Munich, Allemagne, a démissionné avec
effet au 31 août 2011 de son mandat d'administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
IC Invest Holdings S.A.
Signature
Référence de publication: 2011131475/13.
(110152092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Finsteel Energy Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 144.316.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011131438/9.
(110151816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Cinven (Luxco 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 163.382.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(1) Bruno Schick, Manager, born on 4
th
September 1971 in Ehingen (Donau) (Germany), professionally residing at
Main Tower, Neue Mainzer, Str. 52, 60311 Frankfurt am Main, Germany,
(2) Roberto Italia, Manager, born on 5
th
July 1966 in Rome, Italy, professionally residing at Via Manzoni, 30, 20121
Milano, Italy,
(3) Joseph Wan, Manager, born on 30
th
May 1969 in Hong Kong, professionally residing at Suite 5812-14, Two
International Finance Centre, 8, Finance Street, Central, Hong Kong,
each represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to proxies dated 8 resp. 9
September 2011 which shall be registered together with the present deed.
The appearing parties have requested the undersigned notary to draw up the articles of association of a limited liability
company named Cinven (Luxco 1) S.à r.l. ("société à responsabilité limitée") which is hereby established as follows:
129061
L
U X E M B O U R G
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Cinven (Luxco 1)
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twenty one thousand Euro (€ 21,000) divided
into two million one hundred thousand (2,100,000) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by a sole manager or a board of managers appointed
as a collegiate body by the general meeting of shareholders. The sole manager or the members of the board of managers
may but need not be shareholders. The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision
of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is
indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their ap-
pointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be. Vis-à-vis third parties
the sole manager or the board of managers as the case may be, has the most extensive powers to act on behalf of the
Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relating to the Company not
reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.
The board of managers may elect a chairman and one or more vice chairman. Any manager may participate in any
meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by
conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board of
managers by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
129062
L
U X E M B O U R G
Meetings of the board of managers shall be called by the chairman of the board of managers or any two board members.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers five (5) days at least in advance
of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the notice period may be shortened
and the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case
of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of commu-
nication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the members of the board of
managers of the Company (including by way of representation).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable, facsimile, email or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including
circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the signatures of two man-
agers or as decided by the board of managers.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any two managers or as may be resolved by
the board of managers at the relevant meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by any two managers, or as may be resolved at the relevant meeting or a
subsequent meeting.
The Company will be bound by the signature of the sole manager or in the case of a board of managers by the joint
signature of any two managers, as the case may be, or by the joint or single signature of any person or persons to whom
such signatory power shall have been delegated by the sole manager or the board of managers or in case of a board, by
any two managers (including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer: (i) Against any liability to the Company or its Share-
holders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the
conduct of his office; (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in
bad faith and not in the interest of the Company; or (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been
approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval
129063
L
U X E M B O U R G
of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements,
on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first
Tuesday of the month of June at 11:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on the last day of the
month of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation
and end on 31
st
December 2012.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
subscribed and entirely paid-up two million (2,100,000) shares as set forth below:
Subscriber
Number
of Shares
Payment
Bruno Schick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700,000 EUR 7,000
Roberto Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700,000 EUR 7,000
Joseph Wan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700,000 EUR 7,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,100,000
EUR
21,000
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand Euro (€ 21,000) is available
to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,300.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
129064
L
U X E M B O U R G
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
Name
professional or private
Address
Title
Date of birth
City and country
of birth
Danielle Arendt-Michels
(alias Danièle)
42 Op Fanckenacker,
L-3265 Bettembourg
Chartered
Accountant
9
th
January 1961
Ettelbruck
(Luxembourg)
Kevin Whale
Warwick Court Paternoster
Square London EC4M 7AG
Manager
6
th
May 1959
High Wicomb
(United King-
dom)
Bruno Schick
Main Tower, Neue Mainzer,
Str. 52, 60311 Frankfurt
am Main, Germany
Manager
4
th
September 1971 Ehingen (Donau)
(Germany)
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December 2012.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to appearing parties, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said appearing parties signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French.
In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le treizième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg.
Ont comparu:
(1) Bruno Schick, manager, né le 4 septembre 1971 à Ehingen (Donau) (Allemagne), avec résidence professionnelle au
Main Tower, Neue Mainzer, Str. 52, 60311 Frankfurt am Main, Allemagne,
(2) Roberto Italia, manager, né le 5 juillet 1966 à Rome, Italie, avec résidence professionnelle au Via Manzoni, 30, 20121
Milano, Italie,
(3) Joseph Wan, manager, né le 30 mai 1969 à Hong Kong, avec résidence professionnelle au Suite 5812-14, Two
International Finance Centre, 8, Finance Street, Central, Hong Kong,
représentés par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu des procurations en date du 8
resp. 9 septembre 2011, lesquelles seront enregistrées avec le présent acte.
Les parties comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une
société à responsabilité limitée dénommée Cinven (Luxco 1) S.à r.l. qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite
associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Cinven (Luxco 1) S.à r.l." (la "Société"). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de
son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermé-
diaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie
de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)
à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société (y compris vers le haut et sur le coté) prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
129065
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,
du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt et un mille Euros (€ 21.000) divisé en deux
millions cent mille (2.100.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Centime d'Euro (€ 0,01) chacune. Le capital de
la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification
des présents Statuts.
Toute prime d'émission disponible est distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés
représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un gérant unique ou un conseil de gérance nommé en
tant qu'organe collégial par l'assemblée générale des associés. Le gérant unique ou les membres du conseil de gérance
peut/peuvent ou non être associé(s)
Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée
de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad
nutum) et à tout moment.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la
Société et pour autoriser et/ou exécuter tous actes de disposition et d'administration en relation avec les objets de la
Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont
de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou le
conseil de gérance le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes
circonstances et de faire, d'autoriser et d'approuver tous les actes et opérations relatives à la Société non réservés par
la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou tels qu'ils peuvent être prévus dans les statuts.
Le conseil de gérance peut élire un président et un ou plusieurs vice-président(s).
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de
gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter. Les
réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président du conseil de gérance ou deux des membres du
conseil. Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins cinq (5) jours avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la durée de l'avis peut être raccourci et la nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à
la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen
de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins une majorité des gérants et présente
ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des membres
du conseil de gérance de la Société (y compris par voie de représentation).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous les signatures de deux gérants ou tel qu'il est décidé par le conseil de gérance.
129066
L
U X E M B O U R G
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance seront signés par deux gérants ou tel qu'il peut en être
décidé par le conseil de gérance lors de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par deux des gérants, ou tel qu'il peut en être décidé lors de la réunion ou lors d'une
réunion ultérieure.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique , ou dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
conjointe de deux gérants, le cas échéant, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou le conseil de gérance ou en cas de conseil, par deux
des gérants (y compris par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou
procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités. Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou
responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article. Article 9. Droits de vote des associés Chaque associé peut participer aux décisions collectives.
Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute
assemblée des associés par un mandataire spécial.
Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas
échéant) représente l'entièreté des associés de la Société.
Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité
comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée).
Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.
129067
L
U X E M B O U R G
A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l'assemblée générale annuelle sera
tenue le premier mardi du mois de juin de chaque année à 11:00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée
sera tenue le jour ouvrable suivant.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le dernier jour du
mois de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se
termine le 31 décembre 2012.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la
Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant
ou le cas échéant par le conseil de gérance , duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement libéré
les deux millions cent mille (2.100.000) parts sociales tel qu'indiqué ci-dessous:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Paiement
Bruno Schick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000 EUR 7.000
Roberto Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000 EUR 7.000
Joseph Wan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000 EUR 7.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100.000
EUR
21.000
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par paiement en espèces de sorte que la somme de vingt
et un mille Euros (€ 21.000) est à la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa
constitution sont évaluées à environ EUR 1.300,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
129068
L
U X E M B O U R G
Nom
Adresse
Profession
Date de naissance
Pays et lieu de
naissance
Danielle Arendt-Michels
(alias Danièle)
42 Op Fanckenacker,
L-3265 Bettembourg
Expert
Comptable
9 janvier 1961
Ettelbruck
(Luxembourg)
Kevin Whale
Warwick Court Paternoster
Square London EC4M 7AG
Manager
6 mai 1959
High Wicomb
(Royaume-Uni)
Bruno Schick
Main Tower, Neue Mainzer,
Str. 52, 60311 Frankfurt
am Main, Allemagne
Manager
4 septembre 1971
Ehingen (Donau)
(Allemagne)
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le document ayant été lu aux parties comparantes, qui ont requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise,
lesdites personnes comparantes ont signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de
la langue anglaise. Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Signé: T. HOSS – H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 septembre 2011. Relation: LAC/2011/40401. Reçu soixante-quinze euros
(75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le quatorze septembre de l'an deux mille onze.
Référence de publication: 2011128188/429.
(110148118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.
Doralcapital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.479.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131398/10.
(110151650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Elysion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 130.728.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011131400/11.
(110151950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129069
L
U X E M B O U R G
Sampan Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 109.457.
<i>Dépôt rectificatif suite à une erreur du dépôt initial, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 aoûti>
<i>2010 et dont les références du document initial sont L100122949.i>
Le Conseil de Gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L - 1653
Luxembourg au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, avec effet au 2 Août 2010.
Luxembourg, le 29 août 2011.
Pour extrait conforme
Christelle Ferry
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011131727/16.
(110150277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2011.
Eni Algeria Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.540.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2011131401/11.
(110151913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Eni Pakistan (M) Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.539.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2011131402/11.
(110151961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Eni South China Sea Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 85.538.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2011131403/11.
(110151771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Entertainment Concepts S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 141.819.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
129070
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131404/10.
(110151587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Financière Daunou 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 131.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131428/11.
(110151537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Extensa Participations II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 103.620.
<i>Extrait des résolutions des associés du 11 juillet 2011i>
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat se terminant lors de l’approbation des comptes annuels de la société
au 31 décembre 2011:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Münsbach.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 septembre 2011.
Référence de publication: 2011131406/14.
(110151664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Equidem S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 4, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 148.087.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2011i>
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2011, les deux gérants de la société à responsabilité
limité EQUIDEM SARL, ont pris la résolution de transférer le siège social du 57, rue Kennedy L-4599 Differdange au 4,
rue Emile Mark L-4620 Differdange, avec effet à partir du 27 septembre 2011.
Luxembourg, le 21 septembre 2011.
Alain FEIEREISEN / Patrick SIEBENALER
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2011131417/14.
(110151802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Extensa Participations II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 103.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131407/10.
(110152055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
129071
L
U X E M B O U R G
Editions Plus S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3370 Leudelange, 8, Zone Industrielle de Grasbusch.
R.C.S. Luxembourg B 34.083.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131409/10.
(110152048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Energie & Environnement Ingénieurs-conseils S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Hostert, 99, rue Andethana.
R.C.S. Luxembourg B 37.090.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ENERGIE & ENVIRONNEMENT - Ingénieurs Conseils S.A.
Référence de publication: 2011131413/10.
(110151916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
EOI Fire S.à rl., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 80.582.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011131415/10.
(110151963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
EREA Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.948.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2011.
Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Administrateur
i>Christelle Ferry
<i>Représentant Permanenti>
Référence de publication: 2011131418/14.
(110151984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2011.
Eventsys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1311 Luxembourg, 19, boulevard Marcel Cahen.
R.C.S. Luxembourg B 146.831.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011134152/10.
(110154290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
129072
AGC & Partners S.à r.l.
Agri Ventures International S.A.
Alfa Invest S.A.
Alphabet S.A.
Alphemi
Altice VII S.à r.l.
Auberge THILLSMILLEN S.à r.l.
Auto Seikel Luxembourg S.à r.l.
Autos-Métaux-Lux S.àr.l.
Beaufort Lotissement S.A.
Bétons Feidt S.A.
Budget Travel Holdings S.à r.l.
Bulgarian Acquisition Company VI S.à r.l.
Cadogan Joseph II S.à r.l.
Cadogan Joseph II S.à r.l.
Cap Sud S.A.
Carrières Feidt S.A.
Carts & Kiosks S.à r.l.
Castel (Luxembourg) S.à r.l.
Castlement Management S.à r.l.
Cinven (Luxco 1) S.à r.l.
Circles Holding S.A.
City-Image S.à.r.l.
Clover Investments Sàrl
CMT SA
Cofima I S.A.
ConvaTec Healthcare E S.A.
Cosma Finance International S.A.
DAGNY GmbH
Décoman 1 S.A.
Décoman 2 S.A.
DH New Investment XI S.à r.l.
DH Udine S.à r.l.
Diorasis International S.A.
Donneaux Conseils S.à r.l.
Doralcapital S.A.
Doranda S.A.
Editions Plus S.à.r.l.
Elysion S.A.
Energie & Environnement Ingénieurs-conseils S.A.
Eni Algeria Limited
Eni Pakistan (M) Limited
Eni South China Sea Limited
Entertainment Concepts S.A.
EOI Fire S.à rl.
Equidem S.à r.l.
EREA Investissement S.A.
Eventsys S.A.
Extensa Participations II S.àr.l.
Extensa Participations II S.àr.l.
Financière Daunou 16 S.à r.l.
Finsteel Energy Investment S.A.
First London European Holdings S.à r.l.
FLE SICAV-FIS
Freiburg Capital Development S.A.
GKS Prop Co. B S.à r.l.
Green Flash S.A.
Green S.A.
Harbour LuxCo S.à r.l.
Hippo Holding S.à r.l.
IC Invest HOLDINGS S.A.
Marinvest Holding S.A.
Pegaso Marine Research S.A.
Sampan Properties S.à r.l.
Triton III LuxCo A 10 S.à r.l.