logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2642

31 octobre 2011

SOMMAIRE

ARERO - Der Weltfonds  . . . . . . . . . . . . . . . .

126773

Arfis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126771

Asconia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126813

Avancio Investholding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

126813

Cosma Finance International S.A.  . . . . . . .

126771

DB Advisors Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126789

DB Advisors Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126789

DB Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126774

DB Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126774

Deka-EuroGarant 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126786

Deka-WorldGarant 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126787

Digital Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126770

Ditco Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

126814

DWS Dividende Direkt 2014  . . . . . . . . . . . .

126788

DWS Dividende Direkt 2014  . . . . . . . . . . . .

126788

DWS Emerging Markets Corporates 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126788

DWS Emerging Markets Corporates 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126788

DWS Floating Rate Notes  . . . . . . . . . . . . . .

126791

DWS Floating Rate Notes  . . . . . . . . . . . . . .

126791

DWS Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126786

DWS Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126786

DWS Rendite Extra Garant  . . . . . . . . . . . . .

126790

DWS Rendite Extra Garant  . . . . . . . . . . . . .

126790

DWS Rendite Garant 2015 . . . . . . . . . . . . . .

126787

DWS Rendite Garant 2015 . . . . . . . . . . . . . .

126787

DWS Rendite Garant 2015 II  . . . . . . . . . . . .

126786

DWS Rendite Garant 2015 II  . . . . . . . . . . . .

126786

DWS Rendite Optima  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126788

DWS Rendite Optima  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126787

DWS Rendite Plus Garant  . . . . . . . . . . . . . .

126774

DWS Rendite Plus Garant  . . . . . . . . . . . . . .

126792

DWS Renten Direkt 2013  . . . . . . . . . . . . . . .

126792

DWS Renten Direkt 2013  . . . . . . . . . . . . . . .

126791

DWS Renten Direkt 2014 II  . . . . . . . . . . . . .

126790

DWS Renten Direkt 2014 II  . . . . . . . . . . . . .

126790

DWS Top Dynamic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126787

DWS Top Dynamic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126787

DWS Vermögensmandat  . . . . . . . . . . . . . . .

126791

DWS Vermögensmandat  . . . . . . . . . . . . . . .

126790

Eurizon Manager Selection Fund  . . . . . . . .

126785

Eurizon MM Collection Fund  . . . . . . . . . . . .

126785

FI Alpha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126789

FI Alpha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126789

Flairzone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126814

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126774

GFL Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126807

Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126789

Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126789

International Asset Management Fund . . .

126774

Lilabel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126814

PAM International Fund Selection Portfo-

lio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126791

PAM International Fund Selection Portfo-

lio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126791

Plutos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126775

Pradera Holdco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126775

Pradera Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126775

Roots Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126813

Roquepine s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126816

Rossini Lux Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126785

SHIP Luxco Holding & Cy S.C.A..  . . . . . . .

126792

Valore 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126807

126769

L

U X E M B O U R G

Digital Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 66.323.

Notice is hereby given to the shareholders that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of DIGITAL FUNDS (the "Company") will be held at the registered office of the Company at 33A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on <i>9 November 2011 at 14:30 (Luxembourg time) with the following

<i>Agenda:

With effect as of 30 November 2011:

1. To submit the Company, which was governed until 1 July 2011 by the provisions of Part I of the law of 20 December

2002 on undertakings for collective investment, to the provisions of Part I of the law of 17 December 2010 on
undertakings for collective investment, implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the
Council of 13 July 2009, and to amend a series of Articles of the Company's articles of incorporation (the "Articles
of Incorporation"), in particular (not exhaustive summary):

- To replace any reference to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by refe-

rences to the law of 17 December 2010 on undertakings to collective investment;

- To amend Article 4 "Corporate Object" (formerly "Purpose") of the Articles of Incorporation so as to read as

follows:
"The exclusive purpose of the Company is to invest the assets available to it in transferable securities and other
assets permitted by law, in accordance with the principle of risk diversification and with the objective to provide
the shareholders with the income from and the results of the management of its assets.
The Company may take any measures or carry out any transactions that it considers appropriate to achieve and
promote this purpose and will do this in the broadest possible sense in accordance with Part I of the law dated
17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law")."

- To insert in Articles 11, 17 and 25 (formerly 24) of the Articles of Incorporation specific rules for sub-funds

established as a master/feeder structure;

- To insert a new paragraph in Article 17 of the Articles of Incorporation in order to provide the Company with

the authority to perform cross-sub-fund investments;

- To amend Articles 25 (formerly 24) of the Articles of Incorporation in order to adjust mergers and liquidations

of sub-funds to the rules of the 2010 Law.

2. To adjust a series of Articles of the Company's Articles of Incorporation to meet UBS standards, in particular (not

exhaustive summary):

- To allow pooling and co-management of assets of two or more sub-funds and to amend Article 5 Articles of

Incorporation accordingly.

- To amend Article 10 of the Articles of Incorporation in order to allow the adjustments to the net asset value

of share classes if on any trading day the total number of subscription and redemption applications for all share
classes in a sub-fund leads to a net cash in- or outflow (so-called "swing-pricing").

- To insert a new paragraph in Article 14 of the Articles of Incorporation in order to mention the authority of

the Company's board of directors to appoint a designated management company for the Company.

3. To change the date of the annual general meeting and consequently to adapt Article 23 of the Articles of Incor-

poration.

4. To delete the French translation of the Articles of Incorporation and to draw up the Articles of Incorporation or

any amendment thereto henceforth only in English without any translation enclosed.

5. To restate the Articles of Incorporation as a whole in order to reflect the foregoing.
6. Miscellaneous.

The full text of the revised Articles of Incorporation is available to shareholders upon request at the registered office

of the Company 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

These resolutions require a quorum of 50% of the Company's capital to be present or represented and a majority of

2/3 of the votes cast in order to pass the resolution.

At the extraordinary shareholders' meeting, each share entitles to one vote.
Holders of bearer shares may, where applicable, vote at the meeting: in person by producing at the meeting a certificate

of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A, which will be issued to them against deposit of their
share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (Luxembourg) S.A. at the latest on 4 November
2011.

126770

L

U X E M B O U R G

In order to be admitted to the meeting, please send a notice in this respect by fax at least five (5) business days in

advance of the extraordinary general meeting to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 - 44 10 10 -
6249.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS

Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, by fax followed by mail until 4 November
2011, fax number +352 - 44 10 10 - 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011144402/755/64.

Cosma Finance International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.035.

Arfis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.217.

PROJET COMMUN DE FUSION

La fusion envisagée dans ce projet commun de fusion (le Projet Commun de Fusion) sera réalisée par l'absorption de

la société anonyme Cosma Finance International SA par la société anonyme Arfis S.A.

Les conseils d'administration respectifs des sociétés Arfis SA (la "Société Absorbante") et Cosma Finance International

SA (la "Société Absorbée") et ensemble avec la Société Absorbante, (les "Sociétés qui Fusionnent") ont décidé d'établir
le présent Projet Commun de Fusion conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et de présenter le Projet Commun de Fusion à leurs assemblées gé-
nérales des actionnaires respectives.

1. Description de la fusion envisagée. Les conseils d'administration respectifs des sociétés susnommées proposent de

réaliser une fusion par absorption qui impliquera le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société
Absorbée à la Société Absorbante, conformément aux dispositions de l'article 274 de la Loi (la "Fusion").

Les Sociétés qui fusionnent sont des sociétés appartenant à un même groupe et la fusion envisagée fait partie d'une

restructuration interne au groupe visant à regrouper les activités et à simplifier la structure du groupe.

La Fusion sera réalisée sur la base des situations comptables des sociétés qui fusionnent établies en date du 18 octobre

2011.

Les administrateurs décident d'entreprendre toutes les étapes nécessaires à la réalisation de la Fusion, conformément

aux conditions détaillées ci-après dans le Projet Commun de Fusion.

Conformément à l'article 272 de la Loi, la Fusion prendra effet entre les sociétés qui fusionnent lorsque les décisions

concordantes desdites sociétés auront été adoptées, c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale des action-
naires des sociétés qui fusionnent approuvant le Projet Commun de Fusion (la "Date de Prise d'Effet").

La Fusion prendra seulement effet envers les tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des

actionnaires des Sociétés qui Fusionnent, conformément aux articles 9 et 273(1) de la Loi.

2. Informations fournies en vertu de l'article 261(2) de la Loi.
a) Type de personne morale, dénomination sociale et siège social des Sociétés qui Fusionnent
i) La Sociétés Absorbée
La Société Absorbée est une société anonyme dont le siège social se situe au 15 Boulevard du Prince Henri L-1724,

Grand- Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 66035.

ii) La Société Absorbante
La Société Absorbante est une société anonyme dont le siège social se situe au 15 Boulevard du Prince Henri L-1724,

Grand- Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B51217.

b) Rapport d'échange des actions
Il est reconnu que la Fusion est considérée comme une restructuration interne du groupe auquel les sociétés qui

fusionnent appartiennent.

Le rapport d'échange des actions est calculé sur la base de la valeur de l'actif net de la Société Absorbante et de la

valeur de l'actif net de la Société Absorbée, comme le prouvent:

- La situation comptable de la Société Absorbante au 18 octobre 2011.
- La situation comptable de la Société Absorbée au 18 octobre 2011.
i) La Société Absorbante

126771

L

U X E M B O U R G

Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à sept cent cinq mille euros (EUR 705.000,-) composé de

quinze mille (15.000) actions ayant chacune une valeur nominale de quarante sept euros (EUR 47,-) toutes souscrites et
entièrement libérées.

Sur base de la situation comptable au 18 octobre 2011, l'actif net de la Société Absorbante est évalué à sept cent treize

mille huit cent quatre-vingt cinq euros et seize centimes (EUR 713.885,16).

ii) La Société Absorbée
Le capital social souscrit de la Société Absorbée est fixé à sept cent dix huit mille huit cent soixante-dix euros et

quarante-trois centimes (EUR 718.870,43) divisé en sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale toutes
souscrites et entièrement libérées.

Sur base de la situation comptable au 18 octobre 2011, l'actif net de la Société Absorbée est évalué à trente millions

trois cent vingt cinq mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt et onze centimes (EUR 30.325.844,91).

iii) Contrepartie
En contrepartie de l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée, la Société Absorbante,

suite à la Fusion, augmentera son capital social d'un montant de vingt neuf millions neuf cent trente six mille trois cent
vingt et un euros (EUR 29.936.321,-) afin de le porter de son montant actuel de sept cent cinq mille euros (EUR 705.000,-)
à trente millions six cent quarante et un mille trois cent vingt et un euros (EUR 30.641.321,-) par l'émission de six cent
trente six mille neuf cent quarante trois (636.943) actions, de même nature et ayant les mêmes droits et obligations que
les actions de la Société Absorbante.

Les six cent trente six mille neuf cent quarante trois (636.943) actions nouvellement émises de la Société Absorbante

seront attribuées à l'actionnaire unique de la Société Absorbée sur la base d'un rapport d'échange de six cent trente six
mille neuf cent quarante trois (636.943) actions de la Société Absorbante pour sept cents (700) actions détenues dans la
Société Absorbée. Il résulte du rapport d'échange un montant résiduel de trois cent quatre-vingt neuf mille cinq cent
vingt trois euros et quatre-vingt onze centimes (EUR 389.523,91) qui sera considéré comme une soulte en faveur de
l'actionnaire unique.

iv) Paiement en espèces
Aucun paiement en espèces ne sera accordé à l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
c) Modalités de remise des actions de la Société Absorbante
Les actions nouvellement émises seront enregistrées dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante à

compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion.

En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées,
d) Date à partir de laquelle les actions nouvellement émises seront porteuses du droit de participation aux bénéfices

et toute condition particulière relative à ce droit.

Les actions nouvellement émises permettront à leur(s) détenteur(s) de participer aux bénéfices de la Société Absor-

bante à compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion et, à partir de cette date, ce(s) détenteur(s) acquière(ront) tous
les droits attachés à ces parts, en ce compris le droit aux dividendes ou à toute autre distribution future à effectuer à
partir des bénéfices de la période comptable en cours et/ou des réserves accumulées et des profits reportés ou autrement.

Ce droit n'est soumis à aucune condition ni modalité particulière.
e) Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant

réalisées au nom de la Société Absorbante.

Les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées au nom de

la Société Absorbante à compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion.

f) Droits conférés par la Société Absorbante à l'actionnaire / associé ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de

titres autres que des parts sociales.

Aucun droit spécial ni aucune mesure spécifique ne seront accordés par la Société Absorbante.
Ni la société absorbée ni la société absorbante n'ont de parts bénéficiaires en circulation ni d'autres titres; Elles n'ont

pas également émis d'emprunts obligataires.

g) Avantages spéciaux accordés aux experts au sens de l'article 266 de la Loi, aux membres du conseil de gérance et/

ou organes d'administration, de surveillance ou de contrôle des Sociétés qui Fusionnent.

Ni les experts visés à l'article 266 de la Loi (le cas échéant), ni les membres des conseils d'administration, de surveillance

ou de contrôle des Sociétés qui Fusionnent ne seront autorisés à recevoir des avantages particuliers en rapport avec ou
par suite de la Fusion.

3. Conséquences de la Fusion.
3.1 La Fusion déclenchera ipso jure toutes les conséquences détaillées à l'article 274 de la Loi.
En effet, à la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront annulées.
3.2 Sous réserve des dispositions de l'article 274 (2) de la Loi relativement à l'opposabilité aux tiers, la Société Ab-

sorbante deviendra propriétaire des actifs apportés par la Société Absorbée tels qu'ils existent à la Date de Prise d'Effet
sans aucun droit de recours quel qu'il soit contre la Société Absorbée.

126772

L

U X E M B O U R G

3.3 La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante que les créances transférées à la suite de la Fusion sont

certaines et dues mais ne garantissent pas la solvabilité de leurs débiteurs respectifs.

3.4 La Société Absorbante paiera, à compter de la Date de Prise d'Effet, tous les impôts, cotisations, droits, taxes et

primes d'assurance qui seront ou pourront devenir exigibles en relation avec la possession des actifs qui ont été apportés.

3.5 A compter de la Date de Prise d'Effet, la Société Absorbante exécutera tous les contrats et obligations de la Société

Absorbée.

3.6 Les droits et créances afférents aux actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec

tous les titres, soit réels (in rem) soit personnels, y attachés. La Société Absorbante sera donc subrogée, sans novation,
à tous les droits, qu'ils soient réels (in rem) ou personnels, des Sociétés Absorbées à l'égard de tous ses actifs et contre
tous ses débiteurs sans exception aucune.

3.7 La Société Absorbante paiera toutes les dettes de quelque nature que ce soit de la Société Absorbée. Elle paiera

en particulier, le montant principal et les intérêts des dettes de toute nature qui incombent à la Société Absorbée.

3.8 Tous les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante

aussi longtemps que prescrit par la Loi.

3.9 Les mandats des membres du conseil d'administration de la Société Absorbée prendront fin à la Date de Prise

d'Effet de la Fusion. Pleine décharge sera accordée aux membres du conseil d'administration de la Société Absorbée pour
l'exécution de leurs mandats respectifs.

3.10 Les mandats des membres du conseil d'administration de la Société Absorbante ne seront pas affectés par la

Fusion.

4. Dispositions supplémentaires.
4.1 Le coût de la Fusion incombera à la Société Absorbante.
4.2 Les soussignés entreprennent réciproquement de prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de réaliser la

Fusion conformément aux exigences légales et statutaires des Sociétés qui Fusionnent.

4.3 La Société Absorbante effectuera toutes les démarches nécessaires et requises à la réalisation de la Fusion ainsi

que le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

4.4 Les actionnaires des Sociétés qui Fusionnent auront le droit, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale

des actionnaires appelées à se prononcer sur le Projet Commun de-Fusion, de prendre connaissance des documents
suivants au siège social desdites sociétés:

i. le Projet Commun de Fusion;
ii. les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés qui Fusionnent;
iii. un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant

la date du Projet Commun de Fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est
antérieure de plus de six mois à cette date;

iv. les rapports des conseils d'administration des Sociétés qui Fusionnent mentionnés à l'article 265 de la Loi; et
v. le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 266.
4.5 Une copie des documents mentionnés ci-dessus sera délivrée sur demande à tout actionnaire.
4.6 Le présent document a été établi le 18 octobre 2011 à Luxembourg, en trois originaux, aux fins d'être enregistré

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et d'être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations, un mois au moins avant la date des assemblées générales des actionnaires de chacune des Sociétés qui
Fusionnent appelées à se prononcer sur les conditions de la Fusion, conformément à l'article 262 de la Loi.

<i>LES CONSEILS D'ADMINISTRATION
COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A. / ARFIS S.A.
La Société Absorbée / La Société Absorbante
Carlo DE FEO / Remo DE FEO / Claude SCHMITZ / Pierre LENTZ / Gerdy ROOSE
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011147236/152.
(110171018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

ARERO - Der Weltfonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126773

L

U X E M B O U R G

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011132086/10.
(110152292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2011.

DB Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011132089/10.
(110152422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2011.

DB Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011132090/10.
(110152425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2011.

DWS Rendite Plus Garant, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136299/10.
(110157553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.906.

<i>RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la signature de la convocation à une assemblée générale extraordinaire publié dans

le Mémorial C n° 2607 du 27 octobre 2011, page 125092:

au lieu de: «The board of directors»,
lire: «The General Partner».
Référence de publication: 2011147681/12.

International Asset Management Fund, Fonds Commun de Placement.

Die Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements, in Kraft getreten am 1. Juli 2011, für den Fonds International

Asset Management Fund wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2011.

MK LUXINVEST S.A.

Référence de publication: 2011147493/10.
(110171079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

126774

L

U X E M B O U R G

Plutos, Fonds Commun de Placement.

Die Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements, in Kraft getreten am 23. März 2011, für den Fonds Plutos

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Oktober 2011.

Caso Asset Management S.A.

Référence de publication: 2011147293/10.
(110171076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Pradera Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Pradera Holdco S.A.).

Capital social: EUR 44.149.400,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.621.

In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of October,
before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Pradera Holdco S.A., a société anonyme incor-

porated under the laws of Luxembourg under the form of a limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (the "Com-
pany"), incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), of
5 February, 2002, published in the Memorial C n° 950 of 2 June, 2002, the articles of incorporation were amended by a
notarial deed on 26 November 2002, published in the Memorial C n° 84 of 28 January 2003, on 23 May 2003, published
in the Memorial C n° 793 on July 23, 2003, on 28 November 2003, published in the Memorial C n° 136 on February 3,
2004, on 10 April 2008 (published in the Memorial C n° 1339 on 31 May 2008 and for the last time by deed of the
undersigned notary on 4 February 2009, published in the Memorial C n° 556 on 13 March 2009. The company is registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under n° B-86.621.

The meeting was opened with Mr Benoit TASSIGNY, lawyer, residing in B-Nothomb, in the chair,
who appointed as secretary to the meeting Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in F-Russange.
The meeting elected as scrutineer Ms Christine Burgard, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the legal form of the company from a "société anonyme" into a "société à responsabilité limitée".
2. Acceptance of the directors' resignation, and discharge, and appointment of the managers.
3. Acceptance of the auditors' resignation.
4. Change of the name into "Pradera Holdco S.à r.l.".
5. To fix the corporate capital of the "société à responsabilité limitée" at forty-four million one hundred and forty-nine

thousand four hundred euro (EUR 44,149,400.-).

6. Subsequent amendment and restatement of the articles of association.
7. Miscellaneous.
II. That the sole shareholder being duly represented, the proxy of the sole shareholder and the number of its shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the sole shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present
deed.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the sole shareholder represented

declaring  that  it  has due  notice  and  has  knowledge  of  the agenda prior to this  meeting,  no  convening  notices were
necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the legal form of the company from a "société anonyme" into a "société à

responsabilité limitée", without discontinuity of its legal status.

126775

L

U X E M B O U R G

The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilites, the amortisations,

the appreciations, the depreciations.

The "société à responsabilité limitée" shall continue the book-keeping and the accountancy held by the "société ano-

nyme".

The change of legal status is made on the basis of the interim balance sheet as at 30 June 2011, a copy of which, after

having been signed ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed for the
purpose of registration.

<i>Second resolution

The sole shareholder grants discharge to the directors:
- Mrs. Supreetee Kumudini SADDUL, manager, born in Mauritius on 6 November 1963, residing professionally at 33

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

- Mr. Colin John Colquhoun CAMPBELL, Chairman, born in London on 12 February 1956, residing professionally at

Pradera-AM PLC 60 New Broad Street, EC2M 1JJ London (United Kingdom),

- Mr. Roberto LIMETTI, company director, born in Varese on 15 July 1970, residing professionally at Piazza Cavour

2 , Milan, Italy,

- Mr Jaime NAVARRO SANCHEZ, company director, born in Madrid (Spain) on 3 December 1970, residing profes-

sionally at C/ José Ortega y Gasset, 20 7 

a

 ,Madrid, Spain

for the exercise of their mandates till today.
The said persons have been appointed as directors on 30 June 2011 and shall now continue their mandates as managers

of the company for an unlimited period.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to accept to resignation of the statutory auditor DELOITTE S.A.
The said statutory auditor has been appointed on 30 June 2011.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to change the name of the company into "Pradera Holdco S.à r.l."

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides that the capital of the "société à responsabilité limitée" will be at forty-four million one

hundred and forty-nine thousand four hundred euro (EUR 44,149,400.-) divided into four hundred and forty-one thousand
four hundred and ninety-four (441,494) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of them
issued to Pradera Management S.à r.l., acting on behalf of Pradera European Retail Fund.

<i>Sixth resolution

In consequence the sole shareholder resolves to adapt the articles of association to the new legal form of the company

and to set them as follows:

Art. 1. Form. There exists a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by

article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may at any time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the

issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of "Pradera Holdco S.à r.l. ".

Art. 3. Object. The purpose of the Company is the acquisition, selling, financing and exchange of properties or securities

of companies holding properties and more generally assets constitutive of authorised investments of Pradera European
Retail Fund, a mutual investment fund («Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg (the «Fund»).

The Company may provide financial support to companies in which the Company holds directly or indirectly a parti-

cipation, in particular by granting loans, facilities, security interests or guarantees in any form and for any term whatsoever
and grant them any advice and assistance in any form whatsoever.

The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however

within the limitations set forth by the Fund's constitutive documents and the applicable Luxembourg laws and regulations.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.

126776

L

U X E M B O U R G

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the mana-

gement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at forty-four million one hundred and forty-nine thousand four hundred euro (EUR

44,149,400.-) divided into four hundred and forty-one thousand four hundred and ninety-four (441,494) shares, with a
nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Art.  7.  Authorised  capital.  The  authorised  capital  of  the  Company  is  set  at  two  hundred  million  euro  (EUR

200,000,000.-) divided into two million (2,000,000) shares each share with a nominal value of one hundred euro (EUR
100.-).

The board of managers is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the

Extraordinary general meeting of 13 October 2011 in the Memorial, Recueil C, to increase the share capital within the
limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any persons
that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189
paragraph 1 of the Law.

This autorisation may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders (or, as the case may be, by

the sole shareholder) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or,
as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of managers may determine.
The board of managers may in particular determine:
the time and the number of shares to be subscribed and issued;
whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and
issued and the amount of such share premium if any; and,
whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind.
The board of managers may delegate to any authorised manager or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the board of managers within the limits of the authorised

capital, the present article 7 shall be amended accordingly.

Art. 8. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant

to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single

partner.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 10. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 11. Transfer of shares.
11.1 When the Company is composed of a single partner, that single partner may transfer freely its shares.
When the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
11.2 When the Company is composed of several partners, the shares can be transferred by living persons to non-

partners only with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 12. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 13. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the

Law.

Art. 14. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

126777

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Management. The Company is managed and administered by a board of managers composed of at least three

(3) managers, whether partners or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners, as the case may be.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

Any manager may be dismissed by the single partner or the general meeting of partners at any time in the event of his

fraud, gross negligence or wilful misconduct, but not otherwise. Any manager may resign at any time.

The single partner or the general meeting of partners decides upon the compensation of each manager.
The board of managers shall appoint, from among its members, a chairman. The board of managers shall choose a

secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping board meeting minutes.

The board of managers may also appoint officers of the Company considered necessary for the operation and mana-

gement of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board. Officers need not be managers
or shareholders of the Company. The officers appointed shall have the powers and duties entrusted to them by the board.

Art. 16. Meetings of the board of managers. The board of managers shall meet at the place indicated in the notice of

the meeting.

Written notice of any board meeting shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for

such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in
the notice of the meeting. This notice may be waived if each manager consents in writing, by cable, telegram, telex or
telefax.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by cable, telegram, telex or

telefax, another manager as his proxy. Managers may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Meetings of the board of managers may be held by way of conference call, video conference or any other similar means
of communication, in which case the managers participating by such means shall be deemed to be present in Luxembourg.

The board of managers shall act validly only if a majority of managers are present or represented at a meeting of the

board. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented. The chairman of the board
of managers shall have a casting vote.

Resolutions may also be passed in the form of a consent resolution, set out in identical terms. This may be signed

jointly or by the use of counterparts by all the managers.

Art. 17. Powers - Representation of the Company. In dealing with third parties, any manager has the most extensive

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations
consistent with the Company's purpose.

The Company is bound in any circumstances by the sole signature of any manager.

Art. 18. Board of Managers' Committee. The board of managers may, by majority vote, set up one or more committees

to deal with specific matters under its supervision and responsibility, each committee to consist of one or more managers
of the Company and/or nonmanagers.

Art. 19. Death, Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or

any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company
into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 20. Liability. A manager will not incur any personal liability arising out of the functions performed on behalf of the

Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or

is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit
or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was
a manager or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a subsidiary
as a manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust,
committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the board of managers, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted

by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner
in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative)
by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a manager or officer) of the Company
or a subsidiary.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a

manager, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company
or a subsidiary as a manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint

126778

L

U X E M B O U R G

venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by
him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the
power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal or amendment inconsistent with this article 18, shall adversely affect any right or protection of any person

granted pursuant to the law existing at the time of such repeal or amendment.

The right to indemnification conferred in this article 18 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law,

the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance
of its final disposition. The payment of any amounts to any manager, officer, partner, member, employee or agent pursuant
to this article 18 shall subrogate the Company to any right such manager, officer, partner, member, employee or agent
may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 18 shall be contractual rights.

Art. 21. General meeting of the partners.
21.1 If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by the Law to the

general meeting of the partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.
21.2 If the Company is composed of no more than twenty-five (25) partners, the decisions of the partners are taken

in a general meeting or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
management to the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of

the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) partners, the decisions are taken in a general meeting.
If the Company is composed of several partners, decisions of the partners are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the capital. However, resolutions to amend these articles and parti-
cularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of partners representing three quarters of the Company's
capital.

Art. 22. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 23. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December

of each year.

Art. 24. Balance-sheet. Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory

of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen (15) days preceding the deadline set for the annual general meeting of partners.

Art. 25. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation

and provisions is the net profit of the financial year.

Five per cent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer

be mandatory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 26. Interim dividends. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to

his/their share holding in the Company.

Subject to the conditions (if any) fixed by the 1915 Law and in compliance with the foregoing provisions, the manager

or the board of managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The manager or the board
of managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits realised during the current year and profits carried forward or

transferred to an extraordinary reserve,

3. The payment is made once the manager or the board of managers is assured that sufficient amounts are guaranteed

to pay out an advance payment on dividends and that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 27. Dissolution, Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation

will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting
of partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

126779

L

U X E M B O U R G

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in ac-

cordance with applicable laws."

Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately four thousand euro (4,000.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil onze, le treize octobre.
Par-devant nous Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de Pradera Holdco S.A, une société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 33, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), (la «Société»),
constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 février 2002, publié au Mémorial C numéro 950 du 2 juin 2002,
les statuts de la Société ont été modifiés par un acte notarié du 26 novembre 2002, publié au Mémorial C n° 84 du 28
janvier 2003, le 23 mai 2003, publié au Mémorial C n° 793 du 28 juillet 2003, par acte du 28 novembre 2003, publié au
Mémorial C n° 136 du 3 février 2004, par acte du 10 avril 2008, publié au Mémorial C n° 1339 du 31 mai 2008 et pour
la dernière fois par acte du notaire soussigné du 4 février 2009, publié au Mémorial C n° 556 du 13 mars 2009. La société
est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 86.621.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine BURGARD, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
1. Modification de la forme légale de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
2. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat et nomination des gérants.
3. Démission du commissaire aux comptes.
4. Changement de dénomination en «Pradera Holdco S.à r.l.».
5. Fixation du capital de la société à responsabilité limitée à quarante-quatre millions cent quarante-neuf mille quatre

cents euros (44.149.400,- EUR) .

6. Modification subséquente et refonte des statuts.
7. Divers.
II. Que l'actionnaire unique présent ou représenté, la mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre

d'actions  qu'il détient  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence,  cette liste  de présence,  après avoir  été  signée par la
mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes la procuration
de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Actionnaire unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire unique décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à respon-

sabilité limitée sans changement de sa personnalité juridique.

126780

L

U X E M B O U R G

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.

La transformation se fait sur base du bilan intermédiaire arrêté au 30 juin 2011 dont une copie, après avoir été signée

ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

L'Actionnaire unique donne décharge aux administrateurs:
- Madame Supreetee Kumudini SADDUL, gérante, née le 6 novembre 1963 à l'Ile Maurice, ayant sa résidence profes-

sionnelle au 33, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Colin John Colquhoun CAMPBELL, gérant, né le 12 février 1956 à Londres (Angleterre), ayant sa résidence

professionnelle au 60 New Broad Street, EC2M 1JJ London Angleterre,

- Monsieur Roberto LIMETTI, administrateur de sociétés, né à Varese le 15 juillet 1970, ayant sa résidence profes-

sionnelle au Piazza Cavour 2, Milan, Italie,

- Monsieur Jaime NAVARRO SANCHEZ, administrateur de sociétés, né à Madrid (Espagne) le 3 décembre 1970 ayant

sa résidence professionnelle au C/ José Ortega y Gasset, 20, 7a ,Madrid, Espagne.,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.
Ces personnes avaient été nommées en qualité d'administrateurs lors de l'assemblée générale des actionnaires le 30

juin 2011 et ils continueront leurs mandats en qualité de gérants de la société pour une durée illimitée.

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire unique décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes DELOITTE S.A..
Le commissaire aux comptes avait été nommé lors de l'assemblée générale des actionnaires le 30 juin 2011.

<i>Quatrième résolution

L'Actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en «Pradera Holdco S.à r.l.»

<i>Cinquième résolution

L'Actionnaire unique que le capital de la société à responsabilité limitée sera de quarante-quatre millions cent quarante-

neuf mille quatre cents euros (44.149.400,- EUR) représenté par quatre cent quarante et un mille quatre cent quatre-
vingt-quatorze (441.494) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune détenue par Pradera
Management S.à r.l. agissant pour le compte de Pradera European Retail Fund.

<i>Sixième résolution

En conséquence, l'Actionnaire unique décide d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les

arrêter comme suit:

«  Art. 1 

er

 . Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la législation luxembourgeoise

et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par l'article
1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut à tout moment, comporter plusieurs associés, notamment suite à la cession de parts sociales ou à

l'émission de nouvelles parts sociales.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «Pradera Holdco S.à r.l.»

Art. 3. Objet. La Société a pour objet est l'acquisition, la vente, le financement et l'échange d'avoirs ou de titres de

sociétés détenant des avoirs et plus généralement des biens qui font partie des investissements autorisés de Pradera
European  Retail  Fund,  un  Fonds  Commun  de  Placement  organisé  sous  les  lois  du  Grand-Duché  du  Luxembourg  (le
«Fonds»).

La Société pourra fournir un soutien financier aux sociétés dans lesquelles la Société détient directement ou indirec-

tement une participation, en particulier en octroyant des prêts, facilités, sûretés ou garanties de quelque nature et durée
que ce soit et leur fournir tout conseil et assistance de quelque nature que ce soit.

La Société peut avoir toute autre activité qui est jugée utile à l'accomplissement de son objet social, en restant toutefois

dans les limites imposées par les documents constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembourgeois applicables.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée

générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

126781

L

U X E M B O U R G

La gérance peut établir des filiales et des succursales où il le sera jugé utile, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l'étranger.

Art. 6. Capital social.  Le  capital  est  fixé  à  quarante-quatre  millions  cent  quarante-neuf  mille  quatre  cents  euros

(44.149.400,- EUR) représenté par quatre cent quarante et un mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (441.494) parts
sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé deux cent millions d'euros (EUR 200.000.000,-) divisé

en deux millions (2.000.000,-) de parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil de gérance de la Société est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de

publication de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2011 dans le Mémorial, Recueil C, à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs
de parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité
prévues à l'article 189, alinéa 1, de la Loi, Cette autorisation peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale
des associés (ou selon le cas de l'associé unique) délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les
présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance de la Société peut en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime

d'émission, le cas échéant;

et,
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature.
Le conseil de gérance de la Société peut déléguer à tout gérant de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société

ou toute autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement de parts
sociales représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.

A chaque augmentation du capital social de la Société par le conseil de gérance dans les limites du capital autorisé, le

présent article 7 sera modifié en conséquence.

Art. 8. Modification du capital social. Le capital social peut, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique

ou moyennant une résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de l'as-

semblée générale des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 10. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 11. Cession de parts.
11.1 Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
11.2 Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 12. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après qu'elle a été signifiée à la Société ou acceptée par

elle conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 13. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément à la Loi.

Art. 14. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Gérance. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance composé de trois (3) gérants au moins,

associés ou non.

126782

L

U X E M B O U R G

Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des

associés, selon le cas. Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe
leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider la révocation d'un gérant à tout moment en cas de

vol, faute grave ou inconduite intentionnelle, mais en aucun autre cas. Chaque gérant peut se démissionner de ses fonctions
à tout moment.

L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décide de la rémunération de chaque gérant.
Le conseil de gérance pourra nommer, parmi ses membres, un président. Le conseil de gérance pourra choisir un

secrétaire, qui sera gérant ou non et qui sera responsable de la conservation des minutes des réunions du conseil de
gérance.

Le conseil de gérance pourra nommer des fondés de pouvoirs de la Société jugés nécessaires pour la conduite des

affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées à tout moment par le conseil de gérance.
Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être gérant ou associé de la Société. Les fondés de pouvoirs auront les pouvoirs
et obligations qui leur seront conférés par le conseil de gérance.

Art. 16. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunira au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins 24 heures avant l'heure prévue
pour celle-ci, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de
convocation. Il pourra être renoncé à cet avis si chaque gérant y consent par écrit, par câble, télégramme, télex ou message
télécopié.

Tout gérant pourra se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, câble, télé-

gramme, télex ou message télécopié un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil de gérance peuvent être tenues au
moyen de conférences téléphoniques ou visioconférences ou tous autres moyens de communication, auxquels cas les
gérants participant par le biais de tels moyens de communication seront réputés être présents à Luxembourg.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents

ou représentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou repré-
sentés à la réunion. Le Président du conseil de gérance aura un vote décisif.

Les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par des résolutions circulaires identiques en leurs

termes, signées sur un ou plusieurs documents par tous les gérants.

Art. 17. Pouvoirs - Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour

agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son
objet social.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

Art. 18. Comités du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, par un vote à la majorité de tout le conseil,

constituer un ou plusieurs comités afin de traiter sous son contrôle et sa responsabilité de sujets particuliers, chaque
comité comprenant un ou plusieurs membres gérants ou non de la Société.

Art. 19. Décès, Incapacité, la Faillite ou Déconfiture d'un gérant. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un

gérant ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou révocation pour quelque motif que
ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 20. Responsabilité. Un gérant ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne

qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action,
procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que
cette personne (1) a été ou est gérant ou fondé de pouvoir de la Société ou d'une filiale ou (2) a rendu service à la
demande de la Société ou d'une filiale en tant que gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une
autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.

Dans la mesure où le conseil de gérance l'estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure du

possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée d'être
partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être entamé,
en cours d'instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du
fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre que gérant ou fondé de pouvoir) de la Société ou
d'une filiale.

126783

L

U X E M B O U R G

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui

est ou a été gérant, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d'une filiale, ou qui a rendu ou rend des
services à la demande de la Société ou d'une filiale comme gérant, fondé de pouvoir ou fondé de pouvoir, associé, membre,
employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute
dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son
statut, que la Société ou une filiale ait ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense, responsabilité ou
perte en vertu des dispositions légales applicables.

Aucune abrogation ou modification d'une disposition en contradiction avec cet article 18 n'entravera les droits ou la

protection accordés à toute personne en vertu du présent article tels qu'ils sont ou étaient en vigueur au moment ou
antérieurement à de telles abrogations ou modifications.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 18 comporte également, dans la mesure où cela est permis

par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat)
encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un
gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 18 subrogera la Société dans les
droits que peuvent avoir de tels gérants, fondé de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne
ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 18 seront des droits contractuels.

Art. 21. Assemblées générales des associés.
21.1 Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée

générale des associés.

Les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables à cette situation.
21.2 Lorsque la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en

assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés
par lettre recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze

(15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Lorsque la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en assemblée

générale.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu'avec l'accord

des associés représentant plus que la moitié du capital social. Cependant, des décisions de modifier ces statuts et no-
tamment de liquider la Société ne peuvent être valablement prises qu'avec l'accord de la majorité des associés représentant
trois quarts du capital social de la Société.

Art. 22. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés sont établies par écrit et

consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les
procurations seront annexées aux procès-verbaux.

Art. 23. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 24. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés, la gérance dresse un inventaire des biens et

des dettes et établit les comptes annuels conformément à la Loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des

associés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication des documents financiers, au cours d'une

période de quinze (15) jours précédant la date de l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 25. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

Art. 26. Acomptes sur dividendes. Le solde du profit annuel net peut être distribué à/aux associé(s) proportionnelle-

ment au nombre de parts qu'il(s) détient/détiennent dans la Société.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par la Loi de 1915 et conformément aux dispositions qui précèdent, le

gérant ou le conseil de gérance peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Le gérant ou le
conseil de gérance déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

126784

L

U X E M B O U R G

3. Le paiement n'est effectué qu'après le gérant ou le conseil de gérance se soit assuré qu'il y ait des montants suffisants

afin de procéder au versement d'un acompte sur dividendes et qu'il ait obtenu l'assurance que les droits des créanciers
ne sont pas menacés.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

Art. 26. Disposition générale. Tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, est traité dans le respect des dis-

positions légales en vigueur.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ quatre mille euros (4.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du bureau et à la mandataire de l'actionnaire,

connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, M. NEZAR, C. BURGARD, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 octobre 2011. Relation: LAC/2011/45744. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Référence de publication: 2011146894/558.
(110170515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2011.

Eurizon MM Collection Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2011145351/10.
(110168738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2011.

Eurizon Manager Selection Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de EURIZON MANAGER SELECTION FUND (modifié/coordonné) a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2011146468/11.
(110169996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Rossini Lux Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126785

L

U X E M B O U R G

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2011142099/10.
(110164743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

DWS Global, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011142091/10.
(110164762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

DWS Global, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011142090/10.
(110164749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2011.

DWS Rendite Garant 2015 II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011139432/10.
(110161422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

DWS Rendite Garant 2015 II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011139431/10.
(110161419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

Deka-EuroGarant 2, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-EuroGarant 2 modifié au 01.11.2011 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2011138137/11.
(110159857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

126786

L

U X E M B O U R G

Deka-WorldGarant 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-WorldGarant 1 modifié au 01.11.2011 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Référence de publication: 2011138136/11.
(110159856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

DWS Top Dynamic, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136970/10.
(110158396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Top Dynamic, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136969/10.
(110158394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Rendite Garant 2015, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136968/10.
(110158344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Rendite Garant 2015, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136967/10.
(110158341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Rendite Optima, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126787

L

U X E M B O U R G

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136966/10.
(110158339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Rendite Optima, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136965/10.
(110158337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Emerging Markets Corporates 2015, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136964/10.
(110158336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Emerging Markets Corporates 2015, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136963/10.
(110158335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Dividende Direkt 2014, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136962/10.
(110158333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

DWS Dividende Direkt 2014, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136961/10.
(110158331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2011.

126788

L

U X E M B O U R G

FI Alpha, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136318/10.
(110157655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

FI Alpha, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136317/10.
(110157654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Global Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136316/10.
(110157651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Global Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136315/10.
(110157650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DB Advisors Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136314/10.
(110157649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DB Advisors Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126789

L

U X E M B O U R G

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136313/10.
(110157647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Rendite Extra Garant, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136312/10.
(110157643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Rendite Extra Garant, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136311/10.
(110157641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Renten Direkt 2014 II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136310/10.
(110157640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Renten Direkt 2014 II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136309/10.
(110157638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Vermögensmandat, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136308/10.
(110157586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

126790

L

U X E M B O U R G

DWS Vermögensmandat, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136307/10.
(110157584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

PAM International Fund Selection Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136306/10.
(110157583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

PAM International Fund Selection Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136305/10.
(110157580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Floating Rate Notes, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136304/10.
(110157577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Floating Rate Notes, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136303/10.
(110157570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Renten Direkt 2013, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126791

L

U X E M B O U R G

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136302/10.
(110157567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Renten Direkt 2013, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136301/10.
(110157562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

DWS Rendite Plus Garant, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hin-

terlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2011136300/10.
(110157557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

SHIP Luxco Holding &amp; Cy S.C.A.., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.673.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of July.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, (Grand-Duchy of Luxembourg),
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SHIP Luxco Holding &amp; Cy S.C.A." (the "Company"),

a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 154.673, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 28 July 2010, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (the "Mémorial C") dated 11 August 2010, number 1626. The articles of association have been amended for
the last time on 1 

st

 April 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C dated 8 July

2011, number 1517, page 72803.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Christèle ALEXANDRE, maître en droit, residing in Luxembourg, who is also elected

as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To increase the Company's share capital by an amount of one hundred and twenty-two thousand nine hundred and

forty-nine British Pounds (GBP 122,949), so as to raise it from its present amount of eight million three hundred and
forty-six thousand four hundred and twenty-six British Pounds (GBP 8,346,426.00) up to eight million four hundred and
sixty-nine thousand three hundred and seventy-five British Pounds (GBP 8,469,375.00), by the issue of one hundred and
twenty-two thousand nine hundred and forty-nine (122,949) new ordinary shares of category A subdivided into (i) forty
thousand nine hundred and seventy-eight (40,978) new class A1 shares, (ii) forty thousand nine hundred and eighty-four
(40,984) new class A2 shares and (iii) forty thousand nine hundred and eighty-seven (40,987) new class A3 shares, each
having a par value of one British Pound (GBP 1.00), (collectively referred as the "New A Shares"), having the same rights
and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by
means of contribution in kind consisting in eight million six hundred and seventy-four thousand two hundred and eighty-
nine (8,674,289) shares each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), in Ship Luxco 1 S.à r.l., a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered

126792

L

U X E M B O U R G

office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 154.678, such New Shares shall be subscribed as follows:

- thirty-eight thousand one hundred and forty-two (38,142) New A Shares subdivided into (i) twelve thousand seven

hundred and fourteen (12,714) new class A1 shares, (ii) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class
A2 shares and (iii) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class A3 shares by Mr. Phillip McGriskin,
Chief Executive Officer, born on 20 January 1974 in Sydney, Australia, residing at 76, Bathurst Gardens, London, NW10
5HY and paid up by a contribution in kind consisting in the contribution of two million six hundred and ninety thousand
eight hundred and forty-four (2,690,844) shares held by Mr. Phillip McGriskin in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a
total  amount  of  two  million  six  hundred  and  ninety  thousand  eight  hundred  and  forty-four  British  Pounds  (GBP
2,690,844.00) (the "Contribution I").

The Contribution I of two million six hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four British Pounds (GBP

2,690,844.00) shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirty-eight thousand one hundred
and forty-two British Pounds (GBP 38,142.00) and (ii) to the share premium account for an amount of two million six
hundred and fifty-two thousand seven hundred and two British pounds (GBP 2,652,702.00).

- thirty-eight thousand one hundred and forty-two (38,142) New A Shares subdivided into (i) twelve thousand seven

hundred and fourteen (12,714) new class A1 shares, (ii) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class
A2 shares and (iii) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class A3 shares by Mr. Paul Townsend,
Chief Operating Officer, born on 9 July 1963 in Lewisham, United Kingdom, residing at 7 Cedars Road, Beckenham, Kent,
BR3 4JE and paid up by a contribution in kind consisting in the contribution of two million six hundred and ninety thousand
eight hundred and forty-four (2,690,844) shares held by Mr. Paul Townsend in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total
amount of two million six hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four British Pounds (GBP 2,690,844.00)
(the "Contribution II").

The Contribution II of two million six hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four British Pounds (GBP

2,690,844.00) shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirty-eight thousand one hundred
and forty-two British Pounds (GBP 38,142.00) and (ii) to the share premium account for an amount of two million six
hundred and fifty-two thousand seven hundred and two British pounds (GBP 2,652,702.00).

- thirteen thousand five hundred and seven (13,507) New A Shares subdivided into (i) four thousand five hundred and

two (4,502) new class A1 shares, (ii) four thousand five hundred and two (4,502) new class A2 shares and (iii) four
thousand five hundred and three (4,503) new class A3 shares by Mr. Jonathan Fisher, Chief Technology Officer, born on
14 August 1972 in London, United Kingdom, residing Flat 211, King’s Wharf, 301 Kingsland Road, London E8 4DS, United
Kingdom and paid up by a contribution in kind consisting in the contribution of nine hundred and fifty-two thousand nine
hundred and two (952,902) shares held by Mr. Jonathan Fisher, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, (for a total
amount of nine hundred and fifty-two thousand nine hundred and two British Pounds (GBP 952,902.00) (the "Contribution
III").

The Contribution III of nine hundred and fifty-two thousand nine hundred and two British Pounds (GBP 952,902.00)

shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirteen thousand five hundred and seven British
Pounds (GBP 13,507.00) and (ii) to the share premium account for an amount of nine hundred and thirty-nine thousand
three hundred and ninety-five British pounds (GBP 939,395.00).

- thirteen thousand sixteen (13,016) New A Shares subdivided into (i) four thousand three hundred and thirty-eight

(4,338) new class A1 shares, (ii) four thousand three hundred and thirty-nine (4,339) new class A2 shares and (iii) four
thousand three hundred and thirty-nine (4,339) new class A3 shares by Ares Limited, a limited liability company, having
its registered office at 39/41 Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU, registered with the Trade Register in St. Helier
under number 107605, and paid up by a contribution in kind consisting in nine hundred and eighteen thousand two
hundred and eighty-five (918,285) shares held by Ares Limited, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total
amount of nine hundred and eighteen thousand two hundred and eighty-five British Pounds (GBP 918,285.00) (the "Con-
tribution IV").

The  Contribution  IV  of  nine  hundred  and  eighteen  thousand  two  hundred  and  eighty-five  British  Pounds  (GBP

918,285.00) shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirteen thousand sixteen British Pounds
(GBP 13,016.00) and (ii) to the share premium account for an amount of nine hundred and five thousand two hundred
and sixty-nine British pounds (GBP 905,269.00).

- five thousand two hundred and seventy-nine (5,279) New A Shares subdivided into (i) one thousand seven hundred

and fifty-nine (1,759) new class A1 shares, (ii) one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A2 shares and (iii)
one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A3 shares by Mr. John Huggins, Director of Business Operations,
born on 1st January 1960 in London, United Kingdom, residing at 60 Weald Road, Brentwood, Essex, CM14 4TH, United
Kingdom, United Kingdom and paid up by a contribution in kind consisting in three hundred and seventy-two thousand
four hundred and eighty-two (372,482) shares held by Mr. John Huggins, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed,
for  a  total  amount  of  three  hundred  and  seventy-two  thousand  four  hundred  and  eighty-two  British  Pounds  (GBP
372,482.00) (the "Contribution V").

The Contribution V of three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two British Pounds (GBP

372,482.00) shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of five thousand two hundred and seventy-

126793

L

U X E M B O U R G

nine British Pounds (GBP 5,279.00) and (ii) to the share premium account for an amount of three hundred and sixty-
seven thousand two hundred and three British pounds (GBP 367,203.00).

- five thousand two hundred and seventy-nine (5,279) New A Shares subdivided into (i) one thousand seven hundred

and fifty-nine (1,759) new class A1 shares, (ii) one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A2 shares and (iii)
one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A3 shares Mr. Stephen Kavanagh, Head of Development &amp;
Systems Architect, born on 16 February 1969 in London, United Kingdom, residing at 60 Weald Road, Putney, London
SW15 5EL, United Kingdom and paid up by a contribution in kind consisting in three hundred and seventy-two thousand
four hundred and eighty-two (372,482) shares held by Mr. John Huggins, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed,
for  a  total  amount  of  three  hundred  and  seventy-two  thousand  four  hundred  and  eighty-two  British  Pounds  (GBP
372,482.00) (the "Contribution VI").

The Contribution VI of three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two British Pounds (GBP

372,482.00) (i) to the Company's share capital for an amount of five thousand two hundred and seventy-nine British
Pounds (GBP 5,279.00) and (ii) to the share premium account for an amount of three hundred and sixty-seven thousand
two hundred and three British pounds (GBP 367,203.00).

- three thousand three hundred and two (3,302) New A Shares subdivided into (i) one thousand one hundred (1,100)

new class A1 shares, (ii) one thousand one hundred and one (1,101) new class A2 shares and (iii) one thousand one
hundred and one (1,101) new class A3 shares by Mr. Mark O’Brien, Chief Financial Officer, born on 19 April 1971 in
Wolverhampton, United Kingdom, residing at 83 Melrose Avenue, London, NW2 4LR, United Kingdom and paid up by
a contribution in kind consisting in two hundred and thirty-two thousand nine hundred and sixty-two (232,962) shares
held by Mr. Mark O’Brien, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of two hundred and thirty-
two thousand nine hundred and sixty-two British Pounds (GBP 232,962.00) (the "Contribution VII").

The  Contribution  VII  of  two  hundred  and  thirty-two  thousand  nine  hundred  and  sixty-two  British  Pounds  (GBP

232,962.00) shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of three thousand three hundred and two
British Pounds (GBP 3,302.00) and (ii) to the share premium account for an amount of (i) two hundred and twenty-nine
thousand six hundred and sixty British pounds (GBP 229,660.00).

- two thousand nine hundred and seven (2,907) New A Shares subdivided into (i) nine hundred and sixty-nine (969)

new class A1 shares, (ii) nine hundred and sixty-nine (969) new class A2 shares and (iii) nine hundred and sixty-nine (969)
new class A3 shares by Mr. Mark Fleming, Vice President Sales, born on 1 August 1974 in Watseka, Illinois, United States
of America, residing at Wouwermanstraat 1-Boven 1071 LT Amsterdam, The Netherlands and paid up by a contribution
in kind consisting in two hundred and five thousand one hundred and thirty-one (205,131) shares held by Mr. Mark Fleming,
prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of two hundred and five thousand one hundred and
thirty-one British Pounds (GBP 205,131.00) (the "Contribution VIII").

The Contribution VIII of two hundred and five thousand one hundred and thirty-one British Pounds (GBP 205,131.00)

shall be allocated (i) to the Company's share capital for an amount of two thousand nine hundred and seven British Pounds
(GBP 2,907.00) and (ii) to the share premium account for an amount of two hundred and two thousand two hundred
and twenty-four British pounds (GBP 202,224.00).

- five hundred and fifty-four (554) New A Shares subdivided into (i) one hundred and eighty-four (184) new class A1

shares, (ii) one hundred and eighty-five (185) new class A2 shares and (iii) one hundred and eighty-five (185) new class
A3 shares by Mr. Patrick Jonsonn, Chief Executive Officer of Envoy Services Sweden AB, born on 8 July 1967 in Harlanda,
Sweden, residing at 670608-5070, Oja Midgard, 360 32 Gemla, Sweden and paid up by a contribution in kind consisting
in thirty-nine thousand one hundred and thirty (39,130) shares held by Mr. Patrick Jonsonn, prenamed, in Ship Luxco 1
S.à r.l., prenamed, for a total amount of two hundred and five thousand one hundred and thirty-one British Pounds (GBP
39,130.00) (the "Contribution IX").

The Contribution IX of thirty-nine thousand one hundred and thirty British Pounds (GBP 39,130.00) shall be allocated

(i) to the Company's share capital for an amount of five hundred and fifty-four British Pounds (GBP 554.00) and (ii) to
the share premium account for an amount of thirty-eight thousand five hundred and seventy-six British Pounds (GBP
38,576.00).

- six hundred and eighty-seven (687) New A Shares subdivided into (i) (i) two hundred and twenty-nine (229) new

class A1 shares, (ii) two hundred and twenty-nine (229) new class A2 shares and (iii) two hundred and twenty-nine (229)
new class A3 shares by Mr. Stefan Burkwood, Banking Director, born on 4 May 1972 in London, United Kingdom, residing
at 75 Larksway, Bishops Stortford, Hertfordshire, CM23 4DG, United Kingdom and paid up by a contribution in kind
consisting in forty-eight thousand five hundred and thirty-four (48,534) shares held by Mr. Stefan Burkwood, prenamed,
in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of forty-eight thousand five hundred and thirty-four British Pounds
(GBP 48,534.00) (the "Contribution X").

The Contribution X of forty-eight thousand five hundred and thirty-four British Pounds (GBP 48,534.00) shall be

allocated (i) to the Company's share capital for an amount of six hundred and eighty-seven British Pounds (GBP 687.00)
and (ii) to the share premium account for an amount of forty-seven thousand eight hundred and forty-seven British Pounds
(GBP 47,847.00).

- six hundred and nineteen (619) New A Shares subdivided into (i) two hundred and six (206) new class A1 shares,

(ii) two hundred and six (206) new class A2 shares and (iii) two hundred and seven (207) new class A3 shares by Mr.

126794

L

U X E M B O U R G

Edward Heard, Head of Project Management, born on 30 July 1969 in London, United Kingdom, residing at 3 Brook
Meadows, Tiptree, Essex, C05 0QF and paid up by a contribution in kind consisting in forty-three thousand six hundred
and eighty-one (43,681) shares held by Mr. Edward Heard, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount
of forty-three thousand six hundred and eighty-one British Pounds (GBP 43,681.00) (the "Contribution XI").

The Contribution XI of forty-three thousand six hundred and eighty-one British Pounds (GBP 43,681.00) shall be

allocated (i) to the Company's share capital for an amount of six hundred and nineteen British Pounds (GBP 619.00) and
(ii) to the share premium account for an amount of forty-three thousand and sixty-two British Pounds (GBP 43,062.00).

- three hundred and forty-seven (347) New A Shares subdivided into (i) one hundred and fifteen (115) new class A1

shares, (ii) one hundred and sixteen (116) new class A2 shares and (iii) one hundred and sixteen (116) new class A3 shares
by Mrs. Louise Morrison, Assistant Director of Business Operations, born on 30 October 1969 in London, United King-
dom, residing at 67, Dairsie Road, Eltham, London, SE9 1 XN, United Kingdom and paid up by a contribution in kind
consisting in twenty-four thousand five hundred and five (24,505) shares held by Mrs. Louise Morrison, prenamed, in Ship
Luxco  1  S.à  r.l.,  prenamed,  for  a  total  amount  of  twenty-four  thousand  five  hundred  and  five  British  Pounds  (GBP
24,505.00) (the "Contribution XII").

The Contribution XII of twenty-four thousand five hundred and five British Pounds (GBP 24,505.00) shall be allocated

(i) to the Company's share capital for an amount of three hundred and forty-seven British Pounds (GBP 347.00) and (ii)
to the share premium account for an amount of twenty-four thousand one hundred and fifty-eight British Pounds (GBP
24,158.00).

- three hundred and nine (309) New A Shares subdivided into (i) one hundred and three (103) new class A1 shares,

(ii) one hundred and three (103) new class A2 shares and (iii) one hundred and three (103) new class A3 shares by Mr.
Gareth Lewis, Director of Risks and Compliance, born on 29 July 1955 in Bristol, United Kingdom, residing at 13, Gun
Tower Mews, Rochester, Kent. ME1 3GU, United Kingdom and paid up by a contribution in kind consisting in twenty-
one thousand eight hundred and forty (21,840) shares held by Mr. Gareth Lewis, prenamed, in Ship Luxco 1 S.à r.l.,
prenamed, for a total amount of twenty-one thousand eight hundred and forty British Pounds (GBP 21,840.00) (the
"Contribution XIII").

The Contribution XIII of twenty-one thousand eight hundred and forty British Pounds (GBP 21,840.00) shall be allo-

cated (i) to the Company's share capital for an amount of three hundred and nine British Pounds (GBP 309.00) and (ii)
to the share premium account for an amount of twenty-one thousand five hundred and thirty-one British Pounds (GBP
21,531.00).

- eight hundred and fifty-nine (859) New A Shares by subdivided into (i) two hundred and eighty-six (286) new class

A1 shares, (ii) two hundred and eighty-six (286) new class A2 shares and (iii) two hundred and eighty-seven (287) new
class A3 shares by Mr. Ewan McGriskin, Business Development Executive, born on 27 September 1978 in Sydney, Aus-
tralia, residing at Ground Floor, 40 Hammersmith Grove, London W6 7HA, United Kingdom and paid up by a contribution
in kind consisting in sixty thousand six hundred and sixty-seven shares held by Mr. Ewan McGriskin, prenamed, in Ship
Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of sixty thousand six hundred and sixty-seven British Pounds (GBP 60,667.00)
(the "Contribution XIV").

The Contribution XIV of sixty thousand six hundred and sixty-seven British Pounds (GBP 60,667.00) shall be allocated

(i) to the Company's share capital for an amount of eight hundred and fifty-nine British Pounds (GBP 859.00) and (ii) to
the share premium account for an amount of fifty-nine thousand eight hundred and eight British Pounds (GBP 59,808.00).

2. To restate article 5.1 of the Company’s articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of by an amount of one hundred

and twenty-two thousand nine hundred and forty-nine British Pounds (GBP 122,949), so as to raise it from its present
amount  of  eight  million  three  hundred  and  forty-six  thousand  four  hundred  and  twenty-six  British  Pounds  (GBP
8,346,426.00)  up  to  eight  million  four  hundred  and  sixty-nine  three  hundred  and  seventy-five  British  Pounds  (GBP
8,469,375.00) by the issue of one hundred and twenty-two thousand nine hundred and forty-nine (122,949) new ordinary
shares of category A subdivided into (i) forty thousand nine hundred and seventy-eight (40,978) new class A1 shares, (ii)

126795

L

U X E M B O U R G

forty thousand nine hundred and eighty-four (40,984) new class A2 shares and (iii) forty thousand nine hundred and
eighty-seven (40,987) new class A3 shares, each having a par value of one British Pound (GBP 1.00), (collectively referred
as the "New A Shares"), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as
amended by the below resolutions, paid up by means of contribution in kind consisting in eight million six hundred and
seventy-four thousand two hundred and eighty-nine (8,674,289) shares each having a par value of one British Pound (GBP
1.00), in Ship Luxco 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.678.

<i>Subscription

- Mr. Phillip McGriskin, Chief Executive Officer, born on 20 January 1974 in Sydney, Australia, residing at 76, Bathurst

Gardens, London, NW10 5HY, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, previously named, by virtue of a proxy
given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for thirty-eight thousand one hundred and forty-two
(38,142) New A Shares subdivided into (i) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class A1 shares,
(ii) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class A2 shares and (iii) twelve thousand seven hundred
and fourteen (12,714) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in two million six
hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four (2,690,844) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for an
amount of two million six hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four British Pounds (GBP 2,690,844.00)
(the "Contribution I").

The Contribution I of two million six hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four British Pounds (GBP

2,690,844.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirty-eight thousand one hundred and
forty-two British Pounds (GBP 38,142.00) and (ii) to the share premium account for an amount of two million six hundred
and fifty-two thousand seven hundred and two British pounds (GBP 2,652,702.00).

- Mr. Paul Townsend, Chief Operating Officer, born on 9 July 1963 in Lewisham, United Kingdom, residing at 7 Cedars

Road, Beckenham, Kent, BR3 4JE, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, previously named, by virtue of a
proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe thirty-eight thousand one hundred and forty-two
(38,142) New A Shares subdivided into (i) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class A1 shares,
(ii) twelve thousand seven hundred and fourteen (12,714) new class A2 shares and (iii) twelve thousand seven hundred
and fourteen (12,714) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in two million six
hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four (2,690,844) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a
total  amount  of  two  million  six  hundred  and  ninety  thousand  eight  hundred  and  forty-four  British  Pounds  (GBP
2,690,844.00) (the "Contribution II").

The Contribution II of two million six hundred and ninety thousand eight hundred and forty-four British Pounds (GBP

2,690,844.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirty-eight thousand one hundred and
forty-two British Pounds (GBP 38,142.00) and (ii) to the share premium account for an amount of two million six hundred
and fifty-two thousand seven hundred and two British pounds (GBP 2,652,702.00).

- Mr. Jonathan Fisher, Chief Technology Officer, born on 14 August 1972 in London, United Kingdom, residing Flat

211, King’s Wharf, 301 Kingsland Road, London E8 4DS, United Kingdom, here represented by Mrs Christèle ALEXAN-
DRE, previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for thirteen
thousand five hundred and seven (13,507) New A Shares subdivided into (i) four thousand five hundred and two (4,502)
new class A1 shares, (ii) four thousand five hundred and two (4,502) new class A2 shares and (iii) four thousand five
hundred and three (4,503) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in nine hundred
and fifty-two thousand nine hundred and two (952,902) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of
nine hundred and fifty-two thousand nine hundred and two British Pounds (GBP 952,902.00) (the "Contribution III").

The Contribution III of nine hundred and fifty-two thousand nine hundred and two British Pounds (GBP 952,902.00)

is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirteen thousand five hundred and seven British Pounds
(GBP 13,507.00) and (ii) to the share premium account for an amount of nine hundred and thirty-nine thousand three
hundred and ninety-five British pounds (GBP 939,395.00).

- Ares Limited, a limited liability company, having its registered office at 39/41 Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU,

registered with the trade register in St. Helier under number 107605, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE,
previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for thirteen
thousand sixteen (13,016) New A Shares subdivided into (i) four thousand three hundred and thirty-eight (4,338) new
class A1 shares, (ii) four thousand three hundred and thirty-nine (4,339) new class A2 shares and (iii) four thousand three
hundred and thirty- nine (4,339) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in nine
hundred and eighteen thousand two hundred and eighty-five (918,285) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a
total amount of for a total amount of nine hundred and eighteen thousand two hundred and eighty-five British Pounds
(GBP 918,285.00) (the "Contribution IV").

The  Contribution  IV  of  nine  hundred  and  eighteen  thousand  two  hundred  and  eighty-five  British  Pounds  (GBP

918,285.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of thirteen thousand sixteen British Pounds
(GBP 13,016.00) and (ii) to the share premium account for an amount of nine hundred and five thousand two hundred
and sixty-nine British pounds (GBP 905,269.00).

126796

L

U X E M B O U R G

- Mr. John Huggins, Director of Business Operations, born on 1st January 1960 in London, United Kingdom, residing

at 26 Elmshaw Road, Putney, London SW15 5EL, United Kingdom, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE,
previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for five thousand
two hundred and seventy-nine (5,279) New A Shares subdivided into (i) one thousand seven hundred and fifty-nine (1,759)
new class A1 shares, (ii) one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A2 shares and (iii) one thousand seven
hundred and sixty (1,760) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in three hundred
and seventy-two thousand four hundred and eighty-two (372,482) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total
amount of three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two British Pounds (GBP 372,482.00) (the
"Contribution V").

The Contribution V of three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two British Pounds (GBP

372,482.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of five thousand two hundred and seventy-nine
British Pounds (GBP 5,279.00) and (ii) to the share premium account for an amount of three hundred and sixty-seven
thousand two hundred and three British pounds (GBP 367,203.00).

- Mr. Stephen Kavanagh, Head of Development &amp; Systems Architect, born on 16 February 1969 in London, United

Kingdom, residing at 60 Weald Road, Brentwood, Essex, CM14 4TH, United Kingdom, here represented by Mrs Christèle
ALEXANDRE, previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe
for five thousand two hundred and seventy-nine (5,279) New A Shares subdivided into (i) one thousand seven hundred
and fifty-nine (1,759) new class A1 shares, (ii) one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A2 shares and (iii)
one thousand seven hundred and sixty (1,760) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting
in three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two (372,482) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., pren-
amed, for a total amount of three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two British Pounds (GBP
372,482.00) (the "Contribution VI").

The Contribution VI of three hundred and seventy-two thousand four hundred and eighty-two British Pounds (GBP

372,482.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of five thousand two hundred and seventy-nine
British Pounds (GBP 5,279.00) and (ii) to the share premium account for an amount of three hundred and sixty-seven
thousand two hundred and three British pounds (GBP 367,203.00).

- Mr. Mark O’Brien, Chief Financial Officer, born on 19 April 1971 in Wolverhampton, United Kingdom, residing at

83 Melrose Avenue, London, NW2 4LR, United Kingdom, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, previously
named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for three thousand three
hundred and two (3,302) New A Shares subdivided into (i) one thousand one hundred (1,100) new class A1 shares, (ii)
one thousand one hundred and one (1,101) new class A2 shares and (iii) one thousand one hundred and one (1,101) new
class A3 shares, and to pay them up by a contribution in kind consisting in two hundred and thirty-two thousand nine
hundred and sixty-two (232,962) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, (the "Contribution VII") for a total amount of
two hundred and thirty-two thousand nine hundred and sixty-two British Pounds (GBP 232,962.00) (the "Contribution
VII").

The  Contribution  VII  of  two  hundred  and  thirty-two  thousand  nine  hundred  and  sixty-two  British  Pounds  (GBP

232,962.00) is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of three thousand three hundred and two British
Pounds (GBP 3,302.00) and (ii) to the share premium account for an amount of (i) two hundred and twenty-nine thousand
six hundred and sixty British pounds (GBP 229,660.00).

- Mr. Mark Fleming, Vice President Sales, born on 1 August 1974 in Watseka, Illinois, United States of America, residing

at Wouwermanstraat 1-Boven 1071 LT Amsterdam, The Netherlands, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE,
previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for two thousand
nine hundred and seven (2,907) New A Shares subdivided into (i) nine hundred and sixty-nine (969) new class A1 shares,
(ii) nine hundred and sixty-nine (969) new class A2 shares and (iii) nine hundred and sixty-nine (969) new class A3 shares
and to pay them up by a contribution in kind consisting in two hundred and five thousand one hundred and thirty-one
(205,131) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of two hundred and five thousand one hundred
and thirty-one British Pounds (GBP 205,131.00) (the "Contribution VIII").

The Contribution VIII of two hundred and five thousand one hundred and thirty-one British Pounds (GBP 205,131.00)

is allocated (i) to the Company's share capital for an amount of two thousand nine hundred and seven British Pounds
(GBP 2,907.00) and (ii) to the share premium account for an amount of two hundred and two thousand two hundred
and twenty-four British pounds (GBP 202,224.00).

- Mr. Patrick Jonsonn, Chief Executive Officer of Envoy Services Sweden AB, born on 8 July 1967 in Harlanda, Sweden,

residing at 670608-5070, Oja Midgard, 360 32 Gemla, Sweden, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, pre-
viously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for five hundred
and fifty-four (554) New A Shares subdivided into (i) one hundred and eighty-four (184) new class A1 shares, (ii) one
hundred and eighty-five (185) new class A2 shares and (iii) one hundred and eighty-five (185) new class A3 shares and to
pay them up by a contribution in kind consisting in thirty-nine thousand one hundred and thirty (39,130) shares in Ship
Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of total amount of two hundred and five thousand one hundred and thirty-
one British Pounds (GBP 39,130.00) (the "Contribution IX").

126797

L

U X E M B O U R G

The Contribution IX of thirty-nine thousand one hundred and thirty British Pounds (GBP 39,130.00) is allocated (i)

to the Company's share capital for an amount of five hundred and fifty-four British Pounds (GBP 554.00) and (ii) to the
share  premium  account  for  an  amount  of  thirty-eight  thousand  five  hundred  and  seventy-six  British  Pounds  (GBP
38,576.00).

- Mr. Stefan Burkwood, Banking Director, born on 4 May 1972 in London, United Kingdom, residing at 75 Larksway,

Bishops Stortford, Hertfordshire, CM23 4DG, United Kingdom, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, pre-
viously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for six hundred and
eighty-seven (687) New A Shares subdivided into (i) (i) two hundred and twenty-nine (229) new class A1 shares, (ii) two
hundred and twenty-nine (229) new class A2 shares and (iii) two hundred and twenty-nine (229) new class A3 shares and
to pay them up by a contribution in kind consisting in forty-eight thousand five hundred and thirty-four (48,534) shares
in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of forty-eight thousand five hundred and thirty-four British Pounds
(GBP 48,534.00) (the "Contribution X").

The Contribution X of forty-eight thousand five hundred and thirty-four British Pounds (GBP 48,534.00) is allocated

(i) to the Company's share capital for an amount of six hundred and eighty-seven British Pounds (GBP 687.00) and (ii) to
the share premium account for an amount of forty-seven thousand eight hundred and forty-seven British Pounds (GBP
47,847.00).

- Mr. Edward Heard, Head of Project Management, born on 30 July 1969 in London, United Kingdom, residing at 3

Brook Meadows, Tiptree, Essex, C05 0QF, here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE, previously named, by virtue
of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for six hundred and nineteen (619) New A
Shares subdivided into (i) two hundred six (206) new class A1 shares, (ii) two hundred and six (206) new class A2 shares
and (iii) two hundred and seven (207) new class A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in
forty-three thousand six hundred and eighty-one (43,681) in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of forty-
three thousand six hundred and eighty-one British Pounds (GBP 43,681.00) (the "Contribution XI").

The Contribution XI of forty-three thousand six hundred and eighty-one British Pounds (GBP 43,681.00) is allocated

(i) to the Company's share capital for an amount of six hundred and nineteen British Pounds (GBP 619.00) and (ii) to the
share premium account for an amount of forty-three thousand and sixty-two British Pounds (GBP 43,062.00).

- Mrs. Louise Morrison, Assistant Director of Business Operations, born on 30 October 1969 in London, United

Kingdom, residing at 67, Dairsie Road, Eltham, London, SE9 1 XN, United Kingdom, here represented by Mrs Christèle
ALEXANDRE, previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe
for three hundred and forty-seven (347) New A Shares subdivided into (i) one hundred and fifteen (115) new class A1
shares, (ii) one hundred and sixteen (116) new class A2 shares and (iii) one hundred and sixteen (116) new class A3 shares
and to pay them up by a contribution in kind consisting in twenty-four thousand five hundred and five (24,505) shares in
Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of twenty-four thousand five hundred and five British Pounds (GBP
24,505.00) (the "Contribution XII").

The Contribution XII of twenty-four thousand five hundred and five British Pounds (GBP 24,505.00) is allocated (i) to

the Company's share capital for an amount of three hundred and forty-seven British Pounds (GBP 347.00) and (ii) to the
share  premium  account  for  an  amount  of  twenty-four  thousand  one  hundred  and  fifty-eight  British  Pounds  (GBP
24,158.00).

- Mr. Gareth Lewis, Director of Risks and Compliance, born on 29 July 1955 in Bristol, United Kingdom, residing at

13, Gun Tower Mews, Rochester, Kent. ME1 3GU, United Kingdom here represented by Mrs Christèle ALEXANDRE,
previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for three hundred
and nine (309) New A Shares subdivided into (i) one hundred and three (103) new class A1 shares, (ii) one hundred and
three (103) new class A2 shares and (iii) one hundred and three (103) new class A3 shares and to pay them up by a
contribution in kind consisting twenty-one thousand eight hundred and forty (21,840) shares in Ship Luxco 1 S.à r.l.,
prenamed, for a total amount of twenty-one thousand eight hundred and forty British Pounds (GBP 21,840.00) (the
"Contribution XIII").

The Contribution XIII of twenty-one thousand eight hundred and forty British Pounds (GBP 21,840.00) is allocated (i)

to the Company's share capital for an amount of three hundred and nine British Pounds (GBP 309.00) and (ii) to the
share  premium  account  for  an  amount  of  twenty-one  thousand  five  hundred  and  thirty-one  British  Pounds  (GBP
21,531.00).

- Mr. Ewan McGriskin, Business Development Executive, born on 27 September 1978 in Sydney, Australia, residing at

Ground Floor, 40 Hammersmith Grove, London W6 7HA, United Kingdom here represented by Mrs Christèle ALE-
XANDRE, previously named, by virtue of a proxy given on 27 July 2011, hereto annexed, has declared to subscribe for
eight hundred and fifty-nine (859) New A Shares by subdivided into (i) two hundred and eighty-six (286) new class A1
shares, (ii) two hundred and eighty-six (286) new class A2 shares and (iii) two hundred and eighty-seven (287) new class
A3 shares and to pay them up by a contribution in kind consisting in sixty thousand six hundred and sixty-seven (60,667)
shares in Ship Luxco 1 S.à r.l., prenamed, for a total amount of sixty thousand six hundred and sixty-seven British Pounds
(GBP 60,667.00) (the "Contribution XIV").

126798

L

U X E M B O U R G

The Contribution XIV of sixty thousand six hundred and sixty-seven British Pounds (GBP 60,667.00) is allocated (i)

to the Company's share capital for an amount of eight hundred and fifty-nine British Pounds (GBP 859.00) and (ii) to the
share premium account for an amount of fifty-nine thousand eight hundred and eight British Pounds (GBP 59,808.00).

A report, regarding the Contribution I, the Contribution II, the Contribution III, the Contribution IV, the Contribution

V, the Contribution VI, the Contribution VII, the Contribution VIII, the Contribution IX, the Contribution X, the Con-
tribution XI, the Contribution XII, the Contribution XIII and the Contribution XIV, has been drawn up by ALTER AUDIT
S.à r.l., a réviseur d’entreprises, having its registered office at 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, dated July 27,
2011, in accordance with Article 26-1 of the law on commercial companies, which contains the following conclusion:

<i>Conclusion (in French version):

«Sous réserve que toutes les acquisitions des sociétés-cibles ainsi que toutes les assemblées générales des filiales devant

se tenir à la même date se réalisent avant cette opération, sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait
n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l’apport ne correspond pas au nombre
et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d’émission.

La rémunération des apports en nature consiste en 122,949 actions de catégorie A à créer avec une valeur nominale

de GBP 1 chacune, augmentée de la prime d’émission de GBP 8,551,340.«

The aforesaid report issued by Alter Audit Sàrl, prenamed, will remain annexed to the present deed to be filed at the

same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of

incorporation of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:

5.1. The Company has a share capital of eight million four hundred and sixty-nine three hundred and seventy-five

British Pounds (GBP 8,469,375.00) represented by:

six million one hundred and forty-four thousand eight hundred and forty-one (6,144,841) ordinary shares of class A,

subdivided into (i) two million forty-eight thousand two hundred and seventy-five (2,048,275) class A1 shares, (ii) two
million forty-eight thousand two hundred and eighty-one (2,048,281) class A2 shares and (iii) two million forty-eight
thousand two hundred and eighty-five (2,048,285) class A3 shares (the "A Shares", their holders being referred to as "A
Shareholders");

one million five hundred and four thousand five hundred and thirty-two (1,504,532) ordinary shares of class B subdi-

vided into (i) five hundred and one thousand five hundred and ten (501,510) class B1 shares, (ii) five hundred and one
thousand five hundred and ten (501,510) class B2 shares and (iii) five hundred and one thousand five hundred and twelve
(501,512) class B3 shares (the "B Shares", their holders being referred to as "B Shareholders");

eight hundred and twenty thousand (820,000) ordinary shares of class C subdivided into two hundred and seventy-

three thousand three hundred and thirty-three (273,333) class C1 shares, two hundred and seventy-three thousand three
hundred and thirty-three (273,333) class C2 shares and seventy-three thousand three hundred and thirty-four (273,334)
class C3 shares (the "C Shares", their holders being referred to as "C Shareholders" and collectively with the A Shares,
the B Shares, the "Shares"); and

two (2) management (the "Management Shares") shares held by the General Partner (actionnaire commandité).".

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to five thousand five hundred euro.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg),
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «SHIP Luxco

Holding &amp; Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.673, ayant son siège social au
2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 26 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 11 août 2010,

126799

L

U X E M B O U R G

numéro 1626. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 1 

er

 avril 2011 suivant acte reçu par le

notaire soussigné, publié au Mémorial C du 8 juillet 2011, numéro 1517, page 72803.

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Christèle ALEXANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui est

aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

Augmentation du capital social de la Société par un montant de cent vingt-deux mille neuf cent quarante-neuf Livres

Sterling (GBP 122.949,00), de façon à l’accroître de son montant actuel de huit millions trois cent quarante-six mille quatre
cent vingt-six Livres Sterling (GBP 8.346.426,00) à huit millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent soixante-quinze
Livres Sterling (GBP 8.469.375,00), par l’émission cent vingt-deux mille neuf cent quarante-neuf (122.949) nouvelles ac-
tions de classe A, divisées en (i) quarante mille neuf cent soixante-dix-huit (40.978) nouvelles actions de classe A1, (ii)
quarante mille neuf cent quatre-vingt-quatre (40,984) nouvelles actions de classe A2 et (iii) quarante mille neuf cent quatre-
vingt-sept (40,987) nouvelles actions de classe A3 (collectivement désignées comme les «Nouvelles Actions A»), chacune
ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu’indiqués dans
les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par des apports en nature consistant en
huit millions six cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-neuf (8.674.289) parts sociales, chacune ayant une
valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-), dans Ship Luxco 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 154.678, les Nouvelles
Actions A seront souscrites comme suit:

<i>Souscription

- trente-huit mille cent quarante-deux (38.142) Nouvelles Actions A divisées en (i) douze mille sept cent quatorze

(12.714) nouvelles actions de classe A1, (ii) douze mille sept cent quatorze (12.714) actions de classe A2 et (iii) douze
mille sept cent quatorze (12.714) actions de classe A3 par Monsieur Phillip McGriskin, Chief Executive Officer, né le 20
janvier 1974 à Sydney, Australie, demeurant au 76, Bathurst Gardens, London, NW10 5HY, Royaume-Uni et payées par
un apport en nature consistant en l’apport de deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre
(2.690.844) actions détenues par Phillip McGriskin, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de deux
millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP 2.690.844,00) (l’«Apport I»).

L’Apport I s’élevant à deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP

2.690.844,00) sera affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de trente-huit mille cent quarante-deux Livres
Sterling (GBP 38.142,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de deux millions six cent
cinquante-deux mille sept cent deux Livres Sterling (GBP 2.652.702,00).

- trente-huit mille cent quarante-deux (38.142) Nouvelles Actions A divisées en (i) douze mille sept cent quatorze

(12.714) nouvelles actions de classe A1, (ii) douze mille sept cent quatorze (12.714) actions de classe A2 et (iii) douze
mille sept cent quatorze (12.714) actions de classe A3 par Monsieur Paul Townsend, Chief Operating Officer, né le 9
juillet 1963 à Lewisham, Royaume-Uni, demeurant au 7 Cedars Road, Beckenham, Kent, BR3 4JE, Royaume-Uni et payées
par un apport en nature consistant en l’apport de deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre
(2.690.844) actions détenues par Monsieur Paul Townsend, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant
de deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP 2.690.844,00) (l’«Apport
II»).

L’Apport II s’élevant à deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP

2.690.844,00) sera affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de trente-huit mille cent quarante-deux Livres
Sterling (GBP 38.142,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de deux millions six cent
cinquante-deux mille sept cent deux Livres Sterling (GBP 2.652.702,00).

- treize mille cinq cent sept (13.507) Nouvelles Actions A divisées (i) quatre mille cinq cent deux (4.502) nouvelles

actions de classe A1, (ii) quatre mille cinq cent deux (4.502) actions de classe A2 et (iii) quatre mille cinq cent trois (4.503)
actions de classe A3 par Monsieur Jonathan Fisher, Chief Technology Officer, né le 14 août 1972 à Londres, Royaume-
Uni, demeurant Flat 211, King’s Wharf, 301 Kingsland Road, London E8 4DS, Royaume-Uni et payées par un apport en
nature consistant en l’apport de neuf cent cinquante-deux mille neuf cent deux (952.902) actions détenues par Monsieur
Jonathan Fisher, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de neuf cent cinquante-deux mille neuf cent
deux Livres Sterling (GBP 952.902,00) (l’«Apport III»).

L’Apport III s’élevant à neuf cent cinquante-deux mille neuf cent deux Livres Sterling (GBP 952.902,00) sera affecté (i)

au capital social de la Société pour un montant de treize mille cinq cent sept Livres Sterling (GBP 13.507,00) et (ii) au
compte de prime d’émission de la Société pour un montant de neuf cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze
Livres Sterling (GBP 939.395,00).

126800

L

U X E M B O U R G

- treize mille seize (13.016) Nouvelles Actions A divisées en (i) quatre mille trois cent trente-huit (4.338) nouvelles

actions de classe A1, (ii) quatre mille trois cent trente-neuf (4.339) actions de classe A2 et (iii) quatre mille trois cent
trente-neuf (4.339) actions de classe A3 par Ares Limited, une limited liability company, ayant son siège social au 39/41
Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU, enregistrée au Registre de Commerce de St. Helier sous le numéro 107605 et
payées par un apport en nature consistant en l’apport de neuf cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq (918.285)
actions détenues par Ares Limited, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de neuf cent dix-huit
mille deux cent quatre-vingt-cinq Livres Sterling (GBP 918.285,00) (l’«Apport IV»).

L’Apport IV s’élevant à neuf cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq Livres Sterling (GBP 918.285,00) sera affecté

(i) au capital social de la Société pour un montant de treize mille seize Livres Sterling (GBP 13.016,00) et (ii) au compte
de prime d’émission de la Société pour un montant de neuf cent cinq mille deux cent soixante-neuf Livres Sterling (GBP
905.269,00).

- cinq mille deux cent quatre-vingt-deux (5.279) Nouvelles Actions A divisées en (i) mille sept cent cinquante-neuf

(1.759) nouvelles actions de classe A1, (ii) mille sept cent soixante (1760) actions de classe A2 et (iii) mille sept cent
soixante (1760) actions de classe A3 par Monsieur John Huggins, Director of Business Operations, né le 1 

er

 janvier 1960

à Londres, Royaume Uni, demeurant au 26 Elmshaw Road, Putney, Londres SW15 5EL, Royaume Uni et payees par un
apport en nature consistant en l’apport de trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux (372.482) actions
détenues par Monsieur John Huggins, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de trois cent soixante-
douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 372.482,00) (l’«Apport V»).

L’Apport V s’élevant à trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 372.482,00)

sera affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de cinq mille deux cent soixante-dix-neuf Livres Sterling
(GBP 5.279,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de trois cent soixante-sept mille
deux cent trios Livres Sterling (GBP 367.203,00).

- cinq mille deux cent quatre-vingt-deux (5.279) Nouvelles Actions A divisées en (i) mille sept cent cinquante-neuf

(1.759) nouvelles actions de classe A1, (ii) mille sept cent soixante (1760) actions de classe A2 et (iii) mille sept cent
soixante (1760) actions de classe A3 par Monsieur Stephen Kavanagh, Head of Development &amp; Systems Architect, né le
16 février 1969 à Londres, Royaume Uni, demeurant au 60 Weald Road, Brentwood, Essex, CM14 4TH, Royaume Uni
et payees par un apport en nature consistant en l’apport de trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux
(372.482) actions détenues par Monsieur Stephen Kavanagh, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant
de trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 372.482,00) (l’«Apport VI»).

L’Apport VI s’élevant à trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 372.482,00)

sera affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de cinq mille deux cent soixante-dix-neuf Livres Sterling
(GBP 5.279,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de trois cent soixante-sept mille
deux cent trios Livres Sterling (GBP 367.203,00).

- trois mille trois cent deux (3.302) Nouvelles Actions A divisées en i) mille cent (1.100) nouvelles actions de classe

A1, (ii) mille cent une (1.101) actions de classe A2 et (iii) mille cent une (1.101) actions de classe A3 par Monsieur Mark
O’Brien, Chief Financial Officer, né le 19 avril 1971 à Wolverhampton, Royaume Uni, demeurant au 83 Melrose Avenue,
Londres, NW2 4LR, Royaume Uni et payées par un apport en nature consistant en l’apport de deux cent trente-deux
mille neuf cent soixante-deux (232.962) actions détenues par Monsieur Mark O’Brien, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l.,
précitée, pour un montant de deux cent trente-deux mille neuf cent soixante-deux Livres Sterling (GBP 232.962,00)
(l’«Apport VII»).

L’Apport VII s’élevant à deux cent trente-deux mille neuf cent soixante-deux Livres Sterling (GBP 232.962,00) sera

affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de trois mille trois cent deux Livres Sterling (GBP 3.302,00) et
(ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de deux cent vingt-neuf mille six cent soixante Livres
Sterling (GBP 229.660,00).

- deux mille neuf cent sept (2.907) Nouvelles Actions A divisées en i) neuf cent soixante-neuf (969) nouvelles actions

de classe A1, (ii) neuf cent soixante-neuf (969) actions de classe A2 et (iii) neuf cent soixante-neuf (969) actions de classe
A3 par Monsieur Mark Fleming, Vice President Sales, né le 1 

er

 août 1974 à Watseka, Illinois, Etats-Unis d’Amérique,

demeurant au Wouwermanstraat 1-Boven 1071 LT Amsterdam, Pays-Bas et payées par un apport en nature consistant
en l’apport de deux cent cinq mille cent trente et une (205.131) actions détenues par Monsieur Mark Fleming, précité,
dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de deux cent cinq mille cent trente et une Livres Sterling (GBP
205.131,00) (l’«Apport VIII»).

L’Apport VIII s’élevant à deux cent cinq mille cent trente et une Livres Sterling (GBP 205.131,00) sera affecté (i) au

capital social de la Société pour un montant de deux mille neuf cent sept Livres Sterling (GBP 2,907,00) et (ii) au compte
de prime d’émission de la Société pour un montant de deux cent deux mille deux cent vingt-quatre Livres Sterling (GBP
202.224,00).

- cinq cent cinquante-quatre (554) Nouvelles Actions A divisées en i) cent quatre-vingt-quatre (184) nouvelles actions

de classe A1, (ii) cent quatre-vingt-cinq (185) actions de classe A2 et (iii) cent quatre-vingt-cinq (185) actions de classe
A3 par Monsieur Patrick Jonsonn, Chief Executive Officer of Envoy Services Sweden AB, né le 8 juillet 1967 à Harlanda,
Suède, demeurant au 670608-5070, Oja Midgard, 360 32 Gemla, Suède et payées par un apport en nature consistant en

126801

L

U X E M B O U R G

l’apport de trente-neuf mille cent trente (39.130) actions détenues par Monsieur Patrick Jonsonn, précité, dans Ship Luxco
1 S.à r.l., précitée, pour un montant de trente-neuf mille cent trente Livres Sterling (GBP 39.130,00) (l’«Apport IX»).

L’Apport IX s’élevant à trente-neuf mille cent trente Livres Sterling (GBP 39.130,00) sera affecté (i) au capital social

de la Société pour un montant de cinq cent cinquante-quatre Livres Sterling (GBP 554,00) et (ii) au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de trente-huit mille cinq cent soixante-seize Livres Sterling (GBP 38.576,00).

- six cent quatre-vingt-sept (687) Nouvelles Actions A divisées en i) deux cent vingt-neuf (229) nouvelles actions de

classe A1, (ii) deux cent vingt-neuf (229) actions de classe A2 et (iii) deux cent vingt-neuf (229) actions de classe A3 par
Monsieur Stefan Burkwood, Banking Director, né le 4 mai 1972 à Londres, Royaume-Uni, résidant 75 Larksway, Bishops
Stortford, Hertfordshire, CM23 4DG payées par un apport en nature consistant en l’apport de quarante-huit mille cinq
cent trente-quatre (48.534) actions détenues par Monsieur Stefan Burkwood, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée,
pour un montant de quarante-huit mille cinq cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 48.534,00) (l’«Apport X»).

L’Apport X s’élevant à quarante-huit mille cinq cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 48.534,00) sera affecté (i) au

capital social de la Société pour un montant de six cent quatre-vingt-sept Livres Sterling (GBP 687,00) et (ii) au compte
de prime d’émission de la Société pour un montant de quarante-sept mille huit cent quarante-sept Livres Sterling (GBP
47,847,00).

- six cent dix-neuf (619) Nouvelles Actions A divisées en i) deux cent six (206) nouvelles actions de classe A1, (ii) deux

cent six (206) actions de classe A2 et (iii) deux cent sept (207) actions de classe A3 par Monsieur Edward Heard, Head
of Project Management, né le 30 juillet 1969 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 3 Brook Meadows, Tiptree, Essex, C05
0QF, Royaume-Uni, payées par un apport en nature consistant en l’apport de quarante-trois mille six cent quatre-vingt-
une (43.681) actions détenues par Monsieur Edward Heard, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant
de quarante-trois mille six cent quatre-vingt-une Livres Sterling (GBP 43.681,00) (l’«Apport XI»).

L’Apport XI s’élevant à quarante-trois mille six cent quatre-vingt-une Livres Sterling (GBP 43.681,00) sera affecté (i)

au capital social de la Société pour un montant de six cent dix-neuf Livres Sterling (GBP 619,00) et (ii) au compte de
prime d’émission de la Société pour un montant de quarante-trois mille soixante-deux Livres Sterling (GBP 43.062,00).

- trois cent quarante-sept (347) Nouvelles Actions A divisées en i) cent quinze (115) nouvelles actions de classe A1,

(ii) cent seize (116) actions de classe A2 et (iii) cent seize (116) actions de classe A3 par Madame Louise Morrison,
Assistant Director of Business Operations, né le 30 octobre 1969 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 67, Dairsie Road,
Eltham, Londres, Royaume-Uni et payées par un apport en nature consistant en l’apport de vingt-quatre mille cinq cent
cinq (24.505) actions détenues par Madame Louise Morrison, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant
de vingt-quatre mille cinq cent cinq Livres Sterling (GBP 24.505,00) (l’«Apport XII»).

L’Apport XII s’élevant à vingt-quatre mille cinq cent cinq Livres Sterling (GBP 24.505,00) sera affecté (i) au capital social

de la Société pour un montant de trois cent quarante-sept Livres Sterling (GBP 347,00) et (ii) au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de vingt-quatre mille cent cinquante-huit Livres Sterling (GBP 24.158,00).

- trois cent neuf (309) Nouvelles Actions A divisées en i) cent trois (103) nouvelles actions de classe A1, (ii) cent trois

(103) actions de classe A2 et (iii) cent trois (103) actions de classe A3 par Monsieur Gareth Lewis, Director of Risks and
Compliance, né le 29 juillet 1955 à Bristol, Royaume-Uni, résidant au 13, Gun Tower Mews, Rochester, Kent, ME1 3GU
Royaume-Uni et payées par un apport en nature consistant en l’apport de vingt-et-un mille huit cent quarante (21.840)
actions détenues par Monsieur Gareth Lewis, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de vingt-et-
un mille huit cent quarante Livres Sterling (GBP 21.840,00) (l’«Apport XIII»).

L’Apport XIII s’élevant à vingt-et-un mille huit cent quarante Livres Sterling (GBP 21.840,00) sera affecté (i) au capital

social de la Société pour un montant de trois cent neuf Livres Sterling (GBP 347,00) et (ii) au compte de prime d’émission
de la Société pour un montant de vingt-et-un mille cinq cent trente-et-une Livres Sterling (GBP 21.531,00).

- huit cent cinquante-neuf (859) Nouvelles Actions A divisées en i) deux cent quatre-vingt six (286) nouvelles actions

de classe A1, (ii) deux cent quatre-vingt six (286) actions de classe A2 et (iii) deux cent quatre-vingt-sept (287) actions
de classe A3 par Monsieur Ewan McGriskin, Director of Risks and Compliance, né le 27 septembre 1978 à Sydney,
Australie, résidant à Ground Floor, 40 Hammersmith Grove, Londres, W6 7HA Royaume-Uni et payées par un apport
en nature consistant en l’apport de soixante-mille six cent soixante-sept (60.667) actions détenues par Monsieur Ewan
McGriskin, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de soixante-mille six cent soixante-sept Livres
Sterling (GBP 60.667,00) (l’«Apport XIV»).

L’Apport XIV s’élevant à soixante-mille six cent soixante-sept Livres Sterling (GBP 60.667,00) sera affecté (i) au capital

social de la Société pour un montant de huit cent cinquante-neuf Livres Sterling (GBP 859,00) et (ii) au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de soixante mille six cent soixante-sept Livres Sterling (GBP 60.667,00).

2. Modification de l'Article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les décisions ci-dessus.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement

126802

L

U X E M B O U R G

annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cent vingt-deux mille neuf

cent quarante-neuf Livres Sterling (GBP 122.949,00), de façon à l’accroître de son montant actuel de huit millions trois
cent quarante-six mille quatre cent vingt-six Livres Sterling (GBP 8.346.426,00) à huit millions quatre cent soixante-neuf
mille trois cent soixante-quinze Livres Sterling (GBP 8.469.375,00), par l’émission cent vingt-deux mille neuf cent quarante-
neuf (122.949) nouvelles actions de classe A, divisées en (i) quarante mille neuf cent soixante-dix-huit (40.978) nouvelles
actions de classe A1, (ii) quarante mille neuf cent quatre-vingt-quatre (40,984) nouvelles actions de classe A2 et (iii)
quarante mille neuf cent quatre-vingt-sept (40,987) nouvelles actions de classe A3 (collectivement désignées comme les
«Nouvelles Actions A»), chacune ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,00) et ayant les mêmes droits et
obligations tels qu’indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par des
apports en nature consistant en huit millions six cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-neuf (8.674.289)
parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-), dans Ship Luxco 1 S.à r.l., une société à
responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 154.678, les Nouvelles Actions A sont souscrites comme suit:

<i>Souscription

- Monsieur Phillip McGriskin, Chief Executive Officer, né le 20 janvier 1974 à Sydney, Australie, demeurant au 76,

Bathurst Gardens, London, NW10 5HY, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE, maître en
droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare souscrire
trente-huit mille cent quarante-deux (38.142) Nouvelles Actions A divisées en (i) douze mille sept cent quatorze (12.714)
nouvelles actions de classe A1, (ii) douze mille sept cent quatorze (12.714) actions de classe A2 et (iii) douze mille sept
cent quatorze (12.714) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de deux millions six
cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre (2.690.844) actions détenues par Monsieur Phillip McGriskin, précité,
dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-
quatre Livres Sterling (GBP 2.690.844,00) (l’«Apport I»).

L’Apport I s’élevant à deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP

2.690.844,00) est affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de trente-huit mille cent quarante-deux Livres
Sterling (GBP 38.142,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de deux millions six cent
cinquante-deux mille sept cent deux Livres Sterling (GBP 2.652.702,00).

- Monsieur Paul Townsend, Chief Operating Officer, né le 9 juillet 1963 à Lewisham, Royaume-Uni, demeurant au 7

Cedars Road, Beckenham, Kent, BR3 4JE, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE, maître en
droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare souscrire
trente-huit mille cent quarante-deux (38.142) Nouvelles Actions A divisées en (i) douze mille sept cent quatorze (12.714)
nouvelles actions de classe A1, (ii) douze mille sept cent quatorze (12.714) actions de classe A2 et (iii) douze mille sept
cent quatorze (12.714) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de deux millions six
cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre (2.690.844) actions détenues par Monsieur Paul Townsend, précité,
dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-
quatre Livres Sterling (GBP 2.690.844,00) (l’«Apport II»).

L’Apport II s’élevant à deux millions six cent quatre-vingt dix mille huit cent quarante-quatre Livres Sterling (GBP

2.690.844,00) est affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de trente-huit mille cent quarante-deux Livres
Sterling (GBP 38.142,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de deux millions six cent
cinquante-deux mille sept cent deux Livres Sterling (GBP 2.652.702,00).

- Monsieur Jonathan Fisher, Chief Technology Officer, né le 14 août 1972 à Londres, Royaume-Uni, ici représenté par

Madame Christèle ALEXANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le
27 juillet 2011, ci-annexée, demeurant Flat 211, King’s Wharf, 301 Kingsland Road, London E8 4DS, Royaume-Uni déclare
souscrire treize mille cinq cent sept (13.507) Nouvelles Actions A divisées (i) quatre mille cinq cent deux (4.502) nouvelles
actions de classe A1, (ii) quatre mille cinq cent deux (4.502) actions de classe A2 et (iii) quatre mille cinq cent trois (4.503)
actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de neuf cent cinquante-deux mille neuf cent
deux (952.902) actions détenues par Monsieur Jonathan Fisher, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un
montant de neuf cent cinquante-deux mille neuf cent deux Livres Sterling (GBP 952.902,00) (l’«Apport III»).

126803

L

U X E M B O U R G

L’Apport III s’élevant à neuf cent cinquante-deux mille neuf cent deux Livres Sterling (GBP 952.902,00) est affecté (i)

au capital social de la Société pour un montant de treize mille cinq cent sept Livres Sterling (GBP 13.507,00) et (ii) au
compte de prime d’émission de la Société pour un montant de neuf cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze
Livres Sterling (GBP 939.395,00).

- Ares Limited, une limited liability company, ayant son siège social au 39/41 Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU,

enregistrée au Registre de Commerce de St. Helier sous le numéro 107605, ici représenté par Madame Christèle ALE-
XANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée,
déclare souscrire treize mille seize (13.016) Nouvelles Actions A divisées en (i) quatre mille trois cent trente-huit (4.338)
nouvelles actions de classe A1, (ii) quatre mille trois cent trente-neuf (4.339) actions de classe A2 et (iii) quatre mille trois
cent trente-neuf (4.339) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de neuf cent dix-huit
mille deux cent quatre-vingt-cinq (918.285) actions détenues par Ares Limited, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée,
pour un montant de neuf cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq Livres Sterling (GBP 918.285,00) (l’«Apport IV»).

L’Apport IV s’élevant à neuf cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq Livres Sterling (GBP 918.285,00) est affecté

(i) au capital social de la Société pour un montant de treize mille seize Livres Sterling (GBP 13.016,00) et (ii) au compte
de prime d’émission de la Société pour un montant de neuf cent cinq mille deux cent soixante-neuf Livres Sterling (GBP
905.269,00).

- Monsieur John Huggins, Director of Business Operations, né le 1er janvier 1960 à Londres, Royaume Uni, demeurant

au 26 Elmshaw Road, Putney, Londres SW15 5EL, Royaume Uni, ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE,
maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare
souscrire cinq mille deux cent quatre-vingt-deux (5.279) Nouvelles Actions A divisées en (i) mille sept cent cinquante-
neuf (1.759) nouvelles actions de classe A1, (ii) mille sept cent soixante (1760) actions de classe A2 et (iii) mille sept cent
soixante (1760) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de trois cent soixante-douze
mille quatre cent quatre-vingt-deux (372.482) actions détenues par Monsieur John Huggins, précité, dans Ship Luxco 1
S.à r.l., précitée, pour un montant de trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP
372.482,00) (l’«Apport V»).

L’Apport V s’élevant à trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 372.482,00)

sera affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de cinq mille deux cent soixante-dix-neuf Livres Sterling
(GBP 5.279,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de trois cent soixante-sept mille
deux cent trios Livres Sterling (GBP 367.203,00).

- Monsieur Stephen Kavanagh, Head of Development &amp; Systems Architect, né le 16 février 1969 à Londres, Royaume

Uni, demeurant au 60 Weald Road, Brentwood, Essex, CM14 4TH, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Christèle
ALEXANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-
annexée, déclare souscrire cinq mille deux cent quatre-vingt-deux (5.279) Nouvelles Actions A divisées en (i) mille sept
cent cinquante-neuf (1.759) nouvelles actions de classe A1, (ii) mille sept cent soixante (1760) actions de classe A2 et (iii)
mille sept cent soixante (1760) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de trois cent
soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux (372.482) actions détenues par Monsieur Stephen Kavanagh, précité,
dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux
Livres Sterling (GBP 372.482,00) (l’«Apport VI»).

L’Apport VI s’élevant à trois cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 372.482,00)

est affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de cinq mille deux cent soixante-dix-neuf Livres Sterling
(GBP 5.279,00) et (ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de trois cent soixante-sept mille
deux cent trios Livres Sterling (GBP 367.203,00).

- Monsieur Mark O’Brien, Chief Financial Officer, né le 19 avril 1971 à Wolverhampton, Royaume Uni, demeurant au

83 Melrose Avenue, Londres, NW2 4LR, Royaume Uni, ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE, maître en
droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare souscrire
trois mille trois cent deux (3.302) Nouvelles Actions A divisées en i) mille cent (1.100) nouvelles actions de classe A1,
(ii) mille cent une (1.101) actions de classe A2 et (iii) mille cent une (1.101) actions de classe A3, payées par un apport
en nature consistant en l’apport de deux cent trente-deux mille neuf cent soixante-deux (232.962) actions détenues par
Monsieur Mark O’Brien, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de deux cent trente-deux mille
neuf cent soixante-deux Livres Sterling (GBP 232.962,00) (l’«Apport VII»).

L’Apport VII s’élevant à deux cent trente-deux mille neuf cent soixante-deux Livres Sterling (GBP 232.962,00) est

affecté (i) au capital social de la Société pour un montant de trois mille trois cent deux Livres Sterling (GBP 3.302,00) et
(ii) au compte de prime d’émission de la Société pour un montant de deux cent vingt-neuf mille six cent soixante Livres
Sterling (GBP 229.660,00).

- Monsieur Mark Fleming, Vice President Sales, né le 1er août 1974 à Watseka, Illinois, Etats-Unis d’Amérique, de-

meurant au Wouwermanstraat 1-Boven 1071 LT Amsterdam, Pays-Bas, ici représenté par Madame Christèle ALEXAN-
DRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée,
déclare souscrire deux mille neuf cent sept (2.907) Nouvelles Actions A divisées en i) neuf cent soixante-neuf (969)
nouvelles actions de classe A1, (ii) neuf cent soixante-neuf (969) actions de classe A2 et (iii) neuf cent soixante-neuf (969)
actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de deux cent cinq mille cent trente et un

126804

L

U X E M B O U R G

(205,131) actions détenues par Monsieur Mark Fleming, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de
deux cent cinq mille cent trente et une Livres Sterling (GBP 205.131,00) (l’«Apport VIII»).

L’Apport VIII s’élevant à deux cent cinq mille cent trente et une Livres Sterling (GBP 205.131,00) est affecté (i) au

capital social de la Société pour un montant de deux mille neuf cent sept Livres Sterling (GBP 2,907,00) et (ii) au compte
de prime d’émission de la Société pour un montant de deux cent deux mille deux cent vingt-quatre Livres Sterling (GBP
202.224,00).

- Monsieur Patrick Jonsonn, Chief Executive Officer of Envoy Services Sweden AB, né le 8 juillet 1967 à Harlanda,

Suède, demeurant au 670608-5070, Oja Midgard, 360 32 Gemla, Suède, ici représenté par Madame Christèle ALEXAN-
DRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée,
déclare souscrire cinq cent cinquante-quatre (554) Nouvelles Actions A divisées en i) cent quatre-vingt-quatre (184)
nouvelles actions de classe A1, (ii) cent quatre-vingt-cinq (185) actions de classe A2 et (iii) cent quatre-vingt-cinq (185)
actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de trente-neuf mille cent trente (39.130)
actions détenues par Monsieur Patrick Jonsonn, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de trente-
neuf mille cent trente Livres Sterling (GBP 39.130,00) (l’«Apport IX»).

L’Apport IX s’élevant à trente-neuf mille cent trente Livres Sterling (GBP 39.130,00) est affecté (i) au capital social de

la Société pour un montant de cinq cent cinquante-quatre Livres Sterling (GBP 554,00) et (ii) au compte de prime d’émis-
sion de la Société pour un montant de trente-huit mille cinq cent soixante-seize Livres Sterling (GBP 38.576,00).

- Monsieur Stefan Burkwood, Banking Director, né le 4 mai 1972 à Londres, Royaume-Uni, résidant 75 Larksway,

Bishops Stortford, Hertfordshire, CM23 4DG, ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE, maître en droit, de-
meurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare souscrire six cent
quatre-vingt-sept (687) Nouvelles Actions A divisées en i) deux cent vingt-neuf (229) nouvelles actions de classe A1, (ii)
deux cent vingt-neuf (229) actions de classe A2 et (iii) deux cent vingt-neuf (229) actions de classe A3, payées par un
apport en nature consistant en l’apport de quarante-huit mille cinq cent trente-quatre (48.534) actions détenues par
Monsieur Stefan Burkwood, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, (pour un montant de quarante-huit mille cinq
cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 48.534,00) (l’«Apport X»).

L’Apport X s’élevant à quarante-huit mille cinq cent trente-quatre Livres Sterling (GBP 48.534,00) est affecté (i) au

capital social de la Société pour un montant de six cent quatre-vingt-sept Livres Sterling (GBP 687,00) et (ii) au compte
de prime d’émission de la Société pour un montant de quarante-sept mille huit cent quarante-sept Livres Sterling (GBP
47,847,00).

- Monsieur Edward Heard, Head of Project Management, né le 30 juillet 1969 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 3

Brook Meadows, Tiptree, Essex, C05 0QF, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE, maître en
droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare souscrire
six cent dix-neuf (619) Nouvelles Actions A divisées en i) deux cent six (206) nouvelles actions de classe A1, (ii) deux
cent six (206) actions de classe A2 et (iii) deux cent sept (207) actions de classe A3, payées par un apport en nature
consistant en l’apport de quarante-trois mille six cent quatre-vingt-une (43.681) actions détenues par Monsieur Edward
Heard, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de quarante-trois mille six cent quatre-vingt-une
Livres Sterling (GBP 43.681,00) (l’«Apport XI»).

L’Apport XI s’élevant à quarante-trois mille six cent quatre-vingt-une Livres Sterling (GBP 43.681,00) est affecté (i) au

capital social de la Société pour un montant de six cent dix-neuf Livres Sterling (GBP 619,00) et (ii) au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de quarante-trois mille soixante-deux Livres Sterling (GBP 43.062,00).

- Madame Louise Morrison, Assistant Director of Business Operations, né le 30 octobre 1969 à Londres, Royaume-

Uni, résidant au 67, Dairsie Road, Eltham, Londres, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Christèle ALEXANDRE,
maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare
souscrire trois cent quarante-sept (347) Nouvelles Actions A divisées en i) cent quinze (115) nouvelles actions de classe
A1, (ii) cent seize (116) actions de classe A2 et (iii) cent seize (116) actions de classe A3, payées par un apport en nature
consistant en l’apport de vingt-quatre mille cinq cent cinq (24.505) actions détenues par Madame Louise Morrison, précité,
dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de vingt-quatre mille cinq cent cinq Livres Sterling (GBP 24.505,00)
(l’«Apport XII»).

L’Apport XII s’élevant à vingt-quatre mille cinq cent cinq Livres Sterling (GBP 24.505,00) est affecté (i) au capital social

de la Société pour un montant de trois cent quarante-sept Livres Sterling (GBP 347,00) et (ii) au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de vingt-quatre mille cent cinquante-huit Livres Sterling (GBP 24.158,00).

- Monsieur Gareth Lewis, Director of Risks and Compliance, né le 29 juillet 1955 à Bristol, Royaume-Uni, résidant au

13, Gun Tower Mews, Rochester, Kent, ME1 3GU Royaume-Uni ici représenté par Madame Christèle ALEXANDRE,
maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée, déclare
souscrire trois cent neuf (309) Nouvelles Actions A divisées en i) cent trois (103) nouvelles actions de classe A1, (ii) cent
trois (103) actions de classe A2 et (iii) cent trois (103) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant
en l’apport de vingt-et-un mille huit cent quarante (21.840) actions détenues par Monsieur Gareth Lewis, précité, dans
Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant de vingt-et-un mille huit cent quarante Livres Sterling (GBP 21.840,00)
(l’«Apport XIII»).

126805

L

U X E M B O U R G

L’Apport XIII s’élevant à vingt-et-un mille huit cent quarante Livres Sterling (GBP 21.840,00) est affecté (i) au capital

social de la Société pour un montant de trois cent neuf Livres Sterling (GBP 347,00) et (ii) au compte de prime d’émission
de la Société pour un montant de vingt-et-un mille cinq cent trente-et-une Livres Sterling (GBP 21.531,00).

- Monsieur Ewan McGriskin, Director of Risks and Compliance, né le 27 septembre 1978 à Sydney, Australie, résidant

à Ground Floor, 40 Hammersmith Grove, Londres, W6 7HA Royaume-Uni, ici représenté par Madame Christèle ALE-
XANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui donnée le 27 juillet 2011, ci-annexée,
déclare souscrire huit cent cinquante-neuf (859) Nouvelles Actions A divisées en i) deux cent quatre-vingt six (286)
nouvelles actions de classe A1, (ii) deux cent quatre-vingt six (286) actions de classe A2 et (iii) deux cent quatre-vingt-
sept (287) actions de classe A3, payées par un apport en nature consistant en l’apport de soixante-mille six cent soixante-
sept (60.667) actions détenues par Monsieur Ewan McGriskin, précité, dans Ship Luxco 1 S.à r.l., précitée, pour un montant
de soixante-mille six cent soixante-sept Livres Sterling (GBP 60.667,00) (l’«Apport XIV»).

L’Apport XIV s’élevant à soixante-mille six cent soixante-sept Livres Sterling (GBP 60.667,00) sera affecté (i) au capital

social de la Société pour un montant de huit cent cinquante-neuf Livres Sterling (GBP 859,00) et (ii) au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de soixante mille six cent soixante-sept Livres Sterling (GBP 60.667,00).

Les apports en nature ci-dessus ont fait l'objet d'un rapport d’évaluation établi par «ALTER AUDIT Sàrl», réviseur

d’entreprises, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, en date du 27 juillet 2011, conformément
à l’article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales contenant la conclusion suivante:

<i>Conclusion

«Sous réserve que toutes les acquisitions des sociétés-cibles ainsi que toutes les assemblées générales des filiales devant

se tenir à la même date se réalisent avant cette opération, sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait
n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l’apport ne correspond pas au nombre
et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d’émission.

La rémunération des apports en nature consiste en 122,949 actions de catégorie A à créer avec une valeur nominale

de GBP 1 chacune, augmentée de la prime d’émission de GBP 8,551,340.»

Le prédit rapport sera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les déci-

sions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5.1. La Société a un capital social de huit millions quatre cent soixante-neuf mille trois cent soixante-quinze Livres

Sterling (GBP 8.469.375,00) représenté par:

Six millions cent quarante-quatre mille huit cent quarante-et-une (6.144.841) actions ordinaires de classe A, subdivisées

en (i) deux millions quarante-huit mille soixante-quinze (2.048.75) actions ordinaires de classe A1, (i) deux millions qua-
rante-huit mille deux cent quatre-vingt-une (2.048.281) actions ordinaires de classe A2 et deux millions quarante-huit
mille deux cent vingt-cinq (2.048.285) actions ordinaires de classe A3 (les «Actions A», leurs détenteurs étant les «Ac-
tionnaires A»);

un million quatre cent soixante-quinze mille deux cent soixante-deux (1.504.532) actions ordinaires de classe B, sub-

divisées en (i) cinq cent un mille cinq cent dix (501.510) actions ordinaires de classe B1, (ii) cinq cent un mille cinq cent
dix (501.510) actions ordinaires de classe B2 et (iii) cinq cent un mille cinq cent douze (501.512) actions ordinaires de
classe B3 (les «Actions B», leurs détenteurs étant les «Actionnaires B»);

huit cent vingt mille (820.000) actions ordinaires de classe C subdivisées en deux cent soixante-treize mille trois cent

trente-trois (273.333) actions ordinaires de classe C1, deux cent soixante-treize mille trois cent trente-trois (273.333)
actions ordinaires de classe C2 et deux cent soixante-treize mille trois cent trente-quatre (273.334) actions ordinaires
de classe C3 (les «Actions C», leurs détenteurs étant les «Actionnaires C»);

deux (2) actions de commandité (les «Actions de Commandités») détenues par l’actionnaire commandité.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille cinq cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, C. ALEXANDRE, J.J. WAGNER.

126806

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 03 août 2011. Relation: EAC/2011/10518. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011126729/854.
(110145968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Valore 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.768.

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s’est tenue le 20 septembre 2011 au siège social de

la Société a procédé à la nomination avec effet immédiat des personnes suivantes dans leur fonction d’administrateur de
la Société pour une durée de 3 ans:

- M. Riccardo Moraldi, né le 13 mai 1966 à Milan, Italie, demeurant pour les besoins professionnels au 40, avenue de

la Faïencerie L-1510 Luxembourg;

- M. Vincent Cormeau, né le 29 août 1960 à Verviers, Belgique, demeurant pour les besoins professionnels au 3, rue

Belle-Vue, L-1227 Luxembourg; et

- M. Bertrand Michaud, né le 21 novembre 1961 à Paris, France, demeurant pour les besoins professionnels au 3, rue

Belle-Vue, L-1227 Luxembourg.

Le conseil d’administration de la Société est actuellement composé comme suit:
- M. Riccardo Moraldi
- M. Vincent Cormeau
- M. Bertrand Michaud
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2011.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011131010/23.
(110150896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

GFL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 713.950,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 156.900.

In the year two thousand eleven, on the twenty-eight day of June,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GFL Holdings S.à r.l. (the Meeting), a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 156.900, and having a share
capital of six hundred ten thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 610,200) (the Company). The Company has
been incorporated on November 12, 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on De-
cember 20, 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2793 page 134029. The articles of
association of the Company have been amended for the last time on November 25, 2010 pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, prenamed, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Articles).

There appeared

1. Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., an exempted limited partnership incorporated and organized under the laws

of the Cayman Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY
1-9002, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number
33744, and

2. Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., an exempted limited partnership incorporated and organized under

the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand
Cayman KY 1-9002, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
under number 33757,

both here represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, with professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on May 30, 2011,

(hereinafter collectively the Shareholders)

126807

L

U X E M B O U R G

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. That sixty-one million twenty thousand (61,020,000) shares of the Company having a par value of one Canadian

Penny (CAD 0.01) per share, representing the entirety of the voting share capital of the Company of six hundred ten
thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 610,200) are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred three thousand seven hundred fifty

Canadian Dollars (CAD 103,750) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of six
hundred ten thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 610,200), represented by sixty-one million twenty thousand
(61,020,000) shares having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share to seven hundred thirteen thousand
nine hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950), by way of the issue of ten million three hundred seventy-five thousand
(10,375,000) new shares of the Company having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share, with such
shares having the same rights and obligations as the existing shares.

3. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 2 above by way of a payment

in kind.

4. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital adopted under item 2 above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company and any employee of SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A. (each
an Authorized Representative), each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly
issued shares in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

<i>First Resolution:

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second Resolution:

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of one hundred

three thousand seven hundred fifty Canadian Dollars (CAD 103,750) in order to bring the share capital of the Company
from its present amount of six hundred ten thousand two hundred Canadian Dollars (CAD 610,200), represented by
sixty-one million twenty thousand (61,020,000) shares having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) per share
to seven hundred thirteen thousand nine hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950), by way of the issue of ten million
three hundred seventy-five thousand (10,375,000) new shares of the Company having a par value of one Canadian Penny
(CAD 0.01) per share, with such shares having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Third Resolution:

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase

as follows:

<i>Subscriptions - Payments

Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., prenamed and represented as described above (RCP), hereby declares that it

subscribes to ten million three hundred three thousand five hundred forty-eight (10,303,548) new shares and to fully pay
up such shares by a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one hundred three thousand thirty-
five Canadian Dollars and forty-eight cents (CAD 103,035.48) (the RCP Receivable) that RCP has against the Company.

The contribution in kind of the RCP Receivable from RCP to the Company is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the RCP Receivable is evidenced by inter alia, (i) the interim balance sheet

of the Company as at 27 June 2011 signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued
on the date hereof by the management of RCP and acknowledged and approved by the management of the Company. It
results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the attached interim balance sheet as at 27 June 2011 (the Balance Sheet) shows an intercompany receivable in an

amount of at least one hundred three thousand thirty-five Canadian Dollars and forty-eight cents (CAD 103,035.48)
payable by the Company to RCP;

126808

L

U X E M B O U R G

- RCP is the owner of the RCP Receivable, is solely entitled to the RCP Receivable and possesses the power to dispose

of the RCP Receivable;

- the RCP Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et

exigible);

- based on generally accepted accountancy principles the RCP Receivable contributed to the Company per the attached

Balance Sheet is of one hundred three thousand thirty-five Canadian Dollars and forty-eight cents (CAD 103,035.48) and
since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the
Company;

- the RCP Receivable contributed to the Company is freely transferable by RCP to the Company and is not subject to

any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the RCP Receivable contributed to the Company have been or will

be accomplished by RCP and upon the contribution of the RCP Receivable by RCP to the Company, the Company will
become the full owner of the RCP Receivable which will be extinguished by way of a confusion for the purposes of article
1300 of the Luxembourg Civil Code.

Such  certificate  and  a  copy  of  the  Balance  Sheet,  after  signature  ne  varietur  by  the  proxyholder  of  RCP  and  the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., prenamed and represented as described above (RCPP), hereby declares

that it subscribes to seventy-one thousand four hundred fifty-two (71,452) new shares and to fully pay up such shares by
a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of seven hundred fourteen Canadian Dollars and fifty-two
cents (CAD 714.52) (the RCPP Receivable) that RCPP has against the Company.

The contribution in kind of the RCPP Receivable from RCPP to the Company is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the RCPP Receivable is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet signed

for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of
RCPP and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such certificate that, as of
the date of such certificate:

- the attached interim balance sheet as at 27 June 2011 (the Balance Sheet) shows an intercompany receivable in an

amount of at least seven hundred fourteen Canadian Dollars and fifty-two cents (CAD 714.52) payable by the Company
to RCPP;

- RCPP is the owner of the RCPP Receivable, is solely entitled to the RCPP Receivable and possesses the power to

dispose of the RCPP Receivable;

- the RCPP Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et

exigible);

- based on generally accepted accountancy principles the RCPP Receivable contributed to the Company per the atta-

ched Balance Sheet is of seven hundred fourteen Canadian Dollars and fifty-two cents (CAD 714.52) and since the Balance
Sheet no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

- the RCPP Receivable contributed to the Company is freely transferable by RCPP to the Company and is not subject

to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the RCPP Receivable contributed to the Company have been or will

be accomplished by RCPP and upon the contribution of the RCPP Receivable by RCPP to the Company, the Company
will become the full owner of the RCPP Receivable which will be extinguished by way of a confusion for the purposes of
article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

Such certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of RCPP and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles in order to

reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:

Art. 6. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at seven hundred thirteen thousand nine

hundred fifty Canadian Dollars (CAD 713,950), represented by seventy-one million three hundred ninety-five thousand
(71,395,000) Shares having a par value of one Canadian Penny (CAD 0.01) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General

Meeting in the manner required for the amendment of the Articles, as prescribed in article 11 below."

<i>Fifth Resolution:

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company
with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

126809

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, which is known to the notary by its

surname, name, civil status and residence, the said proxy holder of the appearing parties signed the present deed together
with the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-huit juin,
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de GFL Holdings S.à r.l. (l'Assemblée), une société à

responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 64 rue Principale,
L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 156.900, et ayant un capital social de six cent dix mille deux cents Dollars
Canadiens (CAD 610.200) (la Société). La Société a été constituée le 12 novembre 2010 suivant un acte de Maître Henri
Hellinckx, prénommé, publié le 20 décembre 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2793
page 134029. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 25 novembre 2010 suivant un acte de
Maître Henri Hellinckx, prénommé, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (les Statuts).

Ont comparu:

1. Roark Capital Partners II AIV AG, L.P., un exempted limited partnership constitué et régi par les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Iles Cayman, et inscrit
au Registrar of Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 33744, et

2. Roark Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., unexempted limited partnership constitué et régi par les lois des Iles

Cayman, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY 1-9002, Iles Cayman,
et inscrit au Registrar of Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 33757,

tous les deux ici représentés par Madame Solange Wolter-Schierds, employée, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 30 mai 2011;

(ci-après collectivement les Associés)
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes, ainsi que par le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités d'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que soixante et un millions vingt mille (61.020.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Penny

Canadien (CAD 0,01) par part sociale, représentant l'entièreté du capital social votant de la Société d'un montant de six
cent dix mille deux cents Dollars Canadiens (CAD 610.200) sont dûment représentées à cette Assemblée laquelle est
partant régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent trois mille sept cent cinquante Dollars Canadiens

(CAD 103.750) dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de six cent dix mille deux cents
Dollars Canadiens (CAD 610,200), représenté par soixante et un millions vingt mille (61,020,000) parts sociales ayant
une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale à un montant de sept cent treize mille neuf cent
cinquante Dollars Canadiens (CAD 713.950) par l'émission de dix millions trois cent soixante-quinze mille (10.375.000)
nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale, les-
quelles ont les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales existantes.

3. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social telle que décrite au point 2 ci-dessus par voie de

paiement en nature.

4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation du capital

social adoptée au point 2 ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnée à tout gérant de la Société et à tout employé de SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A. (chacun un Repré-
sentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

126810

L

U X E M B O U R G

6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux convo-

cations, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution:

L'Assemblée décide d'augmenter et par la présente augmente le capital social de la Société d'un montant de cent trois

mille sept cent cinquante Dollars Canadiens (CAD 103.750) dans le but de porter le capital social de la Société de son
montant actuel de six cent dix mille deux cents Dollars Canadiens (CAD 610.200), représenté par soixante et un millions
vingt mille (61.020.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) par part sociale à un
montant de sept cent treize mille neuf cent cinquante Dollars Canadiens (CAD 713.950) par l'émission de dix millions
trois cent soixante-quinze mille (10.375.000) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'un Penny
Canadien (CAD 0,01) par part sociale, lesquelles ont les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux parts sociales
existantes.

<i>Troisième résolution:

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes ainsi que la libération intégrale de l'aug-

mentation du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Roak Capital Partners II AIV AG, L.P., prénommé et représenté tel que décrit ci-dessus (RCP), déclare qu'il souscrit

à dix millions trois cent trois mille cinq cent quarante-huit (10.303.548) nouvelles parts sociales et de libérer entièrement
lesdites parts sociales par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de cent trois mille trente-cinq
Dollars Canadiens et quarante-huit centimes (CAD 103.035,48) (la Créance RCP) que RCP possède contre la Société.

L'apport en nature de la Créance RCP de RCP à la Société sera affectée au compte capital social nominal de la Société.
L'évaluation de l'apport en nature de la Créance RCP est documentée entre autres par (i) les comptes intérimaires

de la Société au 27 juin 2011 signés pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis à la date ci-
dessus par la gérance de RCP et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat
que, à la date dudit certificat:

- les comptes intérimaires ci-attachés en date du 27 juin 2011 (les Comptes Intérimaires) montrent une créance d'un

montant d'au moins cent trois mille trente-cinq Dollars Canadiens et quarante-huit centimes (CAD 103.035,48) payable
à la Société par RCP;

- RCP est le propriétaire de la Créance RCP, est le seul ayant-droit de la Créance RCP et possède le pouvoir de

disposer de la Créance RCP;

- la Créance RCP est certaine et deviendra liquide et exigible à sa date d'échéance sans déduction aucune;
- fondé sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance RCP apportée à la Société conformément aux

Comptes Intérimaires ci-joints est de cent trois mille trente-cinq Dollars Canadiens et quarante-huit centimes (CAD
103.035,48) et depuis les Comptes Intérimaires, aucun changement matériel ne s'est produit qui aurait pu déprécier la
valeur de l'apport fait à la Société;

- la créance RCP apportée à la Société est librement cessible par RCP à la Société et n'est sujette à aucune restriction

ou grevée d'aucun nantissement ou gage ou toute autre sûreté qui pourrait limiter sa cession ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités afin de transférer la propriété légale de la Créance RCP apportée à la Société ont été ou seront

accomplies par RCP et immédiatement après l'apport de la Créance RCP à la Société, la Société deviendra le seul pro-
priétaire de la Créance RCP laquelle sera éteinte par voie de confusion conformément et pour les besoins de l'article
1300 du code civil Luxembourgeois.

Ledit certificat et une copie des Comptes Intérimaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de RCP et

le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités d'enregistrement.

Roak Capital Partners Parallel II AIV AG, L.P., prénommé et représenté tel que décrit ci-dessus (RCPP), déclare qu'il

souscrit à soixante et onze mille quatre cent cinquante deux (71.452) nouvelles parts sociales et de libérer entièrement
lesdites parts sociales par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de sept cent quatorze Dollars
Canadiens et cinquante-deux centimes (CAD 714,52) (la Créance RCPP) que RCPP possède contre la Société.

L'apport en nature de la Créance RCPP de RCPP à la Société sera affecté au compte capital social nominal de la Société.
L'évaluation de l'apport en nature de la Créance RCPP est documentée entre autres par (i) les Comptes Intérimaires

signés pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis à la date ci-dessus par la gérance de RCPP
et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

126811

L

U X E M B O U R G

- les comptes intérimaires ci-attachés en date du 27 juin 2011 (les Comptes Intérimaires) montrent une créance d'un

montant d'au moins sept cent quatorze Dollars Canadiens et cinquante-deux centimes (CAD 714,52) payable à la Société
par RCPP;

- RCPP est le propriétaire de la Créance RCPP, est le seul ayant-droit de la Créance RCPP et possède le pouvoir de

disposer de la Créance RCPP;

- la Créance RCPP est certaine et deviendra liquide et exigible à sa date d'échéance sans déduction aucune;

- fondé sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance RCPP apportée à la Société conformément

aux Comptes Intérimaires ci-joints est de sept cent quatorze Dollars Canadiens et cinquante-deux centimes (CAD 714,52)
et depuis les Comptes Intérimaires, aucun changement matériel ne s'est produit qui aurait pu déprécier la valeur de
l'apport fait à la Société;

- la créance RCPP apportée à la Société est librement cessible par RCPP à la Société et n'est sujette à aucune restriction

ou grevée d'aucun nantissement ou gage ou toute autre sûreté qui pourrait limiter sa cession ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités afin de transférer la propriété légale de la Créance RCPP apportée à la Société ont été ou seront

accomplies par RCPP et immédiatement après l'apport de la Créance RCPP à la Société, la Société deviendra le seul
propriétaire de la Créance RCPP laquelle sera éteinte par voie de confusion conformément et pour les besoins de l'article
1300 du code civil Luxembourgeois.

Ledit certificat et une copie des Comptes Intérimaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de RCPP

et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités d'enregistre-
ment.

<i>Quatrième Résolution:

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de refléter les

modifications ci-dessus de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à sept cent treize mille neuf cent cinquante Dollars

Canadiens (CAD 713.950), représenté par soixante et onze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (71.395.000)
Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Penny Canadien (CAD 0,01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous."

<i>Cinquième résolutions:

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et

donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.500,

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergence
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état civil et

demeure, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30721. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

Référence de publication: 2011125904/297.

(110145168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2011.

126812

L

U X E M B O U R G

Roots Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 97.886.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 août 2011

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de la société Hoche Partners Trust Services,
société anonyme, de son mandat de Commissaire aux Comptes de la Société et décide de nommer la société BG

Consulting S.à r.l., ayant son siège social à L-8365 Hagen, 48A rue Principale en tant que nouveau Commissaire aux
Comptes de la Société, son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2014;

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Philippe LHOMME, résidant professionnellement au 451, route de Lennik,

B-1070 Anderlecht, en tant qu’Administrateur de la Société. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
qui se tiendra en 2014.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confirme le mandat de Monsieur Alain HEINZ, Administrateur de Sociétés, résidant professionnellement

à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui
se tiendra en 2014.

<i>Sixième résolution

L’assemblée confirme le mandat de Mademoiselle Violène ROSATI et de Monsieur Fabio MAZZONI, Administrateurs

de sociétés, et prend acte du transfert de leur adresse professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2014;

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2011128377/27.
(110147780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Asconia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 151.540.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2011.

Référence de publication: 2011128159/11.
(110147740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Avancio Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.378.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du
12 septembre 2011 à 10h20
le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 117 Val des Bons Malades / cabinet Watté, L-2121

Luxembourg, Luxembourg

à effet du 12 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

126813

L

U X E M B O U R G

Le 14 septembre 2011.

AVANCIO INVESTHOLDING S.à r.l.
J H VAN LEUVENHEIM
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2011128173/18.
(110148124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Ditco Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.033.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 9 septembre 2011

- les démissions de Maître John H. IGLEHART et Maître Louis M. MUDRY de leurs mandats d'Administrateur sont

acceptées;

- le nombre des Administrateurs est diminué de 4 à 3;
- Monsieur Urs GASSMANN, Directeur de sociétés, né le 10 mars 1962 à Dagmersellen, Suisse, résidant profession-

nellement au 41, rue du XXXI Décembre, 1207 Genève, Suisse est nommé Administrateur. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2011128210/15.
(110148004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Flairzone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 162.373.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 14 septembre 2011.

Référence de publication: 2011128224/10.
(110148130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Lilabel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 163.370.

STATUTS

L'an deux mil onze, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- La société "AFB Services Limited", ayant son siège social à Kowloon/Mongkok, Hong Kong (Chine), 8, Argyle Street,

office tower, Langham Place Suite 3703, immatriculée au Companies Registry de Hong Kong sous 1370262,

ici  dûment  représentée  par  Monsieur  Ludovic  LO  PRESTI,  Expert-Comptable,  demeurant  professionnellement  à

L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener,

Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée déclare constituer entre elle et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "LILABEL S.à r.l".

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans les limites du lieu du siège par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants,

du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

126814

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte

de tiers ou en participation:

- l'achat et la vente de tous produits finis ou non finis à des clients, fournisseurs, détaillants, fabricants ou grossistes.
- la prestation de services, la formation, l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'assistance au management et

toutes prestations de services dans le cadre de commerces de poissons ou fruits et légumes.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

D'une manière générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales immobilières, mobilières, commerciales,

industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement souscrites par l'associée unique la société AFB Services Limited,
ayant son siège social à Kowloon/Mongkok, Hong Kong (Chine), 8, Argyle Street, office tower, Langham Place Suite 3703,
immatriculée au Companies Registry de Hong Kong sous 1370262,

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros

(12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, moyennant certificat bancaire.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. L'associé unique peut céder ses parts à qui il l'entend.
Entre associés les parts sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées ou transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime

des associés.

En cas de refus de cession le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin

à la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par l'assemblée

générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de

l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au
siège social.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,

proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Année sociale - Bilan

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-

mément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

126815

L

U X E M B O U R G

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 15. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 950,- €.

<i>Décisions de l'associée unique

Et à l'instant l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, s'est réunie en lieu et place de l'assemblée

générale, et, a pris les résolutions suivantes:

1.- L'adresse du siège social est fixée L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
2.- Le nombre de gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Régis JACQUART, salarié, né à Verdun le 28 novembre

1954, demeurant professionnellement à L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.

3.- Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Lo Presti, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2011. Relation: LAC/2011/38337. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Tom Benning.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 8 septembre 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011128590/106.
(110147752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

Roquepine s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 135.465.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 septembre 2011 que l'assemblée générale ap-

prouve à l'unanimité la nomination de Madame Céline VIERSET, Master in Finance, née le 21 juin 1974 à ROCOURT
(Belgique), domiciliée professionnellement au 9, rue basse, 4963 Clémency au poste de gérante de la société.

Il est précisé que la durée du mandat est illimitée.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011130952/15.
(110151087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

126816


Document Outline

ARERO - Der Weltfonds

Arfis S.A.

Asconia S.à r.l.

Avancio Investholding S.à r.l.

Cosma Finance International S.A.

DB Advisors Invest

DB Advisors Invest

DB Portfolio

DB Portfolio

Deka-EuroGarant 2

Deka-WorldGarant 1

Digital Funds

Ditco Participations S.A.

DWS Dividende Direkt 2014

DWS Dividende Direkt 2014

DWS Emerging Markets Corporates 2015

DWS Emerging Markets Corporates 2015

DWS Floating Rate Notes

DWS Floating Rate Notes

DWS Global

DWS Global

DWS Rendite Extra Garant

DWS Rendite Extra Garant

DWS Rendite Garant 2015

DWS Rendite Garant 2015

DWS Rendite Garant 2015 II

DWS Rendite Garant 2015 II

DWS Rendite Optima

DWS Rendite Optima

DWS Rendite Plus Garant

DWS Rendite Plus Garant

DWS Renten Direkt 2013

DWS Renten Direkt 2013

DWS Renten Direkt 2014 II

DWS Renten Direkt 2014 II

DWS Top Dynamic

DWS Top Dynamic

DWS Vermögensmandat

DWS Vermögensmandat

Eurizon Manager Selection Fund

Eurizon MM Collection Fund

FI Alpha

FI Alpha

Flairzone S.à r.l.

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR

GFL Holdings S.à r.l.

Global Fund

Global Fund

International Asset Management Fund

Lilabel S.à r.l.

PAM International Fund Selection Portfolio

PAM International Fund Selection Portfolio

Plutos

Pradera Holdco S.A.

Pradera Holdco S.à r.l.

Roots Properties S.A.

Roquepine s.à r.l.

Rossini Lux Fund

SHIP Luxco Holding &amp; Cy S.C.A..

Valore 3 S.A.