logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2435

11 octobre 2011

SOMMAIRE

BCW Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116839

Bellecour Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116839

Bellecour Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116839

Bestime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116840

Biopharma Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

116840

Bowlingcenter Fuussekaul, s.à r.l.  . . . . . . . .

116840

Brisco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116840

BS Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116841

Calidad S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116864

Captherm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116866

Carmel Capital II Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116841

Carmel Capital IV Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116841

Carmel Capital V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116863

Cartonplastgroup Holding SA  . . . . . . . . . . .

116863

CDR Ray Investor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

116866

CEE IT Holdings (LUXEMBOURG) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116866

Cefarg Minerals GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116866

CEH Clean Energies Holding AG  . . . . . . . .

116866

CFC Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116867

ChemCore S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116863

Ciyow International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116867

Clint Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116863

CMA 3 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116867

Cocteau S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116869

Compagnie Européenne de Téléphonie

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116869

Comptoir Foncier de Gravenmacher S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116870

Condor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116870

Condor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116870

Condor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116873

Condor International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116873

Connaught Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

116864

Corn Products Global Holding S.à r.l.  . . . .

116864

Credit Suisse Portfolio Investments (Lu-

xembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116864

Cresford Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

116873

D'Pettener Schlësserei S. à r.l.  . . . . . . . . . .

116873

D.S.J. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116874

D.S.J. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116874

Faraz s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116834

Faraz s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116834

Faraz s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116838

Fidexco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116838

Fiduciaire Beaumanoir S.A.  . . . . . . . . . . . . .

116838

Fiduciaire Beaumanoir S.A.  . . . . . . . . . . . . .

116839

Fiduciaire Deflorenne & Associés S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116839

Forum Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116879

Himalaya S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116880

Home Performance S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116877

Indreni S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116880

Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.  . . .

116841

Mafi s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116874

Norcast S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116870

Sogimme II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116877

Threadneedle Asset Management Hol-

dings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116877

Weldpart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116877

www.Domaine de Linger S.A.  . . . . . . . . . . .

116878

Zwise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116834

116833

L

U X E M B O U R G

Faraz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 1, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 137.959.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118267/10.
(110136039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Faraz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 1, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 137.959.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118268/10.
(110136040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Zwise, Société Anonyme.

Siège social: L-9943 Hautbellain, Maison 51B.

R.C.S. Luxembourg B 162.366.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1) la société anonyme MOUTSCHEN INVEST, en abrégé M. INVEST, ayant son siège à L-9943 Hautbellain, Maison

51B, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 146.395, représentée par Madame Graziella BLANQUART,
employée, demeurant à rue de Prâle, 140, B-4300 Waremme habilitée à engager la société par sa signature isolée, con-
formément à l'article 12 des statuts

2) Monsieur Nicolas MOUTSCHEN, né le 5 mai 1988 à Brasschaat, étudiant, demeurant à Maison 51B, L-9943 Haut-

bellain

Lesdits comparants, représentés comme mentionné ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient

dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «Zwise» (la «So-
ciété»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Hautbellain.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à rendre impossible l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou
de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes activités liées à la

mise en place, à la gestion et à la maintenance de systèmes et parcs informatiques, de solutions logicielles et tous produits
et dérivés s'y reportant, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables
en la matière.

116834

L

U X E M B O U R G

La société peut prendre des intérêts par souscription, voie d'apports, association, fusion ou par tout autre mode dans

toute société, maison ou entreprise, de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire
ou connexe et, d'une façon générale, elle peut réaliser des opérations commerciales, industrielles et financières, tant
mobilières qu'immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences, marques et autres droits se rattachant

à ces brevets ou pouvant les compléter liées au domaine des technologies de l'information et de la communication.

La Société a également pour objet, tant au Luxembourg, qu'à l'étranger, la gestion et/ou la représentation d'entreprises,

de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire ou connexe et pourra à ce titre,
faire partie des organes collégiaux.

L'assemblée générale délibérant ou votant comme en matière de modifications de statuts, a qualité pour interpréter

l'étendue de l'objet social.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par la loi

sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent

vingt (320) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des

actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions non divisibles.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission
d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés à l'(aux) action(s).

Art. 7. Emission d'obligations. La société peut également émettre des obligations conformément aux articles 79 à 98

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Art. 8. Conseil d'Administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale avec ou sans motif.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autre cause,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si

deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son

absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider
la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre, courriel ou télécopieur à tous les

administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas le nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de
la réunion et contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par câble, par courriel, par télé-

gramme, par télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les
réunions  se  tenant  à  une  date  et  à  un  endroit  déterminé  dans  une  résolution  préalablement  adoptée  par  le  conseil
d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par

courriel, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

116835

L

U X E M B O U R G

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En cas

de parité, la voix du Président est prépondérante.

En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil

d'administration seront signés au minimum par le président de la réunion et par un autre administrateur.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou autres seront signés par

le président ou par deux administrateurs ou par toute autre personne dûment nommée par le Conseil d'Administration.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de dispositions et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de

sa compétence.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion jour-

nalière  ainsi  que  la  représentation  de  la  société  en  ce  qui  concerne  cette  gestion,  comprenant  notamment  et  sans
restriction toutes transactions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou
plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou re-

présentants de son choix.

Art. 13. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée.

Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des

actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs
aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce tous les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.

L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par courriel, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre

part aux assemblées générales.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises

à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d'administration ou par deux administrateurs, ou par toute autre personne dûment nommée par le Conseil
d'Administration.

Art. 15. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui sera/seront désigné(s) et révoqué(s) d'après les dispositions légales en vigueur. La durée de leurs fonc-
tions ne peut excéder six (6) ans.

Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés

à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

116836

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur
(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des ac-

tionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2012.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

<i>Souscription

Les Comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent souscrire toutes les actions comme suit:

a) La société anonyme MOUTSCHEN INVEST, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
b) Monsieur Nicolas MOUTSCHEN, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Les actions ainsi souscrites sont libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de HUIT

MILLE euros (EUR 8.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné
par un certificat bancaire.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles sont remplies.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Les actionnaires nomment comme administrateurs:
a) La société M. INVEST, préqualifiée, dont le représentant permanent est Monsieur Nicolas MOUTSCHEN;
b) Monsieur Nicolas MOUTSCHEN, prénommé;
c) Monsieur Pierre RONDOU, né le 31/10/1988 à Liège demeurant à Chemin de la Fagne Collin 11, B-4910 La Reid;
d) Monsieur Pierre-François MAZZIOTTA, né le 07/09/1987 à Liège demeurant au Quai Godefroid Kurth 80/32,

B-4020 Liège.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Paul PAYON, demeurant à Chemin de la Cense

35, B-4960 Malmédy

4) Le mandat des administrateurs prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2017, celui du commissaire prendra

fin à l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.

5) Le siège social est fixé à Maison 51B, L-9943 Hautbellain.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

<i>Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme «Zwise», à savoir:
a) La société M. INVEST préqualifiée, dont le représentant permanent est Monsieur Nicolas MOUTSCHEN;
b) Monsieur Nicolas MOUTSCHEN, prénommé;

116837

L

U X E M B O U R G

c) Monsieur Pierre RONDOU, prénommé, ici représenté par Monsieur Nicolas MOUTSCHEN, prénommé, en vertu

d'une procuration sous seing privé dressée à Demée, le 23 juin 2011, laquelle procuration après avoir été signé NE
VARIETUR par le Notaire et les comparants, restera ci-annexé;

d) Monsieur Pierre-François MAZZIOTTA, prénommé.
Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1) M Invest S.A. est nommée Président du conseil d'administration.
2) De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont nommé Monsieur Nicolas MOUTSCHEN, prénommé,

en qualité d'Administrateur-délégué, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la
société par sa signature isolée.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure,

les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Blanquart, N. Moutschen, P.-F. Mazziotta, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 29 juin 2011. - WIL/2011/498. - Reçu soixante-quinze euros = 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-

ciétés.

Wiltz, le 6 juillet 2011.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2011108231/219.
(110120180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.

Faraz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 1, rue André Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 137.959.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118269/10.
(110136041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Fidexco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 150.524.

En date du 18 décembre 2009, l'associé unique de la société FIDEXCO S.A R.L. a cédé ses 100 parts sociales à la

société JNL PARTICIPATIONS S.A., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B150544,
établie et ayant son siège social 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 ESCH-SUR-ALZETTE.

Suite à cette cession, la nouvelle répartition du capital social est la suivante:
la société JNL PARTICIPATIONS S.A. détient 100 parts sociales, soit la totalité du capital social de la société FIDEXCO

S.A R.L

Fiduciaire Pletschette, Meisch &amp; Associés S.A.
Signature

Référence de publication: 2011118270/16.
(110135728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Fiduciaire Beaumanoir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 52.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118271/9.
(110135549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

116838

L

U X E M B O U R G

Fiduciaire Beaumanoir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 52.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118272/9.
(110135550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Fiduciaire Deflorenne &amp; Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 111.495.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118273/10.
(110135898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

BCW Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.801.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 16 mai 2011

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d’administration de la Société en date du 16 mai 2011 que:
- Madame Catherine Koch a démissionné en tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat
- Monsieur Philippe Stanko né le 15 janvier 1977 à Wittlich en Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 412F

route d’Esch, L-2086 Luxembourg, a été nommé administrateur avec effet immédiat jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en 2011.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR LA SOCIETE

Référence de publication: 2011118167/15.
(110135884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Bellecour Capital, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 153.626.

Les comptes annuels pour la période du 11 Juin 2010 (date de constitution) au 31 Décembre 2010 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118168/11.
(110135868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Bellecour Capital, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 153.626.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 08 août 2011

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Juin 2012, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Nicolas FAURE,
Didier CAZEAUX et Vincent NEURRISSE.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Juin 2012, en qualité de Réviseur d’Entreprises Agrée, Deloitte S.A.,
résidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Luxembourg.

116839

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118169/15.
(110135869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Bestime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 5, boulevard royal.

R.C.S. Luxembourg B 120.056.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118170/10.
(110135737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Biopharma Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 66.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118171/9.
(110135676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Bowlingcenter Fuussekaul, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9156 Heiderscheid, 4, Fuussekaul.

R.C.S. Luxembourg B 108.645.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de Bowlingcenter Fuussekaul S.à.r.l. tenue le 4 août

<i>2011 à 11.00 heures à Heiderscheid

<i>1 

<i>re

<i> résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Jan Luurt Doornbusch, né le 23 avril 1966 à Groningen (Pays-Bas),

demeurant à L-9144 Lehrhof, Maison 5, de son poste de gérant technique avec effet au 3 août 2011.

<i>2 

<i>e

<i> résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Georges Linster, né le 16 août 1956 à Luxembourg, demeurant à

L-1131 Luxembourg, 16 rue Antoine, de son poste de gérant technique avec effet au 3 août 2011.

<i>3 

<i>e

<i> résolution

Les associés décident de nommer au poste de gérant unique Monsieur David Linster, né le 31 juillet 1984 à Luxembourg

et demeurant à L-9171 Michelau, 9 Fleiberstrooss.

Il pourra engager la société par sa seule signature.

Georges LINSTER / David LINSTER / Stéphane LINSTER / Kevin LINSTER.

Référence de publication: 2011118173/20.
(110135709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Brisco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 114.941.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de lʹAssemblée Générale Extraordinaire du 06 décembre 2010 que:
- Certifica ayant son siège à Luxembourg, 54 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire en

remplacement de SER.COM S.à.r.l, commissaire démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2014.

116840

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118174/14.
(110135870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

BS Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.751.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118175/9.
(110135596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Carmel Capital II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 811.900,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.591.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011118177/13.
(110135877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Carmel Capital IV Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.681.400,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 120.152.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011118178/13.
(110135876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.750.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 160.558.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of July,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared:

1) Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B
160655,

duly represented for the purposes hereof by Christine Kröger, having her professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 July 2011 in Luxembourg.

The above mentioned proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

116841

L

U X E M B O U R G

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under registration number B 160558 (the "Company").

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

<i>Agenda

1. Creation of ten different classes of shares to be denominated as class A shares, class B shares, class C shares, class

D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares;

2. Conversion of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company into one thousand two

hundred and fifty (1,250) class A shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares of
the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class C shares of the Company, one thousand two hundred
and fifty (1,250) class D shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares of the Company,
one thousand two hundred and fifty (1,250) class F shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250)
class G shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares of the Company, one thousand
two hundred and fifty (1,250) class I shares of the Company and one thousand two hundred and fifty (1,250) class J shares
of the Company;

3. Increase of the share capital of the Company by a total amount of forty three million seven hundred and thirty seven

thousand five hundred euro (EUR 43,737,500) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) up to a new amount of forty three million seven hundred fifty thousand euro (EUR 43,750,000),
through the issuance of (i) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class
A shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (ii) four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class B shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each,
and (iii) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class C shares of the
Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (iv) four million three hundred seventy three thousand seven
hundred fifty (4,373,750) new class D shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (v) four million
three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class E shares of the Company, with a par
value of one euro (EUR 1) each, (vi) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750)
new class F shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, class (vii) four million three hundred
seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class G shares of the Company, with a par value of one euro
(EUR 1) each, (viii) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class H shares
of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (ix) four million three hundred seventy three thousand seven
hundred fifty (4,373,750) new class I shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, and (x) four
million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class J shares of the Company, with a
par value of one euro (EUR 1) each; and

4. Full restatement of the Company's articles of association.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share

capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to create ten (10) different classes of shares referred to as class A shares, class B shares,

class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares,
whereby each share shall have a nominal value of one euro (EUR 1) and feature such rights and obligations as set out in
the Company's articles of association.

In particular, each share shall be entitled to (1) one vote at any ordinary and extraordinary general meeting of share-

holders.

All classes of shares shall be entitled to pro rata allocations with respect to the year in which the general meeting of

shareholders resolves to make any distribution to the shareholders. This allocation shall be in an amount equal to zero
point twenty-five per cent (0.25 %) of the nominal value of each share.

The balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the

alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class J shares are in existence, class I shares and in such continuation
until only class A shares are in existence).

<i>Second resolution:

Further to the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to proceed with the conversion of the existing

twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with a par value of one euro (EUR 1) each, into one
thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class
B shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class C shares of the Company, one thousand two
hundred and fifty (1,250) class D shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares of
the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class F shares of the Company, one thousand two hundred

116842

L

U X E M B O U R G

and fifty (1,250) class G shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares of the Company,
one thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares of the Company and one thousand two hundred and fifty (1,250)
class J shares of the Company, all with a par value of one euro (EUR 1) each.

As a result of the adoption of the present resolution, the share capital of the Company, which amounts to twelve

thousand five hundred euros (EUR 12,500), is divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares of
the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares of the Company, one thousand two hundred
and fifty (1,250) class C shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class D shares of the Company,
one thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250)
class F shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class G shares of the Company, one thousand
two hundred and fifty (1,250) class H shares of the Company, one thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares
of the Company and one thousand two hundred and fifty (1,250) class J shares of the Company, all with a par value of
one euro (EUR 1) each.

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by a total amount of forty three million

seven hundred thirty seven thousand five hundred euro (EUR 43,737,500) in order to bring it from its current amount
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to a new amount of forty three million seven hundred and fifty
thousand euro (EUR 43,750,000), through the issuance of (i) four million three hundred seventy three thousand seven
hundred fifty (4,373,750) new class A shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (ii) four million
three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class B shares of the Company, with a par
value of one euro (EUR 1) each, and (iii) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750)
new class C shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (iv) four million three hundred seventy
three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class D shares of the Company, with a par value of one euro (EUR
1) each, (v) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class E shares of the
Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (vi) four million three hundred seventy three thousand seven
hundred fifty (4,373,750) new class F shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, class (vii) four
million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class G shares of the Company, with
a  par  value  of  one  euro  (EUR  1)  each,  (viii)  four  million  three  hundred  seventy  three  thousand  seven  hundred  fifty
(4,373,750) new class H shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each, (ix) four million three hundred
seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class I shares of the Company, with a par value of one euro
(EUR 1) each and (x) four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class J shares
of the Company, with a par value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription - Payment

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B
160655,

duly represented for the purposes hereof by Christine Kroger, having her professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 July 2011 in Luxembourg, subscribed for:

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class A shares of the Company,

with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class B shares of the Company,

with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class C shares of the Com-

pany, with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class D shares of the Com-

pany, with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

-, four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class E shares of the Com-

pany, with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class F shares of the Company,

with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

116843

L

U X E M B O U R G

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class G shares of the Com-

pany, with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class H shares of the Com-

pany, with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class I shares of the Company,

with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750),

- four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) new class J shares of the Company,

with a par value of one euro (EUR 1) each, representing a total amount of four million three hundred seventy three
thousand seven hundred fifty euro (EUR 4,373,750).

The proof of the existence and of the value of the total contribution of forty three million seven hundred fifty thousand

euro (EUR 43,737,500) has been produced by the aforementioned party to the undersigned notary.

As  a  result  of  the  issuance  of  such  new  four  million  three  hundred  seventy  three  thousand  seven  hundred  fifty

(4,373,750) class A shares, four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class B
shares, four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class C shares, four million
three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class D shares, four million three hundred seventy
three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class E shares, four million three hundred seventy three thousand seven
hundred fifty (4,373,750) class F shares, four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750)
class G shares, four million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class H shares, four
million three hundred seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class I shares and four million three hundred
seventy three thousand seven hundred fifty (4,373,750) class J shares of the Company referred to above, the share capital
of the Company, which now amounts to forty three million seven hundred sixty two thousand and five hundred euro
(EUR 43,737,500), is now composed and held as follows:

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. holds
- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class A shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class B shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class C shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class D shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class E shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class F shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class G shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class H shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class I shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000),

- Four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class J shares, with a par value of one euro (EUR 1)

each, representing a total amount of four million three hundred seventy five thousand euro (EUR 4,375,000).

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder resolves to fully restate the Company's articles of association, so that they will read as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Kinove Luxembourg Holdings
2 S.à r.l." (the "Company").

Art. 2. Definitions. For the purposes of these articles of association (the "Articles"), the following terms shall be

construed, except where otherwise expressly provided for in these Articles, as having the meaning set forth below:

"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent  the  shareholder  would  have  been  entitled  to  dividend  distributions  according  to  article  24  of  these  Articles,

116844

L

U X E M B O U R G

increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction
and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these Articles,
each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be

cancelled

L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
"Cancellation Value Per Share" means the amount resulting from the division of the Total Cancellation Amount by the

number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

"Interim Account Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation

of the relevant class of shares.

"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
"Luxembourg Law" means the laws and regulations in force in the Grand Duchy of Luxembourg from time to time.
"Total Cancellation Amount" means an amount determined by the board of managers and approved by the general

meeting of shareholders of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts.

Art. 3. Duration The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 4. Purpose.
4.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

4.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

4.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 5. Registered office
5.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
5.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

5.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

116845

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares

Art. 6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company is set at forty-three million seven hundred fifty thousand euros (EUR 43,750,000)

divided into

four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class A shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class B shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class C shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class D shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class E shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class F shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class G shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class H shares,
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class I shares, and
four million three hundred seventy five thousand (4,375,000) class J shares,
each share with a nominal value of one euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the present

Articles.

6.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for the amendment of these Articles.

6.3 Except where otherwise provided in any shareholders' agreement which may be in force between the shareholders

of the Company from time to time in the case of a share capital increase, the Company shall deliver written notice to
each shareholder at least thirty (30) days prior to the date of such contemplated issuance (the "Subscription Period") and
each shareholder shall have the right during the first ten (10) Business days of the Subscription Period to subscribe, at
the same price and at the same terms as any other shareholder, to any amount of such newly issued shares up to such
amount of shares pro rata to its current shareholding in the Company. Any new shares a shareholder would be entitled
but has declined to subscribe for, shall be offered to the remaining shareholders pro rata to their current shareholding
by written notice, which notice shall be given by the Company to each remaining shareholder no later than on the fifteenth
(15) Business Day of the Subscription Period.

6.4 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with class J).

6.5 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the

order provided for in article 6.4 of these Articles), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their
holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as deter-
mined by the general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares
shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class
held by them and cancelled.

6.5.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

6.5.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the

general meeting of shareholders of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation
Amount for each of the classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the
time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders of the
Company in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation
Amount shall never be higher than such Available Amount.

6.5.3 Upon the repurchase and Cancellation Value Per Share of the relevant class, the Cancellation Value Per Share

will become due and payable by the Company.

Art. 7. Shares.
7.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
7.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

7.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company's share capital.

7.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

7.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

116846

L

U X E M B O U R G

7.6 The Company's shares are in registered form.

Art. 8. Register of shareholders.
8.1 A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

8.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 9. Ownership and Transfer of shares.
9.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

9.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

9.3 The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

9.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

9.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.
10.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one

of the Company's corporate bodies.

10.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

10.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

10.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead

of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 11. Convening general meetings of shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

11.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.

11.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

116847

L

U X E M B O U R G

11.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
12.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

12.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
12.3 Quorum and vote
12.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
12.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

12.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

12.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

12.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

12.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 13. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.
14.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
14.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 15. Powers of the board of managers.
15.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".

15.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

15.3 The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

116848

L

U X E M B O U R G

15.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 16. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 17 Election and Removal of managers and term of the office.
17.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

17.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

17.3  Any  manager  shall  hold  office  until  its/his/her  successor  is  elected.  Any  manager  may  also  be  re-elected  for

successive terms.

Art. 18. Convening meetings of the board of managers.
18.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

18.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 19. Conduct of meetings of the board of managers.
19.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

19.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least one (1) class A manager, one (1) class B manager,

and one (1) class C manager are present or represented at a meeting of the board of managers.

19.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers, including at least one (1) class A manager, one (1) class B manager, and one (1) class C manager.
The chairman shall not have a casting vote.

19.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several ofhis/her/its colleagues.

19.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

19.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.19.7 Any manager who has, directly
or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts
with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his/her/its
declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on
and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly
or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which
conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant
transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.

116849

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Minutes of meetings of the board of managers.
20.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

20.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
20.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 21. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by either

(i) the joint signatures of one (1) class A manager, one (1) class B manager, and one (1) class C manager, or (ii) by the
joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by one (1)
class A manager, one (1) class B manager, and one (1) class C manager. The Company will be bound towards third parties
by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated
acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 22. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
22.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

22.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

22.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

22.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

22.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

22.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

22.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 23. Financial year. The Company's financial year shall begin on first (1 

st

 ) January of each year and shall terminate

on thirty-first (31 

st

 ) December of the same year.

Art. 24. Profits - Distributions.
24.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

24.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

24.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

24.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and the following provisions:

24.4.1. Any distribution, including repayments of shareholder loans, redemption of preferred equity certificates and

interest accrued thereon, shares or other Instruments and similar distributions of whatever nature shall be made pari
passu among the shareholders of the Company and and in each case taking into account the commercial and contractual
characteristics of the Instruments held by each of the respective shareholders.

24.4.2. The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board

of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the
board of managers The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate

116850

L

U X E M B O U R G

of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid
on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of
such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are
held by the Company on behalf of holders of shares.

24.4.3. In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro

rata to their shares regardless of class, then

(ii) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the first class in the

reverse alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class J shares are in existence, class I shares and in such
continuation until only class A shares are in existence).

Art. 25. Interim dividends - Share premium.
25.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

25.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 26. Liquidation.
26.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution
which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

26.2. After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the

distribution of the net liquidation proceeds shall be made pari passu among the shareholders and in conformity with and
so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.

H. Governing law

Art. 27. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxyholder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahr zweitausendundelf, den achtundzwanzigsten Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

Ist erschienen:

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend unter dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzog-
tum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 160655,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Christine Kröger, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, kraft einer am 27. Juli 2011 in Luxembourg erteilten Vollmacht.

Die durch die Vollmachtnehmerin und den Notar ne varietur unterzeichnete Vollmacht soll dieser notariellen Urkunde

beigefügt und zusammen mit ihr einregistriert werden.

Die erschienene Partei ist die Alleingesellschafterin (die „Alleingesellschafterin") der Kinove Luxembourg Holdings 2

S.à r.l., einer société à responsabilité limitée gegründet und bestehend gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,
mit eingetragenem Sitz in 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im
luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 160558 (die „Gesellschaft").

Die Alleingesellschafterin erwog sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung"):

116851

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung

1. Schaffung zehn (10) verschiedener Kategorien von Gesellschaftsanteilen unter den Bezeichnungen Gesellschaftsan-

teile der Kategorie A, Gesellschaftsanteile der Kategorie B, Gesellschaftsanteile der Kategorie C, Gesellschaftsanteile der
Kategorie D, Gesellschaftsanteile der Kategorie E, Gesellschaftsanteile der Kategorie F, Gesellschaftsanteile der Kategorie
G, Gesellschaftsanteile der Kategorie H, Gesellschaftsanteile der Kategorie I sowie Gesellschaftsanteile der Kategorie J.

2. Umwandlung der existierenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft in eintau-

sendzweihundertundfünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie A, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Ge-
sellschaftsanteile  der  Kategorie  B,  eintausendzweihundertundfünfzig  (1.250)  Gesellschaftsanteile  der  Kategorie  C,
eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie D, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie E, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie F, ein-
tausendzweihundertundfünfzig  (1.250)  Gesellschaftsanteile  der  Kategorie  G,  eintausendzweihundertundfünfzig  (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie H, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie I und
eintausendzweihundertundfünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie C.

3. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von dreiundvierzigmillionensiebenhundert-

siebenunddreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 43.737.500), um dieses von dem aktuellen Betrag von zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500) auf einen neuen Betrag von dreiundvierzigmillionensiebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR
43.750.000)  zu  bringen,  durch  die  Ausgabe  (i)  viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig
(4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie A der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro
(EUR 1), (ii) viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile
der Kategorie B der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (iii) viermillionendreihundertd-
reiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie C der Gesellschaft mit
jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (iv) viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundert-
fünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie D der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem
Euro (EUR 1), (v) viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschafts-
anteile der Kategorie E der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (vi) viermillionendrei-
hundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie F der Gesell-
schaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (vii) viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsie-
benhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie G der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag
von  einem  Euro  (EUR  1),  (viii)  viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig  (4.373.750)  neuer
Gesellschaftsanteile der Kategorie H der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (ix) vier-
millionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie I
der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), und (x) viermillionendreihundertdreiundsieb-
zigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kategorie J der Gesellschaft mit jeweils einem
Nennbetrag von einem Euro (EUR 1).

4. Neuformulierung der Gesellschaftssatzung.
Nach Erwägung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchte die Alleingesellschafterin, die das gesamte Stamm-

kapital der Gesellschaft vertritt, die Notarin Folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt zehn (10) neue Kategorien von Gesellschaftsanteile zu schaffen, bezeichnet als

Gesellschaftsanteile der Kategorie A, Gesellschaftsanteile der Kategorie B, Gesellschaftsanteile der Kategorie C, Gesell-
schaftsanteile der Kategorie D, Gesellschaftsanteile der Kategorie E, Gesellschaftsanteile der Kategorie F, Gesellschafts-
anteile der Kategorie G, Gesellschaftsanteile der Kategorie H, Gesellschaftsanteile der Kategorie I und Gesellschaftsanteile
der Kategorie J, wobei jeder Gesellschaftsanteil einen Nennbetrag von einem Euro (EUR 1) besitzen und die in der
Gesellschaftssatzung aufgeführten Rechte und Pflichten aufweisen soll.

Insbesondere  soll  jeder  Gesellschaftsanteil  ein  (1)  Stimmrecht  bei  ordentlichen  und  außerordentlichen  Hauptver-

sammlungen der Aktionäre besitzen.

Allen Kategorien der Gesellschaftsanteile sollen pro rata Beteiligungen zustehen für das Jahr, in dem die Gesellschaf-

terversammlung über entsprechende Ausschüttungen an die Gesellschafter beschließt. Die Beteiligung soll für jeden Anteil
null Komma zwei fünf Prozent (0.25%) des Nennwerts des Gesellschaftsanteils betragen.

Ein nach der pro rata erfolgten Ausschüttung verbleibender Restbetrag des Gesamtausschüttungsbetrages soll gänzlich

den jeweiligen Gesellschaftern in alphabetischer Reihenfolge zugeordnet werden (d.h. zuerst Gesellschaftsanteile der
Kategorie J, dann, sofern keine Gesellschaftsanteile der Kategorie J bestehen, Gesellschaftsanteile der Kategorie I, usw.
bis lediglich Gesellschaftsanteile der Kategorie A bestehen).

<i>Zweiter Beschluss:

Über den vorgehenden Beschluss hinaus beschließt die Alleingesellschafterin die Umwandlung der bereits bestehenden

zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) in
eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie A, eintausend zweihundert und fünfzig
(1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie B, eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kate-

116852

L

U X E M B O U R G

gorie C, eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie D, eintausend zwei hundert und
fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie E, eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der
Kategorie F, eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie G, eintausend zwei hundert
und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie H, eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile
der Kategorie I und eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Gesellschaftsanteile der Kategorie J, jeweils mit einem
Nennwert von einem Euro (EUR 1).

Als Ergebnis der Umsetzung des vorliegenden Beschlusses wird das Stammkapital der Gesellschaft, welches sich auf

eine Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beläuft, unterteilt in eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)

Gesellschaftsanteile der Kategorie A, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie B, eintausend zwei hundert und fünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie C, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie D, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie E, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie F, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie G, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie H, eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie I und eintausendzweihundertundfünfzig (1.250)
Gesellschaftsanteile der Kategorie J, jeweils mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1).

<i>Dritter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von dreiundvierzig

millionen  siebenhundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert  Euro  (EUR  43.737.500)  zu  erhöhen,  um  dieses  von  dem
aktuellen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen neuen Betrag von dreiundvierzigmillionen-
siebenhundertundfünfzigtausend Euro (EUR 43.750.000) zu bringen, durch die Ausgabe (i) viermillionendreihundertdrei-
undsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig  (4.373.750)  neuer  Gesellschaftsanteile  der  Kategorie  A  der  Gesellschaft  mit
jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (ii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie B der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (iii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie C der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (iv)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie D der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (v)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie E der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (vi)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie F der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (vii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie G der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (viii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie H der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), (ix)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie I der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), und (x)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuer Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie J der Gesellschaft mit jeweils einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1).

<i>Zeichnung - Zahlung

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet und bestehend unter dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzog-
tum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 160655,

ordnungsgemäß vertreten durch Christine Kröger, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

kraft einer am 27. Juli 2011 in Luxemburg erteilten Vollmacht. zeichnet:

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie A mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie B mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

116853

L

U X E M B O U R G

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie C mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie D mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie E mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie F mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie G mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie H mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie I mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

- viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neue Gesellschaftsanteile der Kate-

gorie J mit einem Nennbetrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertdreiund-
siebzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.373.750),

Der Nachweis der Existenz und des Wertes der Gesamteinlage von dreiundvierzig millionen siebenhundert sieben-

unddreißig tausend fünfhundert Euro (EUR 43.737.500) wurde der Notarin durch die wie oben erwähnten Gesellschafter
vorgelegt.

Als Ergebnis der Ausgabe von
viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie A, (ii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie B, (iii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie C, (iv)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie D, (v)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie E, (vi)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie F, (vii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie G, (viii)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie H, (ix)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie I und (x)

viermillionendreihundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertfünfzig (4.373.750) neuen Gesellschaftsanteilen der Ka-

tegorie J, wie oben aufgeführt, setzt sich nunmehr das Stammkapital der Gesellschaft wie folgt zusammen:

Kinove Luxembourg Holdings 1 S.ä r.l. hält:
- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie A mit einem Nennbe-

trag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie B mit einem Nennbe-

trag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie C mit einem Nennbe-

trag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

116854

L

U X E M B O U R G

- vier millionen dreihundertfünfundsiebzig tausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie D mit einem Nenn-

betrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie E mit einem Nennbe-

trag  von  einem  Euro  (EUR  1),  zu  einem  Gesamtbetrag  von  viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend  Euro
(EUR4.375.000),

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie F mit einem Nennbe-

trag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

- vier millionen dreihundertfünfundsiebzig tausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie G mit einem Nenn-

betrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie H mit einem Nenn-

betrag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000),

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie I mit einem Nennbe-

trag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000), und

- viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Gesellschaftsanteile der Kategorie J mit einem Nennbe-

trag von einem Euro (EUR 1), zu einem Gesamtbetrag von viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR
4.375.000).

<i>Vierter Beschluss:

Die Alleingesellschafterin beschließt die Gesellschaftsatzung vollständig zu erneuern, so dass sie wie folgt lautet:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Geschäftsanteile und/oder jeder anderen

Person, die künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der
Firma "Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l." (die „Gesellschaft").

Art. 2. Definitionen. Im Rahmen dieser Satzung (die „Satzung") sollen die folgenden Begriffe, sofern nicht in der Satzung

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, die folgenden Bedeutungen haben:

„Einziehungsbetrag pro Geschäftsanteil" ist das Ergebnis aus der Division des Gesamteinziehungsbetrags durch die

Anzahl der Geschäftsanteile der jeweiligen Kategorie der Geschäftsanteile, welche zurückgekauft und gelöscht werden
sollen.

„Gesamteinziehungsbetrag" ist der durch den Geschäftsführerrat bestimmte und durch die Hauptversammlung der

Gesellschafter bestätigte Betrag auf Basis der jeweiligen Zwischenbilanzen.

„Luxemburgisches Recht" sind die zu einem gegebenen Zeitpunkt bestehenden und geltenden Gesetze und Vorschrif-

ten des Großherzogtums Luxemburg.

„Verfügbarer Betrag" ist der Gesamtbetrag der Nettogewinne der Gesellschaft (einschließlich des Gewinnvortrags),

sofern und in dem Masse in dem die Gesellschafter gemäß Art. 24 dieser Satzung zum Erhalt von Dividenden berechtigt
gewesen wären, erhöht durch (i) etwaige frei verteilbare Rücklagen und (ii) falls einschlägig, durch den Betrag der Kapi-
talherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage im Hinblick auf die einzuziehende Kategorie der Geschäfts-
anteile, allerdings reduziert um (i) jedwede Verluste (einschließlich des Verlustvortrags) und (ii) jedwede Beträge, welche
entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) verwandt werden müssen, jeweils
wie in den entsprechenden Zwischenbilanzen aufgeführt (zur Klarstellung: ohne doppelte Verrechnungen) so dass:

AA = (NP + P +CR) - (L + LR)
Wobei:
AA = Verfügbarer Betrag
NP= Netto Gewinne (einschließlich Gewinnvortrag)
P = frei verteilbare Reserven
CR= Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage im Hinblick auf die Kategorie der

einzuziehenden Geschäftsanteile

L = Verluste (einschließlich Verlustvortrag)
LR = Beträge, welche entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) verwandt

werden müssen.

„Zwischenbilanz" ist die Zwischenbilanz der Gesellschaft zum Zeitpunkt des jeweiligen Zwischenbilanzdatums.
„Zwischenbilanzdatum"  ist  das  Datum,  welches  frühestens  acht  (8)  Tage  vor  dem  Datum  des  Rückkaufs  und  der

Löschung der jeweiligen Kategorie der Geschäftsanteile liegt.

116855

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung
dieser Satzung erforderlich ist.

Art. 4. Zweck.
4.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investments in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

4.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

4.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-

nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 5. Sitz.
5.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
5.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

5.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg

verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist.

5.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch

einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-

schäftsanteilen

Art. 6. Stammkapital.
6.1  Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  beträgt  dreiundvierzig  millionen  siebhundertfünfzig  tausend  Euro  (EUR

43.750.000) bestehend aus viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie
A

viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie B
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie C
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie D
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie E
viermillionen dreihundert fünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie F
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie G
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie H
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie I, und
viermillionendreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Geschäftsanteilen der Kategorie J mit einem Nominalwert

von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil, von welchen Geschäftsanteilen jeder die in der vorliegenden Satzung auf-
geführten Rechte und Pflichte vermittelt.

6.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der

Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieser Satzung erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

116856

L

U X E M B O U R G

6.3 Sofern nicht in etwaigen, gelegentlich zwischen den Gesellschaftern bestehenden Abreden etwas anderes bestimmt

ist, setzt die Gesellschaft im Falle einer Kapitalerhöhung jeden Gesellschafter schriftlich mindestens dreißig (30) Tage vor
dem vorgesehenen Zeichnungsdatum (die „Zeichnungsperiode") von der vorgesehenen Ausgabe neuer Gesellschaftsan-
teile  in  Kenntnis  und  allen  Gesellschaftern  steht  das  Recht  zu,  innerhalb  der  ersten  zehn  (10)  Geschäftstage  der
Zeichnungsperiode zu demselben Preis und zu denselben Bedingungen wie alle anderen Gesellschafter eine beliebige
Anzahl neuer Gesellschaftsanteile zu zeichnen, maximal jedoch einen solche Anzahl, die der Beteiligung des entsprech-
enden  Gesellschafters  an  dem  jeweiligen  Betrag  des  vor  der  Kapitalerhöhung  bestehenden  Gesellschaftskapitals  ent-
spricht. Jedwede neue Geschäftsanteile, welche einem Gesellschafter zwar angeboten, von diesem aber abgelehnt wurden,
werden den übrigen Gesellschaftern pro rata zu deren aktueller Beteiligungen mit schriftlicher Benachrichtigung ange-
boten,  wobei  die  schriftliche  Benachrichtigung  durch  die  Gesellschaft  an  die  jeweiligen  Gesellschafter  spätestens  am
fünfzehnten (15.) Werktag der Zeichnungsperiode erfolgen soll.

6.4 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch den Rückkauf und die Löschung von Geschäftsanteilen herabgesetzt

werden. Möglich ist auch die Löschung einer ganzen oder mehrerer Kategorien von Geschäftsanteilen durch Rückkauf
und  Löschung  aller  ausgegebenen  Geschäftsanteile  dieser  Kategorien.  Im  Falle  des  Rückkaufs  und  der  Löschung  von
Kategorien  von  Geschäftsanteilen  sollen  der  Rückkauf  und  die  Löschung  in  umgekehrter  alphabetischer  Reihenfolge
durchgeführt werden (beginnend mit Kategorie J).

6.5 Im Falle einer Stammkapitalherabsetzung durch Rückkauf und Löschung einer Kategorie von Geschäftsanteilen (in

der in Artikel 6.4 der Satzung ausgeführten Reihenfolge) besitzt jeder Inhaber von Geschäftsanteilen dieser Kategorie ein
Beteiligungsrecht an dem Verfügbaren Betrag, welches Beteiligungsrecht der Anzahl der von dem betreffenden Gesell-
schafter  in  der  jeweiligen  Kategorie  von  Gesellschaftsanteilen  gehaltenen  Gesellschaftsanteile  entspricht  (wobei  die
Begrenzung in dem durch die Gesellschafterversammlung bestimmten Gesamten Einziehungsbetrag liegt), und die Inhaber
von Geschäftsanteilen der zurückgekauften oder eingezogenen Kategorien der Geschäftsanteile erhalten von der Gesell-
schaft  einen  Betrag,  der  der  Höhe  nach  dem  Einziehungswert  pro  Geschäftsanteil  für  jeden  durch  sie  gehaltenen
Geschäftsanteil der eingezogenen entsprechenden Kategorie entspricht.

6.5.1 Der Einziehungswert pro Geschäftsanteil ergibt sich aus der Division des Gesamteinziehungswerts durch die

Anzahl der in der entsprechenden zurückzukaufenden und zu löschenden Kategorie ausgegebenen Geschäftsanteile.

6.5.2 Der Gesamteinziehungsbetrag soll durch den Geschäftsführerrat bestimmt, und durch die Gesellschafterver-

sammlung der Gesellschaft auf Basis der Zwischenbilanz bestätigt werden. Der Gesamteinziehungsbetrag für jede einzelne
Kategorie J, I, H, G, F, E, D, C, B und A ist der Verfügbare Betrag der entsprechenden Kategorie zum Zeitpunkt der
Einziehung der entsprechenden Kategorie, es sei denn Gegenteiliges wurde durch die Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft nach den Voraussetzungen für eine Abänderung der Satzung beschlossen, wobei der Gesamteinziehungsbe-
trag niemals höher als der verfügbare Betrag sein darf.

6.5.3 Nach dem Rückkauf und der Einziehung der Geschäftsanteile der entsprechenden Kategorie wird der Einzie-

hungswert pro Geschäftsanteil fällig zur Zahlung durch die Gesellschaft.

Art. 7. Geschäftsanteile.
7.1 Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
7.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

7.3 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

7.4 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend

den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

7.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

7.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 8. Gesellschafterverzeichnis.
8.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend dieser
Satzung sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

8.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 9. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
9.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser

116857

L

U X E M B O U R G

Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

9.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

9.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

9.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles

in  privatschriftlicher  oder  notarieller  Form  dokumentiert  werden,  und  eine  solche  Übertragung  wird  gegenüber  der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.

9.5 Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und

diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Do-
kument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 10. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafter üben ihre gemeinsamen Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

10.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesell-

schafterversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff „alleiniger Gesellschafter" nicht
ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, ist ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die „Gesellschafterversammlung"
als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter" zu lesen.

10.3  Die  Gesellschafterversammlung  hat  die  ihr  durch  Gesetz  oder  durch  diese  Satzung  ausdrücklich  verliehenen

Befugnisse.

10.4 Gibt es mehrere Gesellschafter, übersteigt die Gesamtzahl der Gesellschafter allerdings nicht fünfundzwanzig (25),

können, statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch
schriftlichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall werden, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieser Satzung betreffend
Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung finden.

Art. 11. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
11.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

11.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

11.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

11.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 12. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
12.1 In jeder Gesellschafterversammlung wird ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung wird
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

12.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

116858

L

U X E M B O U R G

12.3 Quorum und Stimmabgabe
12.3.1 Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
12.3.2 Sofern sich aus dem Gesetz oder aus dieser Satzung nicht etwas anderes ergibt, werden Gesellschafterbeschlüsse

bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, welche mehr als fünfzig
Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht
erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden
die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen wirksam
gefasst.

12.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

12.5 Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Vi-

deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.

12.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermöglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.

12.7 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 13. Änderung der Satzung. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann diese Satzung durch einen Beschluss der

Gesellschafterversammlung abgeändert werden,  welcher von  einer (i) Mehrheit der  Gesellschafter,  (ii)  die insgesamt
mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, gefasst wird.

Art. 14. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
14.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie

von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

14.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse

aufnehmen und unterzeichnen.

14.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 15. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
15.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff „alleiniger Geschäftsführer" nicht ausdrücklich in dieser
Satzung erwähnt ist, wird ein in dieser Satzung genannter Verweis auf den „Geschäftsführerrat" als Verweis auf den
„alleinigen Geschäftsführer" gelesen werden.

15.2  Der  Geschäftsführerrat  verfügt  über  die  weitestgehenden  Befugnisse,  alle  Handlungen  vorzunehmen,  die  zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung
den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

15.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

15.4 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln wird.

116859

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 17. Vorschlag, Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
17.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche auch über deren Bezahlung und

die entsprechende Amtszeit bestimmt.

17.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich auch Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Ab-
berufung ausgeschlossen.

17.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 18. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

18.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 19. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Ab-

wesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

19.2 Quorum
Die Geschäftsführerversammlung kann lediglich dann beraten und rechtswirksam handeln, wenn mindestens ein (1)

Geschäftsführer der Klasse A, ein (1) Geschäftsführer der Klasse B sowie ein (1) Geschäftsführer der Klasse C bei einer
Geschäftsführerversammlung anwesend oder vertreten sind.

19.3 Abstimmung
Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder der entsprechenden

Geschäftsführerversammlung, sowie der Zustimmung mindestens eines (1) Geschäftsführers der Klasse A, eines (1) Ge-
schäftsführers der Klasse B und eines (1) Geschäftsführers der Klasse C. Der Vorsitzende hat kein ausschlaggebendes
Stimmrecht.

19.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

19.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

19.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

19.7 Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat

116860

L

U X E M B O U R G

und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt  im  Protokoll  über  die  betreffende  Transaktion  aufgenommen  werden.  Dieser  Artikel  18.7  ist  nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 20. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
20.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, nimmt ein Protokoll über jede

Sitzung des Geschäftsführerrats auf, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

20.2 Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, nimmt über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll auf.
20.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

oder die Dritten zugänglich gemacht werden, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Geschäftsführerrats,
von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 21. Geschäfte mit Dritten. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift eines

(1) Geschäftsführers der Klasse A, eines (1) Geschäftsführers der Klasse B sowie (1) eines Geschäftsführers der Klasse
C, oder (ii) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift solcher Personen, denen die entsprechende Zeichnungs-
vollmacht durch einen (1) Geschäftsführer der Klasse A, einen (1) Geschäftsführer der Klasse B und einen (1) Geschäfts-
führer der Klasse C übertragen worden ist, wirksam verpflichtet. Im Bereich der täglichen Geschäftsführung wird die
Gesellschaft durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer jeden Person/solcher Personen, der/denen die allei-
nige  oder  gemeinschaftliche  Wahrnehmung  der  täglichen  Geschäftsführung  übertragen  wurde,  durch  Handlungen  im
Rahmen der Regeln und Beschränkungen der so erteilten Vertretungsmacht wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht

Art. 22. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
22.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

22.2 Die Gesellschafterversammlung wird die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

22.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

22.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte

der Gesellschaft.

22.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

22.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in dieser Satzung genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des
Geschäftsführerrats anwendbar sein.

22.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d'entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1.) Januar jedes Jahres und endet am

einunddreißigsten (31.) Dezember desselben Jahres.

Art. 24. Gewinne - Ausschüttungen.
24.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung wird dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

24.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

24.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

116861

L

U X E M B O U R G

24.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und der folgenden Bestimmungen:

24.4.1 Jedwede Ausschüttung, inbegriffen die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen, der Rückkauf von preferred

equity certificates und die Zahlung der darauf angefallenen Zinsen, der Rückkauf von Geschäftsanteilen oder anderen
Finanzierungsinstrumenten und ähnliche Ausschüttungen welcher Natur auch immer, werden pari passu zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der geschäftlichen und vertraglichen Eigenschaften der Fi-
nanzierungsinstrumente, die durch die entsprechenden Gesellschafter gehalten werden, vorgenommen.

24.4.2 Beschlossene Dividenden können in jeder durch die Geschäftsführer oder gegebenenfalls durch den Geschäfts-

führerrat ausgewählten Währung, sowie zu jedem durch die Geschäftsführer oder gegebenenfalls durch den Geschäfts-
führerrat gewählten Zeitpunkt und an jedem durch die Geschäftsführer oder gegebenenfalls durch den Geschäftsführerrat
ausgewählten Ort gezahlt werden. Die Geschäftsführer, oder gegebenenfalls der Geschäftsführerrat, legen den Wech-
selkurs  hinsichtlich  des  Umtausches  der  Dividendenausschüttung  in  die  Auszahlungswährung  fest.  Eine  beschlossene
Dividende, welche nicht innerhalb von fünf Jahren ausgezahlt wurde, kann auch danach nicht mehr durch den Inhaber der
entsprechenden Gesellschaftsanteile gefordert werden, sondern ist verwirkt und fällt an die Gesellschaft zurück. Auf
erklärte, aber nicht eingeforderte Dividenden, die durch die Gesellschaft für den entsprechenden Inhaber gehalten wer-
den, fallen keine Zinsen an.

24.4.3 Im Falle der Ausschüttung einer Dividende soll die Zuweisung und Zahlung der Dividende wie folgt erfolgen:
(i) Ein Betrag entsprechend 0,25 % des Nennwerts jedes Geschäftsanteils soll allen Gesellschaftern gleichmäßig pro

rata im Verhältnis zu deren Beteiligung unabhängig von der entsprechend Kategorie der Geschäftsanteile ausgezahlt wer-
den, und

(ii)der Restbetrag des verteilten Gesamtbetrags soll vollständig an die Inhaber der ersten Kategorie in umgekehrter

alphabetischer Reihenfolge (z.B. zuerst Geschäftsanteile der Kategorie J, dann sofern diese nicht existieren, Geschäfts-
anteile der Kategorie I und so weiter bis lediglich Geschäftsanteile der Kategorie A existieren) ausgeschüttet werden.

Art. 25. Zwischendividenden - Emissionsagio.
25.1 Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraus-

setzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich Gewinnvorträge und Summen, die aus zu diesem
Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß
dem Gesetz oder dieser Satzung der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden,
in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind. Ausschüt-
tungen  werden  pari  passu  unter  den  Gesellschaftern  der  Gesellschaft  vorgenommen  wobei  die  wirtschaftlichen  und
vertraglichen Eigenschaften der durch die jeweiligen Gesellschafter gehaltenen Finanzierungsinstrumente beachtet wer-
den.

25.2 Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 26. Liquidation.
26.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche

oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Auflösung der
Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

26.2 Nach Zahlung aller Schulden, aller Ansprüche gegen die Gesellschaft und der Ausgaben für die Liquidation, wird

die Verteilung des Liquidationserlöses pari passu zwischen den Gesellschaftern vorgenommen und folgt, um hinsichtlich
des Gesamtbetrages das gleiche wirtschaftliche Ergebnis zu erreichen, den für die Ausschüttung von Dividenden aufge-
stellten Regeln.

H. Gesellschafterbeschluss - Anwendbares recht

Art. 27. Anwendbares Recht. Diese Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht.

Alle in dieser Satzung oder in einem Gesellschafterbeschluss, der möglicherweise zwischen den Gesellschaftern zu ir-
gendeinem Zeitpunkt besteht, nicht geregelten Angelegenheiten, sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen  Partei  auf  Englisch  geschrieben  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Übersetzung.  Auf  ausdrückliche  Anfrage
derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll
die englische Fassung vorrangig sein.

116862

L

U X E M B O U R G

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten

Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument der erschienen Person, dem Notar durch Namen, Vornamen und Anschrift bekannt, vor-

gelesen worden ist, hat die besagte Person diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: C. KROGER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 juillet 2011. Relation LAC/2011/34423. Reçu soixante-quinze euros (75,00 euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 04 août 2011.

Référence de publication: 2011111702/1213.
(110128003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.

Carmel Capital V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 24.893,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.079.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011118179/13.
(110135875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Cartonplastgroup Holding SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 138.435.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 28 avril 2011.

Référence de publication: 2011118180/10.
(110136105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

ChemCore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 57.934.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 août 2011.

Référence de publication: 2011118181/11.
(110135813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Clint Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 134.831.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011118183/11.
(110135788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

116863

L

U X E M B O U R G

Connaught Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.000.000,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 47.733.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2011.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2011118184/14.
(110135929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Corn Products Global Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.230.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/08/2011.

TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011118185/13.
(110135857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Credit Suisse Portfolio Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 2.698.674.419,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 149.672.

Par résolutions signées en date du 30 juin 2011, les associés ont pris les décisions suivantes:
Acceptation de la démission de Germain Trichies, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lu-

xembourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 décembre 2010.

Acceptation de la démission de Fernand Schaus, avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg, de son mandat de gérant avec effet au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2011.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011118186/18.
(110135774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Calidad S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 72.866.

L’an deux mille onze, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CALIDAD S.A.», établie et

ayant son siège social au 16 allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 72866, constitué suivant acte notarié en date du 25 novembre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 82 du 25 janvier 2000.

116864

L

U X E M B O U R G

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert SCHMITZ, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le  Président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Carine  PAJOT,  employée  privée,  avec  adresse  professionnelle  à

Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Géneviève BAUE, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Décision de mettre la société en liquidation.
- Nomination de FIDESCO S.A. comme liquidateur.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société et de pro-

noncer sa mise en liquidation avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
La société anonyme «FIDESCO S.A.,», établie et ayant son siège social au 16 allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 68.578.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. SCHMITZ, C. PAJOT, G. BAUE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 août 2011. Relation: EAC/2011/10598. Reçu douze Euros (12.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011118187/61.
(110135804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

116865

L

U X E M B O U R G

Captherm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.325.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118188/9.
(110135966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

CDR Ray Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 105.805.

Par résolutions signées en date du 5 août 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de Gérant, avec effet immédiat.

2. Nomination de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2011.

Référence de publication: 2011118189/15.
(110136134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

CEE IT Holdings (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 86.557.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118190/10.
(110136078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Cefarg Minerals GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1862 Luxembourg, 2, rue Arthur Knaff.

R.C.S. Luxembourg B 16.865.

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales sous seing privé en date du 15 décembre 2010, les 500 parts sociales sont détenues

avec effet au 1 

er

 Janvier 2011 par l’actionnaire unique Jean WAGNER, retraité, né le 23 avril 1936 à Luxembourg et

résidant à L-1862 Luxembourg, 2, rue Arthur Knaff.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118191/13.
(110135560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

CEH Clean Energies Holding AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 157.330.

<i>Auszug der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. August 2011

- Nach der Mandatsniederlegung von Herrn Bernhard SCHWECHEL, ernennt die Generalversammlung Herrn Ralf

GRASS,  geboren  am  24.  Oktober  1969  in  Wolfhagen,  mit  beruflicher  Adresse  in  der  Industriezone  Schächenwald,
CH-6460 Altdorf, zum Verwaltungsratsmitglied. Sein Mandat endet zur ordentlichen Generalversammlung welche im
Jahre 2016 abgehalten wird.

116866

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 19. August 2011.

<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011118192/15.
(110135891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

CFC Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 115.321.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 juin 2011, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Frédéric Meessen, avec adresse au 6, rue de l'Argentine, 1310 La Hulpe, Belgique
- Jean-Louis Colette, avec adresse au 16, avenue des Créneaux, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

2. renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23, Val Fleuri,

L-1526 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2011.

Référence de publication: 2011118193/21.
(110136133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Ciyow International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5975 Itzig, 24, Cité Bernard Simminger.

R.C.S. Luxembourg B 81.045.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118194/9.
(110135915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

CMA 3 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 151.485.

DISSOLUTION

In the year two thousand eleven, on the eleventh of August;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

CMA S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 102189,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal on August 11, 2011; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and
the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, requested the undersigned notary to authenticate:
I) that it is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of CMA 3 S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the
undersigned notary, dated 19 February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
683 of 31 March 2010, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151485 (the “Company”).

116867

L

U X E M B O U R G

II) that the Company's articles of incorporation (the “Articles”) have not been amended since that date.
III) that the capital of the Company is fixed at seventy thousand Euro (EUR 70,000.-) represented by seven million

(7,000,000) shares with a par value of one Cent (EUR 0.01) each, all fully paid up.

IV) that the appearing party, in its capacity as Sole Shareholder, has resolved to proceed to the immediate dissolution

of the Company and to put it into liquidation.

V) that the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company.
VI) that the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at August 2, 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or provisioned.

A copy of the aforementioned balance sheet, signed “ne varietur” by the person appearing and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party furthermore declares that:
VII) the Company’s activities have ceased;
VIII) the Sole Shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the Company, the balance sheet of the Company as at August 2, 2011 being only an information for all purposes;

IX) following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
X) full discharge is granted to the Company’s managers with respect to their duties;
XI) it should be proceeded to the cancellation of all issued shares; and
XII) the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five (5) years at least at the premises

of Permira Luxembourg S.àr.l. at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred and
fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, said proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le onze août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

CMA S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège

social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 102189,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation sous seing privé lui délivrée le 11 août 2011; en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle
procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:
I) qu’elle est l’associée unique (l’«Associé Unique») de CMA 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 février
2010, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 683 du 31 mars 2010, ayant son siège
social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du
commerce et des sociétés sous le numéro B 151.485 (la «Société»).

II) que les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis cette date.
III) que le capital social de la Société s'élève à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) représenté par sept millions

(7.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de un centime (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement libérées.

116868

L

U X E M B O U R G

IV) que la partie comparante, en sa qualité d’Associée Unique, a décidé de procéder à la dissolution immédiate de la

Société et de la mettre en liquidation.

V) que l’Associé Unique se désigne lui-même liquidateur de la Société.
VI) que l’Associée Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 2 août 2011,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

Une copie du bilan pré-mentionné, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte, pour être enregistrée en même temps auprès de l’administration de l’enregistrement.

La partie comparante déclare encore que:
VII) l’activité de la Société a cessé;
VIII) l’Associée Unique est investi de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du

passif de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 2 août 2011 étant seulement
un des éléments d’information à cette fin;

IX) suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
X) décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour leur mandat;
XI) il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales émises; et
XII) les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée de cinq (5) ans au moins au siège

de Permira Luxembourg S.àr.l. au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2011. LAC/2011/36579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118196/109.
(110135678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Cocteau S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 50.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118198/9.
(110136035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Compagnie Européenne de Téléphonie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 67.616.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118200/10.
(110135753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

116869

L

U X E M B O U R G

Comptoir Foncier de Gravenmacher S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 108.172.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118201/9.
(110136071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Condor International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.693.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118202/9.
(110135580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Condor International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.693.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118203/9.
(110135581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Norcast S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.386.401,76.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.315.

In the year two thousand and eleven, on the seventh of July.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. PALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) II S.à r.l., a limited liability company having its registered office at 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

itself represented by Mr. Juan Álvarez, private employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue

J.F. Kennedy, pursuant to a proxy dated 1 July 2011,

2. PALA HOLDCO (LUXEMBOURG) III S.à r.l., a limited liability company having its registered office at 46A, avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

itself represented by Mr. Juan Álvarez, prenamed, pursuant to a proxy dated 1 July 2011,
3.  SWANMET  HOLDING  PTE.  LTD.,  a  limited  liability  company  having  its  registered  office  at  174,  Gul  Circle,

SGP-629626 Singapore,

itself represented by Mr. Juan Álvarez, prenamed, pursuant to a proxy dated 1 July 2011,
The said proxies, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as aforementioned, declared that they are the sole shareholders (the "Sharehol-

ders") of Norcast S.à r.l. a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg of Luxembourg under number
B 125.315, (the "Company"), incorporated under the denomination of PALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.à r.l.
by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on February 9, 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 920 on 19 May 2007.

116870

L

U X E M B O U R G

The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Leonie GRETHEN,

notary residing in Luxembourg, on April 30, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1300 on 24 June 2010.

The appearing parties, represented as aforementioned, declared that they hold all the five hundred and thirty five

thousand eight hundred and thirty-two (535,832) shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken
on all items of the agenda.

The items on which resolutions are to be passed are as follows:

<i>Agenda

1. To convert the share capital of the Company being EUR 13,395,800.00 into the corresponding amount in the United

States dollars as per the date of the extraordinary general meeting.

2. To amend and restate the Articles of the Company accordingly.
3. Miscellaneous.
The appearing parties, represented as aforesaid, have requested the undersigned notary to record the following re-

solutions:

<i>First resolution

The Shareholders RESOLVED to change the currency of the share capital of the Company from Euro into United

States dollar by applying the exchanged rate of the fixed on the 5 

th

 of July 2011 and corresponding to one Euro (EUR

1.-) = one point forty four seventy two United States dollar (USD 1.4472) .

<i>Second resolution

The Shareholders RESOLVED to convert the existing share capital of thirteen million three hundred and ninety-five

thousand eight hundred euro (EUR 13,395,800.00.-) into nineteen million three hundred eighty six thousand four hundred
and one United States dollars point seventy six Cents (USD 19,386,401.76).

<i>Third resolution

The Shareholders RESOLVED that the share capital of the company as from now on amounts to nineteen million three

hundred eighty six thousand four hundred and one United States dollars point seventy six Cents (USD 19,386,401.76)
divided into five hundred and thirty five thousand eight hundred thirty two (535,832) shares with a nominal value of thirty
six point eighteen United States dollars (USD 36.18) each.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholders RESOLVED to amend article 8 of the articles of association,

which shall from now on read as follows:

“ Art. 8. The company's capital is set at nineteen million three hundred eighty six thousand four hundred and one

United States dollars point seventy six Cents (USD 19,386,401.76) represented by five hundred and thirty five thousand
eight hundred thirty two (535,832) shares of thirty six point eighteen United States dollars (USD 36.18) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le sept juillet.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. PALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG) II S.à r.l., société avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F.

Kennedy,

elle-même représentée par Monsieur Juan Álvarez, employée privée, demeurant professionnellement à L-1855 Lu-

xembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, en vertu d'une procuration du 1 

er

 juillet 2011.

116871

L

U X E M B O U R G

2. PALA HOLDCO (LUXEMBOURG) III S.à r.l., société avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F.

Kennedy,

elle-même représentée par Monsieur Juan Álvarez, préqualifié, en vertu d'une procuration du 1 

er

 juillet 2011.

3. SWANMET HOLDING PTE. LTD., a société avec siège social à 174, Gul Circle, SGP-629626 Singapore,
elle-même représentée par Monsieur Juan Álvarez, préqualifié, en vertu d'une procuration du 1 

er

 juillet 2011.

Les procurations signées "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent être les seuls associés (les «Associés») de Norcast

S.à r.l., une société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg  sous  le  numéro  B  125.315,  (la  «Société»),  constituée  sous  la  dénomination  de  PALA  INVESTMENTS
(LUXEMBOURG) S.à r.l., par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 février 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 920 du 19 mai 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Léonie GRETHEN, notaire de

résidence à Luxembourg, le 30 avril 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1300 du 24
juin 2010.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent détenir toutes les 535.832 (cinq cent trente-

cinq mille huit cent trente-deux) parts sociales en circulation de la Société afin que les décisions peuvent être valablement
prises sur tous les points de l'ordre du jour.

Les points sur lesquels des résolutions doivent être transmis sont les suivants:

<i>Agenda

1. Conversion du capital social de la Société étant EUR 13.395.800,00 en un montant correspondent en dollars US au

jour de la présente assemblée.

2. Modification correspondante des statuts de la Société.
3. Divers.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés DECIDENT de changer la devise du capital social de la Société de l'euro en dollar des États-Unis en

appliquant le taux d'échange fixé sur le 5 Juillet 2011 et correspondant à un euro (EUR 1.-) = un point quarante-quatre
soixante-douze dollar des États-Unis (USD 1,4472).

<i>Deuxième résolution

Les Associés DECIDENT de convertir le capital social existant de treize millions trois cent quatre-vingt-treize mille

huit cents Euros (EUR 13.395.800,-) en dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent un dollars des États-
Unis soixante-seize Cents (USD 19.386.401,76).

<i>Troisième résolution

Les Associés DECIDENT que le capital social de la Société s'élève à partir de maintenant à un montant de dix-neuf

millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent un dollars des États-Unis soixante-seize Cents (USD 19.386.401,76)
divisé en cinq cent trente-cinq mille huit cent trente-deux (535 832) parts sociales avec une valeur nominale de trente-
six dollars des Etats-Unis dix-huit Cents (USD 36,18) chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés DECIDENT de modifier l'article 8 des statuts de la Société,

qui doit désormais se lire comme suit:

« Art. 8. Le capital de la Société est fixé à dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent un dollars des

Etats-Unis soixante-seize Cents (USD 19.386.401,76) représenté par cinq cent trente-cinq mille huit cent trente-deux
(535 832) parts sociales de trente-six dollars des Etats-Unis dix-huit Cents (USD 36,18) chacune."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille cent euro (EUR 1.100.-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

116872

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Alvarez, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 14 juillet 2011. Relation: RED/2011/1462. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 5 août 2011.

Référence de publication: 2011112498/140.
(110129201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.

Condor International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.693.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118204/9.
(110135582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Condor International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.693.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011118205/9.
(110135583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Cresford Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 71.549.

<i>Extrait des résolutions prises lors de

<i>l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 août 2011

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec

adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg; de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec
adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg; de Lux Business Management SARL, ayant son siège
social, 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES
S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.

Luxembourg, le 5 août 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011118206/19.
(110136148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

D'Pettener Schlësserei S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7463 Pettingen, 3, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 104.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118209/10.
(110136177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

116873

L

U X E M B O U R G

D.S.J. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.201.

<i>Les administrateurs:

- Monsieur Norbert SCHMITZ
- la société S.G.A. SERVICES S.A.
- la société FMS SERVICES S.A.
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric HERREMANS,
ont remis leur démission en date du 5 mai 2011.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg CONSEIL
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2011118207/15.
(110136018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

D.S.J. S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.201.

Le domicile de la société anonyme D.S.J. S.A., 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B – 66.201,

est dénoncé ce jour avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2011118208/11.
(110136166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Mafi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Brasserie la Cheminée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl.

R.C.S. Luxembourg B 162.631.

STATUTS

L'an deux mille onze, le trente juin.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Madame Marie-Lou INACIO, assistante-secrétaire, née à Mafra (Portugal) le 8 septembre 1965, demeurant à L-4958

Bascharage, 1, an der Hiehl.

2.- Monsieur Yannick FABRY, tuyauteur, né à Compiègne (France) le 18 décembre 1965, demeurant à F-54250 Frenois-

la-Montagne, 11, rue Hobscheid.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer

entre eux.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "MAFI s.à r.l.". Elle pourra exercer le commerce sous l'enseigne

«BRASSERIE LA CHEMINEE».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet principal l'exploitation d'un café-brasserie avec débit de boissons alcoolisées et non

alcoolisées et petite restauration.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières  ou  autres  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  susceptibles  d'en  favoriser  la
réalisation.

116874

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400.-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (€ 124.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec l'accord unanime de tous les

associés. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social communication

desdits inventaire et bilan.

116875

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Marie-Lou INACIO, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Yannick FABRY, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (€ 12.400.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Madame Marie-Lou INACIO, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indétermi-

née.

2) Monsieur Yannick FABRY, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et du

gérant administratif.

Toutefois, pour tout engagement inférieur à cinq mille euros (€ 5.000.-), la société est valablement engagée par la

signature individuelle de la gérante technique.

4) Le siège social est fixé à L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: INACIO, FABRY, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 1 

er

 juillet 2011. Relation: CAP/2011/2463. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

116876

L

U X E M B O U R G

Bascharage, le 7 juillet 2011.

A. WEBER.

Référence de publication: 2011112917/136.
(110128608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.

Sogimme II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 155.020.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOGIMME II S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Benoît LEJEUNE / Moyse DARGAA
<i>Délégué à la gestion journalière / Administrateur Délégué

Référence de publication: 2011118082/13.
(110134261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 143.975.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011118083/11.
(110134148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

Weldpart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.634.

<i>Extrait des résolutions prises lors

<i>de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2011

- la cooptation de Monsieur Kevin DE WILDE, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Nicole THIRION, démissionnaire, est ra-
tifiée.

Pour copie conforme
WELDPART S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011118085/15.
(110134371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

Home Performance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig, 14, rue Zechel.

R.C.S. Luxembourg B 151.465.

DISSOLUTION

L'an deux mil onze, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée «CAPIGEST s.à r.l.» avec siège social à L-9170 Mertzig, 14, rue Zechel, inscrite

au RCS sous le numéro B 118.160,

Ici représentée par sa gérante unique Madame Mia VAN DE BERG, comptable, demeurant à L-9170 Mertzig, 14, rue

Zechel,

116877

L

U X E M B O U R G

2. La société à responsabilité limitée «EURO PRO SERVICES s.à r.l.» avec siège social à L-9030 Warken, 42, Cité

Waarkdall, inscrite au RCS sous le numéro B 93.723,

Ici représentée par son gérant unique Monsieur Thierry SCHUMACHER, employé privé, demeurant à L-9030 Warken,

42, Cité Warkdall.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Lesdites sociétés sont les seules associées de la société à responsabilité limitée «HOME PERFORMANCE S. à r.l.»,

avec siège social à L-9170 Mertzig, 14, rue Zechel, inscrite au RCSL sous le numéro B 151.465,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 février 2010, publié au Mémorial C numéro

683 du 31 mars 2010.

II. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,-) EUROS, représenté par CENT (100) parts

sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125,-) EUROS chacune entièrement souscrites et libérées par
lesdites sociétés, chacune pour moitié.

Les comparantes, représentant l'intégralité du capital social et représentées comme dit ci-avant, ont pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Elles décident de supprimer l'article 14 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Elles décident de dissoudre et de liquider la société et elles déclarent que la société a cessé toutes ses activités.
En conséquence elles prononcent sa dissolution,
- elles donnent pleine et entière décharge aux gérants,
- elles déclarent que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'elles répondront encore personnel-

lement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Elles régleront également les frais des
présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés au prorata de leur participation, étant entendu que toute
affectation quelconque de l'actif ne pourra avoir lieu avant l'apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-9170 Mertzig, 14, rue

Zechel.

<i>Déclaration en matière de blanchiment d'argent

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération
du capital social ne proviennent pas, respectivement que la société ne s'est pas livrée à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) respectivement d'un acte de terrorisme tel
que défini à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Van de Berg, Schumacher, Tholl.
Enregistré à Mersch, le 3 août 2011. Relation: MER/2011/1554. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des sociétés.

Mersch, le 8 août 2011.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2011118101/57.
(110134915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

www.Domaine de Linger S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 98.374.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 6 juillet 2011, enregistrée

à Esch/Alzette A.C., le 28 juillet 2011; Relation: EAC/2011/10195, que l'AGE a pris les décisions suivantes:

Que le siège social de la société du 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, a été transféré à

sa nouvelle adresse sise à 20, Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

116878

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Karine REUTER
<i>Notar

Référence de publication: 2011118086/15.
(110134883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

Forum Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 133.874.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

«WILONA GLOBAL S.A.», ayant son siège social à Panama, Arango-Orillac, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 , Street (Panama),

ci-après désignée: «le mandant».
Lequel mandant est ici représenté par:
Madame Laurence BARDELLI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
ci-après désignée: «la mandataire»,
en vertu d'une procuration générale donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2011,
ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société «FORUM INVESTMENT S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social

au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 133.874 a été constituée en date du 14 novembre 2007, par acte notarié, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2979 du 21 décembre 2007.

II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté

par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, chaque action étant intégra-
lement libérée.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société «FORUM

INVESTMENT S.A.», prédésignée.

IV.- Que le mandant est devenu successivement propriétaire de toutes les trois cent vingt (320) actions de la susdite

Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il, en tant

qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la

Société.

VIII.- Que les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés

à partir de ce jour, en présence du notaire instrumentaire.

IX.- Que la mandante s'engage à payer les frais du présent acte.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, ladite personne a signé avec

le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. BARDELLI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 août 2011. Relation: EAC/2011/10933. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011118862/48.
(110136365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

116879

L

U X E M B O U R G

Indreni S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Himalaya S.à r.l.).

Siège social: L-2440 Luxembourg, 8, route de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 98.568.

L'an deux mille onze, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.) Monsieur Ramjee GURUNG, restaurateur, né à Okhaldhunga, (Nepal), le 20 septembre 1965, demeurant à L1520

Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer

2.) Madame Meeta GURUNG, employée privée, née à Kathmandu, (Nepal), le 19 mai 1979, demeurant à L-1520

Luxembourg, 72, rue Adolphe Fischer

3.) Monsieur Kamal Bahadur GURUNG, commerçant, né à Okhaldhunga, (Nepal), le 28 novembre 1967, demeurant

à Salleri, 2 Okhaldhunga (Nepal)

4.) Monsieur Khanal DIPAK, employé privé, né le 13 octobre 1982 à Tanahun (Nepal) demeurant à L-2561 Luxembourg,

97, rue de Strasbourg,

5.) Madame Ranjana BASNET, employée, née à Rupandeni (Nepal), le 25 mars 1991, demeurant à L-1261 Luxembourg,

110, rue de Bonnevoie,

6.) Monsieur Prem PANDE, employée, née à Thimpu (Bhoutan), le 20 juin 1979, demeurant à L-1221 Luxembourg,

225, rue de Beggen,

7.) Madame Shanti POKHAREL, employée, née à Nawalparasi (Népal), le 9 septembre 1982, demeurant à L-1221

Luxembourg, 225, rue de Beggen

ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une (1)

procuration donnée sous seing privé délivirées au mandataire

Lesquelles procurations, après avoir été signée «ne varietur» par le notaire et le mandataire du comparant, resteront

annexées au présent acte.

Lesquels comparants ont déclaré qu’ils étaient les seuls et uniques associés, représentant l’intégralité du capital social

de la société à responsabilité limitée "HIMALAYA S. à r.l.", ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 8, route de
Rollingergrund, constituée originairement sous la dénomination de T.T. COMPANY S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 269
du 6 mars 2004. Les statuts de la société ont été modifies pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en
date du 12 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 331 du 8 mars 2007 en
adoptant la dénomination de GURUNG S.à r.l.

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 octobre 2010 en adoptant

la dénomination de HIMALAYA S. à r.l., non encore publié au Mémorial C.

Les associés ont pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en INDRENI S.à r.l..
En conséquence l’article 4 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société prend la dénomination de INDRENI S.à r.l. faisant le commerce sous l’enseigne de HIMALAYA.»

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 août 2011. Relation GRE/2011/2841. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 18 août 2011.

Référence de publication: 2011118296/51.
(110135664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116880


Document Outline

BCW Investment S.A.

Bellecour Capital

Bellecour Capital

Bestime S.A.

Biopharma Investments S.A.

Bowlingcenter Fuussekaul, s.à r.l.

Brisco S.A.

BS Holding S. à r.l.

Calidad S.A.

Captherm S.A.

Carmel Capital II Sàrl

Carmel Capital IV Sàrl

Carmel Capital V S.à r.l.

Cartonplastgroup Holding SA

CDR Ray Investor S.à r.l.

CEE IT Holdings (LUXEMBOURG) S.A.

Cefarg Minerals GmbH

CEH Clean Energies Holding AG

CFC Finance

ChemCore S.A.

Ciyow International S.à.r.l.

Clint Properties S.à r.l.

CMA 3 S.àr.l.

Cocteau S.A.-SPF

Compagnie Européenne de Téléphonie S.A.

Comptoir Foncier de Gravenmacher S.A.

Condor International S.A.

Condor International S.A.

Condor International S.A.

Condor International S.A.

Connaught Luxembourg S.à r.l.

Corn Products Global Holding S.à r.l.

Credit Suisse Portfolio Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Cresford Real Estate S.A.

D'Pettener Schlësserei S. à r.l.

D.S.J. S.A.

D.S.J. S.A.

Faraz s.à r.l.

Faraz s.à r.l.

Faraz s.à r.l.

Fidexco S.à r.l.

Fiduciaire Beaumanoir S.A.

Fiduciaire Beaumanoir S.A.

Fiduciaire Deflorenne &amp; Associés S.à r.l.

Forum Investment S.A.

Himalaya S.à r.l.

Home Performance S.àr.l.

Indreni S.à r.l.

Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.

Mafi s.à r.l.

Norcast S.à r.l.

Sogimme II S.A.

Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl

Weldpart S.A.

www.Domaine de Linger S.A.

Zwise