logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2420

8 octobre 2011

SOMMAIRE

3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .

116157

ACMO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116160

ArtisTantra Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116160

Ayala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116160

Immolux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116151

J.L.T. SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116154

KD Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116160

Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l.  . . .

116114

LSREF Summer Loans, S.à r.l. . . . . . . . . . . .

116157

Maiola International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

116132

Performance Partner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

116128

Photo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116128

Power Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116128

Premium Car Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

116131

ProLogis European Developments Holding

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116114

ProLogis European Finance II S.àr.l.  . . . . .

116114

ProLogis European Finance VI S.à r.l.  . . . .

116129

ProLogis European Finance XIII S.à r.l.  . .

116129

ProLogis European Finance XII S.àr.l. . . . .

116132

ProLogis European Finance XI S.àr.l.  . . . .

116131

ProLogis European Finance XV S.à r.l.  . . .

116130

ProLogis European Holdings II S.à r.l.  . . . .

116130

ProLogis European Holdings IV S.à r.l.  . . .

116142

ProLogis European Holdings S.à r.l. . . . . . .

116142

ProLogis European Holdings VI S.à r.l.  . . .

116143

ProLogis European Holdings XI S.àr.l.  . . .

116153

ProLogis European Holdings X S.à r.l.  . . .

116153

ProLogis France IX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116143

ProLogis France V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116143

ProLogis France XVI S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . .

116143

ProLogis France XXIX S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

116151

ProLogis France XX S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

116144

ProLogis France XXXIII S.à r.l. . . . . . . . . . .

116129

ProLogis France XXXIV S.àr.l.  . . . . . . . . . .

116151

ProLogis France XXXVIII S.à r.l.  . . . . . . . .

116151

ProLogis Germany XII S.àr.l. . . . . . . . . . . . .

116153

ProLogis Spain VII S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

116128

ProLogis Spain VI S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

116131

Quesse SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116153

Quesse SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116154

SF (Lux) Sicav 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116154

Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . .

116130

Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . .

116130

Tecsom Eurl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116156

TPL Bad Aibling S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

116144

UBS SIF Management Company S.A.  . . . .

116156

Uliza Finance & Co S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116156

Varialux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116157

116113

L

U X E M B O U R G

ProLogis European Developments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.297.

<i>Rectificatif du dépôt No L110068948.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116889/15.
(110133768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Finance II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.445.

<i>Rectificatif du dépôt No L110068900.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116890/15.
(110133770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 162.534.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of July.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, a notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B
160.558,

duly represented for the purpose hereof by Ms. Christine Kröger, Maître en Droit, having her professional address in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 15 

th

 , 2011, in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

Such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration
authorities.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité

limitée, which it wishes to incorporate according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and the articles of
association of which shall be as follows:

116114

L

U X E M B O U R G

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Kinove Luxembourg Holdings
3 S.à r.l.” (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by

accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of

managers.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

B. Share capital - Shares - Register of shareholders -

Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1  The  Company’s  share  capital  is  set  at  twelve  thousand  five  hundred  euro  (EUR  12,500),  consisting  of  twelve

thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise

provided by law.

6.3 A shareholder’s right in the Company’s assets and profits shall be proportional to the number of shares held by

him/her/it in the Company’s share capital.

6.4 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company’s dissolution.

116115

L

U X E M B O U R G

6.5 The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed

shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.6 The Company’s shares are in registered form.

Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection

by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-

holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The Company’s shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the
shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or

in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor’s and the transferee’s
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company’s corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of

holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,

by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company’s share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.

10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the

municipality where the Company’s registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company’s accounts.

116116

L

U X E M B O U R G

10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly

passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company’s share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.

11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder’s identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company’s registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In

case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company’s management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.

14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the

corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).

116117

L

U X E M B O U R G

14.3 The Company’s daily management and the Company’s representation in connection with such daily management

may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone

or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a

chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.

16.3  Any  manager  shall  hold  office  until  its/his/her  successor  is  elected.  Any  manager  may  also  be  re-elected  for

successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,

the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least one (1) class A manager, one (1) class B manager,

and one (1) class C manager are present or represented at a meeting of the board of managers.

18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting

of the board of managers, including at least one (1) class A manager, one (1) class B manager, and one (1) class C manager.
The chairman shall not have a casting vote.

18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such manager’s identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company’s registered office.

18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of

the board of managers which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the

116118

L

U X E M B O U R G

sole manager and the Company, which conflicts with the Company’s interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the

board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by either

(i) the joint signatures of one (1) class A manager, one (1) class B manager, and one (1) class C manager, or (ii) by the
joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by one (1)
class A manager, one (1) class B manager, and one (1) class C manager. The Company will be bound towards third parties
by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company’s daily management has been delegated
acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or

several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.

21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company’s books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d’entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The Company’s financial year shall begin on first (1 

st

 ) January of each year and shall terminate

on thirty-first (31 

st

 ) December of the same year.

Art. 23. Profits.
23.1 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

23.3 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company’s annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 24. Interim dividends - share premium.
24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,

under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the

116119

L

U X E M B O U R G

amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company’s auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.

24.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s
dissolution which shall determine the liquidators’/liquidator’s powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The Company’s first financial year shall begin on the date of the Company’s incorporation and shall end on thirty-

first (31 

st

 ) December 2011.

2) Interim dividends may also be paid out during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and Payment

The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., prenamed, and represented as stated above,
paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500) shares

of the Company. All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand four hundred euro (EUR
1,400).

<i>General meeting of shareholders

The incorporating shareholder, representing the Company’s entire share capital and considering itself as duly convened,

has immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly constituted,
the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the board of managers is fixed at four (4).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) Mr. Lucas Flynn, born on December 20 

th

 , 1978 in La Plata, Argentina, residing professionally at c/o Rhône Group

LLP, 5 Princes Gate, 3 

rd

 floor, Knightsbridge, London, SW7 1QJ, United Kingdom, as class A manager of the Company;

b) Mr. Lars Frankfelt, born on July 20 

th

 , 1956 in Brannkyrka, Sweden, with professional address at 29 Esplanade, 1

st

 floor, St Helier, JE2 3QA, Jersey, as class B manager of the Company;

c) Mr. Wim Rits, born on June 14 

th

 , 1970 in Merksem, Belgium, residing professionally at 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class C manager of the Company; and

d) Mr. Ivo Hemelraad, born on October 12 

th

 , 1961 in Utrecht, the Netherlands, with professional address at 15, rue

Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class C manager of the Company.

3. The members of the board of managers are appointed for a nondefined period of time, or until any such date which

may be determined by the general meeting of shareholders.

4. The address of the Company’s registered office is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

116120

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with

the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundelf, den achtzehnten Juli.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Ist erschienen:

Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., eine gemäß dem luxemburgischen Recht gegründete und bestehende Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 160.558,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Christine Kröger, Rechtsanwältin, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Groß-

herzogtum Luxemburg, kraft einer am 15. Juli 2011 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erteilten Vollmacht.

Nachdem die Vollmacht durch die Bevollmächtigte und die unterzeichnete Notarin „ne varietur“ unterzeichnet worden

ist, soll diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.

Solch erschienene Partei hat die Notarin ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzu-

nehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:

A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die

künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma “Kinove
Luxembourg Holdings 3 S.à r.l.” (die “Gesellschaft”).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen

Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus

Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-

gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in

welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3.  Die  Gesellschaft  kann  jedwede  Transaktionen  vornehmen,  welche  direkt  oder  indirekt  ihrem  Zweck  dienen.

Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-

papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder

im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes

beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-

rerrats verlegt werden.

116121

L

U X E M B O U R G

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-

burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.

4.4.  Zweigniederlassungen  oder  andere  Geschäftsstellen  können  im  Großherzogtum  Luxemburg  oder  im  Ausland

durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis -

Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus zwölftau-

sendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-

schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig

(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl

der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.

6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-

fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.

6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-

gekauften  oder  zurückgenommenen  Geschäftsanteile  werden  sofort  gelöscht  und  das  Stammkapital  entsprechend
herabgesetzt.

6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-

schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung

mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-

schafterverzeichnis  erbracht  werden.  Auf  Ersuchen  und  auf  Kosten  eines  Gesellschafters  werden  Zertifikate  dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-

sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter

Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des

Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

116122

L

U X E M B O U R G

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen

und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe

der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-

terversammlung  aus.  In  einem  solchen  Fall,  soweit  anwendbar  und  wo  der  Begriff  “alleiniger  Gesellschafter”  nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
“Gesellschafterversammlung” als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich

verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,

statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die

satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-

sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit

der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass

sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-

denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-

schafterbeschlüsse bei  der  ersten  Abstimmung  wirksam  gefasst,  wenn sie  von  Gesellschaftern angenommen  werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,

Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,

Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.

116123

L

U X E M B O U R G

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-

formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag  drei  Kästchen  enthalten,  die  es  dem  Gesellschafter  ermöglichen,  seine  Stimme  zugunsten  oder  gegen  den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden

müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag

durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern

sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-

schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen

oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein

müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Geschäftsführer” nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den “Geschäftsführerrat”
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer” gelesen werden.

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts

können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede

Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten

des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit

festlegt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen

werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer

kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner

Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

116124

L

U X E M B O U R G

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung

anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner

Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

18.2. Quorum
Die Geschäftsführerversammlung kann lediglich dann beraten und rechtswirksam handeln, wenn mindestens ein (1)

Geschäftsführer der Klasse A, ein (1) Geschäftsführer der Klasse B sowie ein (1) Geschäftsführer der Klasse C bei einer
Geschäftsführerversammlung anwesend oder vertreten sind.

18.3. Abstimmung
Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder der entsprechenden

Geschäftsführerversammlung, sowie der Zustimmung mindestens eines (1) Geschäftsführers der Klasse A, eines (1) Ge-
schäftsführers der Klasse B und eines (1) Geschäftsführers der Klasse C. Der Vorsitzende hat kein ausschlaggebendes
Stimmrecht.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein

anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-

okonferenz  oder  durch  ein  anderes  Kommunikationsmittel  teilnimmt,  welches  es  ermöglicht,  dass  dieses  Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet,  dass  eine  durch  solche  Kommunikationsmittel  abgehaltene  Sitzung  am  eingetragenen  Sitz  der  Gesellschaft
abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in

einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt

oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt  im  Protokoll  über  die  betreffende  Transaktion  aufgenommen  werden.  Dieser  Artikel  18.7  ist  nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung

des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden

sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift eines

(1) Geschäftsführers der Klasse A, eines (1) Geschäftsführers der Klasse B sowie (1) eines Geschäftsführers der Klasse
C, oder (ii) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift solcher Personen, denen die entsprechende Zeichnungs-

116125

L

U X E M B O U R G

vollmacht durch (1) einen Geschäftsführer der Klasse A, einen (1) Geschäftsführer der Klasse B und (1) einen Geschäfts-
führer der Klasse C übertragen worden ist, wirksam verpflichtet. Im Bereich der täglichen Geschäftsführung wird die
Gesellschaft durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer jeden Person/solcher Personen, der/denen die allei-
nige  oder  gemeinschaftliche  Wahrnehmung  der  täglichen  Geschäftsführung  übertragen  wurde,  durch  Handlungen  im
Rahmen der Regeln und Beschränkungen der so erteilten Vertretungsmacht wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder

mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und

ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung

abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten

der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher

aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d’entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1.) Januar jedes Jahres und endet am

einunddreißigsten (31.) Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage

zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt

werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-

versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-

raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.

24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

116126

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 25 Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-

toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.

H. Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-

burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-

ßigsten (31.) Dezember 2011.

2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Der zeichnende Gesellschafter hat die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., vorbenannt, und vertreten wie oben erwähnt,
zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gegen Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäfts-

anteilen.

Alle Geschäftsanteile sind ganz in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es der unterzeichneten Notarin nachgewiesen wurde.

<i>Auslagen

Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentiert und welcher sich selbst als

ordnungsgemäß geladen erachtet, hat sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafter-
versammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1) Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf vier (4) festgesetzt.
2) Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) Herrn Lucas Flynn, geboren am 20. Dezember 1978 in La Plata, Argentinien, mit beruflicher Adresse in c/o Rhône

Group LLP, 5 Princes Gate, 3 

rd

 floor, Knightsbridge, London, SW7 1QJ, Großbritannien, als Geschäftsführer der Klasse

A;

b) Herrn Lars Frankfelt, geboren am 20. Juli 1956 in Brannkyrka, Schweden, mit beruflicher Adresse in 29 Esplanade,

st

 floor, St Helier, JE2 3QA, Jersey, als Geschäftsführer der Klasse B;

c) Herrn Wim Rits, geboren am 14 Juni 1970 in Merksem, Belgien, mit beruflicher Adresse in 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Klasse C; und

d) Herrn Ivo Hemelraad, geboren am 12. Oktober 1961 in Utrecht, Niederlande, mit beruflicher Adresse in 15, rue

Edward Steichen, L2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Klasse C.

3) Die Mitglieder des Geschäftsführerrats sind auf unbestimmte Zeit, oder bis zu einem von der Gesellschafterver-

sammlung festzusetzenden Zeitpunkt ernannt.

4) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Die  unterzeichnete  Notarin,  die  Englisch  versteht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  Urkunde  auf  Anfrage  der

erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben er-
schienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische
Fassung vorrangig sein.

Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten

Tag aufgenommen.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat die Bevollmächtigte

diese originale Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: C. Kröger et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 juillet 2011. LAC/2011/34203. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

116127

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2011.

Référence de publication: 2011108831/745.
(110125252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2011.

ProLogis Spain VII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116909/14.
(110133854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Performance Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 92.040.

Statuts coordonnés suivant acte du 3 août 2011, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Urbain THOLL
<i>Notaire

Référence de publication: 2011116911/12.
(110133610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Photo Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 26.753.

CLÔTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a
déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société PHOTO INVEST S.A., dont le siège social
à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, a été dénoncé en date du 07 août 2006. Ce même jugement a mis les frais
à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Marie-Laure CARAT
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011116913/15.
(110133711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Power Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 59.513.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juin 2011

<i>Résolution n°1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social

à L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé à compter du 1 

er

 juin 2011.

116128

L

U X E M B O U R G

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 juin 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2011116914/15.
(110133623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Finance VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.981.

<i>Rectification du dépôt No L110068932.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sarl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116892/15.
(110133569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Finance XIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.913.

<i>Rectificatif du dépôt No L110007394.04 du 13/01/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116893/15.
(110133764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France XXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.433.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116904/14.
(110133773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

116129

L

U X E M B O U R G

Société Générale Bank &amp; Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

Les comptes consolidés au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/08/2011.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Société Anonyme
Barbara LODS

Référence de publication: 2011116936/13.
(110133684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Société Générale Bank &amp; Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12/08/2011.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Société Anonyme
Barbara LODS

Référence de publication: 2011116937/13.
(110133690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Finance XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.586.

<i>Rectification du dépôt No L110068933.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sarl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116894/15.
(110133560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.783.

<i>Rectification du dépôt No L110053390.04 du 05/04/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116130

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sarl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gerant

Référence de publication: 2011116895/15.
(110133555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis Spain VI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.790.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116908/14.
(110133853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Premium Car Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 1D, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 155.921.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE CORFI
<i>EXPERTS COMPTABLES
63-65 Rue de Merl
L-2146 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2011116915/15.
(110133904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Finance XI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.139.750,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.210.

<i>Rectification du dépôt No L110068905.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sarl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116916/16.
(110133550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

116131

L

U X E M B O U R G

ProLogis European Finance XII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.406.

<i>Rectificatif du dépôt No L110053387.04 du 05/04/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116917/15.
(110133759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Maiola International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.865.

L'an deux mille onze, le neuf juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MAIOLA INTERNATIONAL

S.A.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée le 06 août 2003 suivant acte reçu Maître
Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg ayant agi en remplacement du notaire instrumentant, alors notaire
de résidence à Mersch, publié au Mémorial, C Recueil des Sociétés et Associations ( le «Mémorial»), numéro 1123 du 29
octobre 2003. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 25 février 2005

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis GALIOTTO, clerc de notaire, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les CINQ CENTS (500) actions représentant l'intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de l'année sociale de la société pour qu'elle commence désormais le 1 

er

 juillet et finisse le 30 juin de

chaque année et modification subséquente de l'article 7 des statuts.

2.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 2 

e

 jeudi du mois de juin à 16h00 au 3 

e

 jeudi du mois

de septembre à 16h00 et ce pour la première fois en 2011. Modification subséquente de l'article 8 alinéa 1 

er

 des statuts.

3.- Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg 8, boulevard Royal vers I-24121 Bergamo Via Casalino n.18.
4.- Décision corrélative d'adoption de la nationalité italienne.
5.- Confirmation que tous les actifs et passifs de la société luxembourgeoise, sans limitation resteront la propriété de

la société en Italie.

6.- Décision d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de leur

accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats.

7.- Décision quant à la nomination des administrateurs en Italie.

116132

L

U X E M B O U R G

8.- Décision de continuer l'activité en Italie sous la dénomination MAIOLA SPA et refonte complète des statuts en

vue de les adapter aux dispositions de la loi italienne.

9.- Donner mandat pour procéder à toutes les démarches nécessaires prévues par la loi italienne et luxembourgeoise,

tant en Italie qu'au Grand-Duché de Luxembourg en relation avec le transfert de siège.

10.- Divers.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'année sociale de la société pour qu'elle commence le 1 

er

 juillet et se finisse

le 30 juin de chaque année.

Par conséquent l'exercice social qui a débuté le 1 

er

 janvier 2011 se clôturera exceptionnellement le 30 juin 2011.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année"

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle du 2 

e

 jeudi du mois de juin à 16h00

au 3 

e

 jeudi du mois de septembre à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2011.

Par conséquent l'article 8 premier alinéa est modifié comme suit:

"L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3 

e

 jeudi du mois de septembre à 16.00 heures.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de

ce jour du Grand-Duché de Luxembourg, L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal en Italie à I24121 Bergamo Via Casalino
n.18, et de faire adopter par la société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de
transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle

L'assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité de l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur

les sociétés commerciales.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée confirme que tous les actifs et passifs sans limitation resteront la propriété de la société dont le siège est

transféré en Italie.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la société en Italie
Monsieur ZANETTI Paolo né à Bergamo le 12 septembre 1973 et demeurant à Lugano (Suisse) Via Montalbano, 9 -

de nationalité italienne - Codice Fiscale: ZNT PLA 73P12 A794D

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 30.06.2012.
Les émoluements de l'administrateur unique sont fixés à EUR. 5.000,-par exercice.
L'assemblé générale décide de nommer aux fonctions de membres du "Collegio Sindacale":
Monsieur TUCCI DR. Sergio né à Tione di Trento (TN) le 12 février 1949, et demeurant à Alzano Lombardo (BG)

Via Grumello, 29 - de nationalité italienne, Codice Fiscale TCC SRG 49B12 L174A, inscrit au Registre des Réviseurs
Comptables, institué par D.M. du 12 avril 1995, publié à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/bis du 21 avril 1995,
Président del Collegio Sindacale;

Monsieur CATTANEO DR. Andrea Onorato né à Bergamo (BG) le 21 janvier 1971, et demeurant à Bergamo, Via

Tasso, 50 - de nationalité italienne, Codice Fiscale CTT NRN 71A21 A794Y, inscrit au Registre des Réviseurs Comptables,
institué par D.M. du 23 juillet 2002, publié à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica supplemento n. 60 - IV Serie Speciale
du 30 juillet 2002, Sindaco Effettivo;

Monsieur VALTULINA DR. Mauro né à Bergamo (BG) il 14 septembre 1967, et demeurant à Bergamo, Via Quintino

Basso 9/g - de nationalité italienne, Codice Fiscale: VLT MRA 67P14 A794V, inscrit au Registre des Réviseurs Comptables,
par Décret Ministériel du 07 juin 1999 publié à la Gazzatta Ufficiale della Repubblica du 25 juin 1999 n. 50 IV Serie Speciale,
Sindaco Effettivo;

Monsieur DONATI DR. Alberto né à Urgnano (BG) il 12 septembre1961 et demeurant à Bergamo (BG) Via Palma il

Vecchio, 157 - de nationalité italienne, Codice Fiscale: DNT LRT 61P12 L502W, inscrit au Registre des Réviseur Comp-
table au n. 31/bis du 21 avril 1995, Sindaco Supplente;

116133

L

U X E M B O U R G

Madame PUGLISI VENNERI D.SSA Monica, née à Grottagli (TA) le 22 décembre1980 et demeurant à Bergamo Via

Tasso, 50 - de nationalité italienne, Codice Fiscale: PGL MNC 80T62 E205J, inscrite au Registre des Réviseurs Comptables,
institué par D.M. du 29 avril 2008, publié à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 du 13 mai 2008; Sindaco Supplente.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 30.06.2015.
Les émoluements des sindaci sont fixés selon le minimum des tarifs professionnels. L'Assemblée Générale décide

également que le premier exercice social en Italie de la société prendra fin le 30 juin 2012.

<i>Septième résolution

Consecutivement à l'adoption de la première résolution, il a été unanimement décidé de continuer l'activité en Italie

sous la dénomination MAIOLA SPA et de modifier les statuts de la société afin de les mettre en conformité avec la loi
italienne:

STATUTO

Art. 1. Denominazione. È costituita la società per azioni con la denominazione:
"MAIOLA S.p.A."

Art. 2. Oggetto.
2.1 La Società ha per oggetto l'attività di:
assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento;
coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario delle Società del gruppo di appartenenza.
La Società potrà, inoltre, in via non prevalente e comunque con riguardo alle sole Società del gruppo di appartenenza,

effettuare:

la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
intermediazione in cambi;
servizi di incasso e pagamento e trasferimento fondi.
Sono tassativamente escluse:
la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 216/74 e successive modificazioni;
l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed all'art. 106 del

D.Lgs. n. 385/93;

l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministero

del Tesoro con Decreto 6 luglio 1994 Art. 5, quarto comma.

2.2 Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in funzione strumentale rispetto allo stesso, la Società potrà

effettuare l'acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società o
imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle
società partecipate (controllate o collegate e, comunque, all'interno del medesimo gruppo), anche mediante prestazione
di servizi di direzione ed organizzazione aziendale, di elaborazione meccanica ed elettronica di dati statistici, contabili e
tecnici, di pagamento e concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il tutto escludendo lo svolgimento
di dette operazioni nei confronti del pubblico, ai sensi dei decreti del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994 (pubblicati
della G.U. il 22 luglio 1994 n. 170), e tutte le altre attività finanziarie o professionali riservate.

2.3 Al medesimo fine e nei medesimi limiti la Società potrà inoltre compiere ogni tipo di operazioni commerciali,

industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili; potrà inoltre prestare garanzie reali, fidejussioni
ed avalli.

Art. 3. Sede.
3.1 La società ha sede in BERGAMO (BG)
3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, di

istituire e di sopprimere sedi secondarie, magazzini, depositi, agenzie e negozi anche in altre località del territorio italiano
o all'estero e sedi amministrative in Italia.

Art. 4. Durata. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata; la Società può essere

anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di Legge.

Art. 5. Capitale, azioni e finanziamenti.
5.1 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) diviso in n° 500.000 azioni da Euro 1,00 ciascuna.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
5.2 Gli aumenti del capitale possono essere attuati, per deliberazione dell'assemblea dei soci ed anche mediante la

delega di cui agli art. 2420 ter e 2443 del Codice Civile, anche con offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 Nel rispetto delle norme attualmente vigenti, art. 11 D.L. 01.09.1993 n. 385 e delibera del C.I.C.R. n. 58/1994

(iscrizione a libro soci da almeno tre mesi e partecipazione pari o superiore al 2% del capitale sociale), la società può

116134

L

U X E M B O U R G

acquisire dai soci, in proporzione al valore nominale delle azioni possedute, versamenti in conto aumento capitale, in-
fruttiferi di interessi, ed aventi nel piano economico finanziario natura di acconti infruttiferi per detto aumento.

5.4 Quando le esigenze finanziarie della società lo rendono opportuno l'Organo Amministrativo può anche chiedere

ai soci, sempre nei limiti di quanto previsto dalle citate norme, un versamento temporaneo, con obbligo di restituzione,
in conto finanziamento per elasticità di cassa.

Detto  finanziamento  è  da  intendersi,  in  mancanza  di  diversa  pattuizione  scritta,  infruttifero  di  interessi,  ancorché

effettuato dai soci, o solo da una parte di essi, prescindendo dalla proporzionalità rispetto al valore nominale delle azioni
possedute.

5.5 La società riconosce socio soltanto colui che come tale risulti iscritto nel libro soci.
5.6 Ogni azione da diritto ad un voto.

Art. 6. Trasferimento delle azioni.
6.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:
a) di altri soci;
b) ai figli maschi dei soci;
c) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione

per l'acquisto.

6.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne

comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi
indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione,
fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono
esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio
offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta)
giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

6.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci

interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano
espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

6.5 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il

diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

6.6 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta

contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza

della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripe-
tizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella
denuntiatio.

6.7 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; ogni socio ha diritto di verificare il rispetto

delle condizioni che hanno caratterizzato la cessione.

6.8 Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non

siano soci o discendenti in linea retta ovvero che non siano il coniuge dell'azionista dante causa o altri possessori di azioni
dovranno essere, a cura dei chiamati all'eredità, offerte per l'acquisto a tutti i soci entro 60 giorni dalla data del decesso.

Si fa espresso riferimento ai precedenti comma per quanto riguarda le modalità che regolano l'offerta salvo in ogni

caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi 30 giorni da parte dei soci destinatari della stessa, l'erede

o il legatario acquista la qualità di socio.

Art. 7. Recesso.
7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazione riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso.

116135

L

U X E M B O U R G

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,

spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 23 del presente statuto (introduzione e sop-

pressione di clausole compromissorie).

7.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera

che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti
al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni

dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate

presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società

revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della

consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle
azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato ed i criteri utilizzati nella determinazione

nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.
Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla

determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta)
giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circo-
scrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349,
comma primo, c.c.

7.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle

azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla

base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 30 (trenta) giorni dalla determinazione definitiva

del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni
e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'ac-

quisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rim-

borsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357,
comma terzo c.c.

Qualora non via siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la

riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo

e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art. 8. Unico Socio.
8.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori,

ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o
della sede e cittadinanza dell'unico socio.

8.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione

per l'iscrizione nel registro delle imprese.

8.3 L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
8.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel libro dei

soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

116136

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Soggezione ad attività di controllo e direzione. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui

attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amminis-
tratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 10. Strumenti Finanziari.
10.1 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 Cod.Civ.
10.2 La società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, può emettere, con delibera

dell'Assemblea Straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso
comunque il voto dell'Assemblea generale degli azionisti.

Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito, salva la possibilità di documentare la titolarità e la

legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'Organo Amministrativo, non destinati alla circolazione e contenenti
le seguenti indicazioni: “Strumento Finanziario” Fatta eccezione per il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, ai titolari
degli strumenti finanziari spettano tutti gli altri diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti.

Ai fini dell'esercizio di tali diritti, ciascuno strumento finanziario è equiparato ad una azione.
10.3 I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Am-

ministrazione, ove nominato, e del Collegio Sindacale, mediante delibera della loro Assemblea Speciale.

10.4 Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa

costituzione in  mora,  è  sospeso  dall'esercizio  dei diritti  sociali.  Nei casi più gravi  egli può,  inoltre,  essere dichiarato
decaduto con deliberazione dell'Organo Amministrativo; in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono.

10.5 La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può costituire patrimoni destinati in via esclusiva ad uno

specifico affare.

Sempre previa delibera dell'assemblea straordinaria, la società può convenire che - nel contratto relativo al finanzia-

mento di uno specifico affare - al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati tutti o parte dei
proventi dell'affare stesso.

Art. 11. Domiciliazione.
11.1 Il domicilio dei soci e dei componenti gli Organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai

rispettivi libri sociali.

11.2 È onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nei libri sociali,

anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art. 12. Assemblea convocazione.
12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato e qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società, così come indicato dall'art. 2364 c.c.

Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima e devono

svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.

12.2 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
12.3 Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, e fino a quando

la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Organo Amministrativo potrà scegliere, alternativamente
o cumulativamente tra di loro, quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od

equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per

ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli Organi sociali.

12.4 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
12.5 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità

alle disposizioni di Legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 13. Svolgimento dell'assemblea.
13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso

di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più ammi-
nistratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta
dalla persona designata dagli intervenuti.

116137

L

U X E M B O U R G

13.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-

timazione  dei  presenti,  dirigere  e  regolare  lo  svolgimento  dell'assemblea  ed  accertare  e  proclamare  i  risultati  delle
votazioni.

13.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste

dall'articolo 14.

Art. 14. Principi disciplinanti riunioni in audio e/o video conferenza.
Le riunioni in audio e/o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio

e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 15. Deleghe.
15.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per

delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante
con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

15.2 E' ammessa la delega per fax e anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del

giorno.

15.3 La delega NON può essere rilasciata a dipendenti, ad amministratori, ai sindaci o al revisore.
15.4 Spetta al Presidente di verificare la regolarità delle deleghe.

Art. 16. Verbale dell'assemblea.
16.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nomi-

nato o dal Notaio.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

16.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli. Nel verbale

devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 17. Quorum costitutivi e deliberativi.
17.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-

sentino almeno la metà del capitale sociale.

17.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale

rappresentata in assemblea.

17.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

17.4 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più

della metà del capitale sociale.

17.5  In  seconda  convocazione  l'assemblea  straordinaria  è  validamente  costituita  con  l'intervento  di  tanti  soci  che

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere

inerenti:

a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
b. la trasformazione;
c. lo scioglimento anticipato;
d. la proroga della durata;
e. la revoca dello stato di liquidazione;
f. il trasferimento della sede sociale all'estero;

116138

L

U X E M B O U R G

g. l'emissione di azioni privilegiate.
17.6 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-

dono diverse specifiche maggioranze.

Art. 18. Amministratori - Durata - Revoca - Cessazione.
18.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina; c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

18.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure

l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

18.3 Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi e possono essere anche non soci.
18.4 NON si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod.Civ.
18.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo

Amministrativo è stato ricostituito.

18.6 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori

gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

18.7 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in

caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, cessa l'intero Consiglio.

Art. 19. Consiglio di Amministrazione.
19.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i

suoi membri un Presidente e può eleggere uno o più vice-Presidenti e consiglieri delegati ed un segretario.

19.2 Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi

componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni
contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 Cod.Civ. Non possono essere delegate le attribuzioni
indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod.Civ.

19.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo

circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e
devono entro 20 (venti) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina, i poteri di amministrazione possono essere

attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti
in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di
esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi

in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore

all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

19.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

Art. 20. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.
20.1 In caso di richiesta anche di un solo amministratore il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza

collegiale.

20.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

20.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza
e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché
l'ordine del giorno.

20.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato

membro dell'Unione Europea.

20.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e i revisori, se nominati.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza,

alle condizioni previste dall'art. 14.

20.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di

parità di votazione prevale il voto di chi presiede la seduta.

116139

L

U X E M B O U R G

20.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che

dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21. Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico,

sono investiti dei poteri di ordinaria amministrazione ed inoltre rimangono autorizzati a:

stipulare atti di acquisto, di vendita, di permuta e di affitto aventi durata non superiore a 9 anni - anche a mezzo di

locazione finanziaria - di beni mobili anche registrati, ivi compresa l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli stessi,
con la sola esclusione di ogni atto di disposizione di beni immobili;

richiedere l'apertura di c/c ivi compresa a richiesta di affidamenti bancari, anche sotto forma di prestiti su titoli compresa

l'assunzione di tutti i relativi obblighi ed impegni per linee di credito non superiori a Euro 250.000,00 per ogni Istituto di
Credito;

acquistare e vendere valori mobiliari e titoli di credito in genere escluse le partecipazioni costituenti immobilizzazioni

finanziarie (B III dello Stato Patrimoniale del bilancio) fino all'importo di Euro 500.000,00 per operazione e pagarne il
prezzo o esigerne il controvalore;

acquistare, vendere, permutare e sottoscrivere operazioni sul capitale di partecipazioni societarie costituenti immo-

bilizzazioni societarie purchè in misura non superiore al 20% del capitale sociale;

dare fideiussioni per forniture fino all'importo di Euro 50.000,00 per ogni singola operazione;
transigere e compromettere vertenze, anche attraverso arbitrati, per importi unitari non superiori a Euro 50.000,00

per ogni singola transazione.

Art. 22. Sanzioni per violazioni commesse dagli Amministratori. La società, in tutti i casi in cui ciò non sia vietato dalla

vigente normativa, e nei limiti consentiti, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 472/97 così come modificato dal
D.Lgs 5 giugno 1998 numero 203, assume nei rapporti interni la responsabilità per le violazioni commesse dagli ammi-
nistratori medesimi.

Art. 23. Rappresentanza sociale.
23.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente,
ed a quelle altre persone a cui l'Organo Amministrativo ritenga opportuno conferirLa ai sensi del precedente art. 19 e
nei limiti determinati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale

e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di
cui siano specificamente incaricati.

I rappresentanti della società faranno precedere alla propria firma la denominazione sociale e le rispettive qualifiche.
23.2 La firma e la rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei

poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 24. Compensi dell'organo amministrativo.
24.1 All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, l'Assemblea inoltre

potrà assegnare allo stesso un'indennità o un compenso in misura fissa, unica o periodica anche in misura diversa fra i
singoli componenti, oppure una percentuale degli utili del bilancio, nonché un'indennità di fine rapporto.

24.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano investiti di particolari cariche (Presidente, Vice-Presidente,

Amministratori Delegati ecc.) spetta il rimborso di tutte le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile - qualora non

vi abbia già provveduto l'assemblea - un ulteriore compenso, con eventuale indennità di fine rapporto, in relazione alle
funzioni svolte ed alle deleghe e responsabilità agli stessi attribuite.

24.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri/amministratori delegati, la ripartizione del loro com-

penso è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 25. Collegio Sindacale e controllo contabile.
25.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amminis-

trazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, ogni qualvolta non sia nominato un revisore
contabile e siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2409-bis.

25.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente

e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.
La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente

più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

116140

L

U X E M B O U R G

25.3 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei sindaci componenti il Collegio.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi audio-video collegati, nel rispetto delle modalità di cui all'art.

10 del presente statuto.

25.4 Nei casi previsti dalla Legge o per decisione dei soci viene nominato un revisore contabile.
Il revisore, o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale

e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture

contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
25.5 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico,

che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui

all'articolo 2409-quinquies c.c.; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina

di un nuovo revisore. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale
e sono rieleggibili.

Art. 26. Bilancio e utili.
26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.
26.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di Legge.
26.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione
da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

26.4 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo.
26.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore

della società.

Art. 27. Scioglimento e liquidazione. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è

disciplinata dagli articoli 2484 e seguenti del c.c.

Art. 28. Clausola compromissoria.
28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente
dell'Ordine dei Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici)
giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine
previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.
28.2 L'Organo arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina; esso deciderà in via rituale secondo

equità.

28.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Organo arbitrale vincoleranno

le parti.

28.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Organo arbitrale.
28.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

28.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 29. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge

in materia.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à l'administrateur en Italie Monsieur Zanetti

Paolo, prénommé avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l'effet d'accomplir individuellement toutes les
formalités administratives prévues par la loi italienne et nécessaires à l'inscription de la société à Bergamo, de signer tous
actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

116141

L

U X E M B O U R G

<i>Neuvième résolution

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société par les autorités ita-

liennes compétentes.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Luisella MORESCHI, de Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences

économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition
suspensive.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide que tous les documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés

pendant un période de cinq ans à l'ancien siège de la société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, K. ROTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juin 2011. Relation: LAC/2011/27896. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2011.

Référence de publication: 2011108876/552.
(110123568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2011.

ProLogis European Holdings IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.847.

<i>Rectification du dépôt No L110053400.04 du 05/04/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116896/15.
(110133544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.891.

<i>Rectification du dépôt No L110053396.04 du 05/04/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gerant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116897/15.
(110133547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

116142

L

U X E M B O U R G

ProLogis European Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 85.899.

<i>Rectificatif du dépôt No L110068931.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116898/15.
(110133761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.137.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116899/14.
(110133851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 69.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116900/14.
(110133846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France XVI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 72.783.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

116143

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116901/14.
(110133850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France XX S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 78.057.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116902/14.
(110133852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

TPL Bad Aibling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.125,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.065.

In the year two thousand and eleven, the fifth day of August, before M 

e

 Martine Schaeffer, notary residing in Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 21 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 159.866 (Brack),

hereby represented by Danielle Schroeder, company manager, residing professionally in Luxembourg, in her capacity

as authorised representative of the Company,

AND,
MRS. HELI OLAMI, born on March 27, 1970, domiciled at 5 

th

 Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat-gan, Israël,

hereby represented by Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal ,

being all the shareholders (the Shareholders) of TPL BAD AIBLING S.À R.L., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) under the laws of Luxembourg, having its registered office at 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 123.065 and having a share
capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company has been incorporated by a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 15, 2006 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N°-275 of March 1, 2007. The articles of association of the Company have been
amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated June 19,
2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°-1787 of August 23, 2007.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the agenda of the meeting is worded as

follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of two classes of shares in the share capital of the Company namely (i) class A shares (the Class A Shares)

and (ii) class B shares (the Class B Shares), all having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each;

3. Conversion of the 500 existing shares in the share capital of the Company into Class A Shares;

116144

L

U X E M B O U R G

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of six hundred twenty-five euro (EUR 625.-) in order

to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
represented by five hundred (500) Class A Shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to thirteen
thousand one hundred twentyfive euro (EUR 13,125.-) by way of the creation and issuance of twenty-five (25) new Class
A Shares, having a par value of twentyfive euro (EUR 25.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares;

5. Subscription to and payment of the newly issued shares as specified under item 4. above by a contribution in kind,

the remaining amount to be affected to the Class A share premium account of the Company;

6. Subsequent amendment to article 8. and article 19. of the articles of association of the Company (the Articles) in

order to reflect the creation of new classes of shares adopted under item 2. above and the increase of the share capital
specified under item 4.;

7. Amendment to articles 16 and 17 of the Articles, so that the financial year of the Company shall begin on January

1 of any calendar year and shall end on December 31 of the same calendar year;

8. Modification of the current financial year of the Company, having started on October 1, 2010, to be closed on

December 31, 2010 instead of September 30, 2011;

9. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

10. Miscellaneous.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that they have unanimously taken the following

resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened

and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to create two classes of shares in the share capital of the Company namely (i) class A shares

(the Class A Shares) and (ii) class B shares (the Class B Shares), all having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25)
each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to convert the five hundred (500) existing shares in the share capital of the Company into

Class A Shares.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred twenty-five euro

(EUR 625.-)

in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) Class A Shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each,

to thirteen thousand one hundred twenty-five euro (EUR 13,125.-)
by way of the creation and issuance of twenty-five (25) new Class A Shares of the Company, having a par value of

twenty-five euro (EUR 25.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L., represented as stated above, declares to subscribe to twenty-three (23) new

Class A Shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and to fully pay up such shares by a contribution
in kind consisting of a receivable in an amount of one million six hundred twenty-four thousand one hundred twenty-
three euro (EUR 1,624,123.-) that it has against the Company (the Brack Receivable).

The contribution of the Brack Receivable in an aggregate amount of one million six hundred twenty-four thousand

one hundred twenty-three euro (EUR 1,624,123.-) is allocated as follows:

(i) an amount of five hundred seventy-five euro (EUR 575.-) is allocated to the nominal share capital account of the

Company; and

(ii) an amount of one million six hundred twenty-three thousand five hundred forty-eight euro (EUR 1,623,548.-) is

allocated to the share premium account attached to the Class A Shares of the Company.

The valuation of the Brack Receivable is evidenced by inter alia (i) an interim balance sheet of the Company dated as

of June 30, 2011 and signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued August 2, 2011
by the management of Brack and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such
certificate that:

116145

L

U X E M B O U R G

“Brack is the legal owner of the Brack Receivable. Brack is solely entitled to and possesses the power to dispose of

the Brack Receivable;

- the Brack Receivable is freely transferable and it is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or

lien limiting their transferability or reducing its value;

- all formalities to transfer the legal ownership of the Brack Receivable contributed to the Company have been or will

be accomplished by Brack;

- the outstanding amount payable by the Company under the Brack Receivable corresponds to its nominal value of

one million six hundred twenty-four thousand one hundred twenty-three euro (EUR 1,624,123.-), as shown in the interim
balance sheet of the Company dated as of June 30, 2011. Since the date of the interim balance sheet there have been no
changes to this outstanding amount. The Company being the debtor of the Brack Receivable, the management proposes
to contribute the Brack Receivable into the Company's equity for a contribution value equal to its nominal value of one
million six hundred twenty-four thousand one hundred twenty-three euro (EUR 1,624,123.-); and

- upon contribution of the Brack Receivable to the Company, the Brack Receivable will be extinguished by way of

confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.” MRS. HELI OLAMI
represented as stated above, declares to subscribe to two (2) new Class A Shares having a par value of twenty-five euro
(EUR 25.-) each and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one
hundred forty-one thousand two hundred fifty euro (EUR 141,250.-) that she has against the Company (the Olami Re-
ceivable).

The contribution of the Olami Receivable in an aggregate amount of one hundred forty-one thousand two hundred

fifty euro (EUR 141,250.-) is allocated as follows:

(i) an amount of fifty euro (EUR 50) is allocated to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) an amount of one hundred forty-one thousand two hundred euro (EUR 141,200.-) is allocated to the share premium

account attached to the Class A Shares of the Company.

The valuation of the Olami Receivable is evidenced by inter alia, (i) an interim balance sheet of the Company dated as

of June 30, 2011 and signed for approval by the management of the Company and (ii) a certificate issued on July 25, 2011
by Mrs. Heli Olami and acknowledged and approved by the management of the Company. It results from such certificate
that:

“Mrs. Heli Olami is the legal owner of the Olami Receivable. Mrs. Heli Olami is solely entitled to and possesses the

power to dispose of the Olami Receivable;

- the Olami Receivable is freely transferable and it is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge

or lien limiting their transferability or reducing its value;

- all formalities to transfer the legal ownership of the Olami Receivable contributed to the Company have been or will

be accomplished by Mrs. Heli Olami;

- The outstanding amount payable by the Company under the Olami Receivable corresponds to its nominal value of

one hundred forty-one thousand two hundred fifty euro (EUR 141,250.-), as shown in the interim balance sheet of the
Company dated as of June 30, 2011. Since the date of the interim balance sheet there have been no changes to this
outstanding amount. The Company being the debtor of the Olami Receivable, Mrs. Heli Olami proposes to contribute
the Olami Receivable into the Company's equity for a contribution value equal to its nominal value of one hundred forty-
one thousand two hundred fifty euro (EUR 141,250.-); and

- upon contribution of the Olami Receivable to the Company, the Olami Receivable will be extinguished by way of

confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.”

Such certificates and a copy of the interim balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing

parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in the share

capital, as follows:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Class A Shares
MRS. HELI OLAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 Class A Shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Class A Shares

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend articles 8, 16, 17 and 19 of the

Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. The share capital of the Company is set at thirteen thousand one hundred twenty-five euro (EUR 13,125.-),

represented by five hundred twenty-five (525) class A shares in registered form, having a par value of twenty-five euros
(EUR 25.-) each (the Class A Shares) all subscribed and fully paid-up.

The share capital may be increased in one or several times by the issuance of Class A Shares or class B shares (the

Class B Shares and together with the Class A Shares, the “shares”).

116146

L

U X E M B O U R G

Each share premium amount paid with respect to the issuance of a class of shares in the share capital of the Company

shall be attached to such class of shares.

No distribution of any kind can be made on the Class A Shares before the share premium attached to the Class B

Shares (if any) is repaid in full.”

“ Art. 16. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 17. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of partners together with the balance sheet.”

“ Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

Subject to the provisions of article 8 above, the balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve, as a consequence of the modification of article 16 referred to herein above, that the next

Company's financial year starting on October 1, 2011, will end on December 31, 2011.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the newly issued class A shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 3000.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

En l'an deux mille onze, le cinquième jour du mois d'août, par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence

à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège

social est situé au 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.866 (Brack),

ici représentée par Danielle Schroeder, administratrice de société, résidant professionnellement à Luxembourg, en

tant que mandataire de la Société valablement autorisé,

ET
Mme HELI OLAMI, née le 27 mars 1970, domiciliée au 5 

th

 Tnu'at Hameri Street, 52325 Ramat-gan, Israël,

ici représentée par Vanessa Schmitt, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé,

116147

L

U X E M B O U R G

en tant qu'associés (les Associés) de TPL BAD AIBLING S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois dont le siège social est situé au 21, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.065 et disposant d'un capital social de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500) (la Société). La Société a été constituée par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, le 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 275 le 1 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 1787 le 23 août 2007.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires agissant pour le compte des parties compa-

rantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocations;
2. Création de deux catégories de parts sociales dans le capital de la Société, soit (i) des parts sociales de classe A (les

Parts Sociales de Classe A) et (ii) des parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), toutes d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

3. Conversion des 500 parts sociales existantes de la Société en Parts Sociales de Classe A;
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 625) afin de le porter

de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) Parts Sociales de
Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, à treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125)
par la création et l'émission de vingt-cinq (25) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

5. Souscription et libération des parts sociales nouvellement émises tel que mentionné au point 4. ci-dessus par un

apport en nature, le solde étant affecté au compte de prime d'émission Classe A de la Société;

6. Modification subséquente des articles 8. et 19. des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y faire figurer la création

de nouvelles catégories de parts sociales adoptée au point 2. ci-dessus et l'augmentation du capital social décrite au point
4.;

7. Modification des articles 16 et 17 des Statuts pour que l'exercice social de la Société débute le 1 janvier de chaque

année calendaire et prenne fin le 31 décembre de la même année calendaire;

8. Modification de l'actuel exercice social de la Société qui a débuté le 1 octobre 2010 pour qu'il prenne fin le 31

décembre 2010 au lieu du 30 septembre 2011;

9. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

10. Divers.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'ils ont pris les décisions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, les associés de la Société ayant été valablement

convoqués et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de créer deux catégories de parts sociales dans le capital de la Société, soit (i) des parts sociales

de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et (ii) des parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), toutes
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de convertir les cinq cents (500) parts sociales existantes dans le capital social de la Société en

Parts Sociales de Classe A.

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 625)
afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500)

Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune,

à treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125)
par la création et l'émission de vingt-cinq (25) nouvelles Parts Sociales de Classe A de la Société d'une valeur nominale

de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

116148

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Libération

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-trois (23)

nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et les libère intégra-
lement par un apport en nature qui se compose d'une créance d'un montant de un million six cent vingt-quatre mille cent
vingt-trois euros (EUR 1.624.123) qu'elle détient envers la Société (la Créance Brack).

L'apport de la Créance Brack d'un montant total de un million six cent vingt-quatre mille cent vingt-trois euros (EUR

1.624.123) est affecté de la manière suivante:

(i) un montant de cinq cent soixante-quinze euros (EUR 575) au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de un million six cent vingt-trois mille cinq cent quarante-huit euros (EUR 1.623.548) au compte de

prime d'émission lié au Parts Sociales de Classe A de la Société.

L'évaluation de la Créance Brack est certifiée entre autre par (i) un bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin

2011 et signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis le 2 août 2011 par la gérance de
Brack, reconnu et approuvé par la gérance de la Société. Il ressort dudit certificat que:

«- Brack est le seul propriétaire de la Créance Brack. Brack est le seul ayant droit à la Créance Brack et a le droit d'en

disposer.

- la Créance Brack est librement cessible, elle n'est soumise à aucune restriction ni grevée d'aucun nantissement ou

privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur;

- toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété de la Créance Brack apportée à la Société ont été ou

seront accomplies par Brack;

- le solde dû par la Société selon la Créance Brack correspond à sa valeur nominale de un million six cent vingt-quatre

mille cent vingt-trois euros (EUR 1.624.123) comme démontré dans le bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin
2011. Depuis la date du bilan intérimaire, aucune modification n'a été apportée à ce solde. La Société étant le débiteur
de la Créance Brack, la gérance propose d'apporter au capital de la Société la Créance Brack dont la valeur d'apport
correspond à sa valeur nominale de un million six cent vingt-quatre mille cent vingt-trois euros (EUR 1.624.123); et

- dès l'apport de la Créance Brack à la Société, la Créance Brack sera éteinte par voie de confusion conformément à

l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.» Mme HELI OLAMI, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire
à deux (2) nouvelles Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et les libère
par un apport en nature se composant d'une créance d'un montant de cent quatre-et-un mille deux cent cinquante euros
(EUR 141.250) qu'elle détient envers la Société (la Créance Olami).

L'apport de la Créance Olami d'un montant total de cent quatre-et-un mille deux cent cinquante euros (EUR 141.250)

est affecté de la manière suivante:

(i) un montant de cinquante euros (EUR 50) au compte de capital social de la Société; et
(ii) un montant de cent quatre-et-un mille deux cents euros (EUR 141.200) au compte de prime d'émission lié au Parts

Sociales de Classe A de la Société.

L'évaluation de la Créance Olami est certifiée entre autre par (i) un bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin

2011 et signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat émis le 25 juillet 2011 par Mme Olami,
reconnu et approuvé par la gérance de la Société. Il ressort dudit certificat que:

«- Mme Olami est la seule propriétaire de la Créance Olami. Mme Olami est le seul ayant droit à la Créance Olami

et a le droit d'en disposer.

- la Créance Olami est librement cessible, elle n'est soumise à aucune restriction ni grevée d'aucun nantissement ou

privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur;

- toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété de la Créance Olami apportée à la Société ont été ou

seront accomplies par Mme Olami;

- le solde dû par la Société selon la Créance Olami correspond à sa valeur nominale de cent quarante et un mille deux

cent cinquante euros (EUR 141.250) comme démontré dans le bilan intérimaire de la Société en date du 30 juin 2011.
Depuis la date du bilan intérimaire, il n'y a eu aucune modification à ce solde. La Société étant le débiteur de la Créance
Olami, la gérance propose d'apporter au capital de la Société la Créance Olami dont la valeur d'apport correspond à sa
valeur nominale de cent quarante et un mille deux cent cinquante euros (EUR 141.250); et

- dès l'apport de la Créance Olami à la Société, la Créance Olami sera éteinte par voie de confusion conformément à

l'article 1300 du Code Civil luxembourgeois.»

Les certificats et la copie du bilan intérimaire, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties compa-

rantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les Associés décident d'enregistrer que la participation dans la Société après l'augmentation de capital est la suivante:

BRACK CAPITAL KAUFLAND S.À R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Parts Sociales de Classe A
Mme. HELI OLAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Parts Sociales de Classe A
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Parts Sociales de Classe A

116149

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

En conséquence des décisions qui précèdent, les Associés décident de modifier les articles 8, 16, 17 et 19 des Statuts

de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social est fixé à treize mille cent vingt-cinq euros (EUR 13.125), représenté par cinq cent vingt-cinq

(525) parts sociales de Classe A sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune
(les Parts Sociales de Classe A) toutes souscrites et entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté à une ou plusieurs reprises par l'émission de Parts Sociales de Classe A ou de

parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B et avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales).

Chaque prime d'émission payée en rapport avec l'émission d'une catégorie spécifique de parts sociales dans le capital

social de la Société sera liée à ladite catégorie de parts sociales.

Aucune distribution de quelque nature ne sera effectuée sur les Parts Sociales de Classe A avant que la prime d'émission

liée au Parts Sociales de Classe B (le cas échéant) ne soit entièrement remboursée.»

« Art. 16. L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale avec

le bilan.»

« Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, le solde est à la disposition des associés.
Les Associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur base de relevés de comptes établis par les

gérants montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer
ne peut être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à la réserve prévue par la loi ou par
les présents statuts.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.»

<i>Sixième résolution

Les associés décident, suite à la modification de l'article 16 dont question ci-dessus, que le prochain exercice social,

commençant le 1 

er

 octobre 2011, se terminera le 31 décembre 2011.

<i>Septième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder, pour le
compte de la Société, à l'inscription des parts sociales de classe A nouvellement émises dans le registre des associés de
la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ EUR 3000.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec

le notaire, le présent acte original.

Signé: D. Schroeder, V. Schmitt et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 août 2011. LAC/2011/36051. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

116150

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2011.

Référence de publication: 2011116146/361.
(110133243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2011.

ProLogis France XXIX S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 80.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116903/14.
(110133774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France XXXIV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116905/14.
(110133772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis France XXXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.123.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116906/14.
(110133855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Immolux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 144.690.

L'an deux mille onze, le dix-huit août.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).

116151

L

U X E M B O U R G

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «IMMOLUX HOLDING S.A.», ayant son

siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), constituée le 11 février 2009
par devant le Notaire soussigné, acte publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 504 du
7 mars 2009 (ci-après «la Société»).

L'Assemblée Générale était présidée par Me Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la

Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président a désigné comme secrétaire Me Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la

Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale a choisit comme scrutateur Me Emilie Querel, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue

de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social

libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire;
2. Décision de nommer Me Charles Duro aux fonctions de liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société Me Charles Duro, avocat, né le 5 juin 1958

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Cha-
pelle (Grand-Duché de Luxembourg) (“le Liquidateur”).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus

spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.

L'Assemblée  Générale,  entre  autre,  décide  et  reconnaît  que  la  Société  sera  engagée  envers  les  tiers  par  la  seule

signature du Liquidateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, E. Querel, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 août 2011. Relation: EAC/2011/11307. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118900/54.
(110136337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

116152

L

U X E M B O U R G

ProLogis Germany XII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.933.

<i>Rectificatif du dépôt No L110068969.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116907/15.
(110133766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Holdings X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.591.

<i>Rectification du dépôt No L110068968.04 du 05/05/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116918/15.
(110133557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

ProLogis European Holdings XI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.226.

<i>Rectification du dépôt No L110053383.04 du 05/04/2011

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2011.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representé par Gareth Alan Gregory
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116919/15.
(110133542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Quesse SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 134.325.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2008 tenue de manière extraordinaire

<i>à 8.45 heures le 6 mai 2011

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire

aux comptes, à savoir:

116153

L

U X E M B O U R G

<i>Administrateurs:

- Mme Bourkel Anique, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

<i>Administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

-  WILBUR  ASSOCIATES  LTD,  Union  Court  Building,  Elizabeth  Avenue  &amp;  Shirley  Street  S-E2,  Nassau,  Bahamas,

N-8188, IBC 185200;

qui tous acceptent, pour l'année 2009 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Référence de publication: 2011116924/22.
(110133686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Quesse SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 134.325.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2009 tenue de manière extraordinaire

<i>à 9.45 heures le 6 mai 2011

<i>Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire

aux comptes, à savoir:

<i>Administrateurs:

- Mme Bourkel Anique, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Vancheri Alexandre, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

<i>Administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, adresse professionnelle au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

-  WILBUR  ASSOCIATES  LTD,  Union  Court  Building,  Elizabeth  Avenue  &amp;  Shirley  Street  S-E2,  Nassau,  Bahamas,

N-8188, IBC 185200;

qui tous acceptent, pour l'année 2010 et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Référence de publication: 2011116925/22.
(110133687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

SF (Lux) Sicav 3, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.252.

Les comptes annuels au 31 Mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SF (Lux) SICAV 3
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Peter Sasse / Benjamin Wacker
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2011116933/13.
(110133732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

J.L.T. SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 3, rue de St Hubert.

R.C.S. Luxembourg E 1.833.

L'an deux mil onze, le huit août.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

116154

L

U X E M B O U R G

A comparu:

1. Monsieur Jean-Louis THILL, chargé de cours, demeurant à L-1744 Luxembourg, 3, rue de St Hubert, agissant tant

en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de:

2. Monsieur Fernand Thill, ingénieur diplômé, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 10, rue de la Ferme,
3. Monsieur Daniel Maisch, employé privé, demeurant à L-8081 Bertrange, 38, rue de Mamer, et de
4. Monsieur Nico KARWATZKI, employé privé, demeurant à L-1744 Luxembourg, 3, rue de St Hubert,
en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles après avoir été signées ne varietur par le notaire et le comparant,

resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

Le comparant, après avoir établi qu'avec ses mandants sub 2. et 3. ils détiennent ensemble toutes les 100 parts de la

société civile immobilière J.L.T. SCI, dont le siège est à L-2550 Luxembourg, 114, avenue du X septembre,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, en date du 18

juin 1999, publié au Mémorial C numéro 664 du 02 septembre 1999, immatriculée au R.C.S.L. sous le numéro E 1.833,

et après avoir déclaré que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire actée par Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 19 décembre 2001,
comportant cession de parts sociales et publié au Mémorial C numéro 602 du 18 avril 2002, s'est constitué en assemblée
générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes, prises à l'unanimité:

<i>Cessions de parts sociales

Monsieur Fernand THILL, préqualifié, cède et transporte à Monsieur Nico KARWATZKI, préqualifié et pour lequel

accepte son mandataire Monsieur Jean-Louis THILL, la pleine propriété d'une part de la société civile immobilière J.L.T.
SCI.

Monsieur Daniel MAISCH, préqualifié, cède et transporte à Monsieur Nico KARWATZKI, préqualifié et pour lequel

accepte son mandataire Monsieur Jean-Louis THILL, la pleine propriété d'une part de la société civile immobilière J.L.T.
SCI.

Monsieur Jean-Louis THILL, ici présent, cède et transporte à Monsieur Nico KARWATZKI, préqualifié et pour lequel

il accepte en sa qualité de mandataire, la pleine propriété de vingt-trois (23) parts de la société civile immobilière J.L.T.
SCI.

Les modalités des cessions ci-dessus reprises ont été réglées avant la passation des présentes, hors la vue, la présence

et la comptabilité du notaire instrumentaire.

Le cessionnaire Monsieur Nico KARWATZKI sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit

aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.

L‘associé Monsieur Jean-Louis Thill déclare accepter Monsieur Nico KARWATZKI comme nouveau associé de la

société civile immobilière J.L.T. SCI.

Monsieur Jean-Louis THILL déclare avoir renoncé à son droit de préemption sur les parts cédées.

<i>Modification statutaire

En conformité des cessions ci-dessus, les associés Messieurs Jean-Louis THILL, présent, et Nico KARWATZKI, re-

présenté comme dit-ci-avant, modifient l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

„ Art. 5. Le capital social est fixé à 2.478,9352,- € (deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule neuf mille trois cent

cinquante-deux euros) divisé en 100 parts de 24,789352 € chacune, toutes entièrement libérées en espèces et souscrites
comme suit:

- Monsieur Jean-Louis THILL, chargé de cours, demeurant à Luxembourg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 parts sociales
- Monsieur Nico KARWATZKI, employé privé, demeurant à Luxembourg: . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts socia-

les"

<i>Transfert de siège

Puis les associés ont décidé de transférer le siège de la société à L-1744 Luxembourg, 3, rue de St Hubert.

<i>Acceptation du gérant

Monsieur Jean-Louis Thill, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique, déclare accepter pour compte de la

société tant le transfert du siège social que les prédites cessions de parts conformément à l'article 1690 du code civil, et
déclare dispenser le cessionnaire de les faire signifier à la société par voie d'huissier et n'avoir entre ses mains aucune
opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.L. THILL, C. MINES.

116155

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Capellen, le 9 août 2011. Relation: CAP/2011/3052. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 12 août 2011.

Référence de publication: 2011116533/67.
(110133784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Tecsom Eurl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 87.544.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1 

<i>er

<i> juin 2011

<i>Résolution n°1

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide le transfert du siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, rue du Fossé, 3, à

compter du 1 

er

 juin 2011.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 juin 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire CGS
Signature

Référence de publication: 2011116944/16.
(110133619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

UBS SIF Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.138.

Mandat non renouvelé avec effet au 1 

er

 août 2011:

- Hermann Kranz.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS SIF Management Company S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Mathias Welter / Peter Sasse
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2011116949/14.
(110133725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

Uliza Finance &amp; Co S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 74.552.

CLÔTURE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a
déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société ULIZA FINANCE &amp; CO S.A., dont le siège
social à L-1650 Luxembourg, 6, Avenue Guillaume, a été dénoncé en date du 13 juillet 2006. Ce même jugement a mis
les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Marie-Laure CARAT
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011116950/15.
(110133717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

116156

L

U X E M B O U R G

Varialux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 146.652.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Antoine Clauzel
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116951/11.
(110133767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 116.639.

Les comptes annuels au 31 Mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Antoine Clauzel
<i>Gérant

Référence de publication: 2011116962/11.
(110133765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

LSREF Summer Loans, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 230.375,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.682.

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of August.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

LSREF Summer Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under

the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  147.684,  represented  by  Mr  Philippe  Jusseau,  (the  Sole
Shareholder),

here represented by Ms Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney, given in Luxembourg on 5 August 2011,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF

Summer Loans S.à r.l. (the Company), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established
under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147.682,
incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 6 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations CN° 1766 of 12 September 2009, that has been amended several times and for the last time
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 8 July 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that

it may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 232,250 (two hundred thirty-

two thousand two hundred and fifty euro) by an amount of EUR 1,875 (one thousand eight hundred and seventy-five
euro) to an amount of EUR 230,375 (two hundred thirty thousand three hundred and seventy-five euro) via the cancel-
lation of 15 (fifteen) ordinary shares, having a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each;

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and

116157

L

U X E M B O U R G

3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR 232,250

(two hundred thirty-two thousand two hundred and fifty euro), represented by 1,858 (one thousand eight hundred fifty-
eight) ordinary shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each,

by an amount of EUR 1,875 (one thousand eight hundred and seventy-five euro)
to an amount of EUR 230,375 (two hundred thirty thousand three hundred and seventy-five euro), represented by

1,843 (one thousand eight hundred forty-three) ordinary shares with a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-
five euro) each,

via the cancellation of 15 (fifteen) ordinary shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro)

each, and to reimburse to the Sole Shareholder the said amount of EUR 1,875 (one thousand eight hundred and seventy-
five euro).

As a consequence of the share capital reduction, the Sole Shareholder holds 1,843 (one thousand eight hundred forty-

three) ordinary shares.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association

of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 230,375 (two hundred thirty thousand three hundred

and seventy-five euro), represented by 1,843 (one thousand eight hundred forty-three) ordinary shares with a nominal
value of EUR 125 (one hundred twenty-five euro) each."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy Luxem-
bourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the
Company and to see to any formalities in connection therewith.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le huit août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

LSREF Summer Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 147.684, représentée par M. Philippe Jusseau, (l'Associé Unique),

ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg le 5 août 2011,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée LSREF Summer Loans S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.682, constituée
selon acte de Maître Martine Schaeffer du 6 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C -
N° 1766 du 12 septembre 2009, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu selon acte de Maître Martine Schaeffer du
8 juillet 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

116158

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Réduction de capital de la Société de son montant actuel de EUR 232.250 (deux cent trente-deux mille deux cent

cinquante euros) par un montant de EUR 1.875 (mille huit cent soixante-quinze euros), pour le porter à un montant de
EUR 230.375 (deux cent trente mille trois cent soixante-quinze euros) par voie d'annulation de 15 (quinze) parts sociales
ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune;

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou employé d’Allen &amp; Overy Luxembourg, afin
d’effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l’enregistrement des parts sociales
annulées dans le registre de parts sociales de la Société.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société par un montant de 1.875 (mille huit cent soixante-

quinze)

pour le porter de son montant actuel de EUR 232.250 (deux cent trente-deux mille deux cent cinquante euros),

représenté par 1.858 (mille huit cent cinquante-huit) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125
(cent vingt-cinq euros) chacune,

à un montant de EUR 230.375 (deux cent trente mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 1.843 (mille

huit cent quarante-trois) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune,

par voie d'annulation de 15 (quinze) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq

euros) chacune, et de rembourser ce montant de 1.875 (mille huit cent soixante-quinze) à l'Associé Unique.

Suite à cette réduction de capital, l'Associé Unique détient 1.843 (mille huit cent quarante-trois) parts sociales ordi-

naires émises par la Société.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version

française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 230.375 (deux cent trente mille trois cent soixante-

quinze euros), représenté par 1.843 (mille huit cent quarante-trois) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale
de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy
Luxembourg, afin d'effectuer pour le compte de la Société l’enregistrement des parts sociales annulées dans le registre
de parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 août 2011. LAC/2011/36181. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2011.

Référence de publication: 2011116579/135.
(110133605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

116159

L

U X E M B O U R G

ArtisTantra Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8606 Bettborn, 6, rue de Reimberg.

R.C.S. Luxembourg B 145.358.

<i>Extrait de la convention

<i>de cession de parts du 21/07/2011

<i>Résolution

Monsieur MERTENS Alexis, né le 10/10/1982 à Uccle, résidant professionnellement à L-8606 BETTBORN, 6, rue de

Reimberg cède à Monsieur THILL Michaël, né le 25/02/1970 à Arlon, résidant professionnellement à L-8606 BETTBORN,
6, rue de Reimberg, 5 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Artis Tantra.

La présente cession est réalisée pour un montant de EUR cinq cents (500,- euros) que le cédant déclare avoir reçus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFC Benelux Sàrl
Signature

Référence de publication: 2011116974/17.
(110134164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

ACMO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 140.857.

<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique prises en date du 27 juillet 2011

L'Associé unique de ACMO S.à r.l. (la "Société") a décidé comme suit:
- de nommer Damien Nussbaum, né le 8 octobre 1972 à Strasbourg, France, ayant son adresse professionnelle au 2-8

Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Gérant B et ce avec effet au 27 juillet 2011 et pour une durée indéter-
minée.

Luxembourg, le 17 août 2011.

Saphia Boudjani.

Référence de publication: 2011116975/13.
(110134754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

Ayala, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.418.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011117001/14.
(110134730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

KD Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 143.480.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011117163/9.
(110134519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116160


Document Outline

3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l.

ACMO S.à r.l.

ArtisTantra Sàrl

Ayala

Immolux Holding S.A.

J.L.T. SCI

KD Europe S.à r.l.

Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l.

LSREF Summer Loans, S.à r.l.

Maiola International S.A.

Performance Partner S.à r.l.

Photo Invest S.A.

Power Systems S.A.

Premium Car Concept S.à r.l.

ProLogis European Developments Holding S.à r.l.

ProLogis European Finance II S.àr.l.

ProLogis European Finance VI S.à r.l.

ProLogis European Finance XIII S.à r.l.

ProLogis European Finance XII S.àr.l.

ProLogis European Finance XI S.àr.l.

ProLogis European Finance XV S.à r.l.

ProLogis European Holdings II S.à r.l.

ProLogis European Holdings IV S.à r.l.

ProLogis European Holdings S.à r.l.

ProLogis European Holdings VI S.à r.l.

ProLogis European Holdings XI S.àr.l.

ProLogis European Holdings X S.à r.l.

ProLogis France IX S.à r.l.

ProLogis France V S.à r.l.

ProLogis France XVI S.àr.l.

ProLogis France XXIX S.àr.l.

ProLogis France XX S.à.r.l.

ProLogis France XXXIII S.à r.l.

ProLogis France XXXIV S.àr.l.

ProLogis France XXXVIII S.à r.l.

ProLogis Germany XII S.àr.l.

ProLogis Spain VII S.àr.l.

ProLogis Spain VI S.à.r.l.

Quesse SA

Quesse SA

SF (Lux) Sicav 3

Société Générale Bank &amp; Trust

Société Générale Bank &amp; Trust

Tecsom Eurl

TPL Bad Aibling S.à r.l.

UBS SIF Management Company S.A.

Uliza Finance &amp; Co S.A.

Varialux S.A.