This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2237
22 septembre 2011
SOMMAIRE
Aberdeen Property Investors (General
Partner) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107348
Aberdeen Property Nordic Finance Swe-
den S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107351
Aberdeen Real Estate Holding Company
Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107370
ABH Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107371
Altafinance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107370
BJS Holdings 2 SNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107351
Capellen Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107375
Co-Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107376
DH Salisbury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107367
Fidelity International Real Estate Fund
Company 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107330
Fidelity International Real Estate Fund
Company 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107332
Fidelity International Real Estate Fund
Company 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107334
Fidelity International Real Estate Fund
Company 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107336
Fidelity International Real Estate Fund
Company 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107338
Fidelity International Real Estate Fund
Company 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107340
Fidelity International Real Estate Fund
Company 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107342
Fidelity International Real Estate Fund
Company 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107344
Fidelity International Real Estate Fund
Company 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107346
Fondation des Amis des Musées d'Art et
d'Histoire, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
107372
g b a fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107349
Jose Manuel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107348
Kellogg Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107348
Kellogg Lux III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107349
Kellogg Lux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107349
Kellogg Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107349
Kellogg Lux VI S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107350
Kellogg Lux V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107350
L14 Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
107356
Labalma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107351
Larus Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107351
LeasePlan Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
107350
Le Petit Manoir S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107356
LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107356
LSREF Lux Japan Investments V S.à r.l. . .
107356
Lubrizol Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
107350
Lux Euro-Asian Investments I S.à r.l. . . . . .
107351
Matthews Global Investors S.àr.l. . . . . . . . .
107366
Mawi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107367
Mayroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107371
Mediaxim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107371
Melchior CDO I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107367
Metimmo SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107373
Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107374
NTC Holding G.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107374
NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. . . . . . . . . .
107374
Org & It Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
107366
Ouriense S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107374
Parker Hannifin Partnership S.C.S. . . . . . .
107352
Pic'Art S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107376
Piquet, Price & Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
107376
Piquet, Price & Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
107376
Polar Windows S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107375
Rembrandt III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107357
Rembrandt V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107371
TPG TM V, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107372
Venezuela Cable Service Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107357
Woolpas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107375
107329
L
U X E M B O U R G
Fidelity International Real Estate Fund Company 10, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 135.059.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "Fidelity International Real Fund Company 10",
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by deed of the undersigned
notary on 10 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 297 of 5 February
2008.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. - The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II. - As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III. - That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
107330
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 10», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 297 du 5 février 2008.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. - Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23278. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
107331
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114597/105.
(110131674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 11, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 135.060.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "Fidelity International Real Fund Company 11",
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by deed of the undersigned
notary on 10 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 298 of 5 February
2008.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. - The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II. - As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III. - That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
107332
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 11», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 298 du 5 février 2008.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. - Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
107333
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23279. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114598/105.
(110131677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 13, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 139.953.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "Fidelity International Real Fund Company 13",
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by deed of the undersigned
notary on 30 June 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1855 of 29 July 2008.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. - The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II. - As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III. - That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
107334
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 13», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1855 du 29 juillet 2008.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. - Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
107335
L
U X E M B O U R G
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23280. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114599/104.
(110131681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 14, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 140.070.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "Fidelity International Real Fund Company 14",
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by deed of the undersigned
notary on 30 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1890 of 31 July 2008.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. - The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II. - As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III. - That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
" Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
107336
L
U X E M B O U R G
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 14», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1890 du 31 juillet 2008.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. - Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
107337
L
U X E M B O U R G
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23282. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114600/104.
(110131682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 15, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 140.071.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Fidelity International Real Fund Company 15”,
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by deed of the undersigned
notary on 30 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1893 of 1 August
2008.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II.- As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
107338
L
U X E M B O U R G
“ Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 15», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1893 du 1
er
août 2008.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
107339
L
U X E M B O U R G
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23283. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114601/105.
(110131683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 16, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 153.602.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Fidelity International Real Fund Company 16”,
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by notarial deed on 1 June
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1482 of 20 July 2010.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II.- As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ Art. 16 Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year.”
107340
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 16», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte notarié en date du 1
er
juin 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1482
du 20 juillet 2010.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
107341
L
U X E M B O U R G
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23284. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114602/104.
(110131684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 17, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 153.603.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Fidelity International Real Fund Company 17”,
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by notarial deed on 1 June
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1482 of 20 July 2010.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II.- As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
107342
L
U X E M B O U R G
“ Art. 16 Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 17», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte notarié en date du 1
er
juin 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1482
du 20 juillet 2010.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
107343
L
U X E M B O U R G
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23285. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114603/104.
(110131686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 18, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 153.604.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Fidelity International Real Fund Company 18”,
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by notarial deed on 1 June
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1484 of 20 July 2010.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II.- As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
107344
L
U X E M B O U R G
“ Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 18», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte notarié en date du 1
er
juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1484
du 20 juillet 2010.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
107345
L
U X E M B O U R G
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23286. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114604/104.
(110131687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Fidelity International Real Estate Fund Company 19, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 153.605.
In the year two thousand and eleven, on the eleventh day of May.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “Fidelity International Real Fund Company 19”,
having its registered office at L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, incorporated by notarial deed on 1 June
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1484 of 20 July 2010.
The Meeting is presided over by Mr. Claude HELLERS, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Elena DYACHUK, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. Lionel FANTAUZZO, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II.- As appears from the attendance list, all FIFTEEN THOUSAND (15,000) shares representing the whole capital of
the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1) Change to the financial year so that it shall begin the 1
st
July and shall finish the 30
th
June of the following year.
2) Amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:
"The Company's year starts on the 1 July of each year and ends on 30 June of each year."
3) Amendment of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality
of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office."
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to modify the Company's current financial year so that it will henceforth run from 1
st
of July
and shall end on 30
th
of June of the following year.
The current year that has begun June 1
st
, 2010 will terminate on 30
th
June 2011.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 16 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
107346
L
U X E M B O U R G
“ Art. 16 Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of each year.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend Article 17 of the articles of incorporation so as to henceforth read as follows:
“ Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.”
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the person appearing and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by surname, first
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «Fidelity In-
ternational Real Estate Fund Company 19», avec siège social à L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, constituée
suivant acte notarié en date du 1
er
juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1484
du 20 juillet 2010.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude HELLERS, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Elena DYACHUK, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel FANTAUZZO, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que les QUINZE MILLE (15.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1) Changement de l'année sociale pour qu'elle commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2) Modification de l'article 16 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
3) Modification de l'article 17 des Statuts pour lu donner la teneur suivante:
«Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1
er
juillet et se terminera le 30 juin de
l'année suivante.
L'exercice en cours ayant commencé le 1
er
juin 2010 se terminera le 30 juin 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
107347
L
U X E M B O U R G
« Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. HELLERS, E. DYACHUK, L. FANTAUZZO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2011. Relation: LAC/2011/23287. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011114605/104.
(110131904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.
Jose Manuel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4204 Esch-sur-Alzette, 14, rue Large.
R.C.S. Luxembourg B 117.351.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011107472/10.
(110121906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Kellogg Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 111.325.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011107473/11.
(110121685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 130.335.
Par résolutions prises en date du 22 juin 2011, l’associé unique de Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à
r.l.:
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant de la société avec effet au 22 juin 2011, Elisabeth
Weiland, née le 10/09/1974, à Ettelbruck, Luxembourg, avec adresse professionnelle au 2B rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.
- prend note de la démission de Ian Kent, comme gérant de la société avec effet au 22 juin 2011.
Le conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:
- BURGER Céline
- WEILAND Elisabeth
- RANTANEN Tero
- ANTTONEN Ari
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
107348
L
U X E M B O U R G
Le 04 août 2011.
<i>Pour Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.
i>Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2011112205/22.
(110128454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.
Kellogg Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.831.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011107474/11.
(110121676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Kellogg Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.832.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011107475/11.
(110121679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Kellogg Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 103.520.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011107476/11.
(110121680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
g b a fund, Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.960.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue le 4 avril 2011 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a ratifié la cooptation de Mr Sébastien Waefler en remplacement de Mr Vincent Zeller depuis le 24
mars 2011.
2. L’Assemblée a ratifié la cooptation de Mr Alec de Lezardiere en remplacement de Mr Hervé Seignol depuis le 23
mars 2011.
3. L’Assemblée a reconduit les mandats de:
- M. Antoine Briant, 4 rue Saint-Léger, CH-1205 Genève
- M. Alec de Lezardiere, 6 route Malagnou, 1211 Genève
- M. Sébastien Waefler, 6 route Malagnou, 1211 Genève
pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.
107349
L
U X E M B O U R G
4. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé PricewaterhouseCoopers pour une période
d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.
<i>Pour g b a Fundi>
Référence de publication: 2011109794/21.
(110125642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.
Kellogg Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 120.504.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011107477/11.
(110121681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Kellogg Lux VI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 146.432.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011107478/11.
(110121684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
LeasePlan Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 7, rue Nicolas Brosius.
R.C.S. Luxembourg B 29.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leudelange, le 27 juillet 2011.
Frank Charpentier
<i>Finance Directori>
Référence de publication: 2011107479/12.
(110121913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Lubrizol Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.151.600,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 111.506.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011107480/13.
(110121921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
107350
L
U X E M B O U R G
BJS Holdings 2 SNC, Société en nom collectif.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 162.339.
En date du 20 juillet 2011, les associés de la Société ont décidé d'augmenter le capital d'un montant de 24.327.406
USD représenté par l'émission de 24.327.406 nouvelles parts sociales.
BJS Holdings 2 LLC (BJS 2) et BJS Holdings 3 LLC (BJS 3), déjà associés de la Société, ont acquis ces nouvelles parts
sociales.
De sorte que l'actionnariat se compose comme suit:
- BJS 2 détient 130 380 320 parts sociales
- BJS 3 détient 2 477 226 087 parts sociale
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
BJS Holdings 2 SNC
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011107631/18.
(110123473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.
Lux Euro-Asian Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 81.404.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011107481/10.
(110121462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Labalma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 55.625.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17/07/1996
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LABALMA S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011107482/12.
(110121924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Larus Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 73.028.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011107483/10.
(110121635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 122.626.
Par résolutions prises en date du 30 juin 2011, l’associé unique de Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à r.l.:
- prend note de la démission de Selim Saykan comme gérant de la société avec effet au 11 novembre 2010.
107351
L
U X E M B O U R G
- prend note de la démission de Ian Kent comme gérant de la société avec effet au 22 juin 2011.
- prend note de la démission de Antoine Flipo comme gérant de la société avec effet au 30 juin 2011.
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant de la société avec effet au 22 juin 2011, Elisabeth
Weiland, avec adresse professionnelle au 2B rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant de la société avec effet au 30 juin 2011, Martha
Alexaki, avec adresse professionnelle au 2B rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Le conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:
- Elisabeth Weiland
- Martha Alexaki
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 04 août 2011.
<i>Pour Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à r.l.
i>Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2011112207/22.
(110128455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.
Parker Hannifin Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.172.
In the year two thousand and eleven, on the first day of July, at 3.00 p.m.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, (Grand-Duchy of Luxembourg)
There appeared,
(i) PARKER HANNIFIN PARTNER II GP, a general partnership formed pursuant to the laws of Bermuda, with regis-
tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda (“PHP II GP”), here represented by Maître
Jean STEFFEN, attorney at law, by virtue of a proxy issued under private signature on 1 July 2011;
(ii) PARKER HANNIFIN BERLUX LTD., an exempted company incorporated with limited liability organised under the
laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered
with the Bermuda Registrar of Companies under number 45527, here represented by Maître Jean STEFFEN, attorney at
law, by virtue of a proxy issued under private signature on 1 July 2011; and
The proxies having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary and shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed are the partners in PARKER HANNIFIN PARTNERSHIP S.C.S., société en commandite simple having
its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register number B 158.172, incorporated on December 1
st
, 2010 by deed of the undersigned notary, published in the
Mémorial C number 666, page 31955 (the “Partnership”).
Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Increase of the capital of the Company by an amount of nine hundred and sixteen million three hundred thirty two
thousand three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-) so as to raise it from its present amount of one thousand
Euros (EUR 1,000.-) to nine hundred and sixteen million three hundred thirty three thousand three hundred and two
Euros (EUR 916,333,302.-) by the issue of nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three
hundred and two (916,332,302) limited partnership units, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, for a total
subscription price of nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two Euros
(EUR 916,332,302.-).
2. Subscription of the nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two
(916,332,302.-) limited partnership units by PHP II GP, and payment thereof by a contribution in kind of (i) all the share
capital it holds in PARKER HANNIFIN MANUFACTURING HOLDING DENMARK ApS, incorporated under the laws
of Denmark, with registered office at Bjergvangen 2, DK-3060 Espergaerde, Denmark, registered with the Danish Com-
merce and Companies Agency Register under number 33 64 46 04; (ii) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN
DANMARK ApS, incorporated under the laws of Denmark, with registered office at Industriparken 35, DK-2750 Ballerup,
Denmark, registered with the Danish Commerce and Companies Agency under number 33 64 45 74; (iii) all the share
capital it holds in PARKER HANNIFIN MANUFACTURING DENMARK ApS, incorporated under the laws of Denmark,
with registered office at Industriparken 35, DK-2750 Ballerup, Denmark, registered with the Danish Commerce and
Companies Agency Register under number 30 55 53 17; (iv) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN (NOR-
107352
L
U X E M B O U R G
WAY) HOLDINGS AS, a limited liability company, incorporated under the laws of Norway, with registered office at
Rambergveien 1, 3115 Tønsberg, registered with the Norwegian Register of Business Enterprises under number 991 727
779, (v) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS, a société par actions simplifiées
incorporated under the laws of France, with registered office 17, rue des Bûchillons, ZI du Mont-Blanc, Ville la Grand,
F-74112 Annemasse, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Thonon-les-Bains under number
778 116 038; (vi) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN (AFRICA) (Pty.) Ltd., a private company, incorporated
under the laws of the Republic of South Africa, with registered office at 10 Berne Avenue Aeroport, Kempton Park,
Johannesburg registered with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) under number registration
1966/007656/07; (vii) a claim held by PHP II GP against PARKER HANNIFIN (NORWAY) HOLDINGS AS and (viii) a
claim held by PHP II GP against PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS for an aggregate amount of nine hundred
and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-).
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association to be read as follows:
“ Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Partnership is set at nine hundred and sixteen million three hundred
thirty three thousand three hundred and two Euros (EUR 916,333,302.-) represented by nine hundred and sixteen million
three hundred thirty three thousand three hundred and one (916,333,301.-) limited partnership units held by the limited
partner, and one (1) general partnership unit, held by the general partner, of one Euro (EUR 1.-).”
That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the capital of the Partnership by an amount of nine hundred and sixteen
million three hundred thirty two thousand three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-) so as to raise it from its
present amount of one thousand Euro (EUR 1,000.-) to nine hundred and sixteen million three hundred thirty three
thousand three hundred and two Euros (EUR 916,333,302.-) by the issue of nine hundred and sixteen million three
hundred thirty two thousand three hundred and two (916,332,302.-) limited partnership units, having a par value of one
Euro (EUR 1.-) each, at a total subscription price of nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand
three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-)
<i>Subscription and Paymenti>
Subscription of the nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two
(916,332,302.-) limited partnership units by PHP II GP, and payment of the aggregate amount of the subscription price of
nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-)
out of which nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two Euros (EUR
916,332,302.-) represents the par value of the newly issued limited partnership unit, through contribution in kind of (i)
all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN MANUFACTURING HOLDING DENMARK ApS, incorporated
under the laws of Denmark, with registered office at Bjergvangen 2, DK-3060 Espergaerde, Denmark, registered with
the Danish Commerce and Companies Agency Register under number 33 64 46 04; (ii) all the share capital it holds in
PARKER HANNIFIN DANMARK ApS, incorporated under the laws of Denmark, with registered office at Industriparken
35-37, DK-2750 Ballerup, Denmark, registered with the Danish Commerce and Companies Agency under number 33 64
45 74; (iii) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN MANUFACTURING DENMARK APS, incorporated under
the laws of Denmark, with registered office at Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup, Denmark, registered with the
Danish Commerce and Companies Agency Register under number 30 55 53 17; (iv) all the share capital it holds in PARKER
HANNIFIN (NORWAY) HOLDINGS AS, a limited liability company, incorporated under the laws of Norway, with
registered office at Rambergveien 1, 3115 Tønsberg, registered with the Norwegian Register of Business Enterprises
under number 991 727 779, (v) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS, a société
par actions simplifiées incorporated under the laws of France, with registered office 17, rue des Bûchillons, ZI du Mont-
Blanc, Ville la Grand, F-74112 Annemasse, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Thonon-les-
Bains under number 778 116 038; (vi) all the share capital it holds in PARKER HANNIFIN (AFRICA) (Pty.) Ltd., a private
company, incorporated under the laws of the Republic of South Africa, with registered office at 10 Berne Avenue Aero-
port, Kempton Park, Johannesburg registered with the Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) under
number registration 1966/007656/07; (vii) a claim held by PHP II GP against PARKER HANNIFIN (NORWAY) HOLDING
AS and (viii) a claim held by PHP II GP against PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS for an aggregate amount
of nine hundred and sixteen million three hundred thirty two thousand three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-).
Proof of the existence and value of the contribution for an amount of nine hundred and sixteen million three hundred
thirty two thousand three hundred and two Euros (EUR 916,332,302.-) has been given by delivery of (i) a contribution
certificate dated 1 July, 2011 and issued by the management of PHP II GP, and (ii) a valuation certificate dated 1 July 2011
and issued by the Partnership.
<i>Second resolutioni>
The general meeting subsequently resolved to amend article 5 of the articles of to be read as follows:
107353
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Partnership is set at nine hundred and sixteen million three hundred
thirty three thousand three hundred and two Euros (EUR 916,333,302.-) represented by nine hundred and sixteen million
three hundred thirty three thousand three hundred and one (916,333,301.-) limited partnership units held by the limited
partner, and one (1) general partnership unit, held by the general partner, of one Euro (EUR 1.-).”
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately four thousand three hundred euro (€
4,300.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version
L'an deux mille onze, le premier juillet, à 15:00 heures
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu;
(i) PARKER HANNIFIN PARTNER II GP, une société en nom collectif, constituée selon les lois des Bermudes, avec
siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, («PHP II GP»), représentée par Me Jean
STEFFEN avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé en date du 1
er
juillet 2011; et
(ii) PARKER HANNIFIN BERLUX LTD., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois autrichiennes,
avec siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, immatriculée au Registre de com-
merce de Bermuda sous le numéro 45527,
représentée par Me Jean STEFFEN avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée
sous seing privé en date du 1
er
juillet 2011,
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Les sociétés comparantes prénommées sont les associés de la société PARKER HANNIFIN PARTNERSHIP S.C.S., une
société en commandite simple ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.172, constituée par un acte daté du 1
er
décembre 2010 et reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C numéro 666, page 31955 (la «SCS»).
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire soit le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la SCS à concurrence d'un montant de neuf cent seize millions trois cent trente-
deux mille trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-), pour le porter de son montant actuel de mille Euros (EUR 1.000,-)
à un montant de neuf cent seize millions trois cent trente-trois mille trois cent deux Euros (EUR 916.333.302,-), par
l'émission neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille trois cent deux (916.332.302,-) nouvelles parts comman-
ditaires, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, à un prix de souscription total de neuf cent seize millions
trois cent trente-deux mille trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-).
2. Souscription des neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille trois cent deux (916.332.302,-) nouvelles parts
commanditaires par la société PHP II GP, et le paiement de la prime d'émission s'effectuant par l'apport en nature de (i)
la totalité des parts sociales détenues dans la société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING HOLDING DENMARK
ApS, une société constituée selon les lois de Danemark, avec siège social au Bjergvangen 2, DK-3060 Espergaerde, Da-
nemark, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Danemark sous le numéro 64 46 04; (ii) PARKER
HANNIFIN DANMARK ApS, une société constituée selon les lois de Danemark, avec siège social au Industriparken
35-37, DK-2750 Ballerup, Danemark, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Danemark sous le numéro
33 64 45 74; (iii) PARKER HANNIFIN MANUFACTURING DENMARK ApS, une société constitituée selon les lois de
Danemark, avec siège social au Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup, Danemark, immatriculée au Registre de com-
merce et des sociétés du Danemark sous le numéro 30 55 53; (iv) PARKER HANNIFIN (NORWAY) HOLDINGS AS,
une société constituée selon les lois Norvégiennes, avec siège social au Rambergveien 1, 3115 Tønsberg, immatriculée
au Registre des sociétés commerciales de Norvège sous le numéro 991 727 779; (v) PARKER HANNIFIN FRANCE
HOLDING SAS, une société par actions simplifiées, constituée selon les lois françaises, avec siège social au 17, rue des
Bûchillons, ZI du Mont-Blanc, Ville la Grand, F-74112 Annemasse, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés
107354
L
U X E M B O U R G
de Thonon-les-Bains sous le numéro 778 116 038; (vi) PARKER HANNIFIN (AFRICA) (Pty.) Ltd., une société à respon-
sabilité limitée, constituée selon les lois de le République de l'Afrique du Sud, avec siège social au 10 Berne Avenue
Aeroport, Kempton Park, Johannesburg, immatriculée à la Commission des sociétés et des proriétés intellectuelles (CIPC)
sous le numéro 1966/007656/07; (vii) un droit à recevoir détenu par PHP II GP à l'encontre de la société PARKER
HANNIFIN (NORWAY) HOLDING AS; et (viii) un droit à recevoir détenu par PHP II GP à l'encontre de PARKER
HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS, pour une valeur totale de neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille
trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-).
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent seize millions trois cent trente-trois mille trois cent deux Euros (EUR
916.333.302,-), divisé en neuf cent seize millions trois cent trente-trois mille trois cent une (916.333.301) parts com-
manditaires détenues par les associés commanditaires, et une (1) part commanditée, détenue par l'associé commandité,
ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune«
II. Que l'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de neuf cent
seize millions trois cent trente-deux mille trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-), pour le porter de son montant
actuel d'un mille Euros (EUR 1.000,-) à neuf cent seize millions trois cent trente-trois mille trois cent deux Euros (EUR
916.333.302,-), par l'émission de neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille trois cent deux (916.332.302,-) parts
commanditaires, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, à un prix total de souscription de neuf cent seize
millions trois cent trente-deux mille trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-)
<i>Souscription et Libérationi>
Les neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille trois cent deux (916.332.302,-) parts commanditaires ont été
souscrites par PHP II GP, et le paiement de la valeur totale du montant de la souscription de neuf cent seize millions trois
cent trente-deux mille trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-) étant payé par un apport en nature de (i) la totalité
des parts sociales détenues dans la société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING HOLDING DENMARK ApS, une
société constituée selon les lois de Danemark, avec siège social au Bjergvangen 2, DK-3060 Espergaerde, Danemark,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Danemark sous le numéro 64 46 04; (ii) PARKER HANNIFIN
DANMARK ApS, une société constituée selon les lois de Danemark, avec siège social au Industriparken 35-37, DK2750
Ballerup, Danemark, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Danemark sous le numéro 33 64 45 74;
(iii) PARKER HANNIFIN MANUFACTURING DENMARK ApS, une société constitituée selon les lois de Danemark, avec
siège social au Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup, Danemark, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés
du Danemark sous le numéro 30 55 53; (iv) PARKER HANNIFIN (NORWAY) HOLDINGS AS, une société constituée
selon les lois Norvégiennes, avec siège social au Rambergveien 1, 3115 Tønsberg, immatriculée au Registre des sociétés
commerciales de Norvège sous le numéro 991 727 779; (v) PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS, une société
par actions simplifiées, constituée selon les lois françaises, avec siège social au 17, rue des Bûchillons, ZI du Mont-Blanc,
Ville la Grand, F-74112 Annemasse, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le
numéro 778 116 038; (vi) PARKER HANNIFIN (AFRICA) (Pty.) Ltd., une société à responsabilité limitée, constituée selon
les lois de le République de l'Afrique du Sud, avec siège social au 10 Berne Avenue Aeroport, Kempton Park, Johannesburg,
immatriculée à la Commission des sociétés et des proriétés intellectuelles (CIPC) sous le numéro 1966/007656/07; (vii)
un droit à recevoir détenu par PHP II GP à l'encontre de la société PARKER HANNIFIN (NORWAY) HOLDING AS; et
(viii) un droit à recevoir détenu par PHP II GP à l'encontre de PARKER HANNIFIN FRANCE HOLDING SAS pour une
valeur totale de neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-).
La preuve de l'existence et de valeur de l'apport d'un montant de neuf cent seize millions trois cent trente-deux mille
trois cent deux Euros (EUR 916.332.302,-) a été apportée par la délivrance d'un (i) certificat d'apport daté du 1
er
juillet
2011 et émis par la gérance de la société PHP II GP, et (ii) un certificat d'évaluation daté du 1
er
juillet 2011 et émis par
la SCS.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent seize millions trois cent trente-trois mille trois cent deux Euros (EUR
916.333.302,-), divisé en neuf cent seize millions trois cent trente-trois mille trois cent une (916.333.301) parts com-
manditaires détenues par les associés commanditaires, et une (1) part commanditée, détenue par l'associé commandité,
ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune«
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que soit, qui incombent à la Société en raison de la
présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à quatre mille trois cents euros (€ 4.300,-).
107355
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en français, suivi d'une version anglaise; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, le dit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Steffen, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9188. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Line Gerard.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011111767/221.
(110128177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.
Le Petit Manoir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 24, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 105.037.
Les comptes annuels clôturés au 31-déc-10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011107484/10.
(110121603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 141.313.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011107485/10.
(110121454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
LSREF Lux Japan Investments V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 141.321.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011107486/10.
(110121459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
L14 Capital Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 151.687.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2011.
Référence de publication: 2011107487/10.
(110121630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
107356
L
U X E M B O U R G
Rembrandt III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.231.550,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 88.973.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2011.
Pour extrait conforme
Rembrandt III S.à. r.l.
Mlle Axelle De Donker
Référence de publication: 2011107511/14.
(110121419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Venezuela Cable Service Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.314.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty third day of May, before Maître Francis Kesseler, notary residing
in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARS:
Intercable Holdings Ltd., an exempted company incorporated with limited liability and existing under the laws of the
Cayman Islands, having its registered office at c/o Stuarts Corporate Services Ltd., P.O. Box 2510, Grand Cayman KY1
1104 and registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under the registration number 251868 (the Sole
Shareholder), being the sole shareholder of Venezuela Cable Service Holdings Ltd., a company existing and organised
under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Caledonian Trust (Cayman) Limited, Caledonian
House, 69 Dr. Roy's Drive, PO Box 1043, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands and registered with the Cayman
Islands Registrar of Companies under the registration number 79637 (the Company),
represented by Camilo Luna, lawyer, residing professionally at 33 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue
of a proxy given in Buenos Aires, on 23 May 2011, for the purpose of holding an extraordinary general meeting (the
Meeting) of the sole shareholder of the Company.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, requests the undersigned notary to record the following:
I. that Intercable Holdings Ltd. is the sole shareholder of the Company and that the entirety of the share capital of the
Company is hence duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items of the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice;
II. that the Sole Shareholder resolved by written resolutions dated March 30
th
, 2011 (i) that the Company shall
discontinue as a company existing and organised under the laws of the Cayman Islands and shall continue as a Luxembourg
private limited liability company and (ii) to transfer the registered office and the place of central management of the
Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg;
III. that it results from (i) a balance sheet of the Company dated as of 15 May 2011 (the Balance Sheet) that the net
assets of the Company amount to USD 128,453,112.91 which correspond at least to the equity of the Company and (ii)
a certificate (the Certificate) issued by the management of the Company, that since the date of the balance sheet, no
material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred, which would have depreciated
the net asset value of the Company (copies of (i) the written resolutions of the Sole Shareholder referred to in item II
here above, (ii) the Balance Sheet and (iii) the Certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of
the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the
registration authorities); and
IV. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. transfer of the Company's registered office and the place of central management from Caledonian Trust (Cayman)
Limited, Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, PO Box 1043, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands to 13-15 Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, effective as of 23 May 2011 and as a result, change the nationality of the Company, at
the present time of Cayman Islands nationality to Luxembourg nationality;
107357
L
U X E M B O U R G
2. continuation of the Company under the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
under the name "Venezuela Cable Service Holdings S.à r.l." and amendment and full restatement of the Company's articles
of association (the Articles) for the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg and
setting of the share capital of the Company at USD 1,284,531 represented by 1,284,531 shares having a nominal value of
USD 1 (one dollar of the United States of America) each, all of which are to be held by the Sole Shareholder and to
allocate to the share premium reserve USD 127,168,581.91;
3. approval of the opening balance sheet of the Company as a Luxembourg company;
4. confirmation of the establishment of the registered office of the Company at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg,;
5. appointment of the Company's new managers;
6. determination of the dates of the Company's financial year; and
7. miscellaneous.
These facts exposed and recognised accurate by the Meeting, the Meeting passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the Company's registered office and place of place of central management of the
Company from Caledonian Trust (Cayman) Limited, Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, PO Box 1043, Grand Cayman
KY1-1102, Cayman Islands to 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, effective as of 23 May 2011.
As a result of the above, the Meeting resolves to change the nationality of the Company, at the present time of Cayman
Islands nationality to Luxembourg nationality and that such change does not affect the continuity of life of the Company
which shall remain one and the same body corporate.
<i>Second resolutioni>
Based on the actual balance sheet as well as the Certificate, the net asset value of the Company amounts to USD
128,453,112.91 (one hundred twenty-eight million four hundred and fifty-three thousand one hundred and twelve dollars
and ninety-one cent of the United States of America).
As a result, the Meeting resolves to:
(i) allocate USD 1,284,531 (one million two hundred and eighty-four thousand five hundred and thirty one dollars of
the United State of America) to the share capital of the Company represented by 1,284,531 (one million two hundred
and eighty-four thousand five hundred and thirty one) shares having a nominal value of USD 1 (one dollar of the United
States of America) each, all of which are to be held by the Sole Shareholder.
(ii) allocate the difference between the net assets value and the share capital to the share premium reserve of the
Company for an amount of USD 127,168,581.91 (one hundred twenty-seven million one hundred and sixty-eight thousand
five hundred and eighty-one dollars and ninety one cents of the United States of America)
The Meeting further resolves to continue the Company under the legal form of a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée) under the name "Venezuela Cable Service Holdings S.à r.l." and to amend and
fully restate the Articles for the purpose of its transfer and continuation in the Grand-Duchy of Luxembourg, as follows:
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Vene-
zuela Cable Service Holdings S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to
develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or
affiliated companies.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.
107358
L
U X E M B O U R G
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-city.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 1,284,531 (one million two hundred and
eightyfour thousand five hundred and thirty-one dollars of the United States of America), represented by 1,284,531 (one
million two hundred and eighty-four thousand five hundred and thirty-one) shares having a nominal value of USD 1 (one
dollar of the United States of America) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. Each manager shall be assigned either an
A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager
(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting
of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power.
The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory
power jointly may sub-delegate his or their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or
in case of plurality of managers, the delegating manager(s) will determine this agent's responsibilities and remuneration
(if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
107359
L
U X E M B O U R G
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members (including at least one A and one B manager) is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting (including at least one A manager).
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by a manager with
an A signatory power and a manager with a B signatory power. This notice may be waived if all the managers are present
or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not
be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution
of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
January and ends on 31
st
December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
107360
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor (commissaire) - External auditor (réviseur d'entreprise agréé). In accordance with article
200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-
five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the
Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial
accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to approve the opening balance sheet of the Company as a Luxembourg company as of 23 May
2011.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting confirms the establishment of the registered office of the Company at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting appoints as A managers of the Company for an unlimited period of time:
- Alberto Imar, born in Buenos Aires, Argentina on the 21
st
December 1961 whose address is at Tequendama I -
Apto.203,Parada 6, Punta Del Este, Uruguay; and
- Paul Savoldelli, born in California, United States of America, on the 12
th
February 1959, whose address is at 5332
Ravine Dr, Dallas, Texas;
The Meeting appoints as B managers of the Company for an unlimited period of time:
- Johanna Dirkje Martina, born in Groningen, Netherlands on 28 February 1967, with address at 13-15 avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg; and
- Joost Johannes Tulkens, born in Someren, Netherlands on 26 April 1973, with address at 13-15 avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves that the first Company's financial year shall begin on the day of the present deed and end on 31
December 2011.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately seven thousand euro
(€ 7,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the proxyholder
of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this deed.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de mai, par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Intercable Holdings Ltd., une société constituée et existant sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au c/
o Stuarts Corporate Services Ltd, PO Box 2510, Grand Cayman KY1 1104 et enregistrée auprès du registre de commerce
et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro d'enregistrement 251868 (l'Associé Unique), étant le seul associé de
Venezuela Cable Service Holdings Ltd., une société existante et organisée sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège
social à Caledonian Trust (Cayman) Limited, Caledonian House, 69, promenade du Dr Roy, PO Box 1043, Grand Cayman
KY1-1102, les Iles Cayman et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés des Iles Cayman sous le numéro
79637 enregistrement (la Société),
107361
L
U X E M B O U R G
représentée par Camilo Luna, avocat, demeurant professionnellement au 33 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Buenos Aires, le 23 mai 2011, aux fins de tenir une assemblée générale extraordinaire
(l 'Assemblée) de l'associé unique de la Société.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l 'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui
suit:
I. que Intercable Holdings Ltd. est l'associé unique de la Société et que par conséquent la totalité du capital social de
la Société est dûment représenté à l'Assemblée, qu'en conséquence celle-ci est régulièrement constituée et peut délibérer
sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans préavis;
II. que l'Associé Unique a décidé par résolution écrite en date du 30 mars 2011 (i) que la Société cesse d'exister en
tant que société existante et organisée sous les lois des Iles Cayman et qu'elle continue à exister en tant que société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois et (ii) de transférer le siège social et la direction centrale de la Société
depuis les Iles Cayman vers le Grand-duché de Luxembourg;
III. qu'il résulte de (i) un bilan de la Société en date du 15 mai 2011 (le Bilan) que les actifs nets de la Société s'élève à
128.453.112,91 USD ce qui correspond au moins aux capitaux propres de la Société et (ii) une certificat délivré par la
direction de la Société (le Certificat), que depuis la date du bilan, aucun changement important dans les affaires de la
Société n'a eu lieu, qui aurait déprécié la valeur des actifs nets de la Société (des copies de (i) les résolutions écrites de
l'Associé Unique visée à l'article II ci-dessus, (ii) le Bilan et (iii) le Certificat, après avoir été signées "ne varietur" par le
mandataire de la partie comparante et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumisse en même temps
auprès des autorités d'enregistrement), et
IV. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. transfert du siège social de la Société et de l'administration centrale de Caledonian Trust (Cayman) Limited, Cale-
donian House, 69, promenade du Dr Roy, PO Box 1043, Grand Cayman KY1-1102, Iles Caïmans au 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, à compter du 23 mai 2011 et, par conséquent, changement de la nationalité de la Société
d'une nationalité des Iles Cayman par une nationalité luxembourgeoise;
2. continuation de la Société sous la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de "Venezuela Cable
Service Holdings S.à r.l." et modification et refonte complète des statuts de la Société (les Statuts) en vue de son transfert
et sa continuation au Grand-duché de Luxembourg et la fixation du capital social de la Société à 1.284.531 USD représenté
par 1.284.531 parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar des États-Unis d'Amérique) chacune, détenues
par l'Associé Unique et d'attribuer à la prime de réserve 127.168.581,91 USD;
3. approbation du bilan d'ouverture de la Société en tant que société de droit luxembourgeois;
4. confirmation de l'établissement du siège social de la Société au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,;
5. nomination de nouveaux gérants de la Société;
6. détermination des dates de l'exercice social de la Société, et
7. divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société et le lieu de son administration centrale de Caledonian
Trust (Cayman) Limited, Caledonian House, 69, promenade du Dr Roy, PO Box 1043, Grand Cayman KY1-1102, Iles
Caïmans au 13 -15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, à compter du 23 mai 2011.
En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de changer la nationalité de la Société, actuellement des Iles
Caïmans pour une société de nationalité luxembourgeoise et que pareille modification n'affecte pas la continuité de la vie
de la Société qui restera une seule et même personne morale.
<i>Deuxième résolutioni>
Basé sur le Bilan ainsi que sur le Certificat, la valeur de l'actif net de la Société s'élève à 128.453.112,91 USD (cent
vingt huit millions quatre cent cinquante trois mille cent douze dollars et quatre-vingt-onze centimes des Etats-Unis
d'Amérique).
En conséquence, l'Assemblée décide de:
(i) allouer 1.284.531 USD au capital social de la Société représenté par 1.284.531 parts sociales ayant une valeur
nominale de USD 1 (un dollar des États-Unis d'Amérique) chacune, détenues par l'Associé Unique; et
(ii) Allouer à la prime de réserve la différence entre l'actif net et le capital social de la Société pour un montant de
127.168.581,91 USD (cent vingt-sept millions cent soixante huit mille cinq cent quatre-vingt-un dollars et quatre-vingt-
onze centimes de dollars des Etats-Unis d'Amérique).
L'Assemblée décide en outre de continuer la Société sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous
le nom de "Venezuela Cable Service Holdings S.à r.l." et de modifier et de refondre complètement les Statuts en vue de
son transfert et sa continuation au Grand-duché de Luxembourg, comme suit:
107362
L
U X E M B O U R G
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée (société à responsabilité limitée) de nom "Venezuela
Cable Service Holdings S.à r.l." (La Société).
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme
que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie
de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des droits
intellectuels de toute origine.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit dans le Grand-duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée
générale extraordinaire de ses associés. Il peut être transféré dans les limites de la municipalité de Luxembourg-ville par
une décision du gérant / conseil de gérance de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à 1.284.531 USD (un million deux cent quatre vingt quatre
mille cinq-cent trente et un dollars des États-Unis d'Amérique), représenté par 1.284.531 (un million deux cent quatre
vingt quatre mille cinq cent trente et un) pars sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar des États-Unis
d'Amérique) chacune.
Art. 6. Modifications au capital social. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé
unique ou par décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Partage des profits. Chaque action donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Cession de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans tous les cas, les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables suffisantes.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.
107363
L
U X E M B O U R G
Art. 11. La mort, la suspension des droits civils, Insolvabilité ou de faillite des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite
ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gestion. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Chaque gérant se verra attribuer soit un pouvoir
de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance.
Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée
générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un
pouvoir de signature B conjointement pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou
plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront
la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation
et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres (comprenant au moins un gérant A et un gérant B) est présente ou représentée lors de la réunion du conseil
de gérance.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du
conseil de gérance de la Société par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance
(comprenant au moins un gérant A). Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné.
En cas de pluralité de gérants, un avis de convocation concernant toute réunion du conseil de gérance sera donné à
tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour
la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir
de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B. Cette convocation peut être dispensée lorsque les gérants
sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convo-
cation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Responsabilité du gérant(s). Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Les assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés
se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la
convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
107364
L
U X E M B O U R G
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de vote des, Quorum et de majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des
associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le
conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Commissaire / Réviseur d'entreprises agréé. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit
être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'en-
treprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le bilan d'ouverture de la Société en tant que société luxembourgeoise à partir du
23 mai 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
La réunion confirme l'établissement du siège social de la Société au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée désigne comme gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
- Alberto Imar, né à Buenos Aires, Argentine le 21 Décembre 1961 dont l'adresse est à Tequendama I - Apto.203,
Parada 6, Punta Del Este, Uruguay; et
- Paul Savoldelli, né en Californie, États-Unis d'Amérique, le 12 Février 1959, dont l'adresse est à 5332 Ravine Dr,
Dallas, Texas;
L'Assemblée désigne comme gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Johanna Dirkje Martina, né à Groningen, Pays-Bas le 28 Février 1967, avec adresse au 13-15 avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg; et
- Joost Johannes Tulkens, né à Someren, Pays-Bas le 26 avril 1973, avec adresse au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide que l'exercice de la première société commence le jour du présent acte et se termine le 31
Décembre 2011.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement sept mille euros (€ 7.000,-).
107365
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature le jour de l'année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Luna, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 mai 2011. Relation: EAC/2011/6964. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2011103826/492.
(110118019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.
Matthews Global Investors S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 151.260.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011107490/12.
(110121837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Org & It Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 141.308.
L'an deux mille onze, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Rémy SCHLEIMER, informaticien, demeurant à L-4391 Pontpierre, 32 rue de Luxembourg.
2. Madame Marie Anne SCHLEIMER, étudiante, demeurant à L-4391 Pontpierre, 32 rue du Luxembourg.
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés Monsieur Rémy SCHLEIMER, prédit, de vingt-quatre parts
sociales (24), et Madame Marie Anne SCHLEIMER, prédite, de soixante-seize parts sociales (76) de la société à respon-
sabilité limitée «Org & It Consulting S.àr.l.» avec siège social à L-4391 Pontpierre, 32 rue de Luxembourg, suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juillet 2008, publié au Mémorial C numéro 2314, en date du 23 septembre
2008.
Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:
- Transfert du siège social et modification de l'article deux, premier alinéa des statuts.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Pontpierre à Steinfort et de modifier par conséquent le
premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. ”Le siège social est établi à Steinfort.
(Le reste sans changement ).
L'adresse du siège est fixée à L-8437 Steinfort, 52 rue de Koerich.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués
approximativement à HUIT CENTS EURO (800.-EURO).
107366
L
U X E M B O U R G
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Rémy SCHLEIMER; Marie Anne SCHLEIMER , Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2011. Relation: EAC/ 2011/ 8343. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
août 2011.
Référence de publication: 2011112505/42.
(110128478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.
Melchior CDO I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 79.144.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2011.
TMF Management Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011107491/13.
(110121275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Mawi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.
R.C.S. Luxembourg B 70.961.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011107492/15.
(110121562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
DH Salisbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 150.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 143.574.
In the year two thousand and eleven, on the seventh day of July.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of DHCRE II Holdco II S.à r.l. having its registered office at 28, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 113.167 (the “Sole Shareholder”), acting in its capacity
as the sole shareholder of DH Salisbury S.à r.l., a société à responsabilitée limitée, having its registered office at 28,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 143.574 incorporated by deed dated on
November 26, 2008, published in Memorial C number 43, p 2.027, of January 8, 2009, whose articles of association have
107367
L
U X E M B O U R G
been amended by deed enacted on December 17, 2008, published in the Luxembourg Mémorial C Number 500, p 23.997
of March 6, 2009 (the “Company”).
The Meeting is presided by Flora Gibert, employee residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Sara Lecomte, employee, residing professio-
nally in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the Sole Shareholder represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be registered with these minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 6,000 (six thousand) shares of GBP 25 (twenty-five Great Britain Pounds)
each, representing the whole capital of the Company are duly represented so that the Meeting can validly decide on all
the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with
registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Approval of the accounting situation of the Company for the period from January 1, 2011 to July 7, 2011;
5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
6. Miscellaneous.
IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liqui-
dation).
<i>Second resolution:i>
The Meeting resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., prenamed, as liquidator (The “Liquidator”).
<i>Third resolution:i>
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxem-
bourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).
The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including
those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the partners. The
Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several
persons or entities.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under its sole signature on
behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required
for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance pay-
ments of the liquidation proceeds to the partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolution:i>
The Meeting resolves to approve the accounting situation of the Company for the period from January 1, 2011 to July
7, 2011;
<i>Fifth resolution:i>
The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their
respective mandates until today.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
107368
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le sept juillet.
Devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de DHCRE II Holdco II S.à r.l., une société ayant son siège social au 28,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le N° 113.167, l'«Associé Unique», en qualité d'Associé Unique de la société à responsabilité limitée "DH Salisbury S.à
r.l." (la “Société”), ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le N° 143.574, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 2008, publié au Mémorial C N° 43, page 2.027,
du 8 janvier 2009 et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 17 décembre 2008, publié au Mémorial C N° 500,
p 23.997 du 6 mars 2009.
La séance est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Sara Lecomte, employée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'Associé Unique représenté et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il ressort de cette liste de présence que les 6,000 (six mille) parts sociales de GBP 25 (vingt cinq Livres Sterling)
chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1 janvier 2011 au 7 juillet
2011;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et
6. Divers.
IV.- Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volon-
taire).
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., précité, en tant que liquidateur (le “Liqui-
dateur”).
<i>Troisième résolution:i>
L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en
ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des associés.
Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature
au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation
de la Société et la disposition de ses actifs.
L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances
sur le solde de liquidation aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolution:i>
Les associés décident d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant
du 1 janvier 2011 au 7 juillet 2011.
107369
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolution:i>
L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à
ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31405. Reçu douze euros (12.-€)
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Référence de publication: 2011111621/134.
(110128342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.
Aberdeen Real Estate Holding Company Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 124.951.
Par résolutions prises en date du 22 juin 2011, l’associé unique de Aberdeen Real Estate Holding Company Luxembourg
S.à r.l.:
- décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant de la société avec effet au 22 juin 2011, Elisabeth
Weiland, née le 10/09/1974, à Ettelbruck, Luxembourg, avec adresse professionnelle au 2B rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.
- prend note de la démission de Ian Kent, comme gérant de la société avec effet au 22 juin 2011.
Le conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:
- BURGER Céline
- WEILAND Elisabeth
- RANTANEN Tero
- ANTTONEN Ari
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 04 août 2011.
<i>Pour Aberdeen Real Estate Holding Company Luxembourg S.à r.l.
i>Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2011112208/22.
(110128453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.
Altafinance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.703.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 mai 2011 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée Générale reconduit à l'unanimité les mandats d'Administrateurs de M. Koen LOZIE, de COSAFIN S.A,
1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par M. Jacques BORDET, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxem-
bourg, et M. Joseph WINANDY.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes la société THE
CLOVER, Société Anonyme, ayant son siège social au 8, rue Haute à L-4963 Clémency.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2011.
107370
L
U X E M B O U R G
Pour copie certifiée conforme
K. LOZIE / COSAFIN S.A.
Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011109103/20.
(110123093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2011.
Mayroy, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 48.865.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Mayroy
i>Signature
Référence de publication: 2011107494/11.
(110122109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Mediaxim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8613 Pratz, 13, rue de Folschette.
R.C.S. Luxembourg B 144.498.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011107495/10.
(110121666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
ABH Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 151.018.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, le 15 juin 2011i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société que:
- le mandat du commissaire aux comptes de la Société, à savoir PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a été renouvelé
jusqu'à l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011; et
- les mandats des administrateurs de la Société, à savoir Pavel Nazarian, Ildar Karimov et Johann Jonach ont été
renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2011.
<i>Pour ABH Holdings S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011107588/19.
(110124268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.
Rembrandt V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.020.400,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 88.975.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
107371
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 25 juillet 2011.
Pour extrait conforme
Rembrandt V S.à. r.l.
Mlle Axelle De Donker
Référence de publication: 2011107512/14.
(110121423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
TPG TM V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.467.
EXTRAIT
En date du 4 juillet 2011, l'associé unique de la Société, TPG Partners VI, L.P. a transféré toutes les un million sept
cent quatre vingt seize trois cent soixante quinze (1.796.375) parts sociales en émission dans la Société à:
TPG VI AIV TM II, L.P., un exempted limited partnership constitué et existant sous le droit des Iles Cayman et enregistré
auprès du Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC-48405 ayant son siège social à c/
o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands, agissant
par son general partner TPG GenPar VI AIV TM, L.P. un exempted limited partnership constitué et existant sous le droit
des Iles Cayman et enregistré auprès du Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro
MC-48488 ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY 1-1104, Cayman Islands, agissant par son general partner TPG GenPar VI AIV TM Advisors, Inc. un exempted limited
partnership constitué et existant sous le droit des Iles Cayman et enregistré auprès du Assistant Registrar of Companies
of the Cayman Islands sous le numéro MC-256589 ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O.
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands.
En date du 20 juillet 2011, le nouvel associé unique de la Société a transféré toutes les un million sept cent quatre vingt
seize trois cent soixante quinze (1.796.375) parts sociales en émission dans la Société à:
TPG VI AIV TM I, L.P., un exempted limited partnership constitué et existant sous le droit des Iles Cayman et enregistré
auprès du Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC-48404 ayant son siège social à c/
o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands, agissant
par son general partner TPG GenPar VI AIV TM, L.P. un exempted limited partnership constitué et existant sous le droit
des Iles Cayman et enregistré auprès du Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro
MC-48488 ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY 1-1104, Cayman Islands, agissant par son general partner TPG GenPar VI AIV TM Advisors, Inc. un exempted limited
partnership constitué et existant sous le droit des Iles Cayman et enregistré auprès du Assistant Registrar of Companies
of the Cayman Islands sous le numéro MC-256589 ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O.
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands.
En conséquence, toutes les un million sept cent quatre vingt seize trois cent soixante quinze (1.796.375) parts sociales
en émission dans la Société sont détenues par TPG VI AIV TM I, L.P.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2011.
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011112777/38.
(110128270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.
Fondation des Amis des Musées d'Art et d'Histoire, Luxembourg, Fondation.
Siège social: L-2345 Luxembourg, place du Marché-aux-Poissons.
R.C.S. Luxembourg G 20.
<i>Comptes annuels 2010i>
<i>Rapport des réviseurs de caisse pour l'exercice 2010 à l'Assemblée Généralei>
<i>de la Fondation des Amis des Musées d'Art et d'Histoire, Luxembourgi>
Conformément au mandat qui nous a été confié par l'Assemblée Générale de la Fondation, nous avons contrôlé les
comptes de recettes et dépenses préparés par le Comité de la Fondation pour l'exercice social couvrant la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2010.
107372
L
U X E M B O U R G
Nos contrôles ont été effectués par sondages et sur base des documents justificatifs. Les comptes renseignent un
excédent de recettes sur les dépenses de 8.800,68 euros pour la période sous revue. Les dons aux musées se sont élevés
à 125.000 euros en contrepartie d'un don extraordinaire du même montant.
Nous avons également contrôlé le patrimoine social de la Fondation des Amis des Musées d'Art et d'Histoire au 31
décembre 2009 et 2010. A fin 2010 ce patrimoine s'élève à 23.656,95 euros, ayant augmenté du montant prémentionné
de l'excédent des recettes.
Nous n'avons pas d'autres remarques à formuler sur ces comptes.
Luxembourg, le 26 avril 2011.
Jean Grosges / Fons Schoder
<i>Les réviseurs de caissei>
Constituée le 24 mai 1993
Approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1993
Mémorial 1993 C n° 4088, 1997 C n° 539 et 2004 C n° 770
<i>Exercice 2010 (en EURO)i>
Patrimoine au 31.12.2009
BGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,710.81
BGL epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,145.46
14,856.27
Recettes de l'exercice
Don extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000.00
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,739.00
Intérêts crediteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.18
133,841.18
Dépenses de l'exercice
Don Musées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000.00
Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.50
125,040.50
Patrimoine au 31.12.2010
BGL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,409.31
BGL epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,247.64
23,656.95
8,800.68
8,800.68
Excédent des recettes sur les dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,800.68
Luxembourg, le 31.12.2010.
Signatures
<i>La Présidente / Le Trésorieri>
Référence de publication: 2011110022/50.
(110126179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2011.
Metimmo SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4744 Pétange, 2-4, rue Jean-Pierre Kirchen.
R.C.S. Luxembourg E 2.008.
<i>Assemblée générale des associés au 16 mars 2011i>
Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Pierre POOS en tant que gérant.
Les associés décident de nommer Madame BINI Marie Françoise en tant que nouvelle gérante.
Adresse de Madame BINI Marie Françoise:
26, rue du BERRY F - 54400 COSNES ET ROMAIN
Pierre POOS / Denise BESANCON / Cécile HAMER / Marie Françoise BINI.
Référence de publication: 2011107496/13.
(110121509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
107373
L
U X E M B O U R G
Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, La Belle Etoile.
R.C.S. Luxembourg B 55.505.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011107498/15.
(110121550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
NTC Holding G.P., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 150.289.
Les comptes annuels de la période du 11 décembre 2009 au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NTC Holding G.P.
i>Signature
Référence de publication: 2011107499/13.
(110121602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
NTC Holding G.P. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 311.726,34.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 150.720.
Les comptes annuels de la période du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NTC Holding G.P. & Cie S.C.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011107500/13.
(110121628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Ouriense S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 60.918.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011107502/10.
(110121896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
107374
L
U X E M B O U R G
Capellen Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 87.449.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 29 juillet 2011i>
L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de révoquer, sans délai, Deloitte S.A., ayant son siège
social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 67.895 en leur qualité de Commissaires aux comptes de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de nommer, sans délai, H.R.T. Révision S.A., ayant son
siège social au L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 51.238 en sa qualité de réviseurs d'entreprises de la Société jusqu'à l'assemblée générale
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2011.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011107654/18.
(110124215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.
Woolpas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.594.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 juillet 2011i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011
comme suit:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Stefano De Meo, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, administrateur et président;
- Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, administrateur;
- Madame Sandrine Durante, employée privée, demeurant professionnellement au 19/21, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011112651/26.
(110128457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2011.
Polar Windows S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 49.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.176.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011107504/11.
(110121580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
107375
L
U X E M B O U R G
Pic'Art S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 68.961.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2011107503/15.
(110121548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Piquet, Price & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 94.361.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011107506/10.
(110122006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Co-Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 48.838.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2011i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Christian Knauff, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Peter van Opstal, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Oran-
gefield Trust (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se
termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.
Luxembourg, le 28 juillet 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011107675/18.
(110123669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2011.
Piquet, Price & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 94.361.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011107507/10.
(110122007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
107376
Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.
Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à r.l.
Aberdeen Real Estate Holding Company Luxembourg S.àr.l.
ABH Holdings S.A.
Altafinance S.A.
BJS Holdings 2 SNC
Capellen Invest S.A.
Co-Ventures S.A.
DH Salisbury S.à r.l.
Fidelity International Real Estate Fund Company 10
Fidelity International Real Estate Fund Company 11
Fidelity International Real Estate Fund Company 13
Fidelity International Real Estate Fund Company 14
Fidelity International Real Estate Fund Company 15
Fidelity International Real Estate Fund Company 16
Fidelity International Real Estate Fund Company 17
Fidelity International Real Estate Fund Company 18
Fidelity International Real Estate Fund Company 19
Fondation des Amis des Musées d'Art et d'Histoire, Luxembourg
g b a fund
Jose Manuel S.à r.l.
Kellogg Group S.à r.l.
Kellogg Lux III S.à r.l.
Kellogg Lux II S.à r.l.
Kellogg Lux I S.à r.l.
Kellogg Lux VI S.àr.l.
Kellogg Lux V S.à r.l.
L14 Capital Partners S.A.
Labalma S.A.
Larus Holding S.A.
LeasePlan Luxembourg S.A.
Le Petit Manoir S.à r.l.
LSREF Lux Japan Investments III S.à r.l.
LSREF Lux Japan Investments V S.à r.l.
Lubrizol Luxembourg S.à r.l.
Lux Euro-Asian Investments I S.à r.l.
Matthews Global Investors S.àr.l.
Mawi S.à r.l.
Mayroy
Mediaxim S.A.
Melchior CDO I S.A.
Metimmo SCI
Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer S. à r.l.
NTC Holding G.P.
NTC Holding G.P. & Cie S.C.A.
Org & It Consulting S.à r.l.
Ouriense S.à r.l.
Parker Hannifin Partnership S.C.S.
Pic'Art S.A.
Piquet, Price & Partners S.A.
Piquet, Price & Partners S.A.
Polar Windows S.à r.l.
Rembrandt III S.à r.l.
Rembrandt V S.à r.l.
TPG TM V, S.à r.l.
Venezuela Cable Service Holdings S.à r.l.
Woolpas S.A.