This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2122
10 septembre 2011
SOMMAIRE
Aron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101856
Auchan Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101852
Finagest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101853
Holmani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101856
Holmani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101856
Horses Farm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101810
Hospitality Services Luxembourg S.A. . . .
101810
I.C.C.A. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101821
Icon 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101822
Ignition Luxembourg AWS Holdings, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101821
Ignition Luxembourg AWS Holdings, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101822
IGS Ingenieurgesellschaft für Schadenana-
lyse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101823
Imagine Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
101823
Immobal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101823
Immobilière 166 GR S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
101823
Immo Heima S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101823
International Safety Hard Alloy Corpora-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101822
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101822
Inter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101824
Inversiones Ampudia S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
101824
In Vogue S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101824
Ipes (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
101822
Isis Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101824
Jade Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101836
Jans-1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101836
JCM Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101837
John Deere Cash Management S.A. . . . . . .
101835
John Deere Cash Management S.A. . . . . . .
101835
John Deere Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
101836
John Deere Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
101836
Kalvin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101837
Kalvin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101837
Karmi Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101837
Kellner Group & Associés S.A. . . . . . . . . . .
101838
KIGA s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101837
Kihn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101838
Klee Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101838
Knightlights Property International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101839
Kodesh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101839
Kodesh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101850
Kodesh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101838
Kodesh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101850
Koho Investments (Luxembourg) S.A. . . .
101850
Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
101837
Kurti Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101850
Kurti Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101851
Kurti Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101851
Kurti Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101850
LaMAGGESE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101851
Leica Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101851
Lonworld S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101852
Lowainvest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101855
LSF Marseille S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101855
Luxcasa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101855
L.V. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101851
Premicon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101852
RE Debt Strategy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101810
SPS Platin Securitisation S.A. . . . . . . . . . . .
101825
Telex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101839
101809
L
U X E M B O U R G
Horses Farm S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 118.223.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101051/9.
(110114804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Hospitality Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles De Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 96.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101052/9.
(110115265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
RE Debt Strategy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 161.570.
STATUTES
In the year two thousand and eleven,
on the seventeenth day of June.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“Stichting RE Debt Strategy”, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, having its sta-
tutory office in Rotterdam, The Netherlands, its office address at Spoorhaven 88, 2651AV Berkel en Rodenrijs, (The
Netherlands) and registered with the Dutch Chamber of Commerce (Handelsregister) under number 52935531.
here represented by Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvaux, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy given under private seal given on 16 June 2011,
which proxy, after been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Compartments, Duration
1. Form, Corporate name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") go-
verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The
Company shall be subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation
Law").
1.2 The Company exists under the name of "RE Debt Strategy S.A.".
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders
by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.
2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole
Director") is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.
2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
101810
L
U X E M B O U R G
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole
Director.
3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several
securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.
3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through
another entity or synthetically, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or
part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be
financed by the issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on
the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company is not subject to any risk-
diversification requirements.
3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense
of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;
(b) subscribe or acquire any other participations in companies, partnerships or other undertakings, which do not qualify
as securities or financial instruments, provided that the Company will not actively intervene with the management of such
undertakings in which it holds a holding, directly or indirectly;
(c) acquire loan receivables which may or may not be embedded in securities;
(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial ins-
truments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;
(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;
(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)
and any similar transactions;
(g) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity
securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and
(h) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund
the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company
acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any
agreement entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within the
context of the transaction.
3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development.
4. Compartments.
4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors or the Sole Director is entitled to create one
or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.
4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder
and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.
4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company
attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other
creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that
compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors or the Sole Director may allocate
such assets to another compartment or to the general estate of the Company.
4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may
be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Board of Directors or the Sole Director
between the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis
as it may deem more appropriate.
4.5 The Board of Directors or the Sole Director or its delegates, shall establish and maintain separate accounting
records for each compartment of the Company.
4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Directors or by the Sole Director.
5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
101811
L
U X E M B O U R G
Chapter II - Capital
6. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and
ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, partly paid up (by 25%).
7. Form of the shares. The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions. The ownership
of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.
8. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and
upon conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount
called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.
9. Modification of capital.
9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or by
resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III - Bonds, notes and other debt instruments
10. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or
bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or con-
verted into bearer form.
Chapter IV - Directors, board of directors, approved statutory auditor(s)
11. Board of directors or sole director.
11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least
three members (the "Directors" and each a"Director"), who need not be shareholders.
11.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders,
it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the shareholders
noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of
the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a
permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal
entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.
11.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders deciding on the re-
muneration and the term of appointment for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed
at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors
have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected
for six years from the date of his election.
11.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, resignation or
otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy
until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. In the event of vacancy of the
Sole Director because of death, retirement, resignation or otherwise, an extraordinary general meeting of the Sharehol-
ders or the Sole Shareholder shall elect a Director to fill such vacancy. In case of resignation, the resigning Director will
remain in function until his/her successor has been appointed.
12. Meetings of the board of directors.
12.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman
may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxies.
12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his
proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.
12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
12.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that
each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology,
shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
101812
L
U X E M B O U R G
12.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the
Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by
fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings,
duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
12.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event
such vote is confirmed in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts
shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
13. General powers of the board of directors or the sole director.
13.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of adminis-
tration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director.
13.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose
of the assets of the Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors or the Sole Director
deems appropriate.
14. Delegation of powers.
14.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs
of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members
of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under
such terms and with such powers as the Board of Directors or the Sole Director shall determine.
14.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons
who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
15. Representation of the Company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a
Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the joint signatures
of any two Directors or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any
two Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.
16. Approved statutory auditor(s).
16.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises
agréé(s)) appointed by the Board of Directors or the Sole Director.
16.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with
the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
16.3 The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.
Chapter V - General meeting of shareholders
17. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.
17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting
of shareholders and shall take the decision in writing.
17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. Its resolutions are binding for all shareholders of the Company, irrespective of classes of shares they
hold.
17.4 Any general meeting shall be convened in accordance with the 1915 Law by means of convening notice sent to
each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. In the event that all the share-
holders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may
waive all convening requirements and formalities of publication.
17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive
or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three
(3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to, shall be taken into account.
17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the de-
liberations and resolutions are transmitted on a continuous basis.
101813
L
U X E M B O U R G
17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
17.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by two-thirds of the votes cast of the shareholders present
or represented.
17.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.
18. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg, on the first Friday of
February of each year at 3.00 p.m., If such day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held
on the next following business day.
19. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened
at the written request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company with an
indication of the agenda.
20. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general
meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
Chapter VI - Business year, Distribution of profits
21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of September and ends on the last day of August of the
following year.
21.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It
shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the
annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such
documents.
22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This
allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.
22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and
distribution of net profits.
22.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms
prescribed by law.
Chapter VII - Dissolution, Liquidation
23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders
voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders.
23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or general meeting of shareholders, the Directors or the
Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.
Chapter VIII - Applicable law
24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the Securitisation Law.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends exceptionally on 31 August 2011.
The first annual general meeting shall be held on the first Friday of February 2012.
101814
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for three hundred and ten (310)
shares as follows:
“Stichting RE Debt Strategy”, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
All these shares have been partly paid up, each as to twenty-five percent (25%), so that the sum of seven thousand
seven hundred fifty Euro ( 7,750.- EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand two hundred euro.
<i>First resolution of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting RE Debt Strategy, considering
itself as duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the
meeting of the shareholders passed the following resolutions:
1. The Company's address is fixed at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general
meeting of shareholders to be held in 2012:
(a) Mr Peter Dickinson, company director, born on 1 March 1966 in Nuneaton, United Kingdom, with professional
address at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(b) Mrs Geneviève Blauen-Arendt, company director, born on , 28 September 1962 in Arlon, Belgium, with professional
address at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
(c) Mr Jonathan Herbert, company director, born on 19 October 1977 in Cardiff, United Kingdom, with professional
address at 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the offices of the
undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendelf, am siebzehnten Juni.
Vor Uns Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
“Stichting RE Debt Strategy”, eine Stiftung (Stichting) gegründet nach dem Recht der Niederlande mit Sitz in Spoor-
haven 88, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, Rotterdam, die Niederlande, eingetragen bei der Handelskammer der Nieder-
lande (Handelsregister) unter der Nummer 52935531,
hier vertreten durch Herrn Brendan D. KLAPP, Angestellter, geschäftsansässig in Beles, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer ihm, am 16. Juni erteilten privatschriftlichen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den unterzeich-
neten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen
eingereicht wird.
Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu errichten wünscht.
Kapitel I.- Firma, Sitz, Gesellschaftszweck, Sondervermögen, Dauer des Bestehens
1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt
dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").
1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Firmennamen "RE Debt Strategy S.A.".
101815
L
U X E M B O U R G
2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"),
beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderun-
gen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung in eine andere Gemeinde innerhalb des Groß-
herzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft
(der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der
sich der Sitz der Gesellschaft befindet.
2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorste-
hen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem
Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände
vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt,
die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins
Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende
und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbergesellschaft und/oder Emittentin zu fungieren.
3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar oder über eine andere
Gesellschaft oder synthetisch Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder
Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der
Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst
oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesell-
schaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt.
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keinen Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.
3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:
(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital-oder Personengesellschaften
begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwer-
ben;
(b) andere Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder anderen Unternehmen
zu erwerben, die nicht als Wertpapiere oder Finanzinstrumente qualifizieren, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nicht
aktiv in das Management solcher Unternehmen eingreift, in welchen sie, direkt oder indirekt, Unternehmensbeteiligungen
hält;
(c) Darlehensforderungen zu erwerben, die verbrieft oder unverbrieft sein können;
(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente
verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an
den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfand-
rechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;
(e) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte
abschließen;
(f) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen
abschließen und durchführen;
(g) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte
ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt
und
(h) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum
Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner,
sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr
aufgrund der von ihr gehaltenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren
Tätigkeiten abgeschlossen hat und insoweit diese im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich
erscheinen.
3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,
die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.
4. Sondervermögen.
4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat berechtigt, ein oder
mehrere Sondervermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft ent-
sprechen.
101816
L
U X E M B O U R G
4.2 Unter Vorbehalt des Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind,
ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusam-
menhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind.
4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der
Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen
aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen
Kreditverbindlichkeiten oder Gründung, Verwaltung oder Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind,
noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwal-
tungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte auf die anderen Sondervermögen oder die allgemeine Vermögensmasse
der Gesellschaft umverteilen darf.
4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung eines bestimmten
Sondervermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder
von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat auf die Aktiva der einzelnen Sondervermögen auf pro rata
Basis oder auf jede andere Weise aufgeteilt werden, die als geeignet erscheint.
4.5 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat beziehungsweise seine Bevollmächtigten sollen einzelne
Kontenführungsberichte für jedes Sondervermögen der Gesellschaft erstellen und führen.
4.6 Die Auflösung von Sondervermögen kann von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat beschlossen
werden.
5. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II. - Kapital
6. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in drei-
hundertzehn (310) Anteile als Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR) und ist
teilweise einbezahlt (25%).
7. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen.
Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesell-
schaft geführt wird.
8. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren,
können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwal-
tungsrat jeweils festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll
eingezahlten Anteilen zu gleichen Teilen eingefordert.
9. Kapitalerhöhungen oder -Herabsetzungen.
9.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Ak-
tionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen für die Satzungsänderungen gelten
entsprechen muss.
9.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.
Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel
10. Namens- oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als
Namens-oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als Na-
menspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.
Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, zugelassener Wirtschaftsprüfer
11. Verwaltungsrat oder alleiniger Verwaltungsrat.
11.1 Im Falle des Vorhandenseins einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen
Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein
"Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.
11.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der
Aktionäre festgestellt, dass nur ein Aktionär besteht, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu
führen, bestehend entweder aus einem einzigen Verwaltungsratsmitglied, genannt der alleinige Verwaltungsrat, bis zum
Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die das Bestehen von mehr als einem Aktionär feststellt oder
bestehend aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats
sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens
und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines
Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.
11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Akti-
onäre gewählt, sowie ihre Vergütung und der Zeitraum, für welchen sie gewählt werden, der sechs Jahre nicht
überschreiten soll und können wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung
101817
L
U X E M B O U R G
ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwal-
tungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt es als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung
ernannt.
11.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds oder
aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer
Mehrheit der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung
stattfindet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird. Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes,
Ausscheidens, Rücktritts des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, soll eine außerordent-
liche Hauptversammlung der Aktionäre oder der Alleinaktionär ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz
ausfüllt. Im Fall des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds, bleibt das zurücktretende Verwaltungsratsmitglied solange
im Amt, bis sein/ihr Nachfolger ernannt worden ist.
12. Sitzungen des Verwaltungsrats.
12.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann
von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann,
wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.
12.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied
einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Ein-
haltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.
12.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.
12.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes
Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes
Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Abstimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
12.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt,
dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese
Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt
per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
12.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-
terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolution circulaire). Die Zustimmung kann in
einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem
Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwal-
tungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
12.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon,
wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmit-
gliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
13. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats oder des alleinigen Verwaltungsrats.
13.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme
von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts
wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des
Verwaltungsrats oder der alleinige Verwaltungsrats.
13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in einer
Weise und für eine solche Ausgleichszahlung zu verkaufen, übertragen, abzutreten, belasten oder anderweitig darüber zu
verfügen, wie sie der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat für angemessen erachtet.
14. Übertragung von Befugnissen.
14.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der
Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft
handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat oder der alleinige
Verwaltungsrat fest.
14.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch
an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte
und Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.
101818
L
U X E M B O U R G
15. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen
Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmit-
gliedern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift der
Person, die eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern übertragen wurde, jedoch nur, soweit
diese Befugnis reicht.
16. Zugelassener Wirtschaftsprüfer.
16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftsprüfern (ré-
viseur(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, welche(r) vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat gewählt wird.
16.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird aus dem Kreis der bei der Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfer gewählt und für eine bestimmte Zeit bestellt.
16.3 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.
Kapitel V. - Hauptversammlung
17. Befugnisse des Alleinaktionärs/der Hauptversammlung.
17.1 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär zum Zeitpunkt ihrer Gründung haben, oder wenn alle Anteile der
Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auf-
lösung der Gesellschaft.
17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser sämtliche Befugnisse erhalten, die der Hauptversammlung
zustehen; Beschlussfassungen sollen schriftlich durch den Alleinaktionär erfolgen.
17.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre
der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von
Angelegenheiten der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche
Klassen von Anteilen sie halten.
17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwal-
tungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungs-
mitteilung per Einschreiben erfolgen. Sofern sämtliche Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder
ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden,
können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung
der Tagesordnung verzichten.
17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder
durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss,
und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu
lassen.
17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder
Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der
Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird,
eingegangen sind, werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt.
17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie
identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit
und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht
geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
ständig zu übertragen sind.
17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß
einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, ungeachtet des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.
17.9 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirk-
sam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der
Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Ver-
sammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen
werden. In der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der
vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versamm-
lung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer
Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.
17.10 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten
der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfor-
dernisse beschlossen werden.
18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Freitag im Februar
um 15.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmitteilung näher angegeben wird.
101819
L
U X E M B O U R G
Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird die Jahreshauptversammlung an dem nächstfolgenden Geschäftstag
abgehalten.
19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine
Hauptversammlung ist auf schriftliches Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals
der Gesellschaft vertreten unter Angabe der Tagesordnung.
20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jah-
reshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats September und endet am letzten Tag des
Monats August des darauffolgenden Jahres.
21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung er-
stellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der
Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorge-
legten Unterlagen erstellen.
22. Gewinnausschüttung.
22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5%) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine
solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens
ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.
22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Ver-
wendung und Ausschüttung der Nettogewinne.
22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen
Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
23. Auflösung, Liquidation.
23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst
werden, für den dieselben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung
der Satzung.
23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Hauptver-
sammlung bestellte Liquidatoren.
23.3 Wenn keine Liquidatoren von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Ver-
waltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).
Kapitel VIII. Geltendes Recht
24. Geltendes recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des
Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet ausnahmsweise am 31. August 2011.
Die erste Generalversammlung findet am ersten Freitag im Monat Februar 2012 statt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei 310 (dreihundertzehn) Anteile wie nachstehend
angegeben gezeichnet:
“Stichting RE Debt Strategy”, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile
TOTAL: dreihundertzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Anteile
Diese Anteile sind teilweise eingezahlt, jeder zu fünfundzwanzig Prozent (25%), so dass der Betrag von siebentausend-
siebenhundertfünfzig Euro (7.750.- EUR) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar
nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von
1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.
101820
L
U X E M B O U R G
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer
Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf tausendzweihundert Euro ge-
schätzt.
<i>Erste Beschlüsse des Alleinaktionärsi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting RE Debt Strategy, die die
Versammlung als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung
der Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Als Anschrift der Gesellschaft wird 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
vorgesehen.
2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre
2012 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
(a) Herr Peter Dickinson, Geschäftsführer, geboren am 1. März 1966, in Nuneaton, Großbritannien, geschäftsansässig
in 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
(b) Frau Geneviève Blauen-Arendt, Geschäftsführer, geboren am 28. September 1962, in Arlon, Belgien, geschäftsan-
sässig in 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und
(c) Herr Jonathan Herbert, Geschäftsführer, geboren am 19. Oktober 1977, in Cardiff, Großbritannien, geschäftsan-
sässig in 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache mächtig, aktiert hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten
erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt.
Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, wird der englische Text maßgebend sein.
Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Beles, Großherzogtum Luxemburg, in der Amtsstube des
amtierenden Notars, an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg errichtet.
Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam
mit dem amtierenden Notar diese Originalurkunde.
Gezeichnet: B. D. KLAPP, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 20. Juni 2011. Relation: EAC/2011/7979. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-
EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2011086343/613.
(110096592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.
I.C.C.A. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 76.298.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101055/10.
(110115655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Ignition Luxembourg AWS Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 141.407.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101056/11.
(110115355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101821
L
U X E M B O U R G
Ignition Luxembourg AWS Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 141.407.
Il résulte d'une décision des associés de la société en date du 21 juin 2011 que le siège social de la société est transféré
du 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101057/13.
(110115361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
International Safety Hard Alloy Corporation, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 1.957.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101058/10.
(110115108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.025.850,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 84.221.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101059/10.
(110115810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Ipes (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 150.156.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2011.
Référence de publication: 2011101061/10.
(110115680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Icon 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.611.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101064/10.
(110115453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101822
L
U X E M B O U R G
IGS Ingenieurgesellschaft für Schadenanalyse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6619 Wasserbillig, 7, rue Roger Streff.
R.C.S. Luxembourg B 138.254.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101065/9.
(110115607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Imagine Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 117.964.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101066/10.
(110115422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Immo Heima S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 1, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 107.671.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HEINEN Roger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011101067/11.
(110114718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Immobal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 101.331.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée généralei>
<i>extraordinaire tenue au siège social en date du 18 juillet 2011i>
La démission de Monsieur Mohammed KARA de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Jean-Marc HEITZ, comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de
la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
Pour extrait sincère et conforme
IMMOBAL S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011101069/16.
(110115705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Immobilière 166 GR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 129.220.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101071/10.
(110115032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101823
L
U X E M B O U R G
In Vogue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 142.944.
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale des associés, qui s’est tenue en date du 06 juillet 2011 à 14 heures 30, que:
- le mandat de gérant du sieur Mehdi Mostefa Sba, demeurant à F- 54400 Longwy, 59, avenue Raymond Poincaré, a
été révoqué;
- ont été nommés comme gérants:
1. Monsieur Jaoiad AISSA, demeurant à F-54350 Mont-Saint-Martin, 14, rue des Coquelicots, comme gérant technique;
2. Monsieur Fouad HANINI, demeurant à F- 54430 Rehon, 12, rue Virvaux, comme gérant administratif.
Luxembourg, le 18 juillet 2011.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011101072/17.
(110114793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.859.
Les comptes annuels pour la période du 28 décembre 2009 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101073/11.
(110115814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Inversiones Ampudia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 86.425.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliaraire
i>Signatures
Référence de publication: 2011101075/13.
(110115249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Isis Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R.C.S. Luxembourg B 105.877.
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui s’est tenue en date du 17 juin 2011 que le mandat du Com-
missaire aux Comptes, la société FINORTRUST S.A., numéro d’immatriculation CH-660-0014958-8, avec siège social au
1, Carrefour de Rive, CH-1207 Genève, Suisse a été reconduit, avec effet immédiat et pour une durée d'un an jusqu'à
l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2011101076/13.
(110115205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101824
L
U X E M B O U R G
SPS Platin Securitisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 161.571.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, den siebzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile SCHLESSER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.
Ist erschienen:
"Stichting SPS Platin", eine Stiftung (Stichting) gegründet nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in NL-1017 CA
Amsterdam, 450, Herengracht, eingetragen bei der Handelskammer von Amsterdam unter der Nummer 52932850,
vertreten durch Herrn Rolf CASPERS, Bankangestellter, beruflich wohnhaft in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad
Adenauer,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 16. Juni 2011, die, durch die erschienene Person und den unter-
zeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den
Registerstellen eingereicht wird.
Die Komparentin, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu errichten wünscht:
Kapitel I.- Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Gesellschaftszweck
1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt
dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").
1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Firmennamen "SPS Platin Securitisation S.A.".
2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"),
beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderun-
gen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb
des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb
der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.
2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorste-
hen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem
Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände
vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt,
die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins
Ausland trifft der Verwaltungsrat.
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende
und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbergesellschaft und/oder Emittent zu fungieren.
3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere
Gesellschaft Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten
Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die
Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere
Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder Genussscheine ausgeben, deren
Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt. Klarstellend wird
darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keinen Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.
3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:
(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital-oder Personengesellschaften
begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwer-
ben;
(b) ihre Vermögenswerte in einer Weise und zu einem Gegenwert verkaufen, übertragen, abtreten oder belasten oder
anderweitig darüber verfügen, wie von dem Verwaltungsrat oder einer anderen mit dieser Aufgabe betrauten Person zu
dem betreffenden Zeitpunkt genehmigt;
101825
L
U X E M B O U R G
(c) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente
verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an
den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfan-
drechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;
(d) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte
abschließen;
(e) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen
abschließen und durchführen;
(f) Anleihen, Schuldverschreibungen, Genussscheine oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten)
oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen
Risiken abhängt; und
(g) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum
Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner,
sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr
aufgrund der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit
ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat und insoweit diese im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich
erscheinen.
3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,
die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.
4. Sondervermögen.
4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen auch so-
genannte "Compartments" zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft
entsprechen.
4.2 Unter Vorbehalt des Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind,
ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusam-
menhang mit der Einrichtung, dem Betrieb oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind.
4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der
Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen
aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen
Kreditverbindlichkeiten oder Einrichtung, Betrieb oder Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind,
noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat diese überschüssigen Ver-
mögenswerte auf die anderen Sondervermögen oder die allgemeine Vermögensmasse der Gesellschaft umverteilen darf.
4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Auflösung eines bestimmten
Sondervermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder
vom Verwaltungsrat auf die Aktiva der einzelnen Sondervermögen auf pro rata Basis oder auf jede andere Weise aufgeteilt
werden, die als geeignet erscheint.
4.5 Der Verwaltungsrat beziehungsweise seine Bevollmächtigten sollen einzelne Kontenführungsberichte für jedes
Sondervermögen der Gesellschaft erstellen und führen.
4.6 Die Auflösung von Sondervermögen kann von dem Verwaltungsrat beschlossen werden.
5. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II.- Kapital
6. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00), eingeteilt in drei-
hundertzehn (310) Anteile als Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100,00) und ist
vollständig einbezahlt.
7. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen.
Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesell-
schaft geführt wird.
8. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren,
können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit jeweils fest-
gelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll eingezahlten Anteile
zu gleichen Teilen eingefordert.
9. Kapitalerhöhungen oder -Herabsetzungen.
9.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs oder der Aktionäre erhöht
oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen muss.
9.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.
101826
L
U X E M B O U R G
Kapitel III.- Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel
10. Namens- oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als
Namens-oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere
begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.
Kapitel IV.- Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, unabhängiger Wirtschaftsprüfer
11. Verwaltungsrat.
11.1 Die Geschäfte der Gesellschaft sind durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern
besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein "Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre
handeln muss.
11.2 Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person
einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige
juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger
ernennt.
11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von höchs-
tens sechs Jahren bestellt und können wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Haupt-
versammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn
ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt dieses als für einen Zeitraum von sechs Jahren
ab Ernennung ernannt.
11.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes oder Ausscheidens eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus
anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Mehrheit
der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Platz besetzt, bis die nächste Hauptversammlung statt-
findet, die zur Ratifizierung dieser Wahl aufgefordert werden wird.
12. Sitzungen des Verwaltungsrats.
12.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann
von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann,
wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.
12.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied
einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Ein-
haltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.
12.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.
12.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich, wie beis-
pielsweise per Fax oder per E-mail, ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was
einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Abstimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
12.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder Benutzung von Telekommunikationsmedien, ist erlaubt, vorausgesetzt,
dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese
Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt
per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
12.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-
terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen. Die Zustimmung kann in einem oder mehreren
gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem Wege gefasste Bes-
chlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrats gefasste
Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
12.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon,
wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.
12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmit-
gliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
13. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats.
13.1 Dem Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs und
Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts wegen oder durch
diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
101827
L
U X E M B O U R G
13.2 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft im Einklang mit dem Ver-
briefungsgesetz zu übertragen, abzutreten und darüber zu verfügen.
14. Übertragung von Befugnissen.
14.1 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung
der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder andere Hand-
lungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss; die näheren
Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat fest.
14.2 Der Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch an Personen übertragen, die keine
Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte und Angestellte anstellen und entlas-
sen und deren Bezüge festlegen.
15. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, durch die gemeinsame
Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift der Person, die eine solche Unters-
chriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.
16. Eingetragene(r) unabhängige(r) Wirtschaftsprüfer.
16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren eingetragenen unabhängigen Wirt-
schaftprüfern (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, die vom Verwaltungsrat ernannt werden.
16.2 Die/der unabhängige(n) eingetragene(n) Wirtschaftsprüfer sind/ist auf bestimmte Zeit aus den bei der Commission
de Surveillance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfern ernannt.
16.3 Die/der unabhängige(n) eingetragene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.
Kapitel V. - Hauptversammlung
17. Befugnisse des Alleinaktionärs / der Hauptversammlung.
17.1 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär zum Zeitpunkt ihrer Gründung haben, oder wenn alle Anteile der
Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflö-
sung der Gesellschaft.
17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, erhält dieser sämtliche Befugnisse, die der Hauptversammlung zustehen;
Beschlussfassungen erfolgen schriftlich durch den Alleinaktionär.
17.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre
der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von
Angelegenheiten der Gesellschaft.
17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwal-
tungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungs-
mitteilung per Einschreiben erfolgen. Sofern sämtliche Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder
ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden,
können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung
der Tagesordnung verzichten.
17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder
durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss,
und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu
lassen.
17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Stimmzettels, das eine Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung
vorsieht im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Stimmzettel, die spätestens drei (3) Tage vor der Hauptversammlung
bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird, eingegangen sind,
werden bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt.
17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie
identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit
und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht
geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
ständig zu übertragen sind.
17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß
einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, ungeachtet des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.
17.9 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirk-
sam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der
Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Ver-
sammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen
werden. In der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der
vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versamm-
101828
L
U X E M B O U R G
lung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer
Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.
17.10 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten
der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfor-
dernisse beschlossen werden.
18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am fünfundzwanzigsten Juni
um elf Uhr oder der letzte Werktag davor sollte der fünfundzwanzigsten Juni auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen
Feiertag fallen, und erstmalig im Jahr zweitausendzwölf, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der
Einberufungsmitteilung näher angegeben wird.
19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine
Hauptversammlung ist auf Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals der Gesell-
schaft vertreten.
20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jah-
reshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft
beginnt und am 31. Dezember 2011 endet.
21.2 Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss. Er legt diesen Jahresabschluss zusammen mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftprüfern
vor, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten Unterlagen erstellen.
22. Gewinnausschüttung.
22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5%) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine
solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens
ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.
22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Ver-
wendung und Ausschüttung der Nettogewinne.
22.3 Der Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interimsdividenden
auszuschütten.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
23. Auflösung, Liquidation.
23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, für den die selben Anforderungen
an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung der Satzung.
23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär
oder von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.
23.3 Wenn keine Liquidatoren vom Alleinaktionär oder von der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Ver-
waltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).
Kapitel VIII. - Geltendes Recht
24. Geltendes recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des
Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach Gründung der Gesellschaft hat "Stichting SPS Platin", vorgenannt und vertreten wie vorerwähnt, die dreihun-
dertzehn (310) Anteile gezeichnet.
Diese Anteile sind sämtlich voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00)
der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von
1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.
101829
L
U X E M B O U R G
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer
Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf zirka viertausend Euro (EUR
4.000,00) geschätzt.
<i>Erste Beschlüsse des alleinaktionärsi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Komparentin, die die Versammlung als
ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse
der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Als Anschrift der Gesellschaft wird L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer, vorgesehen.
2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre
zweitausenddreizehn abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:
(a) Frau Heike KUBICA, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 23. Juli 1974 in Lutherstadt Eisleben (Deutschland),
beruflich wohnhaft in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer,
(b) Frau Anja LAKOUDI, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 23. Dezember 1977 in Schlema (Deutschland), beruflich
wohnhaft in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer,
(c) Herr Daniel KRANZ, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 10. März 1972 in Trier (Deutschland), beruflich wohn-
haft in L-1341 Luxemburg, 7, Place de Clairefontaine.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist erklärt, dass auf Wunsch der Erschienenen, die vorlie-
gende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung. Auf Anfrage der gleichen Person
und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.
Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg
errichtet.
Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam
mit dem Notar diese Originalurkunde.
Follows the English translation of the foregoing text:
In the year two thousand and eleven, on the seventeenth day of June.
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
There appeared:
"Stichting SPS Platin", a foundation (Stichting) established under the laws of the Netherlands, having its office in NL-1017
CA Amsterdam, 450, Herengracht, registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 52932850,
represented here by Mr. Rolf CASPERS, bank employee, residing professionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard
Konrad Adenauer,
by virtue of a proxy under private seal given on 16 June 2011, which, initialled "ne varietur" by the appearing person
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish:
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration
1. Form, Corporate name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") gov-
erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles"). The Company shall be
subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation Law").
1.2 The Company exists under the name of "SPS Platin Securitisation S.A.".
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders
by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.
2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") is authorised to change the address of the
Company inside the municipality of the Company’s registered office.
2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely
to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
101830
L
U X E M B O U R G
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.
3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several
securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.
3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through
another entity, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the
activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the
issuance of securities, bonds, notes, certificates or participating certificates by itself or by another securitisation entity
the value or return of which depend on the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the
Company is not subject to any risk-diversification requirements.
3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense
of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;
(b) sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of its assets in such manner and for such compensation as the
Board of Directors, or any person appointed for such purpose shall approve at such time;
(c) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instru-
ments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;
(d) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;
(e) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)
and any similar transactions;
(f) issue bonds, notes, certificates, participating certificates or any other form of debt securities (including by way of
participation interest) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by
the Company; and
(g) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund
the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company
acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any
agreement entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within in the
context of the transaction.
3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development.
4. Compartments.
4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors is entitled to create one or more compartments
corresponding each to a separate part of the Company's estate.
4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder
and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.
4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company
attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other
creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that
compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors may allocate such assets to another
compartment or to the general estate of the Company.
4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may
be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Board of Directors between the Com-
pany's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis as it may deem
more appropriate.
4.5 The Board of Directors or its delegates, shall establish and maintain separate accounting records for each com-
partment of the Company.
4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Directors.
5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital
6. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00), divided into three hundred and
ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, fully paid up.
7. Form of the shares. The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.
101831
L
U X E M B O U R G
The ownership of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.
8. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and
upon conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.
9. Modification of capital.
9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or the
shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.
9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.
Chapter III. - Bonds, notes and other debt instruments
10. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or
bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into
bearer form.
Chapter IV. Directors, Board of directors, Independent auditors
11. Board of directors.
11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least
three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.
11.2 A legal entity may be a member of the Board of Directors of the Company. In such case, such legal entity must
designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The
relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.
11.3 The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are
re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in
function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his
mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
11.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
12. Meetings of the board of directors.
12.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman
may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.
12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the
Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.
12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented
by proxies.
12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, including for example by
fax or email, another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman
has a casting vote.
12.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that
each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology,
shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the
Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by
fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings,
duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
12.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event
such vote is confirmed in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts
shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.
13. General powers of the board of directors.
13.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the Board of Directors.
101832
L
U X E M B O U R G
13.2 The Board of Directors is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in accordance
with the Securitisation Law.
14. Delegation of powers.
14.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board
of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms
and with such powers as the Board shall determine.
14.2 The Board of Directors may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be
Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
15. Representation of the Company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be bound by the
signatures of any two Directors together or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be
delegated by any two Directors of the Company, but only within the limits of such power.
16. Approved statutory auditor(s).
16.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises
agréé(s)) appointed by the Board of Directors.
16.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with
the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
16.3 The registered statutory auditor(s) is/are re-eligible.
Chapter V. - General meeting of shareholders
17. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be
held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.
17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of
shareholders and takes the decision in writing.
17.3 In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
17.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by
registered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and
if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and
formalities of publication.
17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive
or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, are only taken into account the forms received
by the company three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to.
17.7 The shareholders are entitled to participate to the meeting by visioconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
retransmitted in a continuing way.
17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.
17.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds of the votes cast of the shareholders
present or represented.
17.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be
increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.
18. Place and date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held
in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on twenty-fifth June
at eleven o’clock, or the previous business day in case the twenty-fifth June falls on a Saturday, Sunday or public holiday
and for the first time in two thousand and twelve.
101833
L
U X E M B O U R G
19. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened
at the request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company.
20. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general
meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.
Chapter VI. - Business year, Distribution of profits
21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2011.
21.2 The Board of Directors draws up the annual accounts. It submits these annual accounts together with a report
of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the external
auditors who shall make a report containing comments on such documents.
22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This
allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.
22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and
distribution of net profits.
22.3 The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VII. - Dissolution, Liquidation
23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum
as for the amendment of the Articles.
23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.
23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors
shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.
Chapter VIII. - Applicable law
24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law
and the Securitisation Law.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, "Stichting SPS Platin" prenamed and represented as aforesaid, has subscribed
for the three hundred and ten (310) shares.
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00) is
forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about four thousand Euro (EUR 4,000.00).
<i>First resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed party, considering itself as duly convened,
representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of the shareholders
passed the following resolutions:
1. The Company’s address is fixed at L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general
meeting of shareholders to be held in two thousand and thirteen:
(a) Mrs. Heike KUBICA, company director, born on 23 July 1974 in Lutherstadt Eisleben (Germany), residing profes-
sionally in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer,
(b) Mrs. Anja LAKOUDI, company director, born on 23 December 1977 in Schlema (Germany), residing professionally
in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer,
101834
L
U X E M B O U R G
(c) Mr. Daniel KRANZ, company director, born on 10 March 1972 in Trier (Germany), residing professionally in L-1341
Luxembourg, 7, Place de Clairefontaine.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in German followed by an English version.
On request of the same appearing person and in case of divergences between the German and the English texts, the
German version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Gezeichnet: R. Caspers, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juin 2011. Relation: LAC/2011/28036. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. Juni 2011.
Référence de publication: 2011086397/563.
(110096601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.
John Deere Cash Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.957.
<i>Rectificatif au document L090181100 déposé au RCSL le 25 novembre 2009 concernant l'adresse du siège sociali>
Le siège social de John Deere Cash Management S.A. (la "Société") a été transféré à l'adresse 43, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 12 octobre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2011.
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT S.A.
Nils C. Jaeger / Mark Theis
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2011101077/15.
(110115115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
John Deere Cash Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.957.
Messieurs Nils C. JAEGER et Mark THEIS, administrateurs et Madame Nathalie PREVOST, commissaire aux comptes
de John Deere Cash Management S.A. (la "Société") ont changé leur adresse professionnelle avec effet au 12 octobre
2009.
Leur nouvelle adresse est 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2011.
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT S.A.
Nils C. Jaeger / Mark Theis
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2011101078/16.
(110115150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101835
L
U X E M B O U R G
John Deere Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.958.
<i>Rectificatif au document L090181095 déposé au RCSL le 25 novembre 2009 concernant l'adresse du siège sociali>
Le siège social de John Deere Funding S.A. (la "Société") a été transféré à l'adresse 43, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg avec effet au 12 octobre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2011.
JOHN DEERE FUNDING S.A.
Nils C. Jaeger / Mark Theis
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2011101079/15.
(110115177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
John Deere Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.958.
Messieurs Nils C. JAEGER et Mark THEIS, administrateurs et Madame Nathalie PREVOST, commissaire aux comptes
de John Deere Funding S.A. (la "Société") ont changé leur adresse professionnelle avec effet au 12 octobre 2009.
Leur nouvelle adresse est 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2011.
JOHN DEERE FUNDING S.A.
Nils C. Jaeger / Mark Theis
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2011101080/15.
(110115191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Jade Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 137, rue Kuelebierg.
R.C.S. Luxembourg B 87.439.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101081/9.
(110115721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Jans-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 152.921.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2011.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011101083/14.
(110114743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101836
L
U X E M B O U R G
JCM Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 146.685.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101084/9.
(110114785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
KIGA s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8715 Everlange, 16, rue de la Halte.
R.C.S. Luxembourg B 144.200.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101087/9.
(110114826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 147.724.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Signature
<i>Administrateur / Géranti>
Référence de publication: 2011101088/12.
(110115575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kalvin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 100.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101089/9.
(110114813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kalvin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 100.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101090/9.
(110114814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Karmi Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 101.127.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 13 juillet 2011 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2013:
- Richard CALLERI, 34, Bryanston Square, London W1H 2DY, Administrateur et Président;
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, et Administrateur-délégué;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
101837
L
U X E M B O U R G
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011101091/15.
(110114758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kellner Group & Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 123.267.
Il résulte d'une délibération du conseil d'administration que Monsieur Jacques PEFFER, réviseur d'entreprises agréé,
né à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), le 15 avril 1972, demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange,
1, rue Pletzer, a été nommé à la fonction de président du conseil d'administration de la société "KELLNER GROUP &
ASSOCIES S.A.".
Luxembourg, le 15 juillet 2011.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011101092/15.
(110115078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kihn, Société Anonyme.
Siège social: L-3754 Rumelange, 17, rue de l'Usine.
R.C.S. Luxembourg B 10.160.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101094/9.
(110114820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kodesh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 81.586.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assembléei>
<i>Générale Extraordinaire tenue le 8 décembre 2008i>
<i>Résolutionsi>
Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée générale décide de révoquer la société ASYRIS S.A. de son poste de Réviseur d’Entreprise.
2. L’assemblée générale décide de nommer au poste de Réviseur d’Entreprise la société TEAMAUDIT SA ayant son
siège 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg jusqu'à l’assemblée à tenir en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101099/15.
(110115631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Klee Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 36.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101095/10.
(110114687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101838
L
U X E M B O U R G
Knightlights Property International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 107.499.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101097/10.
(110115824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kodesh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 81.586.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101098/10.
(110115513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Telex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 157.581.
In the year two thousand and eleven on June 10
th
.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned,
APPEARED
1) The company MGP Telex S.àr.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg in the form of a private
limited liability company, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered
with the Luxembourg company and commercial register under number B157582,
here represented by Pierre Lancelin, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
2) The company Valfore S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg in the form of a private limited
liability company, having its registered office at 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg company and commercial register under number B132039,
here represented by Pierre Lancelin, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
Which proxies shall be signed “ne varietur” by the representative of the above named parties and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
The prenamed parties represent all the partners of “Telex S.à r.l.”, having its registered office at 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg company and commercial register under number
B157581 incorporated by a deed of Martine DECKER on November 15, 2010, published in the Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, number 294 of February 12, 2011 (the “Company”).
All this being declared, the appearing parties, acting in their above-mentioned capacities, requested the undersigned
notary to draw up as follows:
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
(i) Reclassification of the share capital into parts of class A and of class B and allocation;
(ii) Amendment and restatement of the Company's articles of association;
(iii) Designation of the Company's current Managers as A and B Managers.
After deliberation, the Partners have unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
the Partners hereby resolve to (i) re-classify the Company's existing share capital into two classes of parts (Class A
and Class B) and (ii) allocate the Company's existing share capital as follows:
- Two hundred and fifty (250) Class A Parts shall be allocated to MGP Telex S.àr.l.;
101839
L
U X E M B O U R G
- Two hundred and fifty (250) Class B Parts shall be allocated to Valfore S.à r.l..
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend and restate the Company's articles of association, in particular (without limitation) so
that they shall read with immediate effect as follows:
Art. 1. Partners. The founding partners and all persons and entities who become partners in future (individually, the
“Partner” and collectively, the “Partners”) form a company with limited liability (the “Company”) which is governed by
the laws pertaining to such an entity, as well as by these articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Corporate Object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of
any kind, as well as the management, control and development of such participations.
2.2 The Company may also undertake the investment in and development of real estate properties, as well as real
estate management for its own purposes.
2.3 Within the limits of its activity, the Company may grant mortgages, contract loans, with or without guarantee, and
stand security for other persons or companies, within the same group. It may also borrow with or without interests in
any form and proceed to the issuance of bonds and debentures by way of private placement.
2.4 The Company may carry out any other financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected
with its objects. The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation
which it may deem useful in the accomplishment and development of its objects.
Art. 3. Duration. The Company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. Name. The Company's denomination is “Telex S.à r.l.”.
Art. 5. Registered Office.
5.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board. The registered office
may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of the Partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
5.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the Board.
5.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 6. Share Capital.
6.1 The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 12,500.-), repre-
sented by two hundred fifty (250) class A parts (the “A Parts”) and two hundred fifty (250) class B parts (the “B Parts”,
and with the A Parts, the “Parts”), each in registered form with a par value of twenty-five Pounds Sterling (GBP 25.-), all
subscribed and fully paid up.
6.2 An issue premium may be paid on each class of parts.
6.3 All classes of parts carry the same rights and obligations save as otherwise described hereinafter or in any agreement
that may be entered into amongst the Partners from time to time.
Art. 7. Transfer of Parts. The Company's Parts are freely transferable between Partners.
They may only be disposed of to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in a general meeting,
approved by a majority amounting to three-quarters of the capital and in compliance with any written agreement in force
between the Partners from time to time.
Art. 8. Events Affecting Partners. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the Partners
will not bring the Company to an end.
Art. 9. Limited Liability - Corporate Veil. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the
assets or documents of the Company in respect of their own liabilities. For the avoidance of doubt, this Article 9 shall
not prevent the Partners from pledging their parts assuming that such pledges are in compliance with article 189 of the
1915 Law and any written agreement in force between the Partners from time to time.
101840
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Board of Managers.
10.1 Board of Managers The Company is managed by a board of managers (the “Board”) composed of three (3) class
A managers and three (3) class B managers, who need not be Partners (individually, a “Manager” and collectively, the
“Managers”).
The members of the Board of Managers are appointed and designated as “class A manager” or “class B manager” by
resolutions of the Partners which sets the term of their office and, as the case may be, their remuneration. The class A
managers shall be elected and designated as such by the Partners upon proposal by the holders of the class A parts and
the class B managers shall be elected and designated as such by the Partners upon proposal by the holders of the class B
parts.
The Partners may decide to dismiss Managers without giving any reason. However, subject to any agreement that may
be entered into amongst the Partners from time to time, each Manager can only be removed and replaced upon the
request or subject to the prior written consent of the holders of the class of parts that nominated him or her.
10.2 The Partners shall appoint a chairman in respect of the Board. In the case of an equality of votes at a meeting of
the Board, the chairman shall not have a second or casting vote unless otherwise provided pursuant to the terms of any
written agreement in force between the Partners from time to time.
10.3 In dealing with third parties, the Board has the most extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its objects.
10.4 Meetings of the Board. Unless otherwise agreed by any class A Manager together with a class B Manager:
10.4.1 meetings of the Board shall be held at least once every three months and may be called by any Manager or
whenever a key decision or document has to be made/executed by the Company.
10.4.2 meetings of the Board shall ordinarily be held in Luxembourg.
10.4.3 Subject to article 0 meetings of the Board must be convened on notice to be given by registered mail, fax or
email of no less than three business days, together with an agenda identifying in reasonable detail matters to be discussed
by the Board at the meeting.
10.4.4 Subject to article 0, any relevant documents shall be distributed in advance of the meeting to all Managers so
as to ensure that they are received at least one Business Day prior to the date fixed for the meeting or otherwise as
agreed; and
10.4.5 copies of the minutes of each meeting shall be circulated within three Business Days of the meeting for execution
by all Managers who attended the meeting.
10.5 Each Manager may waive notice of any meeting either prospectively or retrospectively (in respect of himself or
any of his appointed proxies only).
10.6 The quorum for the transaction of business at meetings of the Board shall be (a) a majority of the Managers in
office (b) at least two Managers, including one class A Manager and one class B Manager and (c) provided that the same
number of class A Manager and class B Manager are present or represented.
10.7 Except as provided for in Article 13 (Reserved Matters) and subject to the Board's chairman having a casting vote
if required pursuant to the provisions of any written agreement in force between the Partners from time to time, decisions
of the Board shall be decided by simple majority vote. Each Manager shall have one vote but any Manager may be repre-
sented at any meetings of the Board by a proxy (which must be another Manager of the Company) appointed in writing
by such Manager. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed that of the appointing Manager.
10.8 If a quorum is not present within half an hour from the time set for a meeting of the Board or if during the meeting
a quorum ceases to be present, the Company shall immediately give written notice to the Managers and the meeting shall
be adjourned to a date and time not less than seven (7) business days after the date set for the meeting at the same place.
If at that adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time set for the meeting or if during
the meeting a quorum ceases to be present, the meeting shall be dissolved, and provided that (a) the meeting was not
convened on the basis of a notice having been waived and (b) the non attendance did not arise as a result of force majeure
(as may be defined in any written agreement in force between the Partners from time to time), then the Managers shall
refer to the resolution provisions as set out in any written agreement in force between the Partners from time to time.
10.9 The signature of one class A Manager and one class B Manager shall be required to bind the Company save that
(i) signatory authority for any type of transaction may also be delegated by a resolution of the Managers to any one
Manager or third party in the context of a specific transaction and (ii) each Manager can bind the Company by his/her
sole signature for the purposes of transactions regarding the general administration of the Company (e.g. signing of
proxies, filing of tax returns) provided that any such transaction involves an amount of less than EUR 15,000.-(or equivalent
in any other currency).
10.10 Each Manager may participate in a meeting by conference telephone or other communications equipment by
means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same time. Unless
otherwise determined by the Board, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at the
start of the meeting.
101841
L
U X E M B O U R G
10.11 The minutes of each meeting shall be prepared by the chairman or any Manager and distributed to the other
attending Managers for approval and signature. A Manager may apply for amendments to be made to the text of the
minutes if, in his/her opinion, they do not reflect the content of the meeting.
10.12 Written resolutions signed by all the Managers of the Company will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may
be evidenced by letter, fax or similar communication.
Art. 11. Indemnification.
11.1 The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a Manager
or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him/her in connection with any inves-
tigation, claim, action, suit or proceeding in which he/she becomes involved as a party or otherwise by reason of him/her
being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company
is a shareholder or a creditor and from which he/she is not entitled to be indemnified by such company, and against
amounts paid or incurred by him/her in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he/she shall be
finally adjudged in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence, or wilful misconduct in the conduct of his/her office. In the event of settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction
has approved the settlement or the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty.
11.2 A Partner shall be responsible for and shall indemnify the other Partner and the Company against any loss, liability
or cost that either of them suffers or incurs as a result of a claim by a Manager that was nominated by the Partner for
unfair or wrongful dismissal.
11.3 The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made
by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of
their mandate.
Art. 12. General Meetings.
12.1 Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which its owns. Subject to
Article 13, each Partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each Partner may appoint a proxy to
represent him at meetings.
12.2 In case there is more than one but less than twenty-five Partners, decisions of Partners shall be taken in a general
meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. Subject to Article 13, no decision is deemed
validly taken until it has been adopted by the Partners representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
12.3 General meetings of Partners shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Art. 13. Reserved Matters.
13.1 A unanimous vote (or a unanimous written resolution) of the Partners is required for a Reserved Matter (as
defined in Article 0 below) to be taken.
13.2 A “Reserved Matter” is a decision in relation to any of the following:
13.2.1 All material changes or revisions to the Company's business plan, agreeing a new business plan or any material
increase in quarterly forecast that is not in accordance with the business plan, all in accordance with and subject to the
provisions of any written agreement in force between the Partners from time to time (and for the avoidance of doubt,
“material” for these purposes to be interpreted in accordance with the provisions of any such agreement).
13.2.2 A pre-letting or letting of all or any part of the Company's real estate investment prior to practical completion
unless in accordance with and in the circumstances set out in the business plan.
13.2.3 A forward sale or sale of the Company's real estate investment prior to practical completion unless in accordance
with and in the circumstances set out in the business plan.
13.2.4 The alteration of the constitutional documents of the Company and any of its direct and indirect subsidiaries
(“Group Company”).
13.2.5 The acquisition of any interest in land, any proposal to acquire any interest in land and/or any buildings thereon
unless in accordance with and in the circumstances set out in the business plan (in which case the Partners will only be
required to consent to the terms and the form of the final sale and purchase documents, such consent not to be unrea-
sonably withheld if such documents are in accordance with and in the circumstances set out in the business plan).
13.2.6 Varying the development management agreement (“DMA”) or the development consultancy agreement
(“DCA”) or terminating the DMA or DCA save for the circumstances set out in any shareholder's agreement the Com-
pany Partners may enter into from time to time.
13.2.7 The commencement, compromise or settlement of any litigation in relation to the Company's business, the
estimated cost of which is likely to exceed five hundred thousand Pounds Sterling (GBP 500,000.-).
13.2.8 Entering into a joint venture/partnership or making any corporate acquisition or forming any subsidiary.
13.2.9 Changing the accounting policies of any Group Company in any material manner.
101842
L
U X E M B O U R G
13.2.10 Entering into contracts outside the ordinary course of the Company's business or making any investment or
borrowing, lending or advancing any monies (or entering into any guarantee in connection with the same) which is not
in accordance with the business plan.
13.2.11 Entering into contracts with a person under common control with either of the Partners.
13.2.12 Any tax election and/or any proposed decision or action which may alter the existing taxation status of any
Group Company, unless in accordance with any requirement of any shareholders' agreement entered into between the
Partners.
13.2.13 Winding up or dissolution of any Group Company.
13.2.14 Appointing any party to manage the sale of the Company's property.
13.2.15 Any other matter which the Partners agree in writing is to be treated as a Reserved Matter from time to time.
Art. 14. Financial Year. The Company's financial year commences on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of
December.
Art. 15. Accounts.
15.1 Each year, the Board shall prepare (1) on a quarterly basis unaudited management accounts (prepared in accor-
dance with International Financial Reporting Standards) and (2) upon closing of the books and records of the Company
on the of 31
st
December, the Company's annual financial statements, including the balance sheet, profit and loss account
and accompanying notes.
15.2 Each Partner may inspect, at the Company's registered office, the above quarterly (un-audited) accounts within
fifteen ( 15) business days following each quarter and the above annual (audited) financial statements within six (6) months
following year-end.
15.3 No distributions of dividend shall be paid or declared in respect of the Parts except:
15.3.1 with the unanimous prior written consent of the Partners or as interim dividends as stipulated in these Articles;
or
15.3.2 pursuant to a return of capital or liquidation of the Company; or
15.3.3 in accordance with the business plan and quarterly forecasts; and
15.3.4 in accordance with the Law of 15 August 1915 and to the extent that such distribution would or might, in the
reasonable opinion of the Board, and/or Partners, as the case may be, leave the Company and any member of the Com-
pany's group with sufficient funds for general working capital purposes, to meet liabilities as they fall due or to enable the
Company to create and maintain (or increase) a reserve such that it can meet the liabilities (present or future, actual or
contingent) of the Company's group as they fall due or are expected to fall due; and
15.3.5 in accordance with any instructions if applicable imposed by any senior lender to the Company; and
15.3.6 in accordance with and subject to any written agreement in force between the Partners from time to time.
Art. 16. Audit. The operations of the Company shall be reviewed and the annual financial statements audited by one
(1) or more statutory or independent auditor(s). The general meeting of Partners shall appoint the statutory or inde-
pendent auditor(s) for a fixed term ending after each annual general meeting of the Partners.
Art. 17. Distribution of Profits.
17.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of general expenses, costs, amortizations, charges
and provisions, represents the net profit of the Company.
17.2 Five per cent (5%) of said net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the general meeting of Partners but only
in accordance with the provisions of any agreement that may be entered into amongst the Partners from time to time.
17.3 In addition to this statutory reserve and any other reserve required by law, the Board of Managers may create
such capital reserves from time to time as they may determine are appropriate and shall create a capital surplus reserve
from funds received by the Company as premiums. The Board of Managers is authorised to make any payment of dividends
or other distribution to holders of parts out of this capital surplus reserve but only in accordance with the provisions of
any agreement that may be entered into amongst the Partners from time to time.
17.4 The Board is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the
financial year, to the payment of interim dividends, subject only to the two (2) following conditions: the Board of Managers
may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within thirty (30)
days before the date of the meeting of the Board of Managers; and the interim accounts, which may be un-audited, must
show that sufficient distributable profits and reserves exist.
17.5 Any distribution of dividend, redemption and liquidation proceeds is payable to the Partners pro-rata to their
respective equity interests (including premium) and in accordance with the provisions of any agreement that may be
entered into amongst the Partners from time to time.
101843
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Liquidation. At the time of the winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or more
liquidators, who may be Partners, and who are appointed by the general meeting of Partners who will determine their
powers and remuneration.
Art. 19. Miscellaneous. Each of the Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision
is made in the Articles.”
<i>Third resolutioni>
Following the above restatement, the Partners hereby resolve
(i) to designate as A Manager the following persons:
- Mrs. Delloula AOUINTI, born in Villerupt, France on April 4, 1979, professionally residing at 28 boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg;
- Ms. Joanne FITZGERALD, born in Waterford, Ireland on March 11, 1979 professionally residing at 28 boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr. Graham Peter TYLER
(ii) to designate as B Manager the following persons:
- Ms. Hélyette Marie Cécile JARNY;
- Mr. Mirko FISCHER;
- Mr. Serge Philippe MATON.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at one thousand Euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, known to the notary, by surname,
Christian name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Follows the French version
L'an deux mille onze, le dixième jour du mois de juin.
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU
1) La société MGP Telex S.à r.l., une société constituée sous la législation luxembourgeoise sous forme d'une société
à responsabilité limitée, ayant sons siège social situé au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B157582,
ici représentée par Pierre Lancelin, juriste, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration lui remise sous sceau
privé;
2) La société Valfore S.à r.l, une société constituée sous la législation luxembourgeoise sous forme d'une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social situé au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B132039,
ici représentée par Pierre Lancelin, juriste, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration lui remise sous sceau
privé.
Lesdites procurations, paraphées “ne varietur” par les représentants des parties susnommées et le notaire soussigné,
resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ce qui suit:
Les parties décrites ci-dessus représentent l'intégralité des Associés de la société «Telex S.à r.l.», ayant son siège social
situé au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg sous le numéro B157581, constituée suivant acte de Me Martine DECKER en date du 15 novembre 2010,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 294 en date du 12 février 2011 (la «Société»).
En fois de quoi, les comparants, ès-qualité qu'ils agissent ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ce qui suit:
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
101844
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
(i) Reclassification du capital social en parts de Classe A et de Classe B et attribution au sein de celles-ci;
(ii) Modification et mise à jour des Statuts constitutifs de la Société;
(iii) Nomination des Gérants actuels de la Société en qualité de Gérant A et B.
Après délibération, les Associés ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Par la présente, les Associés décident de (i) reclassifer le capital social actuel de la Société en deux classes de parts
sociales (Classe A et Classe B) et (ii) de procéder à l'attribution du capital social actuel de la Société comme suit:
- Deux cent cinquante (250) Parts de Classe A seront attribuées à MGP Telex S.à r.l.;
- Deux cent cinquante (250) Parts de Classe B seront attribuées à Valflore S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide la modification et la mise à jour des Statuts constitutifs de la Société, notamment (mais sans limite)
afin d'en faire lecture ainsi qu'il suit avec effet immédiat:
Art. 1
er
. Associés. Il est formé une société (ci-après la «Société») à responsabilité limitée par les associés fondateurs
ainsi que par toute personne ou entité susceptible de devenir associé (de manière individuelle, le «Associé» et collecti-
vement, les «Associés») à l'avenir, qui sera soumise à la législation en vigueur pour de telles entités ainsi qu'aux présents
statuts constitutifs de la société (les «Statuts»).
Art. 2. Objet social.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxem-
bourgeoise ou étrangère, et toute autre forme de placement, l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute
autre manière ainsi que la cession par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de
titres obligataires, de notes et de toute autre titre quelconque, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.
2.2 La Société pourra également procéder à des investissements en biens immobiliers et à la mise en valeur de ces
derniers, ainsi qu'à la gestion de biens immobiliers pour la réalisation de son propre objet.
2.3 Dans la limite de ses activités, la Société pourra accorder des hypothèques, des contrats de prêts, avec ou sans
garantie, et se porter garante pour des personnes ou sociétés du même groupe. Elle pourra également emprunter avec
ou sans intérêt sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations et de titres obligataires par voie de placements
privés.
2.4 La Société pourra effectuer toute autre activité financière, industrielle ou commerciale se rattachant directement
ou indirectement à ses objets. En général, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et
effectuer toute opération qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de ses objets.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Nom. La Société porte le nom «Telex S.à r.l.».
Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Il pourra
être transféré dans tout autre endroit de la Commune par décision du Conseil. En outre, le siège social pourra être
transféré dans tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par décision de l'assemblé générale des Associés
adoptées de même que requis pour la modification des Statuts de la Société.
5.2 Il pourra être établi des succursales, des filiales et tout autre bureau tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à
l'étranger par décision du Conseil.
5.3 Au cas où le Conseil estimerait que des évènements ou des développements extraordinaires d'ordre politique ou
militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre ce
siège et l'étranger se sont produit ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.
Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents livre sterling (GBP 12.500,00), représenté par deux
cent cinquante (250) parts de classe A (les «Parts A») et deux cent cinquante (250) parts de classe B (les «Parts B», et,
collectivement, les «Parts») d'une valeur nominale de vingt-cinq livre sterling (GBP 25,00) chacune et sous forme nomi-
native. Toutes les parts sont souscrites et ont été entièrement libérées.
6.2 Une prime pourra être payée sur les parts de chaque classe.
6.3 Toutes les classes de parts jouissent des mêmes droits et obligations à l'exception des prescriptions ci-dessous ou
de tout accord qui pourra être conclu entre Associés occasionnellement.
101845
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Transfert de Part. Les parts de la Société sont librement transférables entre Associés.
Elles ne peuvent être transférées à de nouveaux Associés que sur décision des Associés en assemblée générale, passée
à une majorité s'élevant au trois quarts du capital et conformément à tout accord écrit en vigueur entre Associés occa-
sionnellement.
Art. 8. Circonstances touchant les Associés. Le décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité ou la faillite de
l'un des Associés ne mettra pas fin à la Société.
Art. 9. Responsabilité limitée et Voile social. Les créanciers et les héritiers ne pourront en aucun cas créer une charge
grevant les actifs ou les documents de la Société en rapport à leur responsabilité personnelle. Afin de prévenir toute
incompréhension, le présent Article 9 n'empêchera pas les Associés de déposer leurs parts en nantissement sous réserve
de conformité de ces nantissements à l'Article 189 de la Loi de 1915 et à tout accord écrit en vigueur entre les Associés
occasionnellement.
Art. 10. Conseil de Gérance.
10.1 Conseil de Gérance La Société est administrée par un conseil de gérance (le «Conseil») se composant de trois
(3) gérants de classe A et de trois (3) gérant de classe B, Associés ou non (individuellement, un «Gérant» et collectivement
les «Gérants»).
Les membres du Conseil de Gérance sont nommés et élus «Gérant de classe A» ou «Gérant de classe B» par décision
des Associés qui en déterminent le mandat et, le cas échéant, la rémunération. Les Gérants de classe A sont élus et
nommés à ce titre par les Associés sur proposition des porteurs de parts de classe A et les Gérants de classe B sont élus
et nommés à ce titre par les Associés sur proposition des porteurs de parts de classe B.
Les Associés pourront décider la révocation d'un Gérant sans avoir à en donner la raison. Cependant, sous réserve
de tout accord conclu entre Associés de manière occasionnelle, chaque Gérant ne pourra être démis et remplacé que
sur demande et sous réserve d'acceptation écrite au préalable des porteurs de parts de la classe qui l'ont nommé à ce
poste.
10.2 Les Gérants élisent un président du Conseil. En cas d'égalité de vote, lors d'une réunion du Conseil, le présidant
n'aura pas de seconde voix ou de voix prépondérante sous réserve de disposition contraire stipulée dans tout accord
écrit en vigueur entre les Associés occasionnellement.
10.3 Vis-à-vis les tiers, le Conseil détient les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
Société et pour accomplir et autoriser tous actes et opérations se rattachant à ses objets.
10.4 Réunion du Conseil. Sous réserve d'un accord contraire entre tout Gérant de classe A et tout Gérant de classe
B:
10.4.1 Les réunions du Conseil se tiennent une fois tous les trois mois au moins et peuvent être organisées sur demande
de tout Gérant ou lorsqu'une décision ou un document important doivent être prise/exécuté par la Société.
10.4.2 Les réunions du Conseil se tiennent généralement au Luxembourg.
10.4.3 Sous réserve de l'article 10.5, une convocation à toute réunion du Conseil doit être envoyée par envoi recom-
mandé, fax ou courrier électronique dans un délai minimum de trois jours ouvrables, à laquelle il sera joint un ordre du
jour qui présentera de manière raisonnablement détaillée les points soumis à discussion par le Conseil lors de ladite
réunion.
10.4.4 Sous réserve de l'article 10.5, tout document pertinent sera envoyé à tous les Gérants préalablement à la réunion
en s'assurant que réception de ce dernier sera faite au minimum un jour ouvrable avant la date fixée de la réunion sous
réserve d'un accord préalable; et
10.4.5 Les copies des procès-verbaux de chaque réunion seront circulées dans les trois jours ouvrables suivants la
réunion pour en permettre l'exécution par tous les Gérants présents à la réunion.
10.5 Tout Gérant pourra renoncer à son droit à la convocation à toute réunion à priori ou à posteriori (relativement
à lui-même ou à ses représentants propres uniquement).
10.6 Le Conseil ne peut délibérer et statuer valablement lors d'une réunion qu'en la présence (a) de la majorité des
Gérants en cours de mandat, (b) de deux Gérants au moins comprenant un Gérant de classe A et un Gérant de classe
B si deux Gérants et (c) pour autant qu'un même nombre de Gérants de classe A et de classe B est présent ou représenté.
10.7 Sous réserve des dispositions de l'Article 13 (Décisions réservées) et du président du Conseil détenant la voix
prépondérante le cas échéant aux dispositions de tout accord écrit en vigueur entre les Associés occasionnellement, les
décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix. Chaque Gérant possède une voix et tout Gérant pourra
être représenté lors de toute réunion du conseil par un agent (qui devra être un autre Gérant de la Société) qui sera
nommé par ce dernier par écrit. La voix d'un tel agent aura à toutes fins utiles la valeur de celle du Gérant représenté.
10.8 Au cas où le quorum n'est pas atteint dans les trente minutes qui suivent l'heure prévue de la réunion du Conseil
ou bien si au cours d'une réunion, le quorum n'est plus atteint, la Société en informe les Gérants immédiatement et par
écrit et la réunion est reportée à une date et à une heure au moins 7 jours ouvrables suite à la date prévue de la réunion
en un même lieu. Au cas où, lors de ladite réunion reportée, le quorum n'est pas atteint dans les trente minutes qui
suivent l'heure prévue de la réunion, ou bien si au cours de la réunion, le quorum n'est plus atteint, la réunion est dissoute
et, pour autant que (a) la réunion ne s'est pas tenue suite à une convocation renoncée et (b) que la non-assistance n'est
101846
L
U X E M B O U R G
pas le conséquence d'un cas de force majeure (tel que défini dans tout accord écrit en vigueur entre les Associés occa-
sionnellement), les Gérants s'en référeront aux dispositions résolutives telles que définies dans tout accord écrit en
vigueur entre les Associés occasionnellement.
10.9 Les signatures d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B sont requises pour engager la Société à
l'exception (i) d'une délégation du pouvoir de signature pour tout type de transaction par décision des Gérants en faveur
de tout Gérant quelconque ou d'un tiers dans le cadre d'une transaction précise et (ii) du cas où tout Gérant peut engager
la Société par sa seule signature aux fins de transactions relatives à l'administration générale de la Société (par ex la
signature de procurations, de déclarations fiscales) pour autant qu'une telle transaction ne concerne un montant qui ne
peut dépasser EUR 15.000,- (ou son équivalent dans toute autre devise).
10.10 Tout Gérant pourra prendre part à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de
communication à l'aide duquel tous les participants à la réunion peuvent communiquer les uns avec les autres simulta-
nément. Sous réserve de dispositions contraires prises par le Conseil, il est convenu que la réunion sera tenue là où se
trouve le président en début de réunion.
10.11 Les procès-verbaux de chaque réunion seront préparés par le président ou par tout Gérant et remis aux Gérants
présents pour accord et signature. Tout Gérant peut demander la modification du texte d'un procès-verbal s'il juge que
ce dernier ne reflète pas le contenu de la réunion.
10.12 Toute décision signée par tous les Gérants de la Société sera jugée de validité et d'efficacité égale à celles
approuvées lors d'une réunion dûment organisée et tenue. Ces signatures figureront sur un document unique ou sur
plusieurs copies de ce dernier et seront exécutées par voie de courrier, de fax ou d'un moyen de communication similaire.
Art. 11. Indemnisation.
11.1 Pour autant que la législation l'autorise, la Société procèdera à l'indemnisation de toute personne qui assume ou
a dans le passé, assumé le poste de Gérant ou d'agent, en compensation de toute responsabilité ou de toute dépense
raisonnablement encourue ou versée par cette dernière relativement à toute enquête, réclamation, action, poursuite ou
procès dans lequel elle est impliquée en tant que partie ou autrement en raison de sa position actuelle ou passée de
Gérant ou d'agent de la Société ou, à la demande de cette dernière ou de toute autre société dont la Société est actionnaire
ou créancière et de laquelle cette personne n'a pas droit à une indemnisation, ainsi qu'en compensation de tout montant
versé ou encouru par cette dernière lors de la résolution de ceux-ci, à l'exception des affaires pour lesquelles cette
dernière personne est finalement jugée par un tribunal compétent en la matière relativement à toute enquête, réclamation,
action, poursuite ou procès, coupable de faute lourde ou de mauvaise conduite volontaire dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de résolution, il ne sera procédé à une indemnisation qu'en rapport aux faits que le tribunal compétent en la
matière en aura approuvé la résolution ou suite au conseil juridique que la Société aura reçu confirmant que cette dernière
personne en attente d'indemnisation n'est coupable d'aucun manquement aux devoirs de fonctions.
11.2 Tout Associé est tenu responsable et procèdera à l'indemnisation d'un tiers Associé et de la Société en com-
pensation de toute perte, toute responsabilité ou de toute dépense que l'un d'entre eux encourra ou subira suite à une
réclamation d'un Gérant désigné par ce dernier Associé pour licenciement abusif.
11.3 Les Gérants n'endossent en raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle relativement aux engage-
ments qu'ils prennent régulièrement au nom de la Société. Ils ne sont que des agents fondés de pouvoir et ne sont
responsables que dans le cadre de l'exécution de leur fonction.
Art. 12. Assemblée générale.
12.1 Chaque Associé pourra participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenu. Sous
réserve de l'Article 13, chaque Associé possède des droits de votes proportionnels à sa détention de parts. Chaque
Associé pourra nommer un agent pour le représenter lors des assemblées.
12.2 Au cas où le nombre de Associé est supérieur à un mais ne dépasse pas vingt-cinq, les résolutions des Associés
seront passées en assemblée générale ou par consultation écrite initiée par le Conseil d'administration. Sous réserve de
l'Article 13, une résolution n'est jugée valide que lorsqu'elle est adoptée par les Associés représentant plus de cinquante
pourcent (50%) du capital.
12.3 Les assemblées générales des Associés se tiennent à Luxembourg. L'assistance par voie d'un agent représentant
est possible.
Art. 13. Décisions réservées.
13.1 Un vote à l'unanimité (où une résolution écrite passée à l'unanimité) des Associés est requise pour qu'une Décision
réservée (telle que définie sous l'Article 13.2 ci-dessous) soit prise.
13.2 Une «Décision Réservée» est une décision relative à ce qui suit:
13.2.1 Toute modification ou toute révision matérielle du plan d'entreprise de la Société, l'approbation d'un nouveau
plan d'entreprise ou de tout accroissement matériel en prévision trimestrielle qui n'est pas conforme au plan d'entreprise,
en conformité et sous réserve des dispositions de tout accord écrit en vigueur entre les Associés occasionnellement (et
pour prévenir toute incompréhension, «matériel(le)» aux fins du présent doit s'entendre conformément aux dispositions
de tout accord de ce genre).
101847
L
U X E M B O U R G
13.2.2 Un préaccord de bail ou un bail de l'intégralité ou d'une partie quelconque de l'investissement immobilier de la
Société anticipativement à l'achèvement réel sous réserve de conformité au plan d'entreprise et aux conditions stipulées
dans ce dernier.
13.2.3 La vente ou la vente à terme de l'investissement immobilier de la Société anticipativement à l'achèvement réel
sous réserve de conformité au plan d'entreprise et aux conditions stipulées dans ce dernier.
13.2.4 La modification des documents constitutifs de la Société ou de l'une quelconque de ses filiales directes ou
indirectes («Société du Groupe»).
13.2.5 L'acquisition de tout intérêt en terrain, toute proposition d'acquisition de tout intérêt en terrain et/ou de tout
bâtiment sur ce dernier sous réserve de conformité au plan d'entreprise et aux conditions stipulées dans ce dernier
(auquel cas, il ne sera requis des Associés que d'accorder leur consentement aux termes et à la forme des documents
définitifs de vente et d'achat, ce dernier n'étant pas refusé de manière déraisonnable si lesdits documents sont conformes
au plan d'entreprise et aux conditions stipulées dans ce dernier).
13.2.6 Variations apportées à l'accord d'administration de développement («DMA») ou à l'accord de conseil de dé-
veloppement («DCA») ou la résiliation du DMA ou du DCA à l'exception de circonstances stipulées dans tout accord
des associés que les Associés de la Société peuvent signer occasionnellement.
13.2.7 L'initiation, la transaction ou la résolution de tout litige relativement aux activités de la Société dont le coût
estimé dépassera vraisemblablement cinq cent mille livre sterling (GBP 500.000,-).
13.2.8 L'entrée en coentreprise/partenariat ou la prise de toute acquisition sociale ou l'établissement de toute filiale.
13.2.9 La modification des politiques comptables de toute Société du groupe de toute manière matérielle.
13.2.10 La signature de tout contrat extérieur aux activités habituelles de la Société ou tout investissement ou emprunt,
tout prêt ou toute avance de fonds (ou l'accord de tout dépôt en nantissement relatif à ce qui précède) qui n'est pas
conforme au plan d'entreprise.
13.2.11 La signature d'un contrat avec toute personne sous contrôle commun avec l'un quelconque des Associés.
13.2.12 Toute élection fiscale et/ou toute proposition de décision ou d'action qui pourra entraîner une modification
du statut fiscal actuel de toute Société du Groupe, sous réserve de conformité à toute condition de tout accord d'associés
que pourraient signer les Associés.
13.2.13 La clôture ou la dissolution de toute Société du Groupe.
13.2.14 La nomination de tout tiers pour la gestion de la vente des propriétés de la Société.
13.2.15 Toute autre décision que les Associés s'accordent par écrit à traiter comme une Décision réservée occasion-
nellement.
Art. 14. Exercice fiscale. L'exercice fiscal de la Société commence le 1
er
jour du mois de janvier et s'achève le 31
ème
jour du mois de décembre.
Art. 15. Comptabilité.
15.1 Chaque année, le Conseil préparera (1) les comptes de gestion non-audités sur base trimestrielle (ces derniers
étant préparés conformément aux normes internationales d'information financière – IFRS) et (2) lors de la clôture des
comptes et des registres de la Société le 31 décembre, les relevés financiers annuels de la Société, comprenant le rapport
financier, les comptes bénéfice et perte et les notes jointes.
15.2 Chaque Associé pourra examiner, au siège social de la Société, les comptes trimestriels (non-audités) ci-dessus
dans les quinze (15) jours ouvrables suivant chaque trimestre ainsi que les relevés financiers annuels (audités) dans les six
(6) mois suivant la clôture de l'exercice.
15.3 Il ne sera fait aucun versement ni aucune déclaration de répartition des dividendes relativement aux Parts à
l'exception des cas suivants:
15.3.1 Consentement écrit unanime et préalable des Associés ou bien en tant qu'acompte sur dividende tel que stipulé
dans les Présents; ou bien
15.3.2 Suite à un retour de capital ou à la liquidation de la Société; ou bien
15.3.3 Conformément au plan d'entreprise et aux prévisions trimestrielles; et
15.3.4 Conformément à la Loi du 15 aout 1915 et dans la mesure où une telle répartition laisserait, au jugement
raisonnable du Conseil et/ou des Associés selon le cas, à la Société et à tout membre du groupe de la Société suffisamment
de fonds pour le capital de roulement à des fins générales, pour faire face aux échéances lorsque dues et pour permettre
à la Société de créer et de maintenir (ou d'accroître) une réserve pour que cette dernière puisse faire face aux échéances
(actuelles, ou à venir, effectives ou conditionnelles) du groupe de la Société lorsqu'elles sont dues ou le seront; et
15.3.5 Conformément à toute instruction, le cas échéant, imposée par tout prêteur principal de la Société; et
15.3.6 Conformément et sous réserve de tout accord écrit en vigueur entre les Associés occasionnellement.
Art. 16. Audit. Les opérations de la Société seront revues et les relevés financiers annuels seront audités par un (1)
ou plusieurs auditeurs légaux ou indépendants. L'assemblée générale des Associés nommera les auditeurs légaux ou
indépendants pour une période déterminée qui s'achèvera après chacune des assemblées générales annuelles des Associés.
101848
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Répartition des Bénéfices.
17.1 Le solde créditeur du compte bénéfices et pertes, déduction faite des frais généraux, coûts, amortissements,
charges et dépôts représente le bénéfice net de la Société.
17.2 Cinq pourcent (5%) dudit bénéfice net est affecté à la réserve légale. Cette contribution cesse lorsque la réserve
atteint dix pourcent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des Associés
conformément aux dispositions de tout accord qui aura pu être signé entre Associés occasionnellement.
17.3 Outre cette dernière réserve légale ainsi que toute autre réserve légalement requise, le Conseil de Gérance peut
créer des réserves de capitaux occasionnellement comme ils le jugeront approprié et utile et créeront une réserve
d'excédant de capital des fonds perçus par la Société au titre de prime. Le Conseil de Gérance est autorisé à procéder
au versement de dividendes et à toute autre répartition en faveur des porteurs de parts de cette réserve d'excédant de
capital conformément aux dispositions de tout accord qui aura pu être signé entre Associés occasionnellement.
17.4 Le Conseil est autorisé à procéder aussi souvent qu'il le jugera approprié et à tout moment au cours de l'exercice
fiscal, au versement d'acomptes sur dividendes sous réserves des deux (2) conditions uniques suivantes: le Conseil de
Gérance ne pourra prendre la décision de répartir des acomptes sur dividendes que sur base des comptes intermédiaires
rédigés dans les trente (30) jours qui précèdent la date de la réunion du Conseil de Gérance; et ces comptes intermédiaires
qui peuvent être non-audités, doivent établir l'existence de suffisamment de bénéfices à répartir et de réserves.
17.5 Toute répartition de dividende, et tout revenu de rachat et de liquidation sont payables en faveur des Associés
au prorata de leurs participations respectives (y compris les primes) et conformément aux dispositions de tout accord
qui aura pu être signé entre Associés occasionnellement.
Art. 18. Liquidation. Lors de la clôture de la Société, la liquidation sera effectuée par les soins d'un ou plusieurs
liquidateurs qui peuvent être Associés et qui sont nommés par l'assemblée générale des Associés qui en détermine les
pouvoirs et la rémunération.
Art. 19. Divers. Chacun des Associés s'en référera aux dispositions en vigueur partout où il n'y a pas été dérogé par
les présents statuts.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément à la mise à jour des statuts ci-dessus, les Associés décident par la présente:
(i) De nommer les personnes suivantes au poste de Gérant A:
- Mme. Delloula AOUINTI;
- Mlle. Joanne FITZGERALD;
- M. Graham Peter TYLER;
(ii) De nommer les personnes suivantes au poste de Gérant B:
- Mlle. Hélyette Marie Cécile JARNY;
- M. Mirko FISCHER;
- M. Serge Philippe MATON.
<i>Fraisi>
Il est estimé que les frais, rémunérations et charges sous toute forme quelconque, encourus relativement au présent
acte s'élève à environ mille euros.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion s'est clôturée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des comparants,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française; à la requête des mêmes comparants
et en cas de divergence entre la version en langue anglaise et celle en langue française, c'est la version en langue anglaise
qui sera prépondérante.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
Et, après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, le
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. LANCELIN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juin 2011. LAC/2011/27099. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 22 juin 2011
Référence de publication: 2011086403/586.
(110096892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.
101849
L
U X E M B O U R G
Kodesh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 81.586.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assembléei>
<i>Générale Extraordinaire tenue le 15 octobre 2010i>
<i>Résolutionsi>
Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée générale décide de révoquer la société TEAMAUDIT SA de son poste de Réviseur d’entreprise.
2. L’assemblée générale décide de nommer au poste de Commissaire aux Comptes la société SICRIS SA ayant son
siège 2, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg jusqu'à l’assemblée à tenir en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101100/15.
(110115631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kodesh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 81.586.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011101101/10.
(110115795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Koho Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 74.379.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101102/10.
(110115358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kurti Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 29, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 133.918.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101103/9.
(110115601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kurti Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8067 Bertrange, 30, rue Am Pesch.
R.C.S. Luxembourg B 133.918.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101104/9.
(110115602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101850
L
U X E M B O U R G
Kurti Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8067 Bertrange, 30, rue Am Pesch.
R.C.S. Luxembourg B 133.918.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101105/9.
(110115603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Kurti Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 29, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 133.918.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101106/9.
(110115608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
L.V. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 35.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101107/9.
(110114803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
LaMAGGESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 106.294.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2011 que:
Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, né le 30 septembre 1975 à Liège (Belgique), demeurant profession-
nellement à Luxembourg, 40 Avenue de la Faïencerie L-1510, et Madame Orietta RIMI, employée privée, née le 29
septembre 1976 à Erice (Italie) et demeurant professionnellement au 40 Avenue de la Faïencerie L-1510 ont été élus
administrateurs en remplacement de Monsieur Andrea DE MARIA et de Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI, démission-
naires.
Le mandat de Monsieur Riccardo MORALDI à la fonction d’administrateur est renouvelé.
Ser.Com S.à.r.l., ayant son siège social à, 19, boulevard Grande Duchesse Charlotte, Résidence d’Orange, L-1331
Luxembourg a été élu commissaire en remplacement de Mayfair Trust S. à r.l., démissionnaire.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 4 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101108/19.
(110114975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Leica Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 149.360.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011101109/11.
(110115146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
101851
L
U X E M B O U R G
Lonworld S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 32.710.
<i>Extrait des résolutions prises lors dei>
<i>l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 2011i>
L'Assemblée a été informée du décès de Monsieur Nicolas Kruchten survenu le 12 septembre 2010.
Monsieur Laurent BARNICH, né le 2 octobre 1979 à Luxembourg, domicilié 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été
élu administrateur de catégorie A. Son mandat s'achèvera à l'issue de l`assemblée générale qui sera tenue en 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011101111/14.
(110114668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Auchan Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 45.515.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 29 avril 2011i>
- Monsieur François REMY, Directeur Général Pays, demeurant professionnellement au 5 rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg, est nommé Administrateur-Délégué de la société avec pouvoir d'engager la société sous sa seule
signature pour une période d'un an.
Son mandat d'Administrateur-Délégué prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'année 2012;
- Monsieur Philippe DETAVERNIER, Directeur des Ressources et du Développement Société Auchan France, demeu-
rant professionnellement au 40, avenue de Flandre, F-59964 Croix, est nommé Président du Conseil d'Administration
pour une période d'un an.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
Certifié sincère et conforme
Ph. Detavernier / Signature
Référence de publication: 2011100821/18.
(110115050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Premicon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place J.F. Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 86.412.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendelf, den zwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Aktiengesellschaft deutschen Rechtes "PREMICON AG", mit Sitz in D-81675 München, 3, Einsteinstrasse (Bun-
desrepublik Deutschland) eingetragen beim Amtsgericht München, Aktenzeichen: HRB 122442,
hier vertreten durch Herrn Pierre THOLL, Ingenieur, wohnhaft in L-7214 Bereldingen, 29, rue Bellevue, auf Grund
einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar
"ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
A) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PREMICON S.à r.l.", mit Sitz in L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 86.412, (die "Gesell-
schaft"), gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, mit dem
damaligen Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Joseph ELVINGER, mit
dem Amtssitz in Luxemburg, am 12. Februar 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 900 vom 13. Juni 2002;
B) Das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, eingeteilt in fünfundzwanzig (25)
Anteile mit einem Nominalwert von jeweils fünfhundert Euros (500,- EUR);
C) Die erschienene Partei ist die Eigentümerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft;
101852
L
U X E M B O U R G
D) Die erschienene Partei, als Alleingesellschafterin (die "Alleingesellschafterin") beschließt die Gesellschaft mit so-
fortiger Wirkung aufzulösen;
E) Die Alleingesellschafterin erklärt, dass sie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt und dass sie genaue Kenntnis
der Finanzlage der Gesellschaft besitzt;
F) Die Alleingesellschafterin, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass die Tätigkeit der Gesellschaft beendet ist,
alle ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen worden sind, oder für deren Begleichung Sorge getragen
wird, dass sämtliche Aktiva der Gesellschaft auf die Alleingesellschafterin übergehen, welche erklärt, dass alle Schulden
der Gesellschaft beglichen sind und sie sich verpflichtet alle etwaigen noch nicht beglichenen Schulden zu übernehmen,
ehe eine Zahlung an sich selbst erfolgt;
G) Die Liquidation der Gesellschaft ist somit durchgeführt und abgeschlossen und die Gesellschaft ist als endgültig
aufgelöst zu betrachten;
H) Die Alleingesellschafterin erteilt hiermit dem Geschäftsführer volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates
bis zum heutigen Tag;
I) Die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in den Büro-
räumlichkeiten der "SOMATEC S.A." in L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent, aufbewahrt werden.
Somit hat der unterzeichnete Notar festgestellt, dass die Gesellschaft "PREMICON S.à r.l." aufgelöst worden ist.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.
WORÜBER URKUNDE errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, namens handelnd wie hier-
vor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevoll-
mächtigte gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Signé: P. THOLL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2011. LAC/2011/33152. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 26 juillet 2011.
Référence de publication: 2011105556/54.
(110120795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2011.
Finagest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 75.076.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of July;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
Mr. Grégoire CHASTE, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as proxy of:
LA MESETA INC. (hereinafter referred to as the “Absorbing Company”), a corporation incorporated under the laws
of Delaware, having its registered office at 800 Delaware Avenue, P.O. Box 8702, Wilmington, Delaware 19801, duly
registered with the Delaware Corporations Commission under number 4885444,
on the basis of a proxy given by a resolution of the board meeting of the Absorbing Company dated 29 May 2011.
A copy of the minutes of the board meeting, after having been signed “ne varietur” by the appearing person representing
the Absorbing Company and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it
with the registration authorities.
The appearing person has requested the undersigned notary to state as follows:
According to the terms of the merger proposal as of 26 January 2011, the Absorbing Company wished to merge with
the Absorbed Company pursuant to a merger by absorption.
The merger proposal has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 391 as of
28 February 2011.
According to article 273ter (3) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended (the “Company
law”)., as amended, the undersigned notary has received a certificate attesting the completion by the Absorbing Company
of the formalities to be accomplished by it pursuant to Delaware law, drawn-up by the Delaware Corporations Com-
mission, as well as a copy of the draft terms of merger approved by the Absorbing Company (the “Merger Proposal”), in
101853
L
U X E M B O U R G
order to carry out the legal control incumbent upon him and certifies that the merging companies have approved the
Merger Proposal in the same terms.
According to article 11 of the terms of the Merger Proposal, the merger shall be effective one month and one day
after the publication in the Memorial of the present Merger Proposal, namely on 29 March 2011.
The appearing company, so as represented, requires from the undersigned public notary to act its statements made
pursuant to article 274 of the Company Law.
The company notices:
That pursuant to article 278 sq. of the Company law, the Absorbing Company, holder of WHOLE and ALL (100%) of
the shares representing the entire share capital of the Absorbed Company, has absorbed the Absorbed Company ac-
cording to the terms of Merger Proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 391,
as of 28 February 2011.
The approval of the merger, either by the general meeting of the Absorbing Company, or by the general meeting of
the Absorbed Company, was not necessary, the requirements of article 279 of the Company Law being fulfilled.
As of 29 March 2011, no shareholder of the Absorbing Company has required the convening of a general meeting so
as to resolve whether to approve the merger.
In these circumstances, the merger is fulfilled and completed as of 29 March 2011, and automatically and simultaneously
produces the legal effects contemplated by article 274 of the Company Law, in particular the universal transfer, either
between the Absorbed Company and the Absorbing Company that towards third parties, of all the assets and liabilities
from the Absorbed to the Absorbing Company, and the Absorbed Company ceases to exist.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by its surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt et un juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
A COMPARU:
Monsieur Grégoire CHASTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de
mandataire de:
LA MESETA INC., (ci-après dénommée la “Société Absorbante”), société à responsabilité limitée de droit du Delaware,
avec son siège social au 800 Delaware Avenue, Delaware, Etats-Unis, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés du Delaware sous le numéro 4885444,
en vertu d'un pouvoir donné par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante en date du 29 mai 2011.
Une copie des résolutions du conseil d'administration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante
et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
La personne comparante a demandé au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Aux termes du projet de fusion du 26 janvier 2011, la Société Absorbante a souhaité fusionner par absorption de la
Société Absorbée.
Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 391, du 28 février
2011.
Conformément à l'article 273ter (3) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915
telle que modifiée (la “LSC”), le notaire instrumentant a, en vue d'effectuer le contrôle de la légalité qui lui incombe, reçu
un certificat attestant de l'accomplissement par la Société Absorbante des formalités lui incombant en vertu du droit du
Delaware, établi par la Delaware Corporations Commission, ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la Société
Absorbante (le “Projet de fusion”, et certifie que les sociétés fusionnantes ont approuvé le Projet de fusion dans les
mêmes termes.
Aux termes de l'article 11 du Projet de fusion, la fusion produit ses effets un mois et un jour après la publication au
Mémorial du présent Projet de fusion, soit au 29 mars 2011.
La Société comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en
application de l'article 274 de LSC.
101854
L
U X E M B O U R G
Elle constate:
Qu'en application de l'article 278 et suivants de la LSC, la Société Absorbante détenant l'intégralité (100%) des actions
représentant la totalité du capital social de la Société Absorbée, a absorbé cette dernière conformément au Projet de
fusion publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 391, du 28 février 2011.
Qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale de la Société Absorbante, ni par l'assemblée générale
de la Société Absorbée, n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 LSC ayant été observées.
Qu'au 29 mars 2011, il apparaît qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis la convocation d'une assem-
blée générale pour se prononcer sur l'approbation de la fusion.
Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée au 29 mars 2011, soit un mois après le 28 février 2011, date de
la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 391, et a entraîné de plein droit et simultanément les effets
visés à l'article 274 LSC, notamment, la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante
qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante, et la
Société Absorbée a cessé d'exister.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur demande de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; sur demande de la même personne com-
parante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en une langue connue de la personne comparante, connues du notaire
instrumentant par son nom, prénom, état et demeure, ladite personne comparante, a signé ensemble avec le notaire le
présent acte original.
Signé: G. CHASTE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2011. LAC/2011/33646. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Référence de publication: 2011106154/108.
(110121589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.
Lowainvest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011100273/10.
(110114646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.
LSF Marseille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 90.567.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011100274/11.
(110113718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.
Luxcasa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 152.009.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
101855
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011100276/10.
(110113984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.
Aron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 158.949.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 30 juin 2011, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société ARON S.A.i>
L'Assemblée générale décide d'acter, avec effet immédiat, le rectificatif du dépôt L110103396 du 30 juin 2011, suite à
l'assemblée générale du 30 juin 2011 lors de la Société ARON S.A.
A cet effet, l'Assemblée générale décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission Monsieur Benoît Dabertrand,
né le 16 mai 1970 à Charleroi (Belgique), et, résidant professionnellement à L-1611 Luxembourg au 61, Avenue de la
Gare, en tant qu'administrateur de la Société ARON S.A.
L'Assemblée décide également de nommer Monsieur Sébastien Corman, né le 20 août 1972 à Verviers (Belgique), et,
résidant professionnellement à L-1611 Luxembourg, au 61, Avenue de la Gare, en tant qu'Administrateur de la Société
ARON S.A. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2017.
Dès lors, le conseil d'administration de la société se composera désormais de:
- Mr Sébastien Corman
- Mr Cédric de Caritat
- Mr Nicolas Delattre
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Aron s.a.
Signature
Référence de publication: 2011103967/23.
(110119735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.
Holmani, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 113.731.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, 6, place de Nancy le 14 décembre 2010i>
L’Assemblée Générale décide de ratifier le changement de Commissaire intervenu en date du 24 décembre 2008. Le
nouveau Commissaire est la société PKF Abax Audit, R.C.S. n° B 142867 ayant son siège social au 6, Place de Nancy
L-2212 Luxembourg, et son mandat arrivera à échéance lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2012 en rempla-
cement de la société Abax Audit, R.C.S. n° B 27761.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011101030/15.
(110114834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Holmani, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 113.731.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011101031/11.
(110114882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
101856
Aron S.A.
Auchan Luxembourg
Finagest S.A.
Holmani
Holmani
Horses Farm S.A.
Hospitality Services Luxembourg S.A.
I.C.C.A. S.à.r.l.
Icon 2 S.à r.l.
Ignition Luxembourg AWS Holdings, S.à r.l.
Ignition Luxembourg AWS Holdings, S.à r.l.
IGS Ingenieurgesellschaft für Schadenanalyse S.A.
Imagine Finance S.à r.l.
Immobal S.A.
Immobilière 166 GR S.A.
Immo Heima S.à.r.l.
International Safety Hard Alloy Corporation
Interpublic Group (Luxembourg) S.à r.l.
Inter S.à r.l.
Inversiones Ampudia S.A.
In Vogue S.à r.l.
Ipes (Luxembourg) S.A.
Isis Shipping S.A.
Jade Finance S.à.r.l.
Jans-1 S.à r.l.
JCM Lux S.à r.l.
John Deere Cash Management S.A.
John Deere Cash Management S.A.
John Deere Funding S.A.
John Deere Funding S.A.
Kalvin S.A.
Kalvin S.A.
Karmi Invest S.A.
Kellner Group & Associés S.A.
KIGA s.à.r.l.
Kihn
Klee Holding S.A.
Knightlights Property International S.A.
Kodesh S.A.
Kodesh S.A.
Kodesh S.A.
Kodesh S.A.
Koho Investments (Luxembourg) S.A.
Kumba Iron Ore Holdings S.à r.l.
Kurti Bau S.à r.l.
Kurti Bau S.à r.l.
Kurti Bau S.à r.l.
Kurti Bau S.à r.l.
LaMAGGESE S.A.
Leica Holdings S.à r.l.
Lonworld S.A., SPF
Lowainvest S.à.r.l.
LSF Marseille S.à r.l.
Luxcasa S.à r.l.
L.V. S.A.
Premicon S.à r.l.
RE Debt Strategy S.A.
SPS Platin Securitisation S.A.
Telex S.à r.l.