logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2103

9 septembre 2011

SOMMAIRE

ABC Legacy Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100941

Aberdeen Global II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100943

ABN AMRO Multi-Manager Funds  . . . . . . .

100911

Acobel International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100943

A.G.W. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100935

Airest Collezioni S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

100938

Alba Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100938

Aleph Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

100938

Alfred Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100902

ALS Holdings (International) . . . . . . . . . . . .

100923

ALS Holdings (US)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100933

Amazon Payments Europe S.C.A.  . . . . . . .

100934

Ambigest International S.A. . . . . . . . . . . . . .

100941

Ambolt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100934

Ambolt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100941

A-PQ Luxco Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

100935

Auchan International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

100935

Avere Asset Management S.A.  . . . . . . . . . .

100912

Baobab Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

100921

BNP Paribas Flexi I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100913

BRS International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100935

Carren Gere S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100898

Clairval Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100913

Concept Intérieur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100936

C.T. - A & A S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100902

ECM Real Estate Investments A.G.  . . . . . .

100899

Ecomin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100898

E&G Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100903

FGP IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100933

Fidecum SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100904

FINAGEL S.A., société de gestion de patri-

moine familial (SPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100915

Finagra S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100915

FlyBalaton Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

100898

G.B. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100934

IV Umbrella Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100908

Jef Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100909

Lady Ice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100938

Lux-Pension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100922

MAMERANUS Participations S.A.  . . . . . . .

100943

MAN Umbrella SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100905

Masco Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100944

Matro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100920

Mayroy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100944

Mobimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100921

Montana Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

100922

Naxos International Holding S.A., SPF  . . .

100910

Norddeutsche Landesbank Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100917

Norddeutsche Landesbank Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100918

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.  . . . .

100915

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.  . . . .

100916

Olympia JV CO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100923

Pan European Real Estate Invest  . . . . . . . .

100909

Partelcom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100922

PEF Epsilon Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . .

100905

PEF Epsilon Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . .

100919

Portalo Europe AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100920

Robeco Alternative Investment Strategies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100911

Signam International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

100941

Sky Halle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100919

Société de Financement Médical et Hospi-

talier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100899

Sopartag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100914

Sunset S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100920

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav  . . . . . . .

100909

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav  . . . . . . .

100910

Swiss Rock (Lux) Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100901

100897

L

U X E M B O U R G

Carren Gere S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 107.459.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra extraordinairement le <i>26 septembre 2011 à 10 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31/12/2010;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011124441/322/16.

FlyBalaton Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 150.949.

All Shareholders are hereby convened to attend the

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

which is going to be held at the registered office in Luxembourg, on <i>30 Septembre 2011 at 11.00 am

<i>Agenda:

1. Dissmissal of current directors;
2. Termination of the corporate services agreement with Experta Luxembourg;
3. Appointment of a new domiciliation agent;
4. Discharge of the directors;
5. Appointment of new directors and proposal to appoint Alice Management S.A., Béatrice Management S.A. and

Claire Management S.A. as new directors of FlyBalaton; and

6. Miscellaneous.
The shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their bearer shares five clear days before the

date fixed therefore.

<i>THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2011124442/1017/20.

Ecomin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 20.043.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra extraordinairement le jeudi, <i>29 septembre 2011 à 10.00 heures au siège de la société à

Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice

clôturé au 31.12.2010;

2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2010;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011126134/832/18.

100898

L

U X E M B O U R G

Société de Financement Médical et Hospitalier, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 11.770.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le <i>3 octobre 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2010.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

6. Nominations statutaires
7. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011124962/19.

ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

Notice of a meeting of bondholders is hereby given to the holders of the outstanding 21,221 Bonds (the "Bondholders"

and each individually the "Bondholder") issued on 9 

th

 October 2007 and of 5,311 Bonds issued on 2 

nd

 November 2007,

with ISIN Code XS0319645981 (the "Bonds").

At the request of the bondholders' representative:

MEETING OF THE BONDHOLDERS

of  the  Company  (the "Meeting")  will  be  held  at  Le  Meridien  - Piccadilly,  21,  Piccadilly, London W1J 0BH, United

Kingdom, on <i> 29 

<i>th

<i> September 2011  at 11.00 a.m. (UK time), with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Update by the Bondholders Representative on the present situation regarding ECM REI AG and the insolvency

filing of the Company in the Czech Republic, including the appeal on the declaration of bankruptcy and the consti-
tutional complaint filed by the Bondholders Representative in the Czech Republic;

2. Update by the Bondholders Representative on the present situation regarding ECM REI AG and the Change of

Control suit filed in Luxembourg;

3. Update by the Bondholders Representative on the present situation regarding ECM REI AG and the winding-up

petition filed in Hong Kong S.A.R.;

4. Acknowledgment of the terms and conditions of the appointment of the Bondholder Representative and its advisors

(including Oostvogels Pfister Feyten, Salans LLP, Tarpan Partners &amp; Tanner de Witt, UniCredit) and the scope of
their mandates or work;

5. Vote on approval of Bondholder Representative mandate and reimbursement of Bondholder Representative and

its advisors by Bondholders or from the proceeds of any funds recovered in the insolvency;

6. Miscellaneous.
The Bonds are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with

the clearing and depositary systems Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream Luxembourg"), and UNIVYC
a.s. ("UNIVYC", and collectively with Clearstream, the "Clearstream systems") through which transactions in the Bonds
are affected.

Bondholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and

UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.

Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder

(each, an "Intermediary") are urged to respect the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.

Bondholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Bonds in the relevant Clearing

Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems and provide details concerning their identity
to the Depositary and the Company.

100899

L

U X E M B O U R G

The Bondholders need not be present at the Meeting in person.
The Meeting may validly decide upon this convening notice only if the Bondholders present or represented hold at

least 50 per cent of the total amount of the Bonds outstanding on the date of the Meeting.

The decisions at the Meeting will be passed by a majority consisting of:
1. 50% + 1 vote for the appointment or removal of representatives, the removal of special representatives nominated

by the Issuer and the approval of any protective measure taken in the interests of the Bondholders.

2. not less than two-thirds of the votes cast by Bondholders present or represented in respect of any other decision

the Meeting may validly decide upon.

The attention of the Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will

validly bind all the Bondholders (even those not represented at the Meeting).

A Bondholder may act at the Meeting by appointing another person who needs not be a Bondholder himself.
Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE

INVESTMENTS  A.G.,  Mrs.  Alexandria  Ludowicy,  or  BDO  Tax  &amp;  Accounting,  Mr.  Pierre  LENTZ,  Email:
Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).

Any Bondholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting

certificate issued by the Depositary relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable,
confirmation of the respective Intermediary through which the respective Bondholder holds the Bonds within the Clearing
Systems.

Any Bondholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate(s) to

the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form and his voting
certificate(s) at the registered office of the Company.

Any Bondholder or proxyholder wishing to attend and vote at the Meeting must present at the beginning of the Meeting

all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the Bonds, and
among others the Passport in order to verify the identity of the Bondholder or proxyholder, and a valid and up-to-date
extract from the relevant commercial registry evidencing the powers of the representative of the Bondholder or evi-
dencing that a proxy has been signed validly.

To obtain a voting certificate, Bonds must be deposited with the Depositary of (to the satisfaction of such Depositary)

held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining
voting certificates, not later than 1 pm (CET) on 28 

th

 of September 2011.

Bonds so deposited or held will not be released until the conclusion of the Meeting (or if applicable, any adjournment

of such Meeting).

Confirmation of attendance to the Meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be

effected by fax (or any other permissible means) at the registered office of the Company no later than 1 pm (CET) on
28 

th

 of September 2011.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a beneficial owner will remain valid and

effective for an adjourned Meeting.

The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulated to the Bondholders

by email by the Bondholders' representative.

The contact details of the Company are as follows:

Company

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 45 123 205
Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax &amp; Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES

The details of the Depositary are as follows:

Depositary

Caceis Bank Luxembourg
5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 47 67 73 13
Email: lb-dob-listing@caceis.com
Attention: Corporate Trust Department

Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Astin Capital Management Limited

100900

L

U X E M B O U R G

7-9 Swallow Street, 3 

rd

 Floor

London, W1B 4DE

Fax: +44 (20) 70341001

Email: charles.bray@astincapital.com

Attention: Charles Bray

Luxembourg, on 7 

th

 September 2011.

Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Astin Capital Management Limited

Référence de publication: 2011124963/1035/100.

Swiss Rock (Lux) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 135.671.

Wir möchten Sie hiermit zu der am <i>28. September 2011 um 11 Uhr 15 in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

Großherzogtum Luxemburg stattfindenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Swiss Rock (Lux) Sicav (die "Gesellschaft") einladen. Die Gesellschaft unterliegt seit dem 1. Juli 2011

dem neuen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") und soll
nunmehr an dessen Anforderungen angepasst werden. Das Gesetz von 2010 setzt die Richtlinie 2009/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in das Luxemburgische Recht um. Infolgedessen muss die Satzung
der Gesellschaft angepasst werden. Ferner sollen gleichzeitig eine Reihe von formellen und terminologischen Anpassungen
vorgenommen werden.

Die außerordentliche Generalversammlung wird folgende Tagesordnung haben:

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für

gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz
2, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel
11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h), j) und
Einfügung eines neuen Punkt i), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel
25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.
Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen
gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären
die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und
Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil
I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im

Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.

3. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Das für die Generalversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der General-

versammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversamm-
lung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an
der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entspre-
chend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte

und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011126141/2501/43.

100901

L

U X E M B O U R G

C.T. - A &amp; A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 209, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.654.

The shareholders shall convene to the

ORDINARY GENERAL MEETING

to be held in its offices at 209, route de Longwy, L-1941 LUXEMBOURG, on Wednesday, <i>September 28, 2011 at 02.00

p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of  the Liquidator and  the  Auditor in connection  with the  Company's accounts  for  the  Business  Years

2009/2010, ended March 31, 2010 and 2010/2011, ended March 31, 2011;

2. Approval of the balance sheets and profit and loss accounts for the Business Years 2009/2010, ended March 31,

2010 and 2010/2011, ended March 31, 2011;

3. Discharge to the Liquidator and the Auditor for the business years 2009/2010 and 2010/2011;
4. Appointment of the Auditor;
5. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Ordinary General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

Luxembourg, September 07, 2011.

Luca DI FINO
<i>The Liquidator

Référence de publication: 2011125520/23.

Alfred Berg, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 145.536.

An

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held at 2.00 p.m. on <i> 29 

<i>th

<i> September 2011  at the premises of the Management Company BNP

Paribas Investment Partners Luxembourg, H2O Building, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:

1. Choice  of  English  as  the  official  language  of  the  Articles  of  Association  as  authorised  by  Article  26  (2)  of  the

Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;

2. Article 1: deletion of the reference to abbreviated form of the Company's name.
3. Article 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning under-

takings for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;

4. Article 4: the commune of the registered office will be Hesperange instead of Howald-Hesperange;
5. Article 6: redefinition of the notion of "subfund";
6. Article 7: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";

Articles 8, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term "sub-category" by "class of shares";

7. Articles 8 and 10§6: cancellation of the issuance of share certificates

Deletion of Article 9 concerning lost or damaged certificates;

8. Article 10§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;
9. Article 13§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share

buybacks;

10. Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
11. Article 14§5, the day on which the net asset value is dated (and not the day on which the net asset value is calculated)

shall be referred to in the Articles of Association as the "Calculation Date".
Art. 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested (14b)
and exchange rate (14e);
Art. 14(c): replacement of the date of acceptance of the orders by the order acceptance date;
Art. 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;

100902

L

U X E M B O U R G

12. Article 15 (e) and (f): addition of the terms "categories or classes of shares" for suspensions of NAV and orders in

the event of merger or liquidation;
Art. 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of
merger;
Art. 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in
the master fund;
Art. 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by the Board of Directors to determine
the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;

13. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
14. Article 20: addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company

subfunds, as well as feeder subfunds;

15. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-

sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;

16. Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations

in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;

17. Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-

cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Art. 32: Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master
funds.

In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'

Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their

shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon

proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.

The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available

from the bodies listed in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011126132/755/65.

E&amp;G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Wir möchten Sie hiermit zu der am <i>28. September 2011 um 11 Uhr 40 in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

Großherzogtum Luxemburg stattfindenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der E &amp; G Fonds (die "Gesellschaft") einladen. Die Gesellschaft unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem

neuen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") und soll
nunmehr an dessen Anforderungen angepasst werden. Das Gesetz von 2010 setzt die Richtlinie 2009/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in das Luxemburgische Recht um. Infolgedessen muss die Satzung
der Gesellschaft angepasst werden. Ferner sollen gleichzeitig eine Reihe von formellen und terminologischen Anpassungen
vorgenommen werden.

Die außerordentliche Generalversammlung wird folgende Tagesordnung haben:

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für

gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 4, Artikel 6, Artikel
9, Einfügung eines neuen Punkt (e) und (h) in Artikel 10, Änderung von Artikel 14, Artikel 19 Punkt 6, Streichung
von  Artikel  21  sowie  Neunummerierung  der  daraufolgenden  Artikel,  Änderung  von  Artikel  21  Punkt  1  (neu),
Einfügung eines neuen Artikels 22, Änderung des Artikels 23, Streichung des Artikels 24, Änderung von Artikel 24
Punkt 7 c), d), g), Artikel 26, Artikel 27 und Einfügung eines neuen Punkt l) sowie Änderung von Artikel 30.
Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der zur Verfügung stehenden Gelder in Organismen für
gemeinsame Anlagen, Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten sowie anderen zulässigen Vermögenswerten
nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
gemeinsame Anlagen (einschließlich eventueller nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) ("Gesetz vom 17.

100903

L

U X E M B O U R G

Dezember 2010") und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens
zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie der
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender
Änderungen  und  Ergänzungen)  ("Gesetz  vom  10.  August  1915")  jegliche  Maßnahme  ergreifen  und  Transaktion
ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar
im weitesten Sinne entsprechend Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im

Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.

3. Verschiedenes.
Die geänderte Satzung steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Das für die Generalversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der General-

versammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversamm-
lung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an
der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entspre-
chend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte

und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011126133/2501/48.

Fidecum SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 139.445.

Wir möchten Sie hiermit zu der am <i>28. September 2011 um 11 Uhr in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

Großherzogtum Luxemburg stattfindenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Fidecum SICAV (die "Gesellschaft") einladen. Die Gesellschaft unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem

neuen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") und soll
nunmehr an dessen Anforderungen angepasst werden. Das Gesetz von 2010 setzt die Richtlinie 2009/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in das Luxemburgische Recht um. Infolgedessen muss die Satzung
der Gesellschaft angepasst werden. Ferner sollen gleichzeitig eine Reihe von formellen und terminologischen Anpassungen
vorgenommen werden.

Die außerordentliche Generalversammlung wird folgende Tagesordnung haben:

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für

gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz
2, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel
11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h), j) und
Einfügung eines neuen Punkt i), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel
25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.
Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen
gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären
die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und
Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil
I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Verschiedenes.
Die geänderte Satzung steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Das für die Generalversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der General-

versammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversamm-
lung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an
der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entspre-
chend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

100904

L

U X E M B O U R G

Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte

und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011126135/2501/41.

PEF Epsilon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.652.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011099518/9.
(110112602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

MAN Umbrella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.150.

We hereby give you notice that an extraordinary general meeting of shareholders of the Company was held, before

notary, on September 8, 2011, at the offices of Arendt &amp; Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, with
the agenda as set out below. The quorum required by article 67-1 (2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on
commercial companies as amended was not reached.

You are invited to attend the

RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company, which will be held, before notary, on <i>October 12, 2011 , at 11.00 a.m., at the offices

of Arendt &amp; Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Replacement of all references in the articles of incorporation to the Law of 20 December 2002 by references to

the Law of 17 December 2010 and replacement of all references to the Directive 85/611/EEC by references to the
Directive 2009/65/EC.

2. Amendment of Article 5 point 3 "Company assets" of the articles of incorporation, so as to read as follows:

The Board will assign pursuant to Article 181 (1) of the Law of 17 December 2010 a portion of the Company assets
to each class of share (such portion of the Company assets hereinafter referred to as a sub-fund) for which shares
will be issued pursuant to Article 7 of the Articles of Incorporation in the form of one or more classes of shares.
In relation to third parties, the assets of a sub-fund are only liable for such liabilities attributable to the sub-fund in
question.

3. Addition of a new point 7 under Article 8 "Redemption of shares" of the articles of incorporation, which shall read

as follows:
The Company shall have the right, if the Board so determines, and with the express consent of the relevant share-
holder, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in specie by allocating to the shareholder
investments from the portfolio of assets in such share class or sub-fund equal in value (as calculated in the manner
described in Article 11 hereof) as of the valuation day on which the redemption price is determined to the value
of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on
a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant share
class or sub-fund and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor appointed by the
Company pursuant to Article 22 hereof. The costs of any such transfers shall be borne by the shareholder.

4. Addition of a new point 4 of Article 11 "Net asset value per share" of the articles of incorporation, which shall read

as follows:
With respect to specific share classes or sub-funds and as further specified in the sales prospectus, the Board may
determine to apply an alternative net asset value calculation method (to include such reasonable factors as they
see fit) to the net asset value per share of such share class or sub-fund. This method of valuation is intended to
pass the estimated costs of underlying investment activity of the sub-fund to the active shareholders by adjusting
the net asset value of the relevant share class or sub-fund and thus to protect long-term shareholders from costs
associated with ongoing subscription and redemption activity.
This alternative net asset value calculation method may take account of trading spreads on the investments of the
share class or sub-fund, the value of any duties and charges incurred as a result of trading and may include an
allowance for market impact.

100905

L

U X E M B O U R G

Where the Board, based on the prevailing market conditions and the level of subscriptions or redemptions re-
quested by shareholders or potential shareholders in relation to the size of the relevant share class or sub-fund,
has determined for a particular share class or sub-fund to apply an alternative net asset value calculation method,
the share class or sub-fund may be valued either on a bid or offer basis (which would include the factors referenced
in the preceding paragraph).

5. Addition of new letters g. to k. to point 2 of Article 12 "Frequency and temporary suspension of the calculation of

the net asset value and of the issue and redemption of shares" of the articles of incorporation, which shall read as
follows:
g. following the suspension of the (i) calculation of the net asset value per share, (ii) the issue, (iii) redemption and/
or (iv) the conversion of the units / shares issued within the master fund in which a sub-fund of the Company invests
in its quality as a feeder fund of such master fund;
h. during a period where the relevant indices underlying the derivative instruments which may be entered into by
the relevant sub-funds of the Company are not compiled or published;
i. during any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company, in particular
the derivative instruments and repurchase transactions which may be entered into by the Company in respect of
any sub-fund, cannot promptly or accurately be ascertained;
j. during any period when the dealing of the shares of the relevant share class or sub-fund of the Company on the
relevant stock exchanges where the shares of the relevant share class or sub-fund of the Company are listed is
suspended or restricted;
k. during any period during which the relevant stock exchanges on which the shares of the relevant share class or
sub-fund of the Company are listed are closed.

6. Amendment of point 1 and 2 of Article 13 "The Board of Directors" of the articles of incorporation, so as to read

as follows:
1. The Company is managed by a Board comprising at least three members. The members of the Board are not
required to hold shares in the Company. They are elected by the shareholders' meeting, in particular by the share-
holders at their annual general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until
their successors are elected and qualify. The shareholders' meeting also determines the number of Board members,
their remuneration and their period of office, which may run for a maximum of six years. The Board members may
be re-elected. The shareholders' meeting may assign the day-to-day running of the business in its entirety to one
or more of the persons stipulated in Article 60 of the Law of 10 August 1915.
2. Board members are elected by a simple majority of the shares present or represented at the shareholders'
meeting and shall be subject to the approval of the Luxembourg regulatory authorities.

7. Amendment of letter i) and addition of a new letter j) of Article 18 "Investment policy and investment restrictions"

of the articles of incorporation, which shall read as follows:
i) The relevant sub-fund will not invest more than in aggregate 10% of its net asset value in units of UCITS or other
UCI unless the relevant appendix of such sub-fund in the prospectus of the Company explicitly provides for a
deviant investment policy in this respect. In particular, such appendix may allow the investment in units of a master
fund qualifying as a UCITS provided that the relevant sub-fund invests at least 85% of its net asset value in units of
such master fund and that such master fund shall neither itself be a feeder fund nor hold units/shares of a feeder
fund.
j) A sub-fund may invest in shares of another sub-fund of the Company (the "Target Sub-Fund") provided that
- the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the sub-fund invested in this Target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in
aggregate in units of other Target Sub-Funds; and
- voting rights attached to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned
and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these shares are held by the sub-fund, their value will not be taken into consideration
for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the
net assets as set out in Article 5 point 7; and
- there is no duplication of management, performance, subscription or redemption fees amongst the Target Sub-
Fund and the investing sub-fund.

8. Amendment of Article 21 "Remuneration of the Board" of the articles of incorporation which shall be renamed

"Remuneration and indemnification of the Board", so as to read as follows:
The remuneration for Board members is determined by the shareholders' meeting.
Every Board member, managerial employee, managing director, agent, auditor or officer of the Company and his
personal representatives shall be indemnified and secured harmless out of the assets of the relevant sub-fund(s)
against all actions, proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities ("Losses") incurred or sus-
tained by him in or about the conduct of the Company business or affairs or in the execution or discharge of his
duties, powers, authorities or discretions, including Losses incurred by him in defending (whether successfully or
otherwise) any civil proceedings concerning the Company in any court whether in Luxembourg or elsewhere. No
such person shall be liable: (i) for the acts, receipts, neglects, defaults or omissions of any other such person; or
(ii) by reason of his having joined in any receipt for money not received by him personally; or (iii) for any loss on

100906

L

U X E M B O U R G

account of defect of title to any property of the Company; or (iv) on account of the insufficiency of any security in
or upon which any money of the Company shall be invested; or (v) for any loss incurred through any bank, broker
or other agent; or (vi) for any loss, damage or misfortune whatsoever which may happen in or arise from the
execution or discharge of the duties, powers, authorities, or discretions of his office or in relation thereto, unless
the same shall happen through his own gross negligence or wilful misconduct against the Company.

9. Amendment of Article 26 "Dissolution and merger of sub-funds" of the articles of incorporation which shall be

renamed "Dissolution of sub-funds", so as to read as follows:
Without prejudice to the powers of the Board pursuant to Article 8 point 7, the meeting of the shareholders of a
sub-fund may resolve to reduce the Company assets by dissolving the sub-fund concerned and cancelling any shares
issued in such sub-fund and to pay out to the shareholders the unit price of the shares, as determined on the
valuation day on which the resolution takes effect, less any costs incurred in connection with liquidating the sub-
fund. No quorum is required at the general meetings of sub-fund shareholders and any resolutions put to the vote
of the meeting are passed by a simple majority of the shareholders present or shares represented.
Once a sub-fund has been liquidated, any liquidation proceeds relating to shares that have not been surrendered
will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg following the date on which the liquidation pro-
ceedings were completed.
The liquidation of a sub-fund shall have no influence on any other sub-fund. The liquidation of the last remaining
sub-fund will result in the Company's liquidation.

10. Addition of a new Article 27 "Mergers" of the articles of incorporation, which shall read as follows:

1. The Board may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010) of the
Company or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions
and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the
information to be provided to the shareholders, as follows:
a. The Board may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:
- another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS"); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company concerned as Shares of this New UCITS, or of the
relevant sub-fund thereof as applicable.
In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 17 December
2010), solely the Board will decide on the merger and effective date thereof.
In the case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 17 December
2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective
date of such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes
cast at such meeting.
b. The Board may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010) of any
Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the "New Sub-Fund");
or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the
New Sub-Fund as applicable.
2. Notwithstanding the powers conferred to the Board under the preceding section, the general meeting of share-
holders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010) of the Company
or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions and
procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the infor-
mation to be provided to the shareholders, as follows:
a. The general meeting of the shareholders may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving
or absorbed UCITS, with:
- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof.
The decision shall be adopted by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum re-
quirement and which will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority
of the votes validly cast at such meeting.
b. The general meeting of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the Law of 17 December
2010) of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund
by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
3. Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged to the
Company nor its shareholders.
Shareholders will in any case be entitled to request, without any charge other than those retained by the Company
or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their shares, or, where possible,

100907

L

U X E M B O U R G

to convert them into units or shares of another UCITS pursuing a similar investment policy and managed by the
same management company or by any other company with which the management company is linked by common
management or control, or by substantial direct or indirect holding, in accordance with the provisions of the Law
of 17 December 2010.

11. Renumbering of all Articles after the new Article 27 "Mergers" of the articles of incorporation and all references

thereto.

12. Miscellaneous.

The Meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution

on each item of the agenda may validly be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes validly cast at
the meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011126138/755/180.

IV Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 71.816.

Wir möchten Sie hiermit zu der am <i>28. September 2011 um 11.50 Uhr in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

Großherzogtum Luxemburg stattfindenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Sicav IV Umbrella Fund (die "Gesellschaft") einladen. Die Gesellschaft unterliegt seit dem 1. Juli 2011

dem neuen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010") und soll
nunmehr an dessen Anforderungen angepasst werden. Das Gesetz von 2010 setzt die Richtlinie 2009/65/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in das Luxemburgische Recht um. Infolgedessen muss die Satzung
der Gesellschaft angepasst werden. Ferner sollen gleichzeitig eine Reihe von formellen und terminologischen Anpassungen
vorgenommen werden.

Die außerordentliche Generalversammlung wird folgende Tagesordnung haben:

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für

gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz
2, Artikel 5 Absatz 1, 4, Artikel 7 (Streichung von Absatz 6), Artikel 8 Absatz 2, 5, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e),
(f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel 11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in
Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h) und Einfügung eines neuen Punkt i) und j), Änderung von
Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 23 Absatz 3, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel 25, Änderung von
Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.
Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen
gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären
die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und
Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil
I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im

Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.

3. Verschiedenes.
Die geänderte Satzung steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Das für die Generalversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der General-

versammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversamm-
lung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an
der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entspre-
chend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte

und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011126136/2501/44.

100908

L

U X E M B O U R G

Jef Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 50.124.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le jeudi 8 septembre 2011 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur

la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra mardi <i>18 octobre 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011126137/755/17.

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.055.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à

capital variable) Swiss Rock (Lux) Dachfonds ("Gesellschaft") findet die

JÄHRLICHE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>28. September 2011 um 12.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, rue Gabriel Lippmann, L - 5365

Munsbach, Luxemburg, statt.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Juli 2010 bis zum 30. Juni 2011.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
6. Ernennung Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Generalversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vorgelegt werden oder

die Aktien bis spätestens zum 23. September 2011 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die
Sperrung der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im September 2011.

<i>Der Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Référence de publication: 2011126140/2501/24.

Pan European Real Estate Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 111.271.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société Pan European Real Estate Invest S.A. qui se réunira le <i>22 septembre 2011 à 16.30 heures au Cabinet

Philippe &amp; Partners, 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Accord sur le lieu de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire en dehors du siège social;
2. Lecture des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes et lecture du

rapport du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice écoulé au 31 décembre 2010;

3. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 et affectation du résultat;

100909

L

U X E M B O U R G

4. Décision quant à la continuation des activités de la société au vu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915;
5. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice social clôturé au 31

décembre 2010;

6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011120738/20.

Naxos International Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 34.288.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi <i>27 sept. 2011 à 12:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30/06/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011126139/1267/16.

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.055.

Wir möchten Sie hiermit zu der am <i>28. September 2011 um 11 Uhr 30 in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,

Großherzogtum Luxemburg stattfindenden

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav (die "Gesellschaft") einladen. Die Gesellschaft unterliegt seit dem

1. Juli 2011 dem neuen Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von
2010") und soll nunmehr an dessen Anforderungen angepasst werden. Das Gesetz von 2010 setzt die Richtlinie 2009/65/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in das Luxemburgische Recht um. Infolgedessen muss
die Satzung der Gesellschaft angepasst werden. Ferner sollen gleichzeitig eine Reihe von formellen und terminologischen
Anpassungen vorgenommen werden.

Die außerordentliche Generalversammlung wird folgende Tagesordnung haben:

<i>Tagesordnung:

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für

gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz
2, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel
11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h), j) und
Einfügung eines neuen Punkt i), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel
25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.
Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen
gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären
die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und
Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil
I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im

Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.

3. Verschiedenes.
Die geänderte Satzung steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Das für die Generalversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der General-

versammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversamm-

100910

L

U X E M B O U R G

lung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an
der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entspre-
chend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte

und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011126142/2501/43.

Robeco Alternative Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 87.117.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company ("EGM") held on 18 August 2011 could not

validly deliberate on resolutions due to a lack of quorum required, notice is hereby given of a reconvened

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on <i>30 September 2011 at 11.00 a.m. Luxembourg time, at the registered office of the Company, to deliberate

and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. to resolve upon the liquidation of the Company; and
2. to appoint Robeco Luxembourg S.A., represented by Mr. Norbert C.H.M. Wagemans and Mr. Volker Wytzes (each

acting and signing alone), as liquidator and to determine the liquidator's powers and remuneration.

No quorum is required for the holding of the meeting. The passing of resolution number 1 requires the consent of

two thirds of the votes cast at the meeting. The passing of resolution number 2 (appointment of the liquidator) only
requires the consent of a simple majority of the votes cast at the meeting. Votes cast shall not include votes in relation
to shares represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the votes or have
abstained or have returned a blank or invalid vote.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the EGM by proxy. The proxy forms are available, free

of charge, at the registered office of the Company. Proxies given for the EGM of 18 August 2011 will be taken into
consideration unless they are revoked or its principal has ceased to be a shareholder of the Company. The proxy will
remain in force if the meeting, for whatever reason, is postponed.

Shareholders wishing to attend and vote at the EGM should inform the bank or institution through which the shares

are held in writing no later than 28 September 2011. Shareholders who hold their shares in another way should inform
the Board of Directors of the Company.

Luxembourg, on 22 August 2011 / 9 September 2011.

<i>The Board of Directors .

Référence de publication: 2011119082/755/28.

ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 78.762.

An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held at 2:00 p.m. on Tuesday <i>September 20, 2011 at the premises of the Management Company

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, H2O Building, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

Update of the Articles of Association as following:

<i>Agenda:

1. Choice  of  English  as  the  official  language  of  the  Articles  of  Association  as  authorised  by  Article  26  (2)  of  the

Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;

2. Article 4: correction of the name of Articles 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17

December 2010 concerning undertakings for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;

3. the commune of the registered office (Hesperange instead of Howald-Hesperange);
4. Article 6: redefinition of the notion of "subfund";
5. Article 7: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";

Articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term "sub-category" by "class of shares";

6. Articles 8 and 10§6: cancellation of the issuance of share certificates

Deletion of Article 9 concerning lost or damaged certificates;

7. Article 10§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;

100911

L

U X E M B O U R G

8. Article 13§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share

buybacks;

9. Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;

10. Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested

(14b) and exchange rate (14e);
Article 14(c): replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is
received for the valuation date for listed assets;
Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;

11. Article 15 (e) and (f): addition of the terms "categories or classes of shares" for suspensions of NAV and orders in

the event of merger or liquidation;
Article 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of
merger;
Article 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions
in the master fund;

12. Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by resolution of the Board of Directors

to determine the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the pro-
cessing of orders;

13. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
14. Article 20: addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company

subfunds, as well as feeder subfunds;

15. Article 25: replacing the words "at least one-fith of the capital" by "at least one-tenth of the capital" in the second

paragraph;

16. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-

sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;

17. Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations

in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;

18. Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-

cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Article 32: Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master
funds.

In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'

Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their

shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon

proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.

The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available

from the bodies listed in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011122239/755/65.

Avere Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 116.692.

Please be informed that in accordance with article 67, 5th paragraph of the Luxembourg law, the meeting convened

on August 23, 2011 has been adjourned, while in session, to four weeks.

Accordingly the shareholders are convened to the

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

of Avere Asset Management S.A. that will be held at the registered office in 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg on <i>20/09/2011 at 15.00 o'clock with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Removal of the following persons as directors of the Company with immediate effect:

- Mrs Sonja Bemtgen, residing professionally at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

100912

L

U X E M B O U R G

- Mrs Stéphanie Bouju, residing professionally at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
and
- Mrs Virginie Derains, residing professionally at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

2. Appointment of the following persons as directors of the Company with immediate effect and for a period of three

years:
- Mr Riccardo Moraldi;
- Mr Vincent Cormeau; and
- Mr Bertrand Michaud.

3. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011119621/25.

Clairval Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 19.642.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>19.09.2011 à 14.30 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 30.06.2011;
- Affectation du résultat au 30.06.2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période de 6 ans
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l'Assemblée au Siège Social.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011121259/19.

BNP Paribas Flexi I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 117.580.

Notice of convocation

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Which will be held on <i>September 20, 2011 at 2.00 p.m., at the office of BNP Paribas Investment Partners, H2O building,

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

Update of the Articles of Association as follow:

1. Article 3: reference to the Luxembourg Law of 17 December 2010;
2. Redefinition of the "subfund";
3. Review of the terms "category of shares" and "class of shares" and replacement of all reference to "sub-category"

by "class of share" in the whole document;

4. Articles 8 &amp; 10: cancellation of the share certificate issue;
5. Cancellation of Article 9 "lost or damaged certificates";
6. Article 10: possibility for the Board of Directors to reject share subscription;
7. Article 12: addition of the following paragraph "This redemption price may be rounded off to the next higher or

lower unit or fraction of the currency in question, as determined by the Board of Directors."

8. Creation of a new article 13 allowing the Board to split or consolidate the shares issue within one same class, same

category or same subfund according to the conditions set by it;

9. Amendment of article 14 as follow:

- (b)(e) reference of the valuation day as the date of determination of the value of shares or units and exchange
rate;
- (c) replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is received for
the valuation date for listed assets;

100913

L

U X E M B O U R G

- (d) remove of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the valuation of
unlisted assets;

10. Article 15:

- (e)(f): addition of the terms "categories or classes of shares" for net asset value suspension and orders in the event
of merger or liquidation;
- (f): cancellation of the maximum period of two bank business days for net asset value suspension in case of merger,
splitting or restructuring operation;
- Possibility to suspend the net asset value calculation and orders in the "feeder" subfund in case of same suspension
in the "master" subfund;
- paragraph 3 &amp; 4: replacement of the 10% limit with a limit to be defined by the Board of Directors to determine
the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;

11. Article 17 § 5 is completed as follow "The votes cast shall not include those of directors who did not take part in

the voting, abstained, or cast a blank or void vote."

12. Article 20: possibility for the board to create subfunds investing in other Company subfunds as well as feeder

subfunds;

13. Article 27 is rewriting as follow "Unless otherwise provided for under current law or these Articles of Association,

the General Meeting of Shareholders shall validly deliberate, regardless of the portion of capital represented. Re-
solutions shall be adopted by a simple majority of votes cast. The votes cast shall not include those attached to
shares for which the shareholder did not take part in the voting, abstained, or cast a blank or void vote".

14. Articles 31 &amp; 32: remove of any reference to the 9 month period as from the date of the liquidation regarding the

asset not distributed to a time period set by regulations in force;

15. Article 32:

- Rewriting of the article to give the Board of Directors sole authority to decide on effectiveness and terms, under
the limitation and conditions prescribed by law, for the operation of liquidation, merger and splitting;
- Addition of the liquidation of feeder subfund in the event of liquidation, merger or split of the master fund.

In compliance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended by the

Law of 7 September 1987, the Meeting's deliberations are only valid if at least one-half of the Company's capital is present
or represented.

In  order  to  be  adopted,  resolutions  must  be  carried  out  by  at  least  two-thirds  of  the  votes  of  the  shareholders

expressed. The votes expressed do not comprise those attached to the shares for which the shareholder has not taken
part to the vote or has not voted or whose vote was considered as null or void.

Owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares at

the offices of the finance department at least five full days before the meeting.

Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting are admitted against proof of identity,

provided that they notify their intention to attend the meeting at least five full days beforehand.

The draft new Articles of Association and current prospectus and the last periodic report are available from the

agencies stated in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011122240/755/66.

Sopartag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.820.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011122803/1023/17.

100914

L

U X E M B O U R G

Finagra S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 24.500.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 septembre 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la Société,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011121260/755/19.

FINAGEL S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF), Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 28.619.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme FINAGEL S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>20 septembre 2011 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.05.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011122799/750/17.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 116.546.

Im Jahre zweitausendelf, am ersten Juni.
Vor dem amtierenden Notar Gérard LECUIT, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der “NORD/LB COVERED FINANCE

BANK S.A.”, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon, gegründet laut notarieller Urkunde
vom 9.Mai 2006, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1450 vom 28.Juli 2006.

Die Statuten der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert durch notarielle Urkunde vom 29.Oktober 2010, veröffent-

licht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 2784 vom 6.März 2011.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Christian KURZWEIL, Jurist, geschäftsansässig in

Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Stefan BRANDT, Diplomkaufmann ,geschäftsansässig in Luxemburg. Die

Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Roland Lichter, Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

100915

L

U X E M B O U R G

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon, nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7,

rue Lou Hemmer.

2) Verschiedenes.
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsi-

tzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon,

nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, und somit dem ersten Absatz von Artikel 3 folgenden Wortlaut
zu geben:

“ Art. 3. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Findel (Gemeinde Niederanven). Er kann durch

einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an einen anderen Ort dieser Gemeinde verlegt werden”

<i>Kosten und Gebühren

Die Kosten und Gebühren, in welcher Form auch immer, welcher der Gesellschaft anerfallen durch vorliegende Ur-

kunde, belaufen sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig euro (750,- EUR).

WORÜBER URKUNDE Geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg, in der Amtss-

tube des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. KURZWEIL, S. BRANDT, R. LICHTER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 juin 2011. Relation: LAC/2011/26047. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

Luxemburg, den 29. Juni 2011.

Référence de publication: 2011091088/53.
(110101655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 116.546.

Correctif au dépôt fait en date du 1 

er

 juillet 2011, réf.: L110101655

Im Jahre zweitausendelf, am ersten Juni.
Vor dem amtierenden Notar Gérard LECUIT, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der “NORD/LB COVERED FINANCE

BANK S.A.”, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 26, Route d'Arlon, gegründet laut notarieller Urkunde
vom 9.Mai 2006, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1450 vom 28.Juli 2006.

Die Statuten der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert durch notarielle Urkunde vom 29.Oktober 2010, veröffent-

licht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 2784 vom 6.März 2011.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Christian KURZWEIL, Jurist, geschäftsansässig in

Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Stefan BRANDT, Diplomkaufmann ,geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Roland Lichter, Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

100916

L

U X E M B O U R G

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, Route d'Arlon, nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7,

rue Lou Hemmer.

2) Verschiedenes.
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsi-

tzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, Route d'Arlon,

nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, und somit dem ersten Absatz von Artikel 3 folgenden Wortlaut
zu geben:

“ Art. 3. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Findel (Gemeinde Niederanven). Er kann durch

einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an einen anderen Ort dieser Gemeinde verlegt werden”.

<i>Kosten und Gebühren

Die Kosten und Gebühren, in welcher Form auch immer, welcher der Gesellschaft anerfallen durch vorliegende Ur-

kunde, belaufen sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig euro (750,- EUR).

WORUBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg, in der Amtss-

tube des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. KURZWEIL, S. BRANDT, R. LICHTER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 juin 2011. Relation: LAC/2011/26047. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FUR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

Luxemburg, den 29. Juni 2011.

Référence de publication: 2011117742/53.
(110134453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 10.405.

Im Jahre zweitausendelf, am ersten Juni.
Vor dem amtierenden Notar Gérard LECUIT, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der “NORDDEUTSCHE LANDESBANK

LUXEMBOURG S.A.”, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon, gegründet laut notarieller
Urkunde vom 11.September 1972, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 151 vom
22.September 1972.

Die Statuten der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert durch notarielle Urkunde vom 8.Dezember 2008, veröffent-

licht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 332 vom 14.Februar 2009.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Christian KURZWEIL, Jurist, geschäftsansässig in

Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Stefan BRANDT, Diplomkaufmann,geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Roland Lichter, Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

100917

L

U X E M B O U R G

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon, nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7,

rue Lou Hemmer.

2) Verschiedenes.
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsi-

tzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, route d'Arlon,

nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, und somit dem ersten Absatz von Artikel 3 folgenden Wortlaut
zu geben:

“ Art. 3. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Findel (Gemeinde Niederanven). Er kann durch

einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an einen anderen Ort dieser Gemeinde verlegt werden”

<i>Kosten und Gebühren

Die Kosten und Gebühren, in welcher Form auch immer, welcher der Gesellschaft anerfallen durch vorliegende Ur-

kunde, belaufen sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig euro (750,- EUR).

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg, in der Amtss-

tube des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. KURZWEIL, S. BRANDT, R. LICHTER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 juin 2011. Relation: LAC/2011/26046. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

Luxemburg, den 29. Juni 2011.

Référence de publication: 2011089902/54.
(110101132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2011.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 10.405.

<i>Correctif au dépôt fait en date du 30 juin 2011 réf.: L110101132

Im Jahre zweitausendelf, am ersten Juni.
Vor dem amtierenden Notar Gérard LECUIT, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der “NORDDEUTSCHE LANDESBANK

LUXEMBOURG S.A.”, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 26, Route d'Arlon, gegründet laut notarieller
Urkunde vom 11.September 1972, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 151 vom
22.September 1972.

Die Statuten der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert durch notarielle Urkunde vom 8.Dezember 2008, veröffent-

licht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 332 vom 14.Februar 2009.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Christian KURZWEIL, Jurist, geschäftsansässig in

Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Stefan BRANDT, Diplomkaufmann, geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Roland Lichter, Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

100918

L

U X E M B O U R G

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, Route d'Arlon, nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7,

rue Lou Hemmer.

2) Verschiedenes.
II. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsi-

tzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1140 Luxemburg, 26, Route d'Arlon,

nach L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, und somit dem ersten Absatz von Artikel 3 folgenden Wortlaut
zu geben:

“ Art. 3. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Findel (Gemeinde Niederanven). Er kann durch

einfachen Beschluss des Aufsichtsrates an einen anderen Ort dieser Gemeinde verlegt werden”

<i>Kosten und Gebühren

Die Kosten und Gebühren, in welcher Form auch immer, welcher der Gesellschaft anerfallen durch vorliegende Ur-

kunde, belaufen sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig euro (750.- EUR).

WORUEBER  URKUNDE,  Geschehen  und  aufgenommen  am  Datum  wie  eingangs  erwähnt  zu  Luxemburg,  in  der

Amtsstube des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit dem Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. KURZWEIL, S. BRANDT, R. LICHTER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 juin 2011. Relation: LAC/2011/26046. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations erteilt.

Luxemburg, den 29. Juni 2011.

Référence de publication: 2011117224/55.
(110134299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2011.

PEF Epsilon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 141.652.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011099519/9.
(110112603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Sky Halle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 149.892.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099569/10.
(110112704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

100919

L

U X E M B O U R G

Matro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 128.541.

Par la présente, je tiens à vous faire part de ma décision de démissionner avec effet immédiat, de mon mandat d'Ad-

ministrateur de la Société MATRO S.A..

Luxembourg, le 30 juin 2011.

Fabio MAZZONI.

Référence de publication: 2011099724/10.
(110112064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Sunset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.765,75.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.817.

EXTRAIT

1. Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale des associés de la Société tenue en date du 20 Juillet 2011

que:

- la société DELOITTE S.A., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,

a été réélue en tant que réviseur d'entreprises.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés de la Société qui approuvera les comptes annuels

arrêtés au 31 mars 2012.

- les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société avec effet au 15 Juillet et ce pour une période

indéterminée:

* Madame Bénédicte Moens-Colleaux, employée privée, née le 13 Octobre 1972 à Namur (Belgique), ayant son adresse

professionnelle à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Monsieur François Pfister, avocat, né le 25 Octobre 1961 à Uccle (Belgique), ayant son adresse professionnelle à 291

route d'Arlon, L-2016 Luxembourg;

* Madame Delphine Tempé, avocat, née le 15 Février 1971 à Strasbourg (France), ayant son adresse professionnelle

à 291 route d'Arlon, L-2016 Luxembourg;

2. Suite à un déménagement, Monsieur Stefan Germanus Maria Josef Oostvogels, gérant de la Société, demeure dé-

sormais professionnellement à 1, rue Spierzelt, L-8063 Bertrange, Luxembourg.

3. Suite à un déménagement, Monsieur Michael David Cook Smith, gérant de la Société, demeure désormais profes-

sionnellement à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

4. Suite à un déménagement, Monsieur Steven Frederic Koltes, gérant de la Société, demeure désormais profession-

nellement à 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20, juillet 2011.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2011105106/34.
(110119180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Portalo Europe AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 98.460.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

<i>vom 14.06.2011 um 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Frau Ute Klimek wird als alleiniges Verwaltungsratsmitglied abberufen.
2 Zum neuen alleinigen Verwaltungsratsmitglied bestellt wird die MMS Mercury Management Services S.A., R.C. B

Luxemburg 135.236 mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, vertreten durch ihren ständigen Vertreter,

100920

L

U X E M B O U R G

Herrn Götz Schöbel, geboren am 14.03.1966 in Bad Frankenhausen, geschäftsansässig zu L-1840 Luxemburg, 11A, bou-
levard Joseph II. Das Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet.

Luxemburg, den 14.06.2011

<i>Die Versammlung
Unterschrift

Référence de publication: 2011100545/18.
(110113659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Mobimo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 148.670.

Les Comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13/07/2011.

<i>Pour MOBIMO S.à r.l.
J. REUTER

Référence de publication: 2011099726/12.
(110111612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Baobab Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 124.020.

Il résulte de l'Assemblé Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 28 Juin 2011 que:
1) It was decided the transfer of the registered address of the Company from 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724

Luxembourg to 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2)  It  was  decided  the  termination  of  the  Directorship  of  Mr.  Bodo  Demisch  born  on  02 

nd

  of  October  1944  at

Hahnenklee, Jetzt Goslar Germany with professional address at 9A, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg as
Manager of BAOBAB HOLDINGS S.à r.l. société à responsabilité limitée.

3) It was decided the termination of the Directorship of Mr. Philip Barrett born on 05 

th

 of May 1968 at Aylesbury,

United Kingdom with professional address at 1-3 Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR London, United Kingdom as
Manager of BAOBAB HOLDINGS S.à r.l. société à responsabilité limitée.

4) It was decided the termination of the Directorship of Mr. Benjamin Penaliggon born 08 

th

 on March 1964 at Chard,

United Kingdom with professional address at 1-3 Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR London, United Kingdom as
Manager of BAOBAB HOLDINGS S.à r.l. société à responsabilité limitée.

5) It was decided to appoint Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. with registered address at 15,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as the Sole Manager of the Company, with immediate effect and for an unlimited
period of time.

Traduction française

1) L'assemblée a décidé le changement du siège social de la société du 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724 à 15,

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société BAOBAB HOLDINGS S.à r.l. société à respon-

sabilité limitée de M. Bodo Demisch né le 02 octobre 1944 à Hahnenklee, Jetzt Goslar Allemagne résidant profession-
nellement à 9A, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg.

3) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société BAOBAB HOLDINGS S.à r.l. société à respon-

sabilité limitée de M. Philip Barrett né le 05 mai 1968 à Aylesbury, Royaume-Uni, résidant professionnellement à 1-3
Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR Londres, Royaume Uni.

4) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société BAOBAB HOLDINGS S.à r.l. société à respon-

sabilité limitée de M. Benjamin Penaliggon né le 08 mars 1964 à Chard, Royaume-Uni résidant professionnellement à 1-3
Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR Londres, Royaume Uni.

5) L'assemblée a nommé comme Gérant de la société pour une période indéterminée à partir de 28 Juin 2011:
Pramerica Luxembourg Corporate Directorship Sàr.l. avec l'adresse au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Grand Duché

de Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100921

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, 15 juillet 2011.

Pour avis conforme
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011104919/42.
(110119197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Montana Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 70.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011099727/10.
(110111619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Partelcom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 71.866.

Les Comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 13/07/2011.

<i>Pour PARTELCOM S.A.
J. REUTER

Référence de publication: 2011099734/12.
(110111610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Lux-Pension, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 88.078.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société tenue à Luxem-

bourg, le 14 juillet 2011, enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2011, LAC/2011/32509 l'ordre du jour suivant:

1. Echéance des mandats des membres actuels du conseil d'administration.
2. Nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2012:

M. Jean-Claude FINCK, président
M. Michel BIREL, vice-président
M. Ernest CRAVATTE, administrateur
M. Gilbert ERNST, administrateur
M. Jean HABAY, administrateur
M. Pit HENTGEN, administrateur
M. Guy HOFFMANN, administrateur
M. Guy ROSSELJONG, administrateur
Mme Françoise THOMA, administrateur
M. Charles WAGENER, administrateur
M. Paul WARINGO, administrateur.
3. Echéance du mandat du Réviseur d'Entreprises
4. Nomination du Réviseur d'Entreprises PricewaterhouseCoopers S.A. pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'As-

semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100922

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 juillet 2011.

<i>Pour la société
Joseph Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2011106271/32.
(110121992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

ALS Holdings (International), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.080.

Il résulte de l'Assemblé Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 28 Juin 2011 que:
1) It was decided the transfer of the registered address of the Company from 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724

Luxembourg to 15, Boulevard Joseph II. L-1840 Luxembourg.

2)  It  was  decided  the  termination  of  the  Directorship  of  Mr.  Bodo  Demisch  born  on  02 

nd

  of  October  1944  at

Hahnenklee, Jetzt Goslar Germany with professional address at 9A, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg as
Manager of ALS Holdings (International) société à responsabilité limitée

3) It was decided the termination of the Directorship of Mr. Philip Mathew Barrett born on 05 

th

 of May 1968 at

Aylesbury, United Kingdom with professional address at 1-3 Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR London, United
Kingdom as Manager of ALS Holdings (International) société à responsabilité limitée

4) It was decided to appoint Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. with registered address at 15,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as the Sole Manager of the Company, with immediate effect and for an unlimited
period of time.

Traduction française

1) L'assemblée a décidé le changement du siège social de la société du 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724 à 15,

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société ALS Holdings (International) société à respon-

sabilité limitée de M. Bodo Demisch né le 02 octobre 1944 à Jetzt, Goslar Allemagne résidant professionnellement à 9A,
Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg.

3) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société ALS Holdings (International) société à respon-

sabilité limitée de M. Philip Mathew Barrett né le 05 mai 1968 à Aylesbury Royaume Uni résidant professionnellement à
1-3 Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR Londres, Royaume Uni.

4) L'assemblée a nomme comme Gérant de la société pour une période indéterminée a partir de 28 Juin 2011:
Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. avec l'adresse au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Grand Duché

de Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 15 juillet 2011.

Pour avis conforme
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011104899/36.
(110119137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Olympia JV CO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 161.612.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth day of May.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

NPS European Property Retail (Luxembourg) S.à r.l., a limited liability company, organized by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office in 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, in the course of being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

100923

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, residing professionally at Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “OLYMPIA JV CO S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,
any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real
estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of
security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares in registered form, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

100924

L

U X E M B O U R G

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.
If several managers are appointed, they shall constitute the Board composed of one (1) or several class A managers

and one (1) or several class B managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any A manager and

any B manager of the Company, or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.1 of these Articles.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

100925

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Liability of the managers
10.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

100926

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.

<i>Subscription and Payment

NPS European Property Retail (Luxembourg) S.à r.l., represented as stated above, subscribes to all the five hundred

(500) shares in registered form, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, and agrees to pay them in
full by a contribution in cash of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the Company's disposal and evidence

thereof has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:

100927

L

U X E M B O U R G

- Mrs Mary Frances Harnetty, born on November 29, 1965 in Luton, United-Kingdom, with professional address at

166, Sloane Street, SW1X 9QF London, United Kingdom;

- Mr. Ian Edward Baker, born on February 3, 1961 in Carshalton, United Kingdom, with professional address at 166,

Sloane Street, SW1X 9QF London, United Kingdom.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Russell Perchard, born on January 16, 1978, in St. Helier, Jersey, with professional address at 291, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg;

- Mr. Costas Constantinides born on September 17, 1979 in Nicosia, Cyprus, with professional address at 291, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

- Mr. Wayne Fitzgerald, born on May 11, 1976 in Waterford, Ireland, with professional address at 291, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg.

3. The registered office of the Company is located at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-quatrième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

NPS European Property Retail (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en cours d'immatriculation
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée par Monsieur Régis Galiotto, employé privé de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "OLYMPIA JV CO S.à r.l." (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et dans toute sorte de biens immobiliers, et la gestion de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et
autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généra-
lement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer

100928

L

U X E M B O U R G

à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir
dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature
ou origine que ce soit. La Société peut investir dans l'immobilier quel que soit les modalités d'acquisition, comprenant
notamment l'acquisition par voie de vente ou d'exécution de sûreté.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales

sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le Conseil de gérance composé de un (1) ou plusieurs gérants de

catégorie A et un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est

au Luxembourg.

100929

L

U X E M B O U R G

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et qu'au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition qu'aucune
résolution ne soit valablement adoptée qu'après approbation par au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant
de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion
ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
La Société est engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A

et d'un gérant de catégorie B, ou par la signature unique ou conjointe de toutes les personnes à qui des pouvoirs de
signature ont été délégués conformément à l'article 8.1 des présents statuts.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence faite dans ces Statuts au Conseil de gérance ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.

9.2 La Société est engagée envers les tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée envers les tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et aux
dispositions applicables de la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

100930

L

U X E M B O U R G

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art.13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les

associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

100931

L

U X E M B O U R G

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

NPS European Property Retail (Luxembourg) S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à toutes

les cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

<i>Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de catégorie A de la Société pour une durée indéter-

minée:

- Madame Mary Frances Harnetty, née le 29 novembre 1965 à Luton, Royaume-Uni, dont l'adresse professionnelle se

situe à 166, Sloane Street, SW1X 9QF Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Ian Edward Baker, né le 3 fevrier 1961 à Carshalton, Royaume-Uni, dont l'adresse professionnelle se situe

à 166, Sloane Street, SW1X 9QF Londres, Royaume-Uni.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de catégorie B de la Société pour une durée indéter-

minée:

- Monsieur Russell Perchard, né le 16 janvier 1978, à St. Helier, Guernesey, dont l'adresse professionnelle se situe à

291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

- Monsieur Costas Constantinides, né le 17 septembre 1979 à Nicosia, Chypre, dont l'adresse professionnelle se situe

à 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

- Monsieur Wayne Fitzgerald, né le 11 mai 1976 à Waterford, Irlande, dont l'adresse professionnelle se situe à 291,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 juin 2011. Relation: LAC/2011/25557. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

100932

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011086825/504.
(110097417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2011.

ALS Holdings (US), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 117.088.

Il résulte de l'Assemblé Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 28 Juin 2011 que:
1) It was decided the transfer of the registered address of the Company from 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724

Luxembourg to 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2)  It  was  decided  the  termination  of  the  Directorship  of  Mr.  Bodo  Demisch  born  on  02 

nd

  of  October  1944  at

Hahnenklee, Jetzt Goslar Germany with professional address at 9A, Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg as
Manager of ALS Holdings (US) société à responsabilité limitée

3) It was decided the termination of the Directorship of Mr. Philip Mathew Barrett born on 05 

th

 of May 1968 at

Aylesbury, United Kingdom with professional address at 1-3 Strand, Grand Buildings GB, WC2N 5HR London, United
Kingdom as Manager of ALS Holdings (US) société à responsabilité limitée

4) It was decided to appoint Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. with registered address at 15,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg as the Sole Manager of the Company, with immediate effect and for an unlimited
period of time.

Traduction française

1) L'assemblée a décidé le changement du siège social de la société du 9A, Boulevard du Prince Henri L-1724 à 15,

Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société ALS Holdings (US) société à responsabilité limitée

de M. Bodo Demisch né le 02 octobre 1944 à Jetzt, Goslar, Allemagne, résidant professionnellement à 9A, Boulevard du
Prince Henri L - 1724 Luxembourg.

3) L'assemblée a décidé la fin de mandat comme Gérant de la société ALS Holdings (US) société à responsabilité limitée

de M. Philip Mathew Barrett né le 05 mai 1968 à Aylesbury Royaume Uni, résidant professionnellement à 1-3 Strand,
Grand Buildings GB, WC2N 5HR Londres, Royaume Uni.

4) L'assemblée a nommé comme Gérant de la société pour une période indéterminée à partir du 28 Juin 2011:
Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. avec l'adresse au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Grand Duché

de Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 20 juillet 2011.

Pour avis conforme
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011104900/36.
(110119143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

FGP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.640.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 juin 2011

<i>Première résolution

Les associés de la société acceptent la démission de Monsieur Oliver Brazier de son poste de gérant de la société avec

effet au 30.06.2011.

<i>Deuxième résolution

Les associés de la société nomment Monsieur Christian Senitz, né le 27.01.1978 à Aschersleben, résidant profession-

nellement à 6D Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, au poste de gérant A de la société avec effet au Juin 30 2011.

100933

L

U X E M B O U R G

Monsieur Christian Senitz est désigné pour une période illimitée jusqu'à sa démission ou son remplacement lors de

l'assemblée générale des associés.

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2011099845/19.
(110112994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

G.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 67.319.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 novembre 2010, le mandat des administrateurs:
Gérard Decker demeurant à Luxembourg, né le 20.02.1944 à Luxembourg.
Laurence Heinisch demeurant à Dudelange, née le 03.11.1955 à Luxembourg
Brigitte Bourkel demeurant à Esch sur Alzette, née le 16.05.1950 à Pétange
a été renouvelé pour une durée de 6 ans, le mandat des administrateurs expirera lors de l'assemblée générale ordinaire

tenue en 2016.

le mandat du commissaire aux comptes:
Sylvie Dondelinger demeurant à Bridel, née le 16.11.1955 à Luxembourg
a été renouvelé pour une durée de 6 ans, le mandat du commissaires aux comptes expirera lors de l'assemblée générale

ordinaire tenue en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011099850/19.
(110112929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Amazon Payments Europe S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R.C.S. Luxembourg B 153.265.

EXTRAIT

Par résolutions écrites du 9 mai 2011, le gérant unique a décidé de renouveler, avec effet immédiat, le mandat de la

société Ernst &amp; Young sis au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, au Grand-duché de Luxembourg, R.C.S. Lu-
xembourg B47771, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle
approuvant les comptes annuels de l'exercice 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011099994/16.
(110114516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Ambolt S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 152.942.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 17 juin 2011

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires que le mandat de KPMG S.à r.l., réviseur

d’entreprises  agréé,  avec  siège  social  au  9,  allée  Scheffer,  L-  2520  Luxembourg,  et  enregistré  auprès  du  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103065, en tant que réviseur d’entreprises de la Société
est reconduit pour une année arrivant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en
2012.

100934

L

U X E M B O U R G

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ambolt S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2011099996/16.
(110114255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Auchan International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 73.616.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011100023/9.
(110113785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

A.G.W. S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 162.107.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099986/10.
(110114093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

A-PQ Luxco Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.561.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 138.922.

Par résolutions circulaires signées en date du 13 mai 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Sam Block III, avec adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, Suite

220 South, DC 20004-2505 Washington, Etats-Unis, de son mandat de gérant, avec effet au 28 avril 2011;

2. Nomination de Erica Herberg, avec adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue NW, 20004-2505 Wash-

ington DC, Etats-Unis, au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099987/15.
(110113774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

BRS International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 140.077.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 28 juin 2011

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la Société au 1, place du Théâtre, L-2613 Luxem-

bourg.

Le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de Monsieur Paul Marceul en tant que directeur administratif

de la Société. Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Jean-Pierre Vernier, né le 2 octobre 1952 à
Nantes (France) et demeurant professionnellement au 1, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg en tant que délégué à la
gestion journalière de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011100047/16.
(110114032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

100935

L

U X E M B O U R G

Concept Intérieur, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, rue de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 162.124.

STATUTS

L'an deux mille onze, le premier juillet.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Orlando Manuel DE FIGUEIREDO FERREIRA, employé, né à Almagreira (Portugal) le 24 octobre 1971,

demeurant à L-8190 Kopstal, 25, rue Schmitz.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il déclare constituer:

Art. 1 

er

 .  La société à responsabilité limitée existera sous la dénomination de «Concept Intérieur».

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'artisanat de décorateur et d'ensemblier notamment le conseil en design d'intérieur,

la conception, la coordination, la mise en œuvre et l'exécution des tous travaux y relatifs, le négoce, l'import &amp; l'export,
l'achat, la vente, en gros ou en détail, de tous articles de ces branches.

La société pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand Duché de Luxembourg par décision des associés.
Il peut être créé, par simple décision des associés ou des gérants, des filiales, succursales ou bureaux, tant dans le

Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
En cas de cession ou de transmission entre vifs ou pour cause de mort à un non-associé celui-ci devra faire l'objet d'un

agrément unanime des associés. A défaut d'un tel agrément les autres associés devront s'en porter acquéreurs.

L'associé qui se proposerait de céder tout ou partie de ses parts sociales à un non-associé doit les offrir préalablement,

au moins six (6) mois avant la fin de l'exercice en cours à ses coassociés qui disposeront du droit de préemption jusqu'à
la fin de cet exercice pour s'en porter acquéreurs à la valeur bilan du dernier exercice approuvé.

L'offre aux coassociés des parts à céder à un tiers ou la demande d'agrément d'un héritier ou ayant droit sera adressée

par lettre recommandée à la gérance. L'offre contiendra impérativement le nom et la qualité du ou des cessionnaires, le
nombre et le prix des parts à céder. La gérance communiquera par lettre recommandée le calcul de la valeur des parts
d'après le dernier bilan aux associés en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à
acheter les parts sociales aux prix à fixer amiablement ou par expertise sur base du dernier bilan approuvé. Le silence de
la part des associés pendant ce délai équivaudra à un refus de leur part.

Si aucun des associés restants n'est disposé à acquérir les parts sociales sujettes à cession ou héritage, les associés

restants auront le droit de désigner un ou plusieurs tiers pour acquérir ces parts sociales.

Toute cession de parts sociales sera vérifiée par la gérance quant à sa procédure et acceptée par elle dans un acte

notarié sous peine d'inopposabilité à la société.

100936

L

U X E M B O U R G

Art. 7. La mise en gage ou le nantissement des parts sociales est impossible sans l'accord préalable et unanime des

associés.

Art. 8. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir
leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables «ad nutum» par

les associés qui fixent leurs pouvoirs et les rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartient;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti comme suit:
Cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent

(10%) du capital le solde reste à la disposition des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera le 31 décembre 2011.

<i>Libération des parts sociales

Les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique Monsieur Orlando DE FIGUEIREDO FER-

REIRA, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ 950,- EUR.

<i>Décisions de l'associé unique

Et ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. L'adresse de la société est fixée à L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
2. Le nombre de gérants est fixé à un (1):
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Orlando Manuel DE FIGUEIREDO FERREIRA, préqualifié.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique.
3. La société reprendra à son compte tous engagements concernant le contrat Master Franchise «KIKOIOU» avec la

société BIBUSINESS Sàrl (RCSL B 153771) signé en date du 1 

er

 mars 2011 par l'associé unique afin que celui-ci soit réputé

avoir été contracté par la société dès l'origine (art 12 bis de la loi du 10 août 1915)

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. M. DE FIGUEIREDO FERREIRA, P.DECKER.

100937

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 06 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30515. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Référence de publication: 2011100064/112.
(110113688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Airest Collezioni S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.357.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 14 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099990/10.
(110114619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Alba Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.900,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.342.

EXTRAIT

Suite à une résolution des associés prise en date du 12 juillet 2011, le siège social de la Société a été transféré avec

effet immédiat au 25, avenue de Liberté, L-1931 Luxembourg.

<i>Pour ALBA LUXCO S.A R.L.

Référence de publication: 2011099991/12.
(110113592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Aleph Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 148.100.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011099993/10.
(110114405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Lady Ice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 111BIS, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 162.300.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-sept juin,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. Monsieur Etienne Dontaine, gérant administratif, né à Braine-le-Comte (Belgique), le 28 février 1960, demeurant à

B-1330 Rixensart, 31, avenue Alexandre,

2. Monsieur Mathieu Cox, mixeur de films, né à Watermael-Boitsfort (Belgique), le 6 mars 1973, demeurant à B-1300

Wavre, 29, avenue Philibert Marschouw,

3. Monsieur Philippe Van Leer, bruiteur, né à Uccle (Belgique), le 17 janvier 1960, demeurant à B-1300 Wavre, 61, rue

Grimohaye,

4. Monsieur Pierre Gillet, compositeur, né à Ottignies (Belgique), le 8 février 1963, demeurant à B-5031 Grand-Leez,

1, rue Taille Antoine,

100938

L

U X E M B O U R G

les comparants sub 2), 3) et 4) étant ici représentés par Monsieur Etienne Dontaine, prénommé,
en vertu de trois procurations sous seing privé données à Genval (Belgique), le 15 juin 2011.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au

présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, représentés comme indiqués ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de

tiers:

La création, la production, la distribution, l'édition, la reproduction, les relations publiques, la publicité, le montage,

l'organisation d'activités artistiques commerciales dans tous les secteurs et pour tous supports, dans le domaine des arts
et des médias en général et de la musique en particulier.

Elle a également pour objet la perception de droits d'auteurs des créations qui lui seront cédés, l'achat, la vente de

matériel audiovisuel, neuf ou d'occasion, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec ceux-ci.

La prestation de services divers dans le domaine audiovisuel:
- l'organisation et la production de films publicitaires, documentaires, industriels ou de fiction;
- la traduction, l'adaptation, la réalisation, la diffusion de tout travail médiatique audiovisuel (filmer, enregistrer, mixer

sur tout support cinématographique, vidéographique ou autre);

- la préparation, la réalisation, la finalisation de tout travail ayant trait à la postsynchronisation ou au doublage de films,

qu'ils soient en langue française ou autre.

L'exploitation de studio de doublage, postsynchronisation et bruitage de films de fiction, dessins animés, documentaires

et toute autre forme de produit audiovisuel, la location de station de montage, transfert et copies, l'import-export de
produits.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires,

entreprises, associations ou sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui est de nature à favoriser le
développement de son entreprise.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination «Lady Ice S.à r.l.».

Art. 4. Le siège social est établi à Capellen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.

Art. 7. Lorsque la société compte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après

avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe

la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la

Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) signature(s) de

100939

L

U X E M B O U R G

toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou
les gérants.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la

loi ou les présents statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) parts sociales sont souscrites comme suit:

1. Monsieur Mathieu Cox, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2. Monsieur Philippe Van Leer, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3. Monsieur Pierre Gillet, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4. Monsieur Etienne Dontaine, préqualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre 2011.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant technique pour une durée illimitée:
Monsieur Philippe Van Leer, bruiteur, né à Uccle (Belgique), le 17 janvier 1960, demeurant à B-1300 Wavre, 61, rue

Grimohaye.

2. Est nommé gérant administratif pour une durée illimitée:
Monsieur Mathieu Cox, mixeur de films, né à Watermael-Boitsfort (Belgique), le 6 mars 1973, demeurant à B-1300

Wavre, 29, avenue Philibert Marschouw.

3. Le siège social est fixé à L-8311 Capellen, 111Bis, route d'Arlon.

<i>Avertissement

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparantes sur le fait que la société doit obtenir une autorisation d'éta-

blissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer
son activité commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200)

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

100940

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants des comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: E. DONTAINE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2011. LAC/2011/28528. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011104690/130.
(110118177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Ambolt S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 152.942.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011099995/10.
(110114246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

ABC Legacy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.039.

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 28 avril 2011 et a adopté les résolutions suivantes:
1 - L’Assemblée a reconduit les mandats d’Administrateurs de
Mme Michèle Berger, 3 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
M. Frédéric Fasel, 1 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
M. Pascal Chauvaux, 1 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2012.
2 - L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé Deloitte S.A. jusqu’à la prochaine assemblée

générale des actionnaires en 2012.

<i>Pour ABC Legacy Fund

Référence de publication: 2011099998/17.
(110114550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Ambigest International S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Signam International S.A.).

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 44.620.

L’an deux mille onze, le quatre juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SIGNAM INTERNATIONAL

S.A.», ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 44.620, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 29 juillet 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 470 du 11 octobre 1993, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu, suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 386 du 26 février 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Massimo GILOTTI, demeurant professionnellement à L-2138 Luxem-

bourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents.

100941

L

U X E M B O U R G

L'assemblée élit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue

Cents.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Changement de dénomination en AMBIGEST INTERNATIONAL S.A. et modification afférente de l'article 1 des

statuts

- Modification des articles 5 et 7 des statuts.
- Nomination d'administrateurs A et reclassification des administrateurs actuels en administrateurs B.
- Modification de l'exercice social et modification de l'article 13 des statuts.
- Divers
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l'assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l'unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en AMBIGEST INTERNATIONAL de sorte que le 1 

er

 alinéa

de l'article 1 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de «AMBIGEST INTERNATIONAL S.A.».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 5 et 7 des statuts comme suit:

« Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, désignés

comme administrateurs A et B, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.»

« Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe

d'un administrateur A et d'un administrateur B.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs A, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale

de l'année 2014:

- João Carlos FERREIRA DE ALÉM, né le 21.06.63 à Campo Grande, Lisbonne et demeurant Rua Dr. Correia Guedes

Lote 7, P-2590-038 Sobral de Monte Agraço;

- Nelson Ricardo FERREIRA DE ALÉM, né le 11.03.77 à Arranhó, Arruda dos Vinhos et demeurant Rua de Moscavide

Lote 4.29.01 bloco B 1ª D, P-1990-165 Lisbonne;

- Vítor Manuel FERREIRA DE ALÉM, né le 29.12.65 à Campo Grande, Lisbonne et demeurant Rua do Espargal n°22,

P-2630-048 Arranhó.

L'assemblée décide de classer les administrateurs actuels en tant qu'administrateurs B.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide:
- de modifier l'exercice social de la Société, qui débutera donc le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque

année; et

- que l'année sociale en cours de la Société qui a débuté le 1 

er

 avril 2011 se terminera le 31 décembre 2011 au lieu

du 31 mars 2012.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

100942

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: M. GILOTTI, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31647. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Référence de publication: 2011104516/81.
(110119430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.

Aberdeen Global II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 136.363.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62193 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011099999/10.
(110113790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Acobel International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 105.726.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ACOBEL INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2011100000/11.
(110114534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.

MAMERANUS Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 99.487.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2011:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jens CHRISTIANSEN, administrateur, demeurant professionnellement au 85-87 Parc d'Activités L- 8303

CAPELLEN , aux fonctions d'administrateur et président du conseil d'administration;

- Monsieur Marcel HETTO, administrateur, demeurant professionnellement au 85-87 Parc d'Activités L- 8303 CA-

PELLEN, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Denis CRIDEL, administrateur, demeurant professionnellement au 85-87 Parc d'Activités L- 8303 CAPEL-

LEN, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Erny SIMON, administrateur, demeurant professionnellement au 85-87 Parc d'Activités L- 8303 CAPELLEN,

aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Olivier WEBERT, administrateur, demeurant professionnellement au 85-87 Parc d'Activités L- 8303 CA-

PELLEN , aux fonctions d'administrateur;

-  Monsieur  Andreas  WENER,  administrateur,  demeurant  professionnellement  au  85-87  Parc  d'Activités  L-  8303

CAPELLEN,aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.
L'Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises:
- FIDUO, réviseurs d'entreprises et experts comptables, 10a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2012.

100943

L

U X E M B O U R G

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 mai 2011:

Conformément à l'article 9 des statuts de la société, le Conseil d'Administration nomme comme Président du Conseil

d'Administration de la société, Monsieur Jens Christiansen, avec adresse professionnelle au 85-87, Parc d'Activité, L- 8303
CAPELLEN.

Luxembourg, le 26 Juillet 2011.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2011106290/33.
(110121101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Masco Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 745.000.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 68.104.

EXTRAIT

Les associés de la Société ont accepté, en date du 19 juillet 2011:
- la démission de M. Bill Anderson, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 19 juillet 2011; et
- la nomination de M. John Palmer Lindow III, résidant professionnellement au 21001, Van Born Road, Taylor, Michigan

48180, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de la Société, avec effet au 19 juillet 2011.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société est composé désormais de:
- M. Thomas Voss;
- M. Graham Balls;
- M. John Sznewajs;
- M. Jerry Mollien;
- M. Timothy Wadhams; et
- M. John Palmer Lindow III.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011107489/24.
(110121588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Mayroy, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 48.865.

EXTRAIT

1. Rachat d'actions
Suite à différents rachats d'actions propres de classe D et de classe E, la Société détient au 31 décembre 2010, 1.218.160

actions propres de classe D, pour un montant de EUR 13.370.381,19 et 4.304.016 actions propres de classe E pour un
montant de EUR 148.383.548,44.

Les actionnaires de la Société ont décidé lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 16 juin 2011 de répartir entre

les actionnaires de classe A, de classe B et de classe E existants au prorata de leur participation dans la Société les 4.304.016
actions de classe E détenues en auto-contrôle par la Société, de sorte qu'à ce jour la Société ne détient plus d'actions de
classe E.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011107493/20.
(110122068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

100944


Document Outline

ABC Legacy Fund

Aberdeen Global II

ABN AMRO Multi-Manager Funds

Acobel International S.A.

A.G.W. S.à r.l.

Airest Collezioni S.à r.l.

Alba Luxco S.à r.l.

Aleph Luxembourg S.à r.l.

Alfred Berg

ALS Holdings (International)

ALS Holdings (US)

Amazon Payments Europe S.C.A.

Ambigest International S.A.

Ambolt S.A.

Ambolt S.A.

A-PQ Luxco Investors S.à r.l.

Auchan International S.A.

Avere Asset Management S.A.

Baobab Holdings S.à r.l.

BNP Paribas Flexi I

BRS International S.A.

Carren Gere S.A.

Clairval Spf S.A.

Concept Intérieur

C.T. - A &amp; A S.A.

ECM Real Estate Investments A.G.

Ecomin S.A.

E&amp;G Fonds

FGP IV S.à r.l.

Fidecum SICAV

FINAGEL S.A., société de gestion de patrimoine familial (SPF)

Finagra S.A., SPF

FlyBalaton Investment S.A.

G.B. S.A.

IV Umbrella Fund

Jef Financière S.A.

Lady Ice S.à r.l.

Lux-Pension

MAMERANUS Participations S.A.

MAN Umbrella SICAV

Masco Europe S.à r.l.

Matro S.A.

Mayroy

Mobimo

Montana Properties S.A.

Naxos International Holding S.A., SPF

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.

Nord/LB Covered Finance Bank S.A.

Olympia JV CO S.à r.l.

Pan European Real Estate Invest

Partelcom S.A.

PEF Epsilon Investment S.à r.l.

PEF Epsilon Investment S.à r.l.

Portalo Europe AG

Robeco Alternative Investment Strategies

Signam International S.A.

Sky Halle S.à r.l.

Société de Financement Médical et Hospitalier

Sopartag S.A.

Sunset S.à r.l.

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

Swiss Rock (Lux) Sicav