logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2089

8 septembre 2011

SOMMAIRE

4IPS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100264

ABN AMRO Bank (Ireland) Limited, Lu-

xembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100272

All Car Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100227

Alternative Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100226

Amaris Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100226

Amaris Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100226

Aronda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100227

Astonial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100232

Bau-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100270

Beaucette S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100239

Bellux 2004 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100259

Belron International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100259

Belron NS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100259

Belron OPS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100259

Celux Finance S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

100228

Consulting & Estate Engeneering SA . . . . .

100272

Costeley Development S.A.  . . . . . . . . . . . . .

100237

Crescendo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100239

Deutsche Postbank Vermögens - Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100262

Development Portisco S.A.  . . . . . . . . . . . . .

100272

Develup S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100272

Digital Assets Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100227

Duberion Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100236

ECM Real Estate Investments A.G.  . . . . . .

100228

Euro Advance Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100259

Global Corporate Investments S.A.  . . . . . .

100228

Immobilière des Sables S.A. . . . . . . . . . . . . .

100230

Investment Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100231

Lubesa SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100231

Lux Investcom SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100232

Meridium Financial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

100233

Navitas Solar Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

100247

Nice Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100243

Nord-Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100233

Opaline Investissements S.A. SPF  . . . . . . .

100234

Pharmaceutical Enterprises  . . . . . . . . . . . . .

100237

Piramid Investment Solutions S.A. SPF  . .

100236

Pramerica Financial Guaranty Assurance

Company, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100241

Premium Portfolio SICAV  . . . . . . . . . . . . . .

100232

Premium Portfolio SICAV II  . . . . . . . . . . . .

100235

Publi Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100237

Repco 19 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100262

Rocky Mountains Holding S.A., SPF . . . . . .

100238

SEB Asset Management S.A.  . . . . . . . . . . . .

100247

SEB Strategy Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100243

Serimnir S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100233

Seven Vegas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100238

Société de Promotion pour le Développe-

ment des Activités de Services S.P.F. S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100236

Specials Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100230

Stanley Invest Holding S.A. S.P.F.  . . . . . . .

100235

St. Georges Investment S.A. - SPF . . . . . . .

100235

The Golden Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

100231

The Luxembourg Acquisition Company

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100231

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100264

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100271

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100271

Timberland Luxembourg Holding Asia

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100271

Timberland Luxembourg Holding Asia

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100271

Tuscani S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100234

Unity Foundation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100271

VCB Lease S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100247

Ygrec S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100238

Zola Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100234

100225

L

U X E M B O U R G

Amaris Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 123.867.

Les actionnaires de la société AMARIS GROUP S.A. (ci-après la «Société») sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, en date du <i>26 septembre

<i>2011 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010
3. Affectation des résultats de l'exercice
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124959/278/17.

Amaris Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 123.867.

Les actionnaires de la société AMARIS GROUP S.A. (ci-après la «Société») sont priés de bien vouloir assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, en date du <i>26 septembre

<i>2011 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital par apport en nature de créances:

Augmentation de capital à concurrence de EUR 786.000 (sept cent quatre-vingt-six mille euros), en vue de porter
le capital social de son montant actuel de 40.000 EUR (quarante mille Euros) à EUR 826.000 (huit cent vingt-six
mille Euros), moyennant l'apport des créances détenues à l'encontre de la Société.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital intervenue
3. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124960/278/18.

Alternative Units, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.199.

The Board of Directors inform you that the quorum required in order to vote the points set out on the agenda of

the Extraordinary General Meeting held on 30 August 2011 was not attained. Therefore the Board of Directors is pleased
to convene you to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the SICAV, in front of a public notary, on <i>October 24, 2011 at 11:30 a.m. or any other later date at the registered

office of the SICAV, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Winding-up and opening of the liquidation of the SICAV;
2. Appointment of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as liquidator
3. Determination of the powers and the remuneration of the liquidator
4. Appointment of Ernst &amp; Young S.A. as auditor to the liquidation
5. Miscellaneous.

In accordance with the provisions of the Articles 13 and 31 of the Articles of Incorporation of the SICAV, the deter-

mination of the net asset value, the issue, redemption and conversion of the shares in the SICAV may be suspended as
soon as a meeting is called during which the liquidation of the SICAV shall be put forward. Therefore, shareholders are

100226

L

U X E M B O U R G

informed that the determination of the Net Asset Value per share in the SICAV and the issue, conversion and redemption
of the shares are still suspended as from 12 August 2011.

The shareholders are further advised that, according to the company law in Luxembourg, the resolutions set out on

the above mentioned Agenda may be validly deliberated no matter how many shares will be present or represented at
this second Extraordinary General Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011124965/755/27.

All Car Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 34.943.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 8:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.
L´assemblée générale statutaire du 20 avril 2011 n´a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l´ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n´ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d´administration.

Référence de publication: 2011124964/1267/15.

Aronda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.036.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>September 27, 2011 at 10.30

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at June 30, 2011 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending June 30, 2011.

4. Miscellaneous.

<i>THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2011124966/1023/16.

Digital Assets Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 89.977.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 8:20 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L´assemblée générale statutaire du 12 mai 2011 n´a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l´ordre du jour, le

quorum prévu pas la loi n´ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d´administration.

Référence de publication: 2011124968/1267/15.

100227

L

U X E M B O U R G

Celux Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 19.846.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2011.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011124967/1023/17.

Global Corporate Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 113.751.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 8:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 15 juin 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124970/1267/15.

ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

Notice of a meeting of bondholders is hereby given to the holders of the outstanding 21,221 Bonds (the "Bondholders"

and each individually the "Bondholder") issued on 9 

th

 October 2007 and of 5,311 Bonds issued on 2 

nd

 November 2007,

with ISIN Code XS0319645981 (the "Bonds").

At the request of the Bondholders representing at least 5% of the Bonds,

MEETING OF THE BONDHOLDERS

of the Company (the "Meeting") will be held on <i> 26 

<i>th

<i> September, 2011  , at 10.00 a.m. (CET) on the 27 

th

 floor, Meeting

room "Everest II", City Tower building, street Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Czech Republic, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Information to the Bondholders about steps taken by the Bondholders Representative in the course of the insol-

vency proceeding of the Company.

2. Information to the Bondholders about anticipated steps to be taken by the Bondholders Representative in the

course of the insolvency proceeding of the Company.

3. Presenting amendements to the Bondholders Representative's terms of engagement including the obligation of the

Bondholders Representative to obtain the prior approval of a majority of the Bondholders with respect to the
measures to be taken in the insolvency proceeding of the Company.

4. Recall of the Bondholders Representative.
5. Appointment of a new Bondholders Representative.
6. Miscellaneous.

100228

L

U X E M B O U R G

Each Bondholder may attend and vote at the Meeting by following the same procedure than the previous meeting:
The Bonds are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with

the clearing and depositary systems Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream"), Euroclear System ("Euro-
clear")  and  Centrální  depozitár  cenných  papíru,  a.s.,  being  the  legal  successor  of  UNIVYC,  a.s.,  (Centrální  depozitár
cenných papíru, a.s. "CDCP", collectively with Clearstream and Euroclear the "Clearing Systems") through which trans-
actions in the Bonds are affected.

Bondholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream, Eu-

roclear and CDCP in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.

Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountholder

(each, an "Intermediary") are urged to respect the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary
to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.

Bondholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Bonds in the relevant Clearing

Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems and provide details concerning their identity
to the Depositary and the Company.

The Bondholders need not to be present at the Meeting in person.
The decisions at the Meeting will be passed by a majority consisting of:
1. 50% + 1 vote for the appointment or removal of representatives, the removal of special agents nominated by the

Issuer and the approval of any protective measure taken in the interests of the Bondholders. In this case, the Meeting
may validly decide without any quorum requirement.

2. not less than two-thirds of the votes cast by Bondholders present or represented in respect of any other decision

the Meeting may validly decide upon. In this case, the Meeting may validly decide only if the Bondholders present or
represented hold at least 50 per cent of the total amount of the Bonds outstanding on the date of the Meeting.

The attention of the Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will

validly bind all the Bondholders (even those not representing at the Meeting).

A Bondholder may act at the Meeting by appointing another person who needs not be a Bondholder himself.
Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE

INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, Email: aludowicy@ecmreiag.com, or BDO Tax &amp; Accounting, Mr. Pierre
LENTZ, Email: Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123 207).

Any Bondholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must present at the Meeting a valid voting

certificate issued by the Depositary relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable,
confirmation of the respective Intermediary through which the respective Bondholder holds the Bonds within the Clearing
Systems.

Any Bondholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may deliver his voting certificate(s) to the

person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form and his voting
certificate(s) at the registered office of the Company. Any Bondholder or proxyholder wishing to attend and vote at the
Meeting must present at the beginning of the Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer
of the Meeting, evidencing the holding of the Bonds, and among others the Passport in order to verify the identity of the
Bondholder or proxyholder, and a valid and up-to-date extract from the relevant commercial registry evidencing the
powers of the representative of the Bondholder or evidencing that a proxy has been signed validly.

To obtain a voting certificate, Bonds must be deposited with the Depositary (to the satisfaction of such Depositary),

held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining
voting certificates, not later than 1 pm (CET) on 23 

rd

 September 2011.

Bonds so deposited or held will not be released until the conclusion of the Meeting.
Confirmation of attendance to the Meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be

effected by fax (or any other permissible means) at the registered office of the Company no later than 1 pm (CET) on
23 

rd

 September 2011.

The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulated to the Bondholders.
The contact details of the Company are as follows:

Company
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 45 123 205
Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax &amp; Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES
The details of the Depositary are as follows:

Depositary
Caceis Bank Luxembourg

100229

L

U X E M B O U R G

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: +352 47 67 73 13
Email: lb-dob-listing@caceis.com
Attention: Corporate Trust Department

Bondholders' Representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
Astin Capital Management Limited
7-9 Swallow Street, 3rd Floor,
London, W1B 4DE
Fax: +44 (20) 70341001
Email: charles.bray@astincapital.com
Attention: Charles Bray

Prague, on September 6 

th

 2011.

Mr. Ivo Hala
<i>insolvency Trustee

Référence de publication: 2011124969/534/94.

Immobilière des Sables S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 86.289.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 8:40 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 7 juin 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124971/1267/15.

Specials Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.396.

The shareholders are hereby invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Company which will be held on <i>September 28, 2011 , at 2:00 p.m., at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg

(The "Extraordinary General Meeting"), to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve the interim report of the Liquidator on the results of the liquidation as at August 9, 2011;
2. To approve the financial statements as at December 31, 2010;
3. To approve the advances payments on liquidation proceeds.

No quorum is required for this Extraordinary General Meeting. The decisions, to be validly taken, shall be passed at

the majority of the two thirds of the votes cast on the day of the Extraordinary General Meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy is available upon request at the registered office of the Company.
The interim report of the Liquidator as at August 9, 2011 as well as the financial statements as at December 31, 2010

are available upon request at the registered office of the Company.

Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.
<i>Acting as Liquidator of the Company

Référence de publication: 2011124982/755/21.

100230

L

U X E M B O U R G

Investment Solutions, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 87.158.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 8:50 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 4 juillet 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124972/1267/15.

Lubesa SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 82.407.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 9:10 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 24 juin 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124973/1267/15.

The Golden Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 153.358.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011098744/10.
(110112358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 108.160.

Les comptes annuels au 30 Septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011098745/10.
(110112365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

100231

L

U X E M B O U R G

Astonial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.997.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 septembre 2011 à 09.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2011;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2011;
3. affectation des résultats au 30 juin 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011113534/10/18.

Lux Investcom SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 81.370.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 9:20 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 8 juin 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu pas la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124974/1267/15.

Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 137.056.

Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>30. September 2011 , 10.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011

1.1. Anpassung des Artikel 4 der Satzung an das BaFin Rundschreiben 14/2008 zur Sicherstellung der Anwendbarkeit
des deutschen Investmentsteuergesetzes.
1.2. Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010
angepasst.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2011 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Kapitals, das nicht erreicht wurde.
Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien
getroffen.

100232

L

U X E M B O U R G

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage
vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbe-
scheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen
Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 25. September 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV (DZ PRIVAT-

BANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4009 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.

Luxembourg, im August 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011118500/755/32.

Meridium Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.222.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 9:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.
L'assemblée générale statutaire du 10 mai 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124975/1267/15.

Nord-Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.445.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 9:50 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 17 mai 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124976/1267/15.

Serimnir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.998.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 septembre 2011 à 09.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2011;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2011;
3. affectation des résultats au 30 juin 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

100233

L

U X E M B O U R G

5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011113537/10/18.

Zola Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 77.869.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 6 mai 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124986/1267/15.

Opaline Investissements S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 53.437.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 septembre 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2011.

4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011124977/1023/16.

Tuscani S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 119.507.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 10:50 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du vendredi 22 avril 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du

jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124985/1267/15.

100234

L

U X E M B O U R G

Stanley Invest Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 88.828.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 10:40 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 12 juillet 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124984/1267/15.

St. Georges Investment S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.251.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ST. GEORGES INVESTMENT S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>27 septembre 2011 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince

Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011124983/750/16.

Premium Portfolio SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 145.322.

Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV II werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>30. September 2011 , 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011

1.1. Anpassung des Artikel 4 der Satzung an das BaFin Rundschreiben 14/2008 zur Sicherstellung der Anwendbarkeit
des deutschen Investmentsteuergesetzes.
1.2. Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010
angepasst.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2011 stan-

den, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Kapitals, das nicht erreicht wurde.
Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheits-

quorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien
getroffen.

100235

L

U X E M B O U R G

Um  an  dieser  zweiten  Außerordentlichen  Generalversammlung  teilnehmen  zu  können,  müssen  Aktionäre  von  in

Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage
vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbe-
scheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen
Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 25. September 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV II (DZ PRIVAT-

BANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4009 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com
angefordert werden.

Luxembourg, im August 2011.

<i>Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011118501/755/32.

Duberion Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.996.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2011;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2011;
3. affectation des résultats au 30 juin 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011113539/10/18.

S.P.D.A.S., Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.P.F. S.A., Société

Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 15.683.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 10:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 21 avril 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124981/1267/16.

Piramid Investment Solutions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.944.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 10:10 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

100236

L

U X E M B O U R G

2. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124979/1267/15.

Pharmaceutical Enterprises, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 48.294.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 8 avril 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124978/1267/15.

Publi Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 33.068.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le vendredi <i>14 octobre 2011 à 8:10 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.
L'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2011 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour;

le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011124980/1267/15.

Costeley Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.994.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 septembre 2011 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2011;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2011;
3. affectation des résultats au 30 juin 2011;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011113540/10/18.

100237

L

U X E M B O U R G

Seven Vegas S.A., Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 135.762.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 septembre 2011 à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2 

ème

 étage) avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturés au

31.12.2009 et 31.12.2010;

3. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31.12.2009 et 31.12.2010 et affectations des résultats;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société

par ses actionnaires;

7. Elections statutaires;
8. Divers.
Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au

bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011119622/693/24.

Rocky Mountains Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 16.204.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>19 septembre 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011121249/755/18.

Ygrec S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 72.632.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue Extraordinairement, qui aura lieu le <i>16 septembre 2011 à 13.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre

2010, et affectation des résultats.

100238

L

U X E M B O U R G

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat du 31

décembre 2008 au 31 décembre 2010.

4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011122237/1023/20.

Beaucette S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 38.156.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 septembre 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011122242/1023/17.

Crescendo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 90.930.

In the year two thousand and eleven, on the second of August.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION, acting as trustee of THE CONCERTO TRUST ,

having its registered office at 2 

nd

 Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados,

West Indies,

hereby represented by Abdelrahime BENMOUSSA, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Barbados on July 27 

th

 , 2011.

2. ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION, acting as trustee of THE SYMPHONY TRUST, having

its registered office at 2 

nd

 Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados, West

Indies,

hereby represented by Abdelrahime BENMOUSSA, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Barbados on July 27 

th

 , 2011.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as said before, have declared and requested the officiating notary to state:
That the appearing parties are the current shareholders (Associés) of CRESCENDO 1 S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under Section B number 90.930, incorporated by a deed
of Maître Gerard LECUIT, then notary residing in Hesperange, of December 20 

th

 , 2002, published in the Memorial C,

Recueil des Sociétés et Associations number 223 on March 1 

st

 , 2003, (the "Company").

That the appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of the Company and that they have taken, through

their proxy-holder, the following resolutions:

100239

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The shareholders resolve to reduce the nominal value of the shares from its current amount of one hundred Euros

(EUR 100.-) to twelve Euros and fifty cents (EUR 12.50) and to change the number of the shares from one hundred
twenty-five (125) to one thousand (1000) shares.

The one thousand shares have been subscribed as follows

ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION as trustee of THE CONCERTO TRUST . . . . .

200

ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION as trustee of THE SYMPHONY TRUST . . . . .

800

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend Article 6 of the articles of association of the Company which shall henceforth read

as follows:

Art 6. The company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.-EUR) represented

by one thousand (1000) shares with a par value of twelve euros and fifty cents (12.50 EUR) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-.).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le deux août.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.  ROYAL  BANK  OF  CANADA  FINANCIAL  CORPORATION,  agissant  comme  trustee  de  THE  CONCERTO

TRUST, ayant son siège social à 2 

nd

 Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados,

West Indies,

ici représentée par Abdelrahime BENMOUSSA, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée à Barbados le 27 juillet 2011.

2. ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION, agissant comme trustee de THE SYMPHONY TRUST,

ayant son siège social à 2 

nd

 Floor, Building No. 2, Chelston Park, Collymore Rock, BB-11000 St Michael, Barbados, West

Indies,

ici représentée par Abdelrahime BENMOUSSA, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée à Barbados le 27 juillet 2011.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de
l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentée comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elles sont les associés actuels de la société «CRESCENDO 1 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 90.930, constituée par acte de Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à
Hesperange, en date du 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 223 du

er

 mars 2003 («la Société»).

Que les parties comparantes sont les seuls associés actuels (les «Associés») de la Société et qu'elles ont pris, par leur

mandataire, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de diminuer la valeur nominale des actions de leur montant actuel de cent euros (EUR 100,-) à

douze euros et cinquante centimes (EUR 12,50) et de changer le nombre de parts sociales de cent vingt-cinq (125) à mille
(1000).

Les cent parts ont été souscrites comme suit:

100240

L

U X E M B O U R G

ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION agissant comme trustee de THE CONCERTO
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

ROYAL BANK OF CANADA FINANCIAL CORPORATION Agissant comme trustee de THE SYMPHONY
TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« Art 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,EUR) représenté par mille (1000) parts sociales

de douze euros et cinquante centimes (EUR 12.50-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du comparant, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire ins-

trumentant par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. BENMOUSSA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 août 2011. LAC/2011/35157. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011118802/104.
(110136683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.946.

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of March.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l.,a société à responsabilité limitée, incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B
142862,

duly represented by Mrs. Carole Noblet, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg,

on 24 February 2011.

This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of Pramerica Financial Guaranty Assurance Company S.A.,a société ano-

nyme having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies' register under the number B 142946, incorporated pursuant to a deed of
Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 November 2008, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28 November 2008, under number 2862 (hereafter the “Company”).

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:

<i>First Resolution

Following the statutory amendment, the Company has no legal obligation to implement an independent auditor (ré-

viseur d'entreprises agréé) for the Company as well as renew his mandate. The Sole Shareholder therefore resolves to
appoint, with effect as of 1 

st

 January 2011, a statutory auditor, Mr. Chuck Levy, controller, born on June 9, 1959 in

Hackensack, NJ, United States of America, with professional address at 3 Gateway Center, 4 

th

 Floor, 100 Mulberry

Street, Newark, NJ 07102, United States of America.

100241

L

U X E M B O U R G

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 22 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“ Art. 22. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their
term of office, which may not exceed six years.

The institution of statutory auditor(s) is suppressed if one or more independent auditors (réviseurs d'entreprises

agréés) are appointed in accordance with article 69 (1) of the law of 19 December 2002 concerning the register of
commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended.”

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundelf, den achten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxembourg,

Ist erschienen:

Pramerica Group Luxembourg Holding Company S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxembourg, mit eingetragenem
Sitz in 412 F, route d' Esch, L-1030 Luxembourg, eingetragen in das luxemburgische Handelsregister unter der Nummer
B 142862,

hier rechtmäßig vertreten durch Frau Carole Noblet, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, mittels ord-

nungsgemäßer Vollmacht ausgestellt in Luxembourg am 24 Februar 2011.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung “ne varietur” durch den unterzeichnenenden Notar und durch die für die Er-

schienene Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschiene ist Einzelaktionärin der Pramerica Financial Guaranty Assurance Company S.A., eine société anonyme

(Aktiengesellschaft), mit eingetragenem Sitz in 412 F, route D' Esch, L-1030 Luxembourg, eingetragen in das luxembur-
gische Handelsregister unter der Nummer B 142946, wirksam gegründet gemäß notarieller Urkunde von Herrn Maître
Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, Großherzogtum Luxembourg am 7 November 2008 und veröffentlicht
im  Mémorial  C,  Receuil  des  Sociétés  et  Associations  28  November  2008  unter  der  Nummer  2862  nachfolgend  die
(“Gesellschaft”)

Die Einzelaktionärin, welche das gesamte Gesellschaftskapital hält, faßt folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Nach der Änderung der Satzung besteht für die Gesellschaft keine Rechtspflicht, einen unabhängigen Steuerprüfer

(réviseur d' enterprises agréé) zu berufen oder sein Mandat zu verlängern. Die Einzelaktionärin beschließt daher, mit
Wirkung vom 1 Januar 2011 Herrn Chuck Levy, (Bilanz-) Prüfer, geboren am 9 Juni 1959 in Hackensack, NJ, Vereinigte
Staaten von Amerika, mit Berufsanschrift 3 Gateway Center, 4 

th

 Floor, 100 Mulberry Street, Newark, NJ 07102, Ver-

einigte Staaten von Amerika, als unabhängigen Steuerprüfer zu berufen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Einzelaktionärin beschließt, Artikel 22 der Gründungssatzung zu wie folgt neu zu fassen:

“ Art. 22. Die Geschäfte der Gesellschaft müssen von einem oder mehreren Steuerprüfer(n) überprüft werden, der/

die Aktionär(e) sein darf/dürfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre soll den oder die Steuerprüfer berufen und seine/
ihre Amtszeit festlegen, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Verpflichtung zu einem oder mehrerer satzungsmäßiger Steuerprüfer besteht nicht, sobald einer oder mehrere

unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'enterprises agrees) gemäß Artikel 69 (1) des Gesetzes vom 19 Dezember
2002 bezüglich des Handels-und Gesellschaftsregisters und der Rechnungslegung und jährlichen Geschäftsabschlüsse be-
nannt worden sind.”

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde

erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt auf Nachfrage der erschienenen

Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist, nebst einer deutschen Fassung; im Falle der Nachfrage
durch die erschienene Person und von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die eng-
lische Fassung maßgeblich sein.

100242

L

U X E M B O U R G

Die Bevollmächtigte der erschienen Partei ist dem Notar mit Familienname, Name, Zivilstatus und Wohnsitz bekannt.

Die Urkunde wurde der Bevollmächtigten der erschienen Partei vorgelesen; ferner haben sie und der Notar die vorlie-
gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. NOBLET und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mars 2011. Relation: LAC/2011/12322. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

-FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 24. Mai 2011.

Référence de publication: 2011121513/93.
(110139539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2011.

SEB Strategy Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de SEB Strategy Fund coordonné (partie générale et partie spécifique) a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Asset Management S.A.

Référence de publication: 2011124370/9.
(110142998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Nice Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 86.628.

a) Forme, dénomination, siège et capital de la Société dont la scission partielle sans dissolution a été proposée par le

conseil d'administration de la Société en date du 24 juin 2011:

NICE FINANCE SA., une société anonyme luxembourgeoise dont le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section
B numéro 86628.

Capital social: EUR 72.100,- (soixante-douze mille cent Euros), représenté par 721 (sept cent vingt et une) actions

entièrement libérées d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

b) La nouvelle société:
En date du 24 juin 2011, le conseil d'administration de la Société a proposé la scission partielle sans dissolution de la

Société par la constitution d'une société anonyme luxembourgeoise nouvelle, à dénommer NICE FINANCE 2 S.A. et
avec son siège social à L- 1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ci-après dénommée la «Société
Nouvelle».

c) Assemblée générale des actionnaires de la Société:
Le conseil d'administration de la Société doit, dès que faisable après le délai d'un mois suivant le dépôt et la publication

de ce projet de scission partielle conformément à l'article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée (la «Loi»), convoquer l' actionnaire unique de la Société à une assemblée générale extraordinaire (l'«As-
semblée») pour approuver la scission partielle proposée, par laquelle la Société transférera, sans dissolution, une partie
de son patrimoine, activement et passivement, à la Société Nouvelle.

d) Attribution des actions de la Société Nouvelle à l'actionnaire unique de la Société.
Une partie des éléments d'actif et de passif de la Société doivent être attribués à la Société Nouvelle conformément

au tableau qui suit.

e) Modalités de remise des actions de la Société Nouvelle.
Les actions de la Société Nouvelle seront nominatives et inscrites au nom de l'actionnaire unique dans le registre des

actions de la Société Nouvelle.

L'actionnaire unique de la Société Nouvelle obtiendra sur demande un certificat.
f) Date de prise d'effet de la scission partielle:
D'un point de vue comptable la scission partielle prendra effet le 1 

er

 juillet 2011.

g) Date à partir de laquelle les actions dans la Société Nouvelle donnent le droit de participer aux bénéfices:
les actions donneront le droit de participer aux distributions des bénéfices de la Société Nouvelle à partir de sa

constitution.

h) Avantages:

100243

L

U X E M B O U R G

Aucun  avantage  particulier  ne  sera  attribué  aux  administrateurs  et  au  commissaire  de  la  Société  et  de  la  Société

Nouvelle en rapport avec et comme conséquence de la scission partielle de la Société et, à l'exception de sa rémunération
usuelle pour ses services, le réviseur indépendant établissant le rapport requis par l'article 26-1 de la Loi n'aura aucun
avantage particulier. La Société n'a pas émis en faveur de quiconque des valeurs mobilières autres que les actions détenues
par l'actionnaire unique existant.

i) Attribution du patrimoine:

Actif

Bilan 19.06.2011

en EUR

C. Actif immobilisé

NICE FINANCE

S.A.

NICE FINANCE

2 S.A.

III Immobilisations financières
LIMA LTO S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.689.529,25

D. Actif circulant
IV. Avoirs en banque
Banques à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385.667,17

9.240.000,00

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.075.196,42

9.240.000,00

Passif
A. Capitaux propres
I. Capital souscrit
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

41.100,00

IV. Réserves
IV.1. Réserve légale
Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

4.110,00

V. Résultats reportés
Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378.307,34

623.495,85

Résultat en affectation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.200.628,31

8.571.258,81

B. Provisions pour risques et charges
Provision pour impôt sur la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,66

35,34

C. Dettes

1.462.134,11

Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.075.196,42

9.240.000,00

j) Statuts de la Société Nouvelle:
Le projet des statuts de la Société Nouvelle est le suivant:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "NICE FINANCE 2 S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avan-
ces et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

100244

L

U X E M B O U R G

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante et un mille cent Euros (EUR 41.100,-) représenté par quatre cent onze (411)

actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. La société ne reconnaît qu'un

seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété
d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions
doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société. L'absence de la désignation
d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, de la catégorie

A ou de la catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus
par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat.
Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à
l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consé-
cutifs.

Lorsque qu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la

composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la
constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Les administrateurs seront

élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

100245

L

U X E M B O U R G

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie

A ensemble avec un administrateur de la catégorie B, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule
signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à

un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 15

juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. Les autres assemblées

générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs
liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine
leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Les premiers administrateurs et commissaire de la Nouvelle Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire

de 2017 seront

<i>Administrateurs de catégorie A:

- M. Adalberto MIANI, administrateur de sociétés, né à Torino (Italie), le 17 septembre 1938, demeurant à Monte

Carlo (Principauté de Monaco), 5, boulevard Princesse Grace, président du conseil d'administration.

- M. Pietro MOGGI, administrateur de sociétés, né à Capriasca (Suisse), le 14 mars 1965, demeurant à CH-6901 Lugano

(Suisse), 10, Via Somaini.

100246

L

U X E M B O U R G

<i>Administrateurs de catégorie B:

- M. Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- M. David GIANNETTI, administrateur de sociétés, né à Briey (France), le 19 décembre 1970, demeurant profes-

sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Commissaire:

La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège à L-1331 Luxembourg,

67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

La première année sociale de la Nouvelle Société commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2011

et la première assemblée générale statutaire se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2011.

<i>Pour NICE FINANCE S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011124115/213.
(110142345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2011.

Navitas Solar Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 154.730.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 13. April 2011

Aus den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der Navitas Solar Group S.A. vom 13. April 2011 ergibt

sich, dass folgende Entscheidungen getroffen wurden:

Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen, den Auftrag von PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., mit Sitz in

400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2011 (zweitausendelf)
befindet, zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. April 2011.

Navitas Solar Group S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2011124954/17.
(110143200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2011.

SEB Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 28.468.

Le règlement de gestion de SEB Absolut Fund coordonné (partie générale et partie spécifique) a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011124371/10.
(110143111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2011.

VCB Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitburg.

R.C.S. Luxembourg B 163.264.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the second of September.
Before Maître Henri BECK notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

VCB Lease Stichting, a foundation organised under the laws of The Netherlands with its official seat in Amsterdam and

its address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam;

100247

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Ms. Peggy SIMON, private employee, residing in Berdorf, by virtue of a proxy, given on Sep-

tember 2, 2011,

such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “VCB Lease S.à r.l.”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager

(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the financing, leasing and remarketing of a Boeing, model 747-8 F aircraft

(the “Aircraft”) and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters or things as may be necessary
to achieve, or which are incidental or conductive to, any of the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the Company may acquire and sell the Aircraft and finance such acquisition through

loans or other financial arrangements, in whatever form, and issue guarantees and grant any form of security interest or
other liens over its assets, including mortgages and pledges, to secure the financing obligations entered into by the Com-
pany or by Cargolux Airlines International S.A. with respect to the acquisition, financing or leasing of the Aircraft.

The Company may further issue guarantees and grant any form of security interest or other liens over its assets,

including mortgages and pledges, to secure any indebtedness now or hereafter and directly or indirectly owing to Export-
Import Bank of the United States (“Ex-Im Bank”) or to any agent or trustee acting for Ex-Im Bank or to any person or
entity who is the beneficiary, directly or indirectly, of any past, present or future guarantee by Ex-Im Bank (but only to
the extent such indebtedness, if not owed to Ex-Im Bank, is guaranteed by Ex-Im Bank), from any of (i) Cargolux Airlines
International S.A.; (ii) any affiliate of Cargolux Airlines International S.A.; (iii) any special purpose company arranged in
part by Cargolux Airlines International S.A.; or (iv) any other person or entity to the extent that Cargolux Airlines
International S.A., any affiliate thereof or any such special purpose company is obligated to pay or reimburse such other
person or entity for such indebtedness or has agreed to guarantee such indebtedness.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty-five thousand United States Dollars (USD

25,000.-) divided into two thousand five hundred (2,500) shares with a nominal value of ten United States Dollars (USD
10.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to nonshareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.

100248

L

U X E M B O U R G

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time but only for cause by a resolution
of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or

class B Managers (the “Class B Managers”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or the Board of Managers (if more

than two Managers have been appointed) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), or the Board of Managers (if more than two Managers have
been appointed), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any of its members so requires.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence of all Managers.
Decisions will be taken by the unanimous consent of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
In cases of urgency, one or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any

other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

100249

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have
been qualified Class A Managers and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company. The foregoing also applies if, at the request of the Company, he
incurs expenses for any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and by which he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or
proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided
only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel
that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be
entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws the Company's annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including
more in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more
statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine

the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the inde-
pendent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 10 May at 10 a.m at the registered office of
the Company.

100250

L

U X E M B O U R G

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as designated by the Manager(s).

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
two (2) Managers (including one Class A and one Class B Manager if the Managers have been qualified Class A Managers
and Class B Managers) acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

100251

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the sole shareholder or, as the

case may be, the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

subscribed

capital

number

of shares

amount paid-in

VCB Lease Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-

2,500

USD 25,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-

2,500

USD 25,000.-

The amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) was thus as from that moment at the disposal

of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately [one thousand six hundred euro (EUR 1.600.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2011.

<i>Shareholders resolutions

<i>First Resolution

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following

for an unlimited duration:

- GT Fiduciaires S.A., with registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and registered with the Lu-

xembourg Register of Commerce and Companies under number B121.820.

100252

L

U X E M B O U R G

<i>Third Resolution

The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of approved independent auditors and further resolved

to appoint the following for a period ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts
of the financial year ending on 31 December 2023:

- Statera Audit S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B156.148.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present

deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Echternach by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by her surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendelf, am zweiten September.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

VCB Lease Stichting, eine Stiftung niederländischen Rechts mit Geschäftssitz in Amsterdam und mit Adresse in Prins

Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,

vertreten durch Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf, kraft der am 2. September 2011 erteilten

Vollmacht;

die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wur-

de, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „VCB Lease S.à r.l.“ firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der

Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) im

Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung, das Leasing und Weitervermarktung eines

Flugzeugs, Typ Boeing, Model 747-8 F (das „Flugzeug“) und solche Maßnahmen, Aufgaben oder Dinge durchzuführen oder
herbeizuführen, die notwendig sind, um einen der genannten Zwecke zu erreichen oder zu fördern.

Um ihren Zweck zu erreichen kann die Gesellschaft das Flugzeug kaufen und verkaufen und diesen Erwerb durch

Darlehen  oder  andere  Finanzierungsgeschäfte  jeglicher  Art  finanzieren  und  Garantien  und  andere  Sicherheiten  oder
Gläubigerrechte, einschließlich Hypotheken und Pfandrechte, über ihre Güter gewähren, um die Finanzierungsverbind-
lichkeiten die von der Gesellschaft oder von Cargolux Airlines International S.A. zum Erwerb, der Finanzierung oder dem
Leasing des Flugzeuges eingegangen wurden, abzusichern.

Die  Gesellschaft  kann  außerdem  Garantien  gewähren  und  jede  Art  von  Sicherheiten  oder  Gläubigerrechten,  ein-

schließlich Hypotheken und Pfandrechte, über ihre Güter gewähren, um die Finanzierungsverbindlichkeiten, abzusichern,
die jetzt oder später und direkt oder indirekt gegenüber Export-Import Bank of the United States (“Ex-Im Bank”) oder
einem Vertreter oder Treuhänder, der für Ex-Im Bank handelt oder einer anderen Person oder Gesellschaft, die direkt
oder indirekt Begünstigte von einer vergangenen, gegenwärtigen oder zuküftigen Garantie von Ex-Im Bank ist (aber nur
soweit die Finanzierungsverbindlichkeit, wenn sie nicht Ex-Im Bank geschuldet ist, von Ex-Im Bank besichert wird) be-
stehen,  durch  jeden  von  (i)  Cargolux  Airlines  International  S.A;  (ii)  einer  Tochtergesellschaft  von  Cargolux  Airlines
International S.A.; (iii) einer Zweckgesellschaft, die zumindest teilweise von Cargolux Airlines International S.A. arrangiert
wurde; oder (iv) jeder anderen Person oder Gesellschaft soweit Cargolux Airlines International S.A., eine ihrer Toch-

100253

L

U X E M B O U R G

tergesellschaften oder eine solche Zweckgesellschaft dieser anderen Person oder Gesellschaft gegenüber zur Zahlung
oder Erstattung dieser Finanzierungsverbindlichkeiten verpflichtet ist oder diese garantiert hat.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend

US-Dollar (USD 25.000,-), und ist in zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile mit einem Nennwert von je zehn US-Dollar
(USD 10,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits-und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs

oder die Insolvenz oder ein

vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-

ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)

gegründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, aber nur aus gutem Grund,
durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)

„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer oder der Geschäfts-

führungsrat (wenn mehr als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten

100254

L

U X E M B O U R G

an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder
zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.

Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben

(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat (wenn mehr
als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Voll-
macht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen

Schriftführer  benennen,  welcher  selbst  kein  Geschäftsführer  sein muss  und  für die  Protokollführung der  Sitzung  der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-

rungsrates muss einberufen werden, wenn eines seiner Mitglieder dies verlangt.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit

des Geschäftsführungsrates ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.

Alle Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg statt.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit aller seiner amtierenden Mitglieder.
Entschlüsse werden per Einstimmigkeitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des

Geschäftsführungsrates gefasst.

In dringenden Fällen können ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates durch eine Telefonkonferenz-

schaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen,
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.

Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-

weitig  übermittelt  werden,  können  von  einem  Geschäftsführer  oder  durch  zwei  (2)  Geschäftsführer  (d.h.  einem
Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B
qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.

Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die

(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

100255

L

U X E M B O U R G

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-

bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder

irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  persönlich  an  einer  solchen  Gesellschaft  oder  einem  solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmen sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte
tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu
handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-

lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, kann,
und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, muss, das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, ein-
schließlich der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.

Die statutorischen oder zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den)

Gesellschafter ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederer-
nannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen
werden außer in Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aus guten Gründen
oder einvernehmlich abberufen werden kann.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz

zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 10. Mai um 10 Uhr am Gesell-
schaftsitz der Gesellschaft abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-

halten oder an jedem anderen von den Geschäftsführern bestimmten Ort im Großherzogtum Luxemburg.

Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die

Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz

100256

L

U X E M B O U R G

von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit -Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahmeund

Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu

von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-

versammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von

Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-

schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen werden, ist das Quorum die Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter

unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer (d.h. einem Geschäftsführer A und einem Geschäftsführer B, wenn
die Geschäftsführer als Geschäftsführer A und Geschäftsführer B qualifiziert worden sind) gemeinsam, wenn mehr als ein
Geschäftsführer ernannt worden ist, unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des

Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn

verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr

100257

L

U X E M B O U R G

vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Akti-
onäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der Gesellschafter, oder gegebenenfalls

des alleinigen Gesellschafters, aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei
viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen

sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt
geltenden Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gege-

benenfalls das Emmissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

gezeichnetes

Kapital

Anzahl der

Anteile

eingezahlter

Betrag

VCB Lease Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25.000,-

2.500

USD 25.000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25.000,-

2.500

USD 25.000,-

Die Summe von fünfundzwanzigtausend US-Dollar (USD 25.000,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Moment

an zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Voraus-
setzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden
Fassung, gewahrt wurden.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr ein tausend sechs hundert Euro (EUR 1.600.-) geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2011.

<i>Gesellschafterbeschlüsse

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 19, rue de Bitburg, L-1273 Luxemburg, Groß-

herzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter hat die Anzahl der Geschäftsführer auf einen (a) festgelegt und die folgende Person auf unbe-

grenzte Zeit als Geschäftsführer ernannt:

- G.T. Fiduciaires S.A., mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg und eingetragen beim Handels-und Gesell-

schaftsregister Luxemburg unter der Nummer B121.820.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter hat die Anzahl von zugelassenen Wirtschaftsprüfern auf einen (1) festgelegt und die folgenden

Person bis zur Gesellschafterversammlung, die über die Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres, das am
31. Dezember 2023 endet, als zugelassener unabhängiger Wirtschaftsprüfer ernannt:

- Statera Audit S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in 28, rue Henri

VII, L-1725 Luxemburg und eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B156.148.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

100258

L

U X E M B O U R G

Woraufhin  vorliegende  Urkunde  am  eingangs  erwähnten  Datum  von  dem  unterzeichnenden  Notar  in  Echternach

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den, dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 05 septembre 2011. Relation: ECH/2011/1453. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

<i>Le Receveur ff. (signé): D. SPELLER.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels-und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 05. September 2011.

Référence de publication: 2011124407/623.
(110143326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2011.

Euro Advance Fund, Fonds Commun de Placement.

The liquidation of the Fund has been closed on September 6, 2011, by decision of the board of directors of JAPAN

FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the "Management Company") acting as liquidator to the Fund.

The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of Mizuho Trust &amp; Banking (Luxembourg)

S.A., 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, for a period of five years.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2011124961/1232/10.

Bellux 2004 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 103.293.

Belron OPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.421.012.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.240.

Belron International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 71.640.

Belron NS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.989.012.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.237.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of the month of June.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Bellux 2004 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 103.293 (he-
reafter named "B2004"), incorporated pursuant to a deed of 20 September 2009 of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial") number 1236 of 2 December 2004 whose articles of incorporation have been amended for the last time on
3 November 2004 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, published in the Mémorial number 321 of 12
April 2005;

2) Belron OPS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 156.240 (he-
reafter named "BOPS"), incorporated pursuant to a deed of 20 October 2010 of Maître Blanche Moutrier, notary residing
in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 2580 of 26 November 2010 and

100259

L

U X E M B O U R G

whose articles of incorporation have been amended for the last time on 8 December 2010 pursuant to a deed of Maître
Blanche Moutrier, prenamed, published in the Mémorial number 177 of 28 January 2011;

3) Belron International S.A., a société anonyme, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-

xembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 71.640 (hereafter
named "BISA"), incorporated pursuant to a deed of 17 September 1999 of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing
in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 895 of 26 November 1999 and whose articles
of incorporation have been amended for the last time on 26 March 2001 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
prenamed, published in the Mémorial number 1049 of 22 November 2001;

4) Belron NS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 156.237 (he-
reafter named "BNS"), incorporated pursuant to a deed of 20 October 2010 of Maître Blanche Moutrier, prenamed,
published in the Mémorial number 2575 of 25 November 2010 and whose articles of incorporation have been amended
for the last time on 8 December 2010 pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, prenamed, published in the Mémorial
number 178 of 28 January 2011;

pursuant to proxies dated 5 May 2011, which remained attached to the merger proposal received by the undersigned

notary on 9 May 2011.

The appearing parties requested the undersigned notary to state as follows:
1. that the condition to the merger proposal, i.e. the completion of the merger between Carglass Luxembourg S.à r.l.,

as merged company, and BOPS, as merging company, is fulfilled, as described in the merger deed of record dated 16 May
2011 of the undersigned notary published in the Mémorial number 1130 of 27 May 2011;

2. that the merger proposal relating to mergers of the following companies was published in the Official Gazette of

the Grand Duchy of Luxembourg, the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1059 of 20 May 2011
(the “Merger Proposal”):

a. step 1: B 2004, as absorbing company, and BOPS, as absorbed company;
b. step 2: BISA, as absorbing company, and B2004, as absorbed company;
c. step 3: BNS, as absorbing company, and BISA, as absorbed company;
3. that each of B2004 in relation to step 1, BISA in relation to step 2 and BNS in relation to step 3 are hereafter referred

to as the "Absorbing Companies", and each of BOPS in relation to step 1, B2004 in relation to step 2 and BISA in relation
to step 3 are hereafter referred to as to the "Absorbed Companies". Each of the Absorbing Companies and each of
Absorbed Companies are hereafter referred to as the "Merging Companies". For the avoidance of doubt, each of the
following items applies to each of steps 1, 2 and 3;

4. that article 6 of the Merger Proposal provides that the mergers between each of the Absorbed Companies and each

the Absorbing Companies shall become effective one month after the publication of the Merger Proposal in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, and thus the merger between the Merging Companies took effect on 21 June
2011;

5. that pursuant to article 267(1) a) and b) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the

“Law”), the Merger Proposal and the annual accounts of the last three financial years, where relevant, of each of the
Merging Companies have been made available at the registered office of each of the Merging Companies at least one
month before the effective date of the merger between the Merging Companies;

6. that none of the shareholders of each of the Absorbing Companies has requested that a general meeting be called

pursuant to article 279(1)c) of the Law; and

7. that each of the Absorbed Companies ceased to exist.
A certificate of each of the Merging Companies certifying the availability of the documents and the absence of convening

of a general meeting of each of the Absorbing Companies pursuant to article 279(1)c) of the Law, which after having been
initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties have thus requested the undersigned notary to issue the present certificate pursuant to article

273 of the Law.

<i>Statement

Pursuant to article 273 of the Law, the undersigned notary hereby declares that she made the necessary verifications

and certifies the existence and the validity of acts and formalities to be carried out by the Merging Companies and that
in consequence the conditions of article 279 of the Law have been fulfilled.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

100260

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the appearing person, the said person signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt et unième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Bellux 2004 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 103.293 (ci-
après dénommée «B2004»), constituée le 20 septembre 2009 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») numéro 1236 du 2 décembre 2004, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 3 novembre
2004 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, prénommé, publié au Mémorial numéro 321 du 12 avril 2005;

2) Belron OPS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156.240 (ci-
après dénommée «BOPS»), constituée le 20 octobre 2010 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 2580 du 26 novembre 2010,
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 8 décembre 2010 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier,
prénommée, publié au Mémorial numéro 177 du 28 janvier 2011;

3) Belron International S.A., une société anonyme, avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  à  Luxembourg  sous  le  numéro  B  71.640  (ci-après
dénommée «BISA»), constituée le 17 septembre 1999 suivant acte reçu de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de rési-
dence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 895 du 26 novembre 1999, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois le 26 mars 2001 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, prénommé, publié au
Mémorial numéro 1049 du 22 novembre 2001;

4) Belron NS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 9Bb, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156.237 (ci-
après dénommée «BNS»), constituée le 20 octobre 2010 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, prénommée,
publié au Mémorial numéro 2575 du 25 novembre 2010, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 8
décembre 2010 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, prénommée, publié au Mémorial numéro 178 du 28 janvier
2011;

par mandats spéciaux datés du 5 mai 2011, lesquels resteront annexés au projet de fusion reçu le 9 mai 2011 par le

notaire soussigné.

Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
1. que la condition préalable au projet de fusion, i.e. la réalisation de la fusion entre Carglass Luxembourg S.à r.l., en

tant que société absorbée, et BOPS en tant que société absorbante, a été réalisée, telle que décrite dans le constat de
fusion établi par le notaire soussigné le 16 mai 2011 et publié au Mémorial numéro 1130 du 27 mai 2011;

2. que le projet de fusion relatif aux fusions des sociétés suivantes a été publié au Journal Officiel du Grand Duché de

Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1059 du 20 mai 2011 (le «Projet de Fusion»):

a. étape 1: B2004, en tant que société absorbante, et BOPS, en tant que société absorbée;
b. étape 2: BISA, en tant que société absorbante, et B2004, en tant que société absorbée;
c. étape 3: BNS, en tant que société absorbante, et BISA, en tant que société absorbée;
3. que chacune de B2004 en relation avec l'étape 1, BISA en relation avec l'étape 2 et BNS en relation avec l'étape 3

sont désignées ci-après les «Sociétés Absorbantes», et chacune de BOPS en relation avec l'étape 1, B2004 en relation
avec l'étape 2 et BISA en relation avec l'étape 3 sont désignées ci-après les «Sociétés Absorbées». Chacune des Sociétés
Absorbantes et chacune des Sociétés Absorbées sont désignées ci-après les «Sociétés Fusionnantes». Afin d'éviter tout
doute, chacun des points suivants s'applique à chacune des étapes 1, 2 et 3;

4. que la clause 6 du Projet de Fusion prévoit que les fusions entre chacune des Sociétés Absorbées et chacune des

Sociétés Absorbantes prendront effet un mois après la publication du Projet de Fusion dans le Journal Officiel du Grand
Duché de Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et que donc la fusion a pris effet entre les
Sociétés Fusionnantes en date du 21 juin 2011;

5. que conformément à l'article 267 (1) a) et b) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi»), le Projet de Fusion, les comptes annuels des trois derniers exercices, dans la mesure où ils existent,
de chacune des Sociétés Fusionnantes ont été rendus disponibles au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes
au moins un mois avant la date à laquelle la fusion a pris effet entre les Sociétés Fusionnantes;

6. qu'aucun associé des Sociétés Absorbantes n'a demandé la convocation d'une assemblée générale conformément à

l'article 279 (1) c) de la Loi;et

7. que chacune des sociétés Absorbées a cessé d'exister.

100261

L

U X E M B O U R G

Une attestation de chacune des Sociétés Fusionnantes certifiant la disponibilité desdits documents et l'absence d'une

demande de convocation d'une assemblée générale des Sociétés Absorbantes sous l'article 279 (1) c) de la Loi, après
avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes ont ainsi requis le notaire instrumentaire d'émettre le présent certificat conformément à

l'article 273 de la Loi.

<i>Déclaration

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire instrumentaire déclare qu'il a effectué les vérifications nécessaires

et certifie l'existence et la validité des actes et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes et de ce fait que les
conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais reconnaît qu'à la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une tradition en français; à la demande de cette même partie, la version anglaise prévaudra
en cas de différences entre la version anglaise et la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Daurel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 juin 2011. LAC/2011/28801. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Référence de publication: 2011099148/167.
(110113294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Repco 19 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 94.780,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 112.980.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011

Il résulte d'une assemblée générale de la Société tenue le 7 Juin 2011 que:
1. PriceWaterhouseCoopers S.à r.l. avec siège social au 400 Route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65477 a démissionné de ses fonctions de reviseur d'enterprise agréé de la
Société, avec effet immédiat.

2. Monsieur David Bannerman, né le 2 février 1962 à Edimbourg résidant professionnellement au 2 rue Jean Bertholet

L-1233 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat. Son mandat expirera lors
de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

KETVEL Pii / JANIETZ Bernd.

Référence de publication: 2011099036/18.
(110111829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 72.338.

Im Jahre zweitausendelf, am neunzehnten Juli,
vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven,
sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft „Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.“ mit Sitz in 18-20, rue

Gabriel Lippmann, L-5365 Schuttrange, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer R.C.S. Lu-
xembourg B 72.338 und gegründet gemäß Urkunde des Notars Frank BADEN, vormals mit dem Amtssitz in Luxemburg,
vom 29. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1018 vom 31.
Dezember 1999, letztmalig abgeändert durch den unterzeichnenden Notar am 28. April 2008, veröffentlicht im Mémorial
C – Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1350 vom 3. Juni 2008, zu einer außerordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.

100262

L

U X E M B O U R G

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christoph Wagner, Jurist, geschäftsansässig in Munsbach. Zum Schriftführer

wird Frau Julia Spanier, Juristin, geschäftsansässig in Munsbach, bestimmt.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Julia Spanier, vorbenannt.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie der Stück-

zahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, und die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter
haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die  Anwesenheitsliste  wird  durch  den  Vorsitzenden  abgeschlossen  und  durch  den  Versammlungsvorstand  unter-

zeichnet.  Eventuelle  Vollmachten,  welche  durch  die  Erschienenen  und  den  unterzeichnenden  Notar  "ne  varietur"
paraphiert wurden, bleiben gegenwärtigem Protokoll beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist, und dass somit die Ver-

sammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.- Anpassung des Gesellschaftszwecks an den durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 geänderten Rechtsrahmen

und demnach Neufassung von Artikel 3 der Gesellschaftssatzung.

2.- Aufhebung des genehmigten Kapitals und demnach Streichung von Artikel 5, Absatz 4.
3.- Ersetzung des in Artikel 9 enthaltenen Hinweises auf „Artikel 78 (1) des Gesetzes vom zwanzigsten Dezember

zweitausend und zwei“ durch den Hinweis auf „Artikel 102 (1) des Gesetzes vom siebzehnten Dezember zweitausend
und zehn“ und demnach Neufassung von Artikel 9 der Gesellschaftssatzung.

4.- Ersetzung des in Artikel 23 enthaltenen Hinweises auf „das Gesetz vom zwanzigsten Dezember zweitausend und

zwei“ durch den Hinweis auf „das Gesetz vom siebzehnten Dezember zweitausend und zehn“ und demnach Neufassung
von Artikel 23 der Gesellschaftssatzung.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftszweck an den durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 geän-

derten Rechtsrahmen anzupassen und demnach Neufassung von Artikel 3 der Gesellschaftssatzung:

Art. 3. „Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) sowie die Aus-

führung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Verwaltung solcher OGA verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 15
des Gesetzes vom siebzehnten Dezember zweitausend und zehn bleiben.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das genehmigte Kapital aufzuheben und demnach Streichung von Artikel 5, Absatz

4 um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. „Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünfzehn Millionen Euro (EUR 15.000.000,-), aufgeteilt in einhun-

dertfünfzigtausend (150.000) Aktien ohne Nennwert; es ist in voller Höhe eingezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesell-

schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ("Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünf-
zehn") und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.“

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den in Artikel 9 enthaltenen Hinweises auf „Artikel 78 (1) des Gesetzes vom

zwanzigsten Dezember zweitausend und zwei“ durch den Hinweis auf „Artikel 102 (1) des Gesetzes vom siebzehnten
Dezember zweitausend und zehn“ zu ersetzen und demnach Neufassung von Artikel 9 der Gesellschaftssatzung:

Art. 9. „Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können

an die in Artikel 102 (1) des Gesetzes vom siebzehnten Dezember zweitausend und zehn aufgeführten Personen über-
tragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse, Zeichnungsberechtigung und Vergütungen werden durch den
Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des Ver-

waltungsrates oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest,
welche von der Gesellschaft getragen werden.“

100263

L

U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den in Artikel 23 enthaltenen Hinweis auf „das Gesetz vom zwanzigsten Dezember

zweitausend und zwei“ durch den Hinweis auf „das Gesetz vom siebzehnten Dezember zweitausend und zehn“ zu erse-
tzen und demnach Neufassung von Artikel 23 der Gesellschaftssatzung:

Art. 23. „Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen

Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom siebzehnten Dezember zweitausend und zehn und das Gesetz vom zehnten
August neunzehnhundertfünfzehn.“

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tau-

sendeinhundert Euro (EUR 1.100.-) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt,
und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.

Gezeichnet: Christophe Wagner, Julia Spanier, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 juillet 2011. LAC / 2011 / 32811. Reçu 75.- €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 22. Juli 2011.

Référence de publication: 2011103445/90.
(110118666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 101.643.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098747/9.
(110112288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

4IPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 162.196.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the sixth of July.
Before the undersigned Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg;

There appeared:

- Mr Uwe NIELSEN born on the 7 

th

 February 1963 in Saarbrücken (D) residing in L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf,

here represented by Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, réviseur d'entreprise, residing professionally in
Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on June 20 

th

 , 2011,

- Mr Thomas HEDEGAARD born on the 29 

th

 November 1977 in Horsholm (DK) residing in CH-6006 Luzern, 14,

Schadrutihalde, here represented by Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, prenamed, by virtue of a proxy,
given under private seal on June 20 

th

 , 2011,

- Mr Lars Wolff GRAVERSEN born on the 24 

th

 April 1972 in Silkeborg (DK) residing in DK-8600 Silkeborg, 25,

Strandvejen, here represented by Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, prenamed, by virtue of a proxy, given
under private seal on June 20 

th

 , 2011.

All the proxys, initialed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the officiating notary to draw up the following

articles of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declared to organize.

100264

L

U X E M B O U R G

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as

amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of 4IPS S.àr.l..

Art. 3. Object. The Company has as one of its principal objectives investment in the research of computer software

and the acquisition, and eventual sale, of the intellectual property rights related to new research.

The Company has as its objects the holding of participations, in whatever form, in Luxembourg and/or in foreign

companies, as well as the management, development and administration of these participations.

The Company can acquire through purchase, contribution-in-kind, option, or in any other manner investments in any

currency and dispose of these by sale, cession, exchange, or any other method.

The Company can equally buy and develop intellectual property rights and other related rights connected to these,

or assist in their completion.

The Company can borrow and grant companies in which it has direct, or indirect, interest, every assistance, loans,

advances, or guarantees..

The Company shall be able to carry out any operation, whether commercial, industrial, or financial, that is deemed to

be in its interest and the achievement of its objects.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Mondorf-les-Bains.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by decision of the management.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by ninety (90)

shares with no par value.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant

to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting of

partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

100265

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the

law.

Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar

event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or

not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of
each manager.

Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition of

subsidiaries without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more than
fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners.

Art. 16. Powers. Each manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal

concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the
Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in

relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual signature

of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been
delegated by the managers, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners.
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10 

th

 , 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing,

recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners
and the power of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws

up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation

and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

100266

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Dissolution, Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation

will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting
of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with

applicable laws.

<i>Subscription and Payment

Thereupon, now appears Mr. Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, prenamed, acting in his capacity as duly

authorized agent and attorney in fact of the Shareholders by virtue of proxys given on June 20 

th

 2011.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of
- Mr Uwe NIELSEN to ten (10) shares with no nominal value,
- Mr Thomas HEDEGAARD to forty (40) shares with no nominal value,
- Mr Lars Wolff GRAVERSEN to forty (40) shares with no nominal value,
The proof of such payment was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2011.

<i>Extraordinary general meeting

The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following re-

solutions:

1. Resolved to set at one (1) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Manager for an

unlimited period:

Mr Uwe NIELSEN, prenamed.
2. Resolved that the registered office shall be in L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above persons,

the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by their

surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le six juillet.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN notaire de résidence à Luxembourg, soussigné

ONT COMPARU:

Mr Uwe NIELSEN né le 7 février 1963 à Saarbrücken (D) avec adresse à L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf, ici

représenté par Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, rèviseur d'entreprise avec adresse professionnelle à
Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 20 juin 2011,

Mr Thomas HEDEGAARD né le 29 novembre 1977 à Horsholm (DK) avec adresse à CH-6006 Luzern, 14, Schadru-

tihalde, ici représenté par Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, pré-qualifié, en vertu d'une procuration datée
du 20 juin 2011

Mr Lars Wolff GRAVERSEN né le 24 avril 1972 à Silkeborg (DK) avec adresse à DK-8600 Silkeborg, 25, Strandvejen,

ici représenté par Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, pré-qualifié, en vertu d'une procuration datée du 20
juin 2011.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent

acte aux fins d'enregistrement.

Lesquelles comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.

100267

L

U X E M B O U R G

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de 4IPS S.àr.l..

Art. 3. Objet. La Société a comme un de ses objets principaux l'investissement dans la recherche de programmes et

logiciels pour ordinateurs et l'acquisition et la vente éventuelle des droits de propriété intellectuelle en relation avec cette
recherche.

La Société a parmi ses autres objets la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou étrangères

ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut faire l'acquisition d'investissements par achat, apport en nature, option ou toute autre forme, cela dans

n'importe quelle devise, et en disposer par vente, cession, échange ou toute autre méthode.

La société peut également acheter et développer des droits de propriété intellectuelle ou autres qui y sont liés, ou

aider à leur achèvement.

La Société peut également emprunter ou accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect des

prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société doit être capable d'effectuer toute opération, qu'elle soit commerciale, industrielle ou financière, qu'elle

jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée

générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Mondorf-les-Bains.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représentés par quatre-

vingt-dix (90) parts sociales sans valeur nominale.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de

l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d'un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d'associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

100268

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement

similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un

gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou l'ac-

quisition de filiales sans le vote favorable de l'associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante
pour cent (50%) des parts présentes ou représentées à l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Pouvoirs. Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion

et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles
rentrent dans l'objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en
demandant soit en défendant.

Art. 17. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de tout

gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été
délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés.
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit

sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de

quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit

et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que
les procurations leur seront annexées.

Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas de l'assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes

annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.

Art. 24. Répartition des bénéfices. L'excèdent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que

ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

100269

L

U X E M B O U R G

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés,

selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu Mr Nicolas VAINKER BOUVIER DE LAMOTTE, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire

dûment autorisé des associés, précités, en vertu des procurations donnés le 20 juin 2011.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de
Mr Uwe NIELSEN, pré-qualifié, dix (10) parts sociales
Mr Thomas HEDEGAARD, pré-qualifié, quarante (40) parts sociales
Mr Lars Wolff GRAVERSEN, pré-qualifié, quarante (40) parts sociales
La preuve du paiement des douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille euros (1.000,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2011.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Fixation du nombre de Gérants à un (1) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:
- M. Uwe NIELSEN, pré-qualifié.
2) Fixation du siège social de la Société à L-5670 Altwies 2, route de Mondorf.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire

du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Vainker Bouvier de Lamotte, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2011. Relation: LAC/2011/31333. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 18 juillet 2011.

Référence de publication: 2011101384/315.
(110115428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.

Bau-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 27.968.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011099159/14.
(110112642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

100270

L

U X E M B O U R G

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 101.643.

<i>Rectificatif du dépôt n° L080048687 du 01/04/2008

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098748/10.
(110112290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 101.643.

<i>Rectificatif du dépôt n° L070042415 du 28/03/2007

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098749/10.
(110112291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Timberland Luxembourg Holding Asia S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.635.

<i>Rectificatif du dépôt n° L080048691 du 01/04/2008

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098752/10.
(110112280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Timberland Luxembourg Holding Asia S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 11.675.200,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 102.635.

EXTRAIT

L'accord de vente en date du 31 mars 2005 des 287.461 parts sociales de la Société détenues par la société TIMBER-

LAND (GIBRALTAR) HOLDING LIMITED au profit de TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., a été amendé
de  sorte  que  291.000  parts  sociales  de  la  Société  détenues  par  la  société  TIMBERLAND  (GIBRALTAR)  HOLDING
LIMITED ont été transférées au 31 mars 2005 au profit de TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group Sàrl
<i>Domicilitaire

Référence de publication: 2011098753/16.
(110112282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Unity Foundation, Fondation.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 17, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg G 95.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 mai 2011

L'Assemblée Générale accepte les démissions de leurs postes d'administrateurs de Monsieur Joubin Bashiri et de

Madame Mahvash Ahmadzadeh.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

100271

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 juillet 2011.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011098790/15.
(110111690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

ABN AMRO Bank (Ireland) Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.813.

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

La succursale est fermée en date du 30 avril 2011 sur décision du conseil d'administration de ABN AMRO Bank (Ireland)

Limited.

Luxembourg, le 15 juillet 2011.

<i>Pour ABN AMRO Bank (Ireland) Limited, Luxembourg Branch
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011099109/13.
(110112927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.

Consulting &amp; Estate Engeneering SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 109.882.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011098962/10.
(110111883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Development Portisco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 110.558.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011098963/10.
(110111688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Develup S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 74.312.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2011, les mandats des Administrateurs Madame Renata

LORENZ, Monsieur Paul LORENZ, administrateur-délégué, LANNAGE S.A., société anonyme, KOFFOUR S.A., société
anonyme, et VALON S.A., société anonyme, ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société
anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg, le 04 juillet 2011.

<i>Pour: DEVELUP S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011098964/17.
(110112118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

100272


Document Outline

4IPS S.à r.l.

ABN AMRO Bank (Ireland) Limited, Luxembourg Branch

All Car Services S.A.

Alternative Units

Amaris Group S.A.

Amaris Group S.A.

Aronda S.A.

Astonial S.A.

Bau-Invest S.A.

Beaucette S.A., SPF

Bellux 2004 S.àr.l.

Belron International S.A.

Belron NS S.à r.l.

Belron OPS S.à r.l.

Celux Finance S.A., SPF

Consulting &amp; Estate Engeneering SA

Costeley Development S.A.

Crescendo 1 S.à r.l.

Deutsche Postbank Vermögens - Management S.A.

Development Portisco S.A.

Develup S.A.

Digital Assets Group S.A.

Duberion Strategies S.A.

ECM Real Estate Investments A.G.

Euro Advance Fund

Global Corporate Investments S.A.

Immobilière des Sables S.A.

Investment Solutions

Lubesa SA

Lux Investcom SA

Meridium Financial S.A.

Navitas Solar Group S.A.

Nice Finance S.A.

Nord-Finance

Opaline Investissements S.A. SPF

Pharmaceutical Enterprises

Piramid Investment Solutions S.A. SPF

Pramerica Financial Guaranty Assurance Company, S.A.

Premium Portfolio SICAV

Premium Portfolio SICAV II

Publi Europe S.A.

Repco 19 S.A.

Rocky Mountains Holding S.A., SPF

SEB Asset Management S.A.

SEB Strategy Fund

Serimnir S.A.

Seven Vegas S.A.

Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.P.F. S.A.

Specials Fund

Stanley Invest Holding S.A. S.P.F.

St. Georges Investment S.A. - SPF

The Golden Group S.A.

The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

Timberland Luxembourg Finance S. à r.l.

Timberland Luxembourg Holding Asia S.àr.l.

Timberland Luxembourg Holding Asia S.àr.l.

Tuscani S.A.

Unity Foundation

VCB Lease S.à r.l.

Ygrec S.A., SPF

Zola Investments S.A.