This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2078
7 septembre 2011
SOMMAIRE
Coditel Holding Lux II Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
99734
Cronos Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99702
Eiffel Titrisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99732
Finathem Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99711
Fondation Nicolas et Jean-Paul Lanners
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99698
GER LOG 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99729
Imdlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99700
Immobilière Grün S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
99701
Immo D.A. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99701
Institut de beauté Selma S.à r.l. . . . . . . . . .
99699
Insurance Market Research S.A. . . . . . . . . .
99701
Intelligent Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . .
99702
Iona Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
99718
Ja.Ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99698
JP Commercial XI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
99711
K Beta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99702
Koliphi Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . .
99702
Kravid S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99710
KSM Participations Mobilières et Immobi-
lières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99710
Kunstkammer Corporation S.à r.l. . . . . . . .
99703
KWISTUM Administration S.à r.l. . . . . . . .
99711
Laboratoire de Biotechnologie du Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99718
Lafayette S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99730
La Foncière du Capitole S.A. . . . . . . . . . . . .
99703
Langers et Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99730
LDIGTL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99732
LDMadgency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99730
Leeverg Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
99728
Les Papillons S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99738
Lesswood S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99738
Lilac Holding Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99738
Liquiditätsfluss No.1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99728
Liquiditätsfluss No.2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
99729
Lithonia Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99742
Lizard Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99742
LK1 Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99742
LKE International Holding S.à r.l. . . . . . . . .
99729
L Multi Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99721
Lorfinance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99743
LSP (Leidwanger Stéphane Participations)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99743
Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg
S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99730
Lusonia Services S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . .
99743
Madeleine Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99701
MAS Luxinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99743
Massiv-Passiv S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99703
McKey Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
99744
Mercury Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
99710
Meridian Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
99744
Mermaid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99744
MERRILL LYNCH (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99739
Mirabaud Select Equities . . . . . . . . . . . . . . . .
99731
Nanosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99742
New Star International Property (Luxem-
bourg 4) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99730
Orion Investment Partners Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99700
Salisbury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99739
Seamer Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
99720
Supermarché MASSEN S.A. . . . . . . . . . . . .
99744
TDL Financing Luxembourg Sàrl . . . . . . . .
99703
99697
L
U X E M B O U R G
Ja.Ita, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52B, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 129.167.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011098457/10.
(110112460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Fondation Nicolas et Jean-Paul Lanners, Fondation.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
R.C.S. Luxembourg G 116.
Actif
Bilan au 31 décembre 2010
Passif
EUR
EUR
Titres ayant le caractère
d'immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 407,61 Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185 920,14
Avoirs en banques, CCP et encaisse . . . . . . 206 337,40 Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294 239,45
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . .
15 585,42
495 745,01
495 745,01
Débit
Compte de résultat au 31 décembre 2010
Crédit
EUR
EUR
Dépenses de la fondation . . . . . . . . . . . . . . . 14 500,00 Intérêts créditeurs sur dépôts à terme . . . .
2 657,67
Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 Dividendes obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 448,00
Autres intérêts et charges assimilées . . . . . . .
20,25 Dons obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 000,00
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 585,42
30 105,67
30 105,67
<i>Dépenses de la fondationi>
Olympiade des mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000,00
Concours informatique (CIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500,00
Assoc. des Jeunes Scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500,00
Prix Lanners (Uni.lu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500,00
Partenariat Ukraine Deux Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000,00
14 500,00
Dépenses
Budget de l'exercice 2011
Recettes
EUR
EUR
Dépenses concernant l'objet de la fondation
Recettes concernant l'objet de la fondation
Olympiade des Mathématiques . . . . . . . . . . .
6 000,00 Intérêts créditeurs sur dépôts à terme . . . .
3 000,00
C.I.L. (concours informatique) . . . . . . . . . . . .
2 500,00 Dons à recevoir de CERATIZIT S.A. . . . . . .
25 000,00
Jeunes scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500,00 Dividendes BIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 448,00
Partenariat Ukraine Deux Luxembourg . . . . .
2 000,00
Prix Lanners (Uni.lu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500,00
Charges financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Excédent de recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 948,00 Excédent de dépenses: . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
30 448,00
30 448,00
Référence de publication: 2011103150/39.
(110117313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2011.
99698
L
U X E M B O U R G
Institut de beauté Selma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4676 Niederkorn, 6A, rue Theis.
R.C.S. Luxembourg B 162.075.
STATUTS
L'an deux mille onze.
Le sept juin.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU
Madame Selma MUJKIC, esthéticienne, née à Zavidovici le 20 janvier 1984,
demeurant à L-4610 Niederkorn, 4, rue de Longwy
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
Institut de beauté Selma S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté, de pédicure, d'esthéticienne, de manucure-con-
fectionneur d'ongles artificiels.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Niederkorn.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Madame Selma MUJKIC, prénommée CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
99699
L
U X E M B O U R G
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT EUROS (€ 900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en
assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommée gérante de la société:
Madame Selma MUJKIC, prénommée
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-4676 Niederkorn, 6A, rue Theis.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Mujkic Selma, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 juin 2011. Relation: EAC/2011/7580. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011098431/70.
(110112202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Imdlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou-Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 135.752.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098442/9.
(110111341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Orion Investment Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 122.514.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique en date du 15 juin 2011i>
L'associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les
comptes annuels au 31 décembre 2011:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant à 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant à 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf les Bains (Grand-Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant à 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant à 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France); et
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant à 43 Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer;
- Monsieur Christopher Jenner;
- Monsieur Ronald W. de Koning;
- Monsieur Olivier de Nervaux; et
- Monsieur Anthony Halligan.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
99700
L
U X E M B O U R G
<i>Pour Orion Investment Partners Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2011103676/29.
(110117772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2011.
Immo D.A. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4660 Differdange, 24, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 80.661.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098444/9.
(110111414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Immobilière Grün S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 35.834.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098445/9.
(110112097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
IMR S.A., Insurance Market Research S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 32/2, rue Léon Kauffman.
R.C.S. Luxembourg B 124.513.
EXTRAIT
Le conseil d'administration, dans ses résolutions du 13 juillet 2011, a renouvelé les mandats des délégués à la gestion
journalière pour une durée indéterminée:
- Monsieur Philippe LEONET, Administrateur-délégué, administrateur de sociétés, rue Eugène Ronveaux, 248b, B-5350
Ohey, Belgique;
- Monsieur Jean-Louis LERUTH, Administrateur-délégué, Président, administrateur de sociétés, 32/2 rue Léon Kauff-
man, L-1853 Luxembourg, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
<i>Pour INSURANCE MARKET RESEARCH S.A. en abrégé IMR S.A.i>
Référence de publication: 2011098448/16.
(110111331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Madeleine Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 46.135.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 26 novembre 2010i>
<i>Troisième résolution:i>
Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg, le
23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en qualité
de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui
se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MADELEINE FINANCE S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2011098531/17.
(110111529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
99701
L
U X E M B O U R G
Cronos Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 91.889.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale
Ordinaire tenue à Luxembourg le 17 juin 2011i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Patrick Wagenaar, Jean-Michel Gelhay et Donald Villeneuve en qualité d'administrateurs pour
le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012.
2. de réélire KPMG Audit S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2012.
Luxembourg, le 11 juillet 2011.
<i>Pour CRONOS INVEST
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeuri> / -
Référence de publication: 2011099815/20.
(110113067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.
Intelligent Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.890.
Les comptes annuels au 31 mars 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INTELLIGENT ENGINEERING S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011098449/11.
(110111790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
K Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.250.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.636.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098459/11.
(110111589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Koliphi Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 152.974.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098463/9.
(110111921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
99702
L
U X E M B O U R G
Kunstkammer Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 149.770.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011098464/10.
(110112359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Massiv-Passiv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 86.620.
Les documents de clôture de l'année 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch.
<i>Pour MASSIV-PASSIV S.A.
i>Arend Consult S.à r.l., Mersch
Signature
Référence de publication: 2011098539/13.
(110111476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
La Foncière du Capitole S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 31, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 65.678.
Il résulte des résolutions d'une réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 10 juin 2011 à
Luxembourg qu'il a été décidé de transférer l'adresse du siège social avec effet à dater du 10 juin 2011 vers L- 2340
Luxembourg, 31, rue Philippe II.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2011.
<i>Pour LA FONCIERE DU CAPITOLE S.A.
i>Par mandat spécial
B.P. 386
L-2013 LUXEMBOURG
Steve HOFFMANN
<i>AVOCATi>
Référence de publication: 2011098489/18.
(110111958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
TDL Financing Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.656.
In the year two thousand and eleven, on the fifteen day of June.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
TDL Luxembourg Ltd., a company incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office
at 2500, 700-9
th
Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 3V4, registered with Alberta Registrar of Corporation,
Canada under number 2015998178, acting through its Luxembourg branch, TDL, Luxembourg Branch, having its regis-
tered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 160.551 (hereafter referred to as the “Sole Member”);
duly represented by M
e
Vanessa Morolli, lawyer, residing in L-2132 Luxembourg 20, avenue Marie-Thérèse, by virtue
of a proxy dated June 15, 2011.
99703
L
U X E M B O U R G
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that TDL Luxembourg Ltd acting through its Luxembourg branch, TDL, Luxembourg Branch, is the sole member
of TDL Financing Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its re-
gistered office set at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B160.656, incorporated by a deed received by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxem-
bourg on April 20, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter referred
to as the “Company”).
II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according
to the following items:
1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 5,220,000.- (five million two hundred twenty
thousand US Dollar) so as to bring it from its current amount of USD 20,000. (twenty thousand US Dollar) represented
by 20 (twenty) ordinary shares with no mention of par value to the amount of USD 5,240,000.- (five million two hundred
forty thousand US Dollar) by the issue of 5,220 (five thousand two hundred twenty) mandatory redeemable preferred
shares class A with no mention of par value each with the payment of a share premium attached to the mandatory
redeemable preferred shares class A amounting to USD 516,101,574.66 (five hundred sixteen million one hundred and
one thousand five hundred seventy-four US Dollar sixty-six cents) and the allocation of an amount of USD 522,000.- (five
hundred twenty-two thousand US Dollar) to the legal reserve of the Company;
2. Subscription and payment by the Sole Member of 5,220 (five thousand two hundred twenty) new issued mandatory
redeemable preferred shares class A together with a the payment of a share premium attached of USD 516,101,574.66
(five hundred sixteen million one hundred and one thousand five hundred seventy-four US Dollar sixty-six cents) and the
allocation of an amount of USD 522,000.- (five hundred twenty-two thousand US Dollar) to the legal reserve of the
Company by the contribution in kind of claims;
3. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the planned corporate
capital increase;
4. Amendment of articles 5.5 (iii), 5.6 of the articles of incorporation of the Company;
5. Amendment of article 17.2 of the articles of incorporation of the Company;
6. Amendment of article 18 of the articles of incorporation of the Company; and
7. Any other business.
<i>First resolutioni>
The Sole Member decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 5,220,000.- (five
million two hundred twenty thousand US Dollar) so as to bring its from its present amount of USD 20,000.- (twenty
thousand US Dollar) to the amount of USD 5,240,000.- (five million two hundred forty thousand US Dollar) represented
by the existing ordinary shares and by the issue of 5,220 (five thousand two hundred twenty) mandatory redeemable
preferred shares class A with no mention of a par value, together with the payment of a share premium attached to the
mandatory redeemable preferred shares class A amounting to USD 516,101,574.66 (five hundred sixteen million one
hundred and one thousand five hundred seventy-four US Dollar sixty-six cents) and the allocation of an amount of USD
522,000.- (five hundred twenty-two thousand US Dollar) to the legal reserve of the Company, the whole amount to be
fully paid up through a contribution in kind consisting of the claims described below.
<i>Second resolutioni>
Therefore the Sole Member decided to issue 5,220 (five thousand two hundred twenty) mandatory redeemable pre-
ferred shares class A with no mention of a par value, together with the payment of a share premium attached to the
mandatory redeemable preferred shares class A amounting to USD 516,101,574.66 (five hundred sixteen million one
hundred and one thousand five hundred seventy-four US Dollar sixty-six cents) and to allocate an amount of USD
522,000.- (five hundred twenty-two thousand US Dollar) to the legal reserve of the Company.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
There now appeared Me Vanessa Morolli, acting in her capacity as duly appointed special attorney of the Sole Member
by virtue of a proxy given on June 15, 2011 which will remain attached to the present deed.
The appearing person declared to:
- subscribe for and fully pay 5,220 (five thousand two hundred twenty) mandatory redeemable preferred shares class
A with no mention of par value, for a total amount of USD 5,220,000.- (five million two hundred twenty thousand US
Dollar);
- pay a share premium attached to the mandatory redeemable preferred shares class A amounting to USD
516,101,574.66 (five hundred sixteen million one hundred and one thousand five hundred seventy-four US Dollar sixty-
six cents);
99704
L
U X E M B O U R G
- allocate to the legal reserve of the Company an amount of USD 522,000.- (five hundred twenty-two thousand US
Dollar).
by the contribution in kind of claims, excluded all real estate assets, in an aggregate amount of USD 521,843,574.66
(five hundred twenty-one million eight hundred forty three thousand five hundred seventy-four US Dollar and sixty-six
cents) (hereafter referred to as the “Claims”).
<i>Description of the contributioni>
The appearing person stated that:
The contribution in kind consisted of the full ownership of the Claims excluded all real estate assets, for a total amount
of USD 521,843,574.66 (five hundred twenty-one million eight hundred forty-three thousand five hundred seventy-four
US Dollar and sixty-six cents), these Claims being valued by the board of managers of the Company at the amount of
USD 521,843,574.66 (five hundred twenty-one million eight hundred forty-three thousand five hundred seventy-four US
Dollar and sixty-six cents) on the basis of a valuation made by the Sole Member, owner of the Claims.
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the ownership and the value of the Claims has been given to the undersigned notary.
<i>Board of Managers’ interventioni>
Thereupon intervened Me Vanessa Morolli, duly appointed special attorney of the board of managers of the Company,
presenting a written confirmation issued by the managers of the Company duly authorized by the board of manager having
approved the valuation described above.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole
Member decided to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:
5.1. “The Corporation's share capital is set at five million two hundred forty thousand US Dollar (USD 5,240,000.-)
divided into twenty (20) ordinary shares (hereinafter the "Ordinary Shares") and five thousand two hundred twenty
(5,220) class A Mandatory Redeemable Preferred Shares (hereinafter the “Class A MRPS”). The Corporation may in
addition to the Ordinary Shares issue from time to time Class A MRPS, class B Mandatory Redeemable Preferred Shares
(the "Class B MRPS"), class C Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Class C MRPS"), class D Mandatory Re-
deemable Preferred Shares (the "Class D MRPS"), class E Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Class E MRPS"),
class F Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Class F MRPS"), class G Mandatory Redeemable Preferred Shares
(the "Class G MRPS"), class H Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Class H MRPS"), class I Mandatory Redee-
mable Preferred Shares (the "Class I MRPS"), class J Mandatory Redeemable Preferred Shares (the "Class J MRPS") (the
Class A MRPS, the Class B MRPS, the Class C MRPS, the Class D MRPS, the Class E MRPS, the Class F MRPS, the Class
G MRPS, the Class H MRPS, the Class I MRPS and the Class J MRPS are each hereinafter referred to as a "Class of MRPS");
while they are all hereinafter collectively referred to as "MRPS"; the MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter
referred to individually as a "Share" and collectively as the "Shares”.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member decided to amend article 5.5 and 5.6 of the Company’s articles of incorporation as follow:
5.5. (iii) “the redemption price of each share in a Class of MRPS redeemed will be equal to the face value of the
redeemed MRPS increased by the share premium (if any) attached to the relevant Class of MRPS and that is attributable
to the MRPS so redeemed.”
5.6. “All MRPS are issued in the form of convertible shares either into Ordinary Shares or into any other Class of
MRPS. MRPS may be converted pursuant to the following terms and conditions:
(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of MRPS may at any time before such date,
request (in one or several occasions) in writing to convert either into Ordinary Shares or into any other Class of MRPS
all or part of the MRPS;
(ii) the conversion price of the MRPS to be converted will be equal to the face value of such MRPS increased by the
share premium (if any) attached to the relevant Class of MRPS to which the MRPS belongs and that is attributable to the
MRPS being converted and which is not returned to the holder as partial consideration for the conversion (the “Con-
version Price”);
(iii) the number of Ordinary Shares to be issued upon such conversion of MRPS into Ordinary Shares will be equal to
the Conversion Price divided by the estimated fair market value, as reasonably determined by the board of managers of
the Corporation, of an Ordinary Share on the conversion date;
(iv) the number of MRPS to be issued upon such conversion of MRPS into any other Class of MRPS will, to the extent
that such other Class of MRPS has issued and outstanding Shares immediately preceding the conversion time, be equal
to the Conversion Price divided by the estimated fair market value, as reasonably determined by the board of managers
99705
L
U X E M B O U R G
of the Corporation, of a Share of the other Class of the MRPS on the conversion date. In any other case, each MRPS to
be converted shall be converted into one Share of the other Class of MRPS.
(v) no decimal of Shares will be available on conversion. The board of managers of the Corporation may (in the case
of decimals) either round up or round down to the closest appropriate number of Shares; and
(vi) the share premium (if any) attached to the converted Class of MRPS and that is attributable to the MRPS so
converted, will, except to the extent that the MRPS holder requests to have all or a portion of such share premium
returned to the holder as partial consideration for the conversion of MRPS, be allocated to the share premium of the
Ordinary Shares or to the share premium of the relevant Class of MRPS into which the relevant MRPS have been con-
verted.
Converted MRPS will be cancelled forthwith after conversion.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Member decided to amend article 17.2 of the Company’s articles of incorporation as follow:
17.2. “Out of the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account.
This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Corporation.
The general meeting of the Sole Member, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the board of managers of the Corporation,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by a resolution of either the sole member or the board of managers,
and
4. The payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors
of the Corporation are not threatened.”
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Member decided to amend article 18 of the Company’s articles of incorporation as follow:
“ Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 The dissolution of the Corporation can only be decided by the Sole Member under the voting conditions of article
199 of the Law for the amendment of articles of incorporation and under the cumulative condition that a positive vote
of the Ordinary Shares and a positive vote of the MRPS have been given for each class of shares according to the voting
conditions of the above-mentioned article 199 of the Law.
18.2 In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the Sole Member effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
18.3 The power to amend these articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the
Sole Member.
18.4 The power of the board of managers of the Corporation will end upon the appointment of the liquidator(s). After
the payment of all debts and liabilities of the Corporation or deposit of any funds to that effect, the remaining available
amount will be paid first in priority to the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares according to the par value
of such Shares and the share premium if any attached to each Mandatory Redeemable Preferred Shares. Holder of
Ordinary Shares will then be entitled to the remaining available amount (if any) on a pro rata basis (according to the
number of Ordinary Shares held in the Corporation’s capital by the holder of such Ordinary Shares).”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about six thousand four hundred thirty-five
Euro (EUR 6,435.-).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
99706
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le quinze juin.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TDL Luxembourg Ltd., une société constituée et organisée sous le droit canadien, ayant son siège social situé à 2500,
700-9
th
Avenue SW, Calgary, Alberta, Canada T2P 3V4, Alberta, enregistrée auprès du registre des sociétés d’Alberta,
Canada, sous le numéro 2015998178, agissant par le biais de sa succursale luxembourgeoise TDL, Luxembourg Branch,
ayant son siège social situé au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.551 (ci-après «l’Associé Unique»);
dûment représentée par Maître Vanessa Morolli, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20,
avenue Marie-Thérèse, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 15 juin 2011.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, agissant ès-qualité, a déclaré et demandé au notaire:
I. d’acter que TDL Luxembourg Ltd, agissant par le biais de sa succursale luxembourgeoise, TDL, Luxembourg Branch
est l’Associé Unique de TDL Financing Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B160.656, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
le 20 avril 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).
II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l’intérêt de la Société, conformément à l’agenda ci-
dessous:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 5.220.000,- (cinq millions deux
cent vingt mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 20.000,- (vingt mille dollars américains)
représenté par 20 (vingt) parts sociales ordinaires sans mention de valeur nominale, à un montant de USD 5.240.000,-
(cinq millions deux cent quarante mille dollars américains) par l’émission de 5.220 (cinq mille deux cent vingt) parts
privilégiées obligatoirement rachetables catégorie A sans mention de valeur nominale avec le paiement d’une prime
d’émission attachée aux parts privilégiées obligatoirement rachetables catégorie A d’un montant de USD 516.101.574,66
(cinq cent seize millions cent un mille cinq cent soixante-quatorze dollars américains et soixante-six cents) ainsi que
l’allocation d’un montant de USD 522.000,- (cinq cent vingt-deux mille dollars américains) à la réserve légale de la Société;
2. Souscription et libération par l’Associé Unique de toutes les nouvelles parts privilégiées obligatoirement rachetables
catégorie A avec le paiement d’une prime d’émission attachée aux parts privilégiées obligatoirement rachetables catégorie
A d’un montant de USD 516.101.574,66 (cinq cent seize millions cent un mille cinq cent soixante-quatorze dollars amé-
ricains et soixante-six cents) ainsi que l’allocation d’un montant de USD 522.000,- (cinq cent vingt-deux mille dollars
américains) à la réserve légale de la Société par l’apport en nature des droits à recevoir;
3. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l’augmentation planifiée du capital social de la
Société;
4. Modification des articles 5.5 (iii); 5.6. des statuts de la Société;
5. Modification de l’article 17.2 des statuts de la Société;
6. Modification de l’article 18 des statuts de la Société; et
7. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d’un montant de USD 5.220.000,- (cinq millions
deux cent vingt mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 20.000,- (vingt mille dollars
américains) à un montant de USD 5.240.000,- (cinq millions deux cent quarante mille dollars américains) représenté par
les parts sociales ordinaires existantes et par l’émission de 5.220 (cinq mille deux cent vingt) parts privilégiées obligatoi-
rement rachetables catégorie A sans mention de valeur nominale, ensemble avec le paiement d’une prime d’émission
attachée aux parts privilégiées obligatoirement rachetables catégorie A d’un montant de USD 516.101.574,66 (cinq cent
seize millions cent un mille cinq cent soixante-quatorze dollars américains et soixante-six cents) et l’allocation d’un mon-
tant de USD 522.000,- (cinq cent vingt-deux mille dollars américains) à la réserve légale de la Société, le montant total
étant payé par l’apport en nature des droits à recevoir ci-dessous décrits.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé d’émettre 5.220 (cinq mille deux cent vingt) parts privilégiées obligatoirement rachetables
catégorie A sans mention de valeur nominale, ensemble avec le paiement d’une prime d’émission attachée aux parts
privilégiées obligatoirement rachetables catégorie A de USD 516.101.574,66 (cinq cent seize millions cent un mille cinq
99707
L
U X E M B O U R G
cent soixante-quatorze dollars américains et soixante-six cents) et d’allouer un montant de USD 522.000,- (cinq cent
vingt-deux mille dollars américains) à la réserve légale de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes M
e
Vanessa Morolli, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’Associé Unique,
en vertu d’une procuration donnée le 15 juin 2011 qui restera annexée aux présentes.
La partie comparante a déclaré:
- souscrire et libérer en totalité 5.220 (cinq mille deux cent vingt) parts privilégiées obligatoirement rachetables de
catégorie A sans mention de valeur nominale, pour un montant total de USD 5.220.000, (cinq millions deux cent vingt
mille dollars américains);
- payer une prime d’émission rattachée aux parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie A d’un montant
de USD 516.101.574,66 (cinq cent seize millions cent un mille cinq cent soixante-quatorze dollars américains et soixante-
six cents);
- allouer à la réserve légale de la Société un montant de USD 522.000,- (cinq cent vingt-deux mille US dollars).
par l’apport en nature de droits à recevoir, à l’exclusion de tout actif immobilier, d’un montant total de USD
521.843.574,66 (cinq cent vingt et un millions huit cent quarante-trois mille cinq cent soixante-quatorze dollars américains
et soixante-six cents) (ci-après les «Droits»).
<i>Description de l’apporti>
La partie comparante a déclaré que:
L’apport en nature a consisté en la pleine propriété des Droits, à l’exclusion de tout actif immobilier, pour un montant
total de USD 521.843.574,66 (cinq cent vingt et un millions huit cent quarante-trois mille cinq cent soixante-quatorze
dollars américains et soixante-six cents), ces Droits ayant été évalués par le conseil de gérance de la Société à un montant
de USD 521.843.574,66 (cinq cent vingt et un millions huit cent quarante-trois mille cinq cent soixante-quatorze dollars
américains et soixante-six cents) sur la base d’une évaluation émise par l’Associé Unique, détenteur des Droits.
<i>Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport:i>
Preuve de la propriété et de la valeur des Droits a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Intervention du conseil de gérance:i>
Est alors intervenue M
e
Vanessa Morolli, en sa qualité de mandataire spécial du conseil de gérance de la Société, en
présentant une confirmation écrite émise par les gérants de la Société dûment autorisés par le conseil de gérance ayant
approuvé l'évaluation décrite ci-dessus.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des déclarations et des résolutions qui ont précédé, l’apport ayant été accompli, l’Associé Unique a
décidé de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société comme suit:
5.1. «Le capital social est fixé à cinq millions deux cents quarante mille dollars américains (USD 5.240.000,-) représenté
par vingt (20) parts ordinaires (ci-après les "Parts Ordinaires") et cinq mille deux cents vingt (5.220) parts privilégiées
obligatoirement rachetables de catégorie A (ci-après les «PPOR de catégorie A»). La Société peut également émettre en
plus des Parts Ordinaires des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie B (ci-après les "PPOR de caté-
gorie B",) des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie C (ci-après les "PPOR de catégorie C"), des
parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie D (ci-après les "PPOR de catégorie D"), des parts privilégiées
obligatoirement rachetables de catégorie E (ci-après les "PPOR de catégorie E"), des parts privilégiées obligatoirement
rachetables de catégorie F (ci-après les "PPOR de catégorie F"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de
catégorie G (ci-après les "PPOR de catégorie G"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie H (ci-
après les "PPOR de catégorie H"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie I (ci-après les "PPOR
de catégorie I"), des parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie J (ci-après les "PPOR de catégorie J"), (les
PPOR de catégorie A, les PPOR de catégorie B, les PPOR de catégorie C, les PPOR de catégorie D, les PPOR de catégorie
E, les PPOR de catégorie F, les PPOR de catégorie G, les PPOR de catégorie H, les PPOR de catégorie I et les PPOR de
catégorie J) sont ci-après individuellement désignées comme une "Catégorie de PPOR" et collectivement comme les
"PPOR"; les PPOR et les Parts Ordinaires sont ci-après individuellement désignées comme une "Part" et collectivement
comme les "Parts".
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de modifier les articles 5.5 et 5.6 des statuts de la Société comme suit:
99708
L
U X E M B O U R G
5.5. (iii) «le prix de rachat de chaque part dans une Catégorie de PPOR rachetée sera égal à la valeur nominale des
PPOR rachetées majoré par la prime d'émission (le cas échéant) attachée à cette catégorie de PPOR et qui est attribuable
aux PPOR ainsi rachetées.»
5.6. «Toutes les PPOR sont émises sous la forme de parts convertibles soit en Parts Ordinaires soit en toute autre
catégorie de PPOR. Les PPOR pourront être converties conformément aux conditions et modalités suivantes:
(i) nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, le détenteur de PPOR peut à tout moment avant cette date,
demander (en une ou plusieurs fois) par écrit la conversion de certaines ou de toutes les PPOR en Parts Ordinaires ou
en toute autre Catégorie de PPOR.
(ii) le prix de conversion des PPOR convertibles sera égal à la valeur nominale de chaque PPOR majoré par la prime
d’émission (le cas échéant) attachée à la catégorie de PPOR concernée à laquelle les PPOR appartiennent et qui est
applicable aux PPOR converties et qui ne sont pas restituées au détenteur à titre de paiement partiel pour la conversion
(le «Prix de Conversion»);
(iii) Le nombre de Parts Ordinaires émis suite à la conversion de PPOR en Parts Ordinaires sera égal au Prix de
Conversion divisé par la juste valeur marchande, d’une Part Ordinaire à la date de la conversion, comme raisonnablement
déterminée par le conseil de gérance de la Société;
(iv) le nombre de PPOR émis suite à la conversion de PPOR en Parts Ordinaires ou en toute autre Catégorie de PPOR,
dans la limite ou une telle Catégorie de PPOR a émis et circulé des Parts immédiatement avant la conversion, sera égal
au Prix de Conversion divisé par la juste valeur marchande, comme raisonnablement déterminé par le conseil de gérance
de la Société, d’une Part d’une autre Catégorie de PPOR au jour de la conversion. Dans tout autre cas, chaque PPOR
convertible devra être converti en une Part d’une autre Catégorie de PPPOR.».
(v) Aucun rompu de Parts ne sera permis lors de la conversion. Le conseil de gérance de la Société pourra (en cas de
décimal) soit arrondir à la hausse ou à la baisse au plus près du nombre approprié de Parts; et
(vi) La prime d’émission (le cas échéant) attachée à la Classe de PPOR convertie et qui est attribuable aux PPOR ainsi
converties, sera, excepté dans la mesure où le détenteur des PPOR demande une partie ou la totalité d’une telle prime
d’émission lui soit restituée à titre de rémunération partielle pour la conversion des PPOR, allouée à la prime d’émission
de Parts Ordinaire ou à la prime d’émission de la Catégorie de PPOR concernée dans laquelle les PPOR concernées ont
été converties.
Les PPOR seront annulées immédiatement à l'issue de leur conversion.”
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 17.2 des statuts de la Société comme suit:
17.2. Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation
cessera d’être requise dès que le montant de la réserve légale s’élèvera à dix pourcent (10%) du capital social émis de la
Société. L’assemblée générale de l’Associé Unique, sur recommandation du conseil de gérance déterminera l’allocation
des bénéfices annuels nets.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance de la Société,
2. Ces comptes montrent un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
3. La décision de payer un dividende intérimaire est prise par une résolution de l’assemblée générale de l’Associé
Unique ou le conseil de gérance, et
4. Le paiement sera effectué une fois que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants
de la Société ne sont pas menacés.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de modifier l’article 18 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 18. Dissolution et Liquidation.
18.1 La dissolution de la Société peut être décidée uniquement par l’Associé Unique aux conditions de vote prévues
par l’article 199 de la Loi relatif à la modifications de statuts et sous les conditions cumulatives qu’un vote positif des Parts
Ordinaires et un vote positif des PPOR aient été donné pour chaque classe de parts conformément aux conditions de
vote de l’article 199 de Loi ci-avant mentionné.
18.2 En cas de la dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront
être des personnes physiques ou morales), nommé(s) par l’Associé Unique, décidant une telle dissolution et qui déter-
minera leurs pouvoirs et rémunérations.
18.3 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de
l’Associé Unique.
18.4 Les pouvoirs du conseil de gérance de la Société cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le
paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cet effet, le montant
restant sera payé en priorité au détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables en fonction de la valeur
99709
L
U X E M B O U R G
nominale de ces Parts augmenté par le montant des dividendes accumulés et non payés le cas échéant et de la prime
d’émission le cas échéant attachée à chaque Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables au prorata du nombre de
Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables qu’il détient dans le capital social de la Société. Le détenteur d’Actions
Ordinaires sera autorisé à recevoir le cas échéant le montant restant au pro rata (en vertu du nombre de Parts Ordinaires
détenus dans le capital social de la Société par le détenteur de telles Parts Ordinaires)»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
six mille quatre cent trente-cinq euros (EUR 6.435,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n’ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom,
nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: MOROLLI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 22 juin 2011. REM 2011 / 805. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Mondorf-les-Bains, le 5 juillet 2011.
Référence de publication: 2011093043/365.
(110105301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.
Mercury Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 24.323.
Les documents de clôture de l'année 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch.
<i>Pour MERCURY PROPERTIES S.A.
i>AREND CONSULT S.A R.L., MERSCH
Signature
Référence de publication: 2011098547/13.
(110111475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Kravid S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 55.402.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098476/9.
(110112277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
KSM Participations Mobilières et Immobilières S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 94.138.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098477/9.
(110112504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
99710
L
U X E M B O U R G
KWISTUM Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098478/11.
(110111583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Finathem Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 102.126.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Sociétéi>
<i>tenue au siège social de la Société le 30 juin 2011i>
Lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 30 juin 2011, il a été décidé de:
1. réélire, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en l'année 2012 pour statuer sur l'approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2011, les administrateurs de la Société, à savoir:
- Mr. Vincent GOY, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Mr. Olivier GUYOT, demeurant au 15, rue de la Pompe, F-75016, Paris;
- Mr. Jean-Daniel CAMUS, demeurant au 40, rue Barbet de Jouy, F-75007 Paris
- Mr. Bertrand HAINGUERLOT, demeurant au 37, rue de Babylone, F-75007 Paris, et
- Mr. Alain COCHENET, demeurant au 1, allée de la Comtesse de Ségur, F- 94420 Le Plessis Trévise.
2. réélire PricewaterhouseCoopers S.à r.l., société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 400, rue
d'Esch, L-1014 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 65.477, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se
tenir en l'année 2012 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011102195/25.
(110114897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
JP Commercial XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 161.882.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
The company Jargonnant Partners S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office at
6, rue Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
section B, number 78 830,
duly represented by Ms. Diane Wolf, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
on the 24
th
of June 2011, hereto attached. Such appearing party, represented as here above stated, has requested the
99711
L
U X E M B O U R G
undersigned notary to state the articles of association of a private limited company ("société à responsabilité limitée")
governed by the relevant laws and the present articles:
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a
company in form of a Gesellschaft mit begrenzter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the
Companies' Act of August 10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of "JP Com-
mercial XI S.à r.l.".
Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Lu-
xembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of the
manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager
(s).
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will be made
and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under
the given circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate
located in Luxembourg or abroad.
The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches,
as well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion,
sale and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnership or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Title II. Capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by ten thousand
(10,000) shares with a par value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, which have been fully subscribed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of
the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority
consent of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change
the nationality of the company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The members may also take resolutions in writing without meeting if there are twenty-five (25) members or less.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner
or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
99712
L
U X E M B O U R G
Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes
or drawn-up in writing.
Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members
representing at least three quarters (3/4) of the company's share capital.
In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets
or documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.
Title III. Administration and Audit
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines
their powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are
appointed.
The managers may be removed without cause.
Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who needs
not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of the members.
The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of
the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, telegram
or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the managers.
Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by e-mail, telegram or telefax another
manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram or telefax.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those
reserved by law to be decided upon by the members.
Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. Each manager may confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers, appoint
and dismiss all officers and employees, and fix their remuneration.
Art. 16. The company will be bound by the signature of two managers or by any person(s) to whom power has been
delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the
company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.
Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December
31st of the same year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual accounts and
in general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit and loss
account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the
net profit of the company.
Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but
will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this
threshold is not met anymore.
The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual
net profits will be disposed of.
99713
L
U X E M B O U R G
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).
Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent auditors.
The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall determine
their number, remuneration and term of office.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the
shares they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Subscriptioni>
The ten thousand (10,000) shares have been fully paid-in by Jargonnant Partners S.à r.l., pre-named, so that the amount
of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the company, as was certified to the notary
executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>General meeting of the memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital represented
as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at three (3).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today for an unlimited period:
- Hubert Hansen, 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxembourg, born 17.10.1951 in Ettelbrück, licencé en droit
- Lothar Rafalski, 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxembourg, born 29.11.1952 in Hamburg, Senior Consultant
- Daniel Schulenburg, professionally residing at Stollbergstr. 11, 80539 Munich, Germany, born 27.01.1961 in Algier,
Merchant.
3) The registered office of the Company is in 1417 Luxembourg, 6 rue Dicks, Luxembourg.
4) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2011.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
this deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausend und elf, am achtundzwanzigsten Juni,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
99714
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft Jargonnant Partners S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, rue
Dicks, 1417 Luxembourg, Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg, unter der Sek-
tion B, Nummer 78830,
hier vertreten durch Frau Diane Wolf, Privatangestellte, geschäftlich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 24. Juni 2011, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung unterliegt, zu beurkunden.
Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, die später Gesellschafter der Gesellschaft wer-
den, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem derzeitig geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und der folgenden
Satzung unterliegt und die Bezeichnung "JP Commercial XI S.à r.l." trägt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg).
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung einer Verlegung
an Dritte hat durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, das unter den gegebenen Umständen hierzu am besten in
der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über Im-
mobilien in Luxemburg oder im Ausland.
Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften und
Niederlassungen sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb, die Ent-
wicklung, die Förderung, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in Eigentum,
Eigentumsrechten und Einrichtungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die
der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann zudem als Komplementär oder Kommanditist mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung
für alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung
ihres Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.
Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingeteilt in zehntau-
send (10.000) Gesellschaftsanteile zu je einem Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), die vollständig einbezahlt wurden.
Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-
schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte
der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafter-
versammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters
oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-
undzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter besitzt.
99715
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen. Falls ein Geschäftsanteil im Besitz
von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuld-
ner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der Ge-
sellschaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, die im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Pro-
tokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesell-
schaftern übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der
Zustimmung der Gesellschafter, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren.
In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-
lebenden Lebenspartner erfolgt.
Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur
Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-
sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.
Titel III- Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, die Vergütung und die Dauer des Mandats der Geschäfts-
führer, wobei diese ihr Amt solange ausüben, bis ein Nachfolger bestimmt wurde.
Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Aufzeichnung
der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar
an dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, in
denen die Art der Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann durch die schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder Fax erteilte Zustimmung eines jeden
Geschäftsführers verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen,
die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die aus einem Zeitplan hervorgehen, der vorher durch einen Geschäfts-
führungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per e-mail, Telegramm
oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder Fax durchgeführt werden.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des
Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.
99716
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden.
Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vor-
sitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung jeg-
liche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, die nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss, übertragen,
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Vergütung festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift jeder in
Übereinstimmung mit dem Artikel 15 bevollmächtigten Person verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den
Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der
Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.
Das Guthaben der Gewinn- und Verlustbilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-
visionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5 % (fünf Prozent)
zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn
die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10 % (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt
aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen
auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über
die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde gegebenenfalls von dem Wirtschaftsprüfer geprüft;
4. Dieser Zwischenabschluss weist ausreichend Gewinne auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der an-
deren freien Reserven;
5. Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren, wird durch die Geschäftsführung getroffen.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unab-
hängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung einer
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die
natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über
diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu den Ge-
schäftsanteilen, die sie halten, zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung.
Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern
oder zwischen dem/den Geschäftsführer(n) und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes ("arbitrage“) gemäß der Zivilprozessordnung.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.
<i>Zeichnungi>
Die zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch Jargonnant Partners S.à r.l., vor-
benannt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht,
wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
99717
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer
Gründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, der das gesamte Stammkapital vertritt,
vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste folgende Beschlüsse:
1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen.
2) Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tage zu Geschäftsführern auf unbegrenzte Dauer
ernannt:
- Hubert Hansen, wohnhaft 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxemburg, geboren am 17.10.1951 in Ettelbrück,
licencé en droit
- Lothar Rafalski, wohnhaft 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxemburg, geboren am 29.11.1952 in Hamburg, Senior
Consultant
- Daniel Schulenburg, geschäftsansässig Stollbergstraße 11, 80539 München, Deutschland, geboren am 27.01.1961 in
Algier, Kaufmann.
3) Der Sitz der Gesellschaft ist in 1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, Luxemburg.
4) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-
zember 2011.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat dieser zusammen mit dem Notar die
vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: D. WOLF und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juillet 2011. Relation: LAC/2011/29916. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 6. Juli 2011.
Référence de publication: 2011094590/368.
(110106546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Laboratoire de Biotechnologie du Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-3505 Dudelange, 6, rue Dominique Lang.
R.C.S. Luxembourg B 105.350.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098480/9.
(110111412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Iona Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 11.100,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.103.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Iona Holdings, LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware, United States of
America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 8042365,
99718
L
U X E M B O U R G
here represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, having her professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on
June 17, 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name of “Iona Management S.à r.l.” (the Company), having its
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154103, established by a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, dated June 15, 2010 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1634 of August 12, 2010, and whose bylaws have not been amended since the incorporation.
II. The Company's share capital is fixed at eleven thousand one hundred British Pounds (GBP 11.100,00), represented
by eleven thousand one hundred (11,100) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, all of which
are fully paid up.
III. The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.
IV. The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated
dissolution of the Company.
V. The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares waiving the appointment of a
liquidator to carry out the anticipated dissolution as per article 29 of the Company's articles and embodying this role.
VI. The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have
been settled or provisioned.
VII. The appearing person, as the sole shareholder of the Company, expressly declares that it assumes all the respon-
sibilities and debts of the Company.
VIII. The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to its sole shareholder at
their net book value, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually
unknown, in the same way as the latter was liable; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.
IX. The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of
today.
X. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five (5) years at
the Company's former registered office.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present dissolution are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above,
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his full
name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille onze, le vingt juin.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch sur Alzette, Grand Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Iona Holdings, LLC, une limited liability company de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son
siège social sis au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, Etats Unis d'Amérique,
enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 8042365,
ici représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le
17 juin 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
99719
L
U X E M B O U R G
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand Duché de Luxembourg sous
la dénomination «Iona Management S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
154103, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1634 du 12 août 2010, et dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis la constitution.
II. Le capital social de la Société est fixé à onze mille cent livres sterling (GBP 11.100,00), représenté par onze mille
cent (11.100) parts sociales intégralement libérées d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,00) chacune.
III. Le comparant est actuellement propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la Société.
IV. Par la présente, le comparant, en sa qualité de seul associé de la Société, prononce la dissolution anticipée de la
Société avec effet immédiat.
V. Le comparant, en sa qualité de seul associé de la Société, déclare renoncer à la nomination d'un liquidateur en vue
de la dissolution anticipée de la Société suivant l'article 29 des statuts de la Société et prendre cette position à son compte.
VI. Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société est apuré ou
provisionné.
VII. Le comparant, en sa qualité de seul associé de la Société, déclare assumer les responsabilités et les dettes de la
Société.
VIII. L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif à sa valeur nette comptable et il répondra
personnellement de tous les engagements de la Société, même inconnus à l'heure actuelle, de la même manière que celle-
ci y était tenue; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
IX. L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.
X. Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à l'ancien siège social
de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme mille deux cents euros (€ 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch sur Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 juin 2011. Relation: EAC/2011/8548. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011098433/106.
(110111548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Seamer Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.451.589,96.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.331.
Veuillez prendre le note du changement de dénomination et adresse des associés suivantes, à partir du 11 juillet 2011:
Candover 2001 UK No 1 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 UK No 1 L.P., imma-
triculé sous le numéro LP7641 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré
au 12 Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 UK No 2 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 UK No 2 L.P., imma-
triculé sous le numéro LP7642 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré
au 12 Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 UK No 3 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 UK No 3 L.P., imma-
triculé sous le numéro LP7654 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré
au 12 Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
99720
L
U X E M B O U R G
Candover 2001 UK No 4 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 UK No 4 L.P., imma-
triculé sous le numéro LP7755 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré
au 12 Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 UK No 5 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 UK No 5 L.P., imma-
triculé sous le numéro LP7756 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré
au 12 Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 UK No 6 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 UK No 6 L.P., imma-
triculé sous le numéro LP7942 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré
au 12 Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 US No 1 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 US No 1 L.P., immatriculé
sous le numéro LP7643 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré au 12
Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 US No 2 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 US No 2 L.P., immatriculé
sous le numéro LP7644 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré au 12
Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 US No 3 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 US No 3 L.P., immatriculé
sous le numéro LP7645 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré au 12
Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Candover 2001 US No 4 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 US No 4 L.P., immatriculé
sous le numéro LP7795 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré au 12
Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni
Candover 2001 US No 5 LP devient Arle Capital Partners Limited on behalf of Candover 2001 US No 5 L.P., immatriculé
sous le numéro LP7949 auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et Pays des Galles, et son siège est transféré au 12
Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SEAMER HOLDING S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant B
i>Signatures
Référence de publication: 2011103054/47.
(110116053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2011.
L Multi Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 83.343.
In the year two thousand eleven, on the thirtieth of June.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of L Multi Select (the "Company”), a public limited company
(société anonyme), qualifying as an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital
variable), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 83.343, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in
Luxembourg, on August 16, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) N
° 776 of September 18, 2001. The articles of incorporation have been amended for the last time on November 28, 2008
by a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing then in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), and
were published in the Mémorial, number 16 of 6 January 2009.
The meeting was opened at 5.00 p.m. under the chairmanship of Mrs Michèle Kemp, avocat, residing professionally in
Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Marie-Laure Martinet, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Xavier Rouvière, maître en droit, residing professionally in Luxembourg,
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. -The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Approval of the explanatory report in relation to the contemplated merger by absorption (the “Merger”) whereby
“L Multi Select - L Multi Select US Equity Fund” and “L Multi Select - L Multi Select European Equity Fund”, the two
remaining sub-funds of the Company (hereafter the “Absorbed Sub-Funds”), will be respectively merged into the two
99721
L
U X E M B O U R G
sub-funds “HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity” and “HSBC International Select Fund –
MultiAlpha Europe Equity”, (hereafter the “Absorbing Sub-Funds”) of HSBC International Select Fund, a société d'inves-
tissement à capital variable, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 84.174 (the “Absorbing Company”).
2. Approval of the report of the independent expert on the terms of the Merger.
3. Approval of the Merger and of the content of the common merger plan (the “Common Merger Plan”).
4. Dissolution of the Company without liquidation by contribution of all its assets and liabilities to the Absorbing
Company.
5. Approval of the financial statements of the Company from 1 January 2011 to 29 June 2011.
6. Termination of the mandate of the directors of the Company as of the date where the Merger will become effective
among the Company and the Absorbing Company and discharge to be granted to the directors of the Company for their
office.
7. Decision to terminate the mandate of the auditor of the Company as of the date where the Merger will become
effective among the Company and the Absorbing Company and discharge to be granted to the auditor of the Company
for its office.
8. Miscellaneous.
II. - The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders
represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled «ne varietur» by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.
III. - The quorum of at least fifty per cent (50%) of the issued capital of the Company is required by Article 67-1 (2)
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”) and the resolution on each item
of the agenda, has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast in the Company.
All the shares being registered shares, convening notices have been sent by registered mail to each registered share-
holder on 30 May 2011.
IV. - Pursuant to the attendance list, five (5) shareholders, holding together four hundred twenty-three thousand eight
hundred fifty-six (423,856) shares out of seven hundred fifty-six thousand seven hundred thirty-nine (756,739) issued
shares, that is to say approximately fifty-six (56%) per cent of the issued shares, are present or represented.
V. - That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
VI. - That the Common Merger Plan has been drawn-up pursuant to a deed of the undersigned notary on 20 May 2011
in compliance with Article 271 of the 1915 Law under the terms of which the Company will be absorbed by HSBC
International Select Fund, a société d'investissement à capital variable, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 84.174, incorpo-
rated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on 26 October 2001, published in the
Mémorial N° 1031 of 19 November 2001 and which have been amended for the last time on 31 July 2009 by a notarial
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial,
number 1987 of 12 October 2009 (hereafter the “Absorbing Company”).
VII. -That the Common Merger Plan has been published, in compliance with Article 262 of the 1915 Law, in the
Mémorial of 30 May 2011.
VIII. - That the Common Merger Plan did not mention the existence of the class I EUR shares of the sub-fund L Multi
Select – L Multi Select European Equity Fund and in particular the following information:
- the exchange ratio in respect of the class I shares EUR of the L Multi Select – L Multi Select European Equity Fund
will be determined by dividing the net asset value per class I share EUR calculated on 29 June 2011 in this subfund by the
net asset value per share of the class I shares (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe
Equity;
- the net asset value per class I share (EUR) of the HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity (“Ab-
sorbing Sub-Fund”) will be calculated in EUR in the same manner as the net asset value per class I share EUR of the L
Multi Select – L Multi Select European Equity Fund (“Absorbed Sub-Fund”). No exchange rate shall consequently need
to be applied in order to calculate the number of the class I shares (EUR) of the Absorbing Sub-Fund to be issued on 30
June 2011, the effective date of the Merger, in exchange for the existing class I shares EUR of the Absorbed Sub-Fund.
This information has however been reflected in detail in (i) the notice to shareholders of the Company, (ii) the ex-
planatory reports drawn up by the board of directors of the Company and the Absorbing Company and (iii) the convening
notices to the present meeting sent by registered mail to each registered shareholder on 30 May 2011.
IX. - The extraordinary general meeting of the shareholders acknowledges the deposit at the registered office of the
Company of the documents provided for by article 267 of the 1915 Law, one month before the present meeting.
99722
L
U X E M B O U R G
After deliberation, the general meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting approves the terms of the explanatory report drawn-up and issued in compliance with article
265 of the 1915 Law by the board of directors of the Company (the “Board of Directors”) on 30 May 2011 setting out
the legal and economic explanations for the Merger between the Company, as absorbed company, and HSBC International
Select Fund, as absorbing company and in particular the exchange ratios.
A copy of the explanatory report of the Board of Directors will remain annexed to the present deed.
<i>Second resolutioni>
The general meeting approves the terms of the report drawn-up and issued on May 30,2011 by Pricewaterhouse-
Coopers S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 65.477, acting as the independent expert
on the terms of the Merger.
The report of the independent expert will remain annexed to the present deed.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to approve the Merger pursuant to the terms of the Common Merger Plan published in
the Mémorial of 30 May 2011, which have been duly completed by the additional information reflected in (i) the notice
to shareholders of the Company, (ii) the explanatory reports drawn up by the board of directors of the Company and
the Absorbing Company and (iii) the convening notices to the present meeting sent by registered mail to each registered
shareholder on 30 May 2011, as drawn-up by the Company together with the Absorbing Company, in particular:
- the exchange ratio of one (1) class A share EUR of the L Multi Select – L Multi Select European Equity Fund for
6.395547 class A share(s) (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity, resulting
from the division of the net asset value per class A share EUR calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset
value per share of the class A shares (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
- the exchange ratio of one (1) class A share USD of the L Multi Select – L Multi Select European Equity Fund for
6.395547 class A share(s) (USD) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity, resulting
from the division of the net asset value per class A share USD calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset
value per share of the class A shares (USD) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
- the exchange ratio of one (1) class I share EUR of the L Multi Select – L Multi Select European Equity Fund for
6.868714 class I share(s) (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity, resulting
from the division of the net asset value per class I share EUR calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset
value per share of the class I shares (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
- the exchange ratio of one (1) class A share EUR of the L Multi Select – L Multi Select US Equity Fund for 5.327331
class A share(s) (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity, resulting from
the division of the net asset value per class A share EUR calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset value
per share of the class A shares (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity;
- the exchange ratio of one (1) class A share USD of the L Multi Select – L Multi Select US Equity Fund for 5.327331
class A share(s) (USD) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity, resulting from
the division of the net asset value per class A share USD calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset value
per share of the class A shares (USD) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity;
- the exchange ratio of one (1) class I share EUR of the L Multi Select – L Multi Select US Equity Fund for 5.520509
class I share(s) (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity, resulting from
the division of the net asset value per class I share EUR calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset value
per share of the class I shares (EUR) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity;
- the exchange ratio of one (1) class I share USD of the L Multi Select – L Multi Select US Equity Fund for 6.183363
class I share(s) (USD) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity, resulting from
the division of the net asset value per class I share USD calculated on 29 June 2011 in this sub-fund by the net asset value
per share of the class I shares (USD) in the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity.
The general meeting further resolves to approve the ipso jure and simultaneous consequences of the Merger as
provided for under article 274 of the 1915 Law, i.e.:
a. the universal transfer, both as between the Company and the Absorbing Company and vis-à-vis third parties, of all
of the assets and liabilities of “L Multi Select -L Multi Select US Equity Fund” and “L Multi Select -L Multi Select European
Equity Fund”, the two remaining sub-funds of the Company being respectively contributed to the two sub-funds of the
Absorbing Company, i.e. “HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity” and “HSBC International
Select Fund – MultiAlpha Europe Equity”;
b. the Company shall cease to exist; and
c. the cancellation of the shares of the Company;
99723
L
U X E M B O U R G
as well as, any other consequences enumerated in the Common Merger Plan.
The general meeting further resolves to approve the allotment of 4,596,686.724 shares without nominal value, to be
newly issued by the Absorbing Company in consideration for the universal transfer of all of the assets and liabilities of
the Company to the Absorbing Company, in accordance with the share exchange ratios set forth in the Common Merger
Plan.
The 4,596,686.724 shares to be newly issued by the Absorbing Company in respect of the sub-fund HSBC International
Select Fund – MultiAlpha North America Equity and the sub-fund HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe
Equity will be registered in the register of shareholders of the Absorbing Company in the name of each registered
shareholder of the Company as of the effective date of the Merger and will be granted the same rights as for the existing
shares, in particular, a right to dividend distributions as from 30 June 2011.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting states that, by the contribution of all the assets and liabilities of the Company to HSBC Interna-
tional Select Fund with effect on 30 June 2011, the Company will cease to exist as of such date, being the effective date
of the Merger, in compliance with Article 274 of the 1915 Law.
The approval of the Merger by the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company, HSBC
International Select Fund, is not necessary to the extent that the conditions provided for by article 264 of the 1915 Law,
have been complied with; notwithstanding this fact, shareholders of HSBC International Select Fund, representing at least
five percent (5%) of the share capital, may nevertheless convene an extraordinary general meeting of shareholders to
approve the Merger as provided for by that article 264, in which case the board of directors of HSBC International Select
Fund has undertaken to inform the undersigned notary at the latest on 1 July 2011 at 6.00 p.m..
<i>Fifth resolutioni>
After having carefully reviewed the financial statements of the Company from 1 January 2011 to 29 June 2011, the
general meeting decides to approve these.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to terminate the mandate of Mrs Monique Erbeia,
Mr. Vincent de Palma, Mr. Jean-Michel Starck, as directors of the Company, as of the date where the Merger will
become effective among the Company and the Absorbing Company.
The general meeting further acknowledges the resignation of Mr. Daniel Roy, as chairman and member of the Board
of Directors with effect as of 14 May 2011 (the “Date of Resignation”).
The general meeting finally decides to grant full discharge to Mr. Daniel Roy until the Date of Resignation as well as
to Mrs Monique Erbeia, Mr. Vincent de Palma and Mr. Jean-Michel Starck for the execution of their office until the date
where the Merger will become effective among the Company and the Absorbing Company.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to terminate the mandate of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 400,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 65.477, as auditor of the Company, as of the date where the Merger will become effective
among the Company and the Absorbing Company.
The general meeting further decides to grant full discharge to PricewaterhouseCoopers S.à r.l. for the execution of
its office until the date where the Merger will become effective among the Company and the Absorbing Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares having verified the compliance with the conditions enumerated in articles 257 and
following of the 1915 Law, and states that the Merger has been decided in compliance with the provisions of the legal
requirements.
All the resolutions have been taken separately and by unanimous vote.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.
99724
L
U X E M B O U R G
Follows the French translation:
L'an deux mil onze, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de L Multi Select (la «Société»), une société
anonyme, sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, constituée et régie selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.343, constituée
suivant acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial») N°776 du 18 septembre 2001. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois le 28 novembre 2008, suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, numéro 16 du 6 janvier 2009.
L'assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Mme Michèle Kemp, avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg
qui nomme comme secrétaire Mme Marie-Laure Martinet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit M. Xavier Rouvière, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scruta-
teur.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation du rapport explicatif portant sur la fusion par absorption envisagée (la «Fusion»), par laquelle «L Multi
Select – L Multi Select US Equity Fund» et «L Multi Select – L Multi Select European Equity Fund», les deux compartiments
restants de la Société (ci-après les «Compartiments Absorbés»), seront fusionnés respectivement dans deux comparti-
ments «HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity» et «HSBC International Select Fund –
MultiAlpha Europe Equity», (ci-après les «Compartiments Absorbants»), de HSBC International Select Fund, une société
d'investissement à capital variable, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.174 (la «Société Absorbante»).
2. Approbation du rapport de l'expert indépendant sur les conditions de la Fusion.
3. Approbation de la Fusion et du contenu du projet commun de fusion (le «Projet Commun de Fusion»).
4. Dissolution de la Société sans liquidation par apport de tous ses avoirs et engagements à la Société Absorbante.
5. Approbation des états financiers de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2011 au 29 juin 2011.
6. Fin du mandat des administrateurs de la Société à partir de la date où la Fusion deviendra effective entre la Société
et la Société Absorbante et décharge à donner aux administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat.
7. Décision de mettre fin au mandat du réviseur de la Société à partir de la date où la Fusion deviendra effective entre
la Société et la Société Absorbante et décharge à donner au réviseur de la Société pour l'exécution de son mandat.
8. Divers.
II. Que les noms des actionnaires présents ou représentés par une procuration, des mandataires des actionnaires
représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence,
après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les mem-
bres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations
des actionnaires représentés, après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
III. Que le quorum requis par l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée
(la «Loi de 1915») est d'au moins cinquante pour cent (50%) du capital émis de la Société et que les résolutions sur chaque
point porté à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux-tiers (2/3) des voix valablement
exprimées de la Société.
Toutes les actions étant des actions nominatives, des avis de convocation ont été envoyés par lettre recommandée à
chaque actionnaire nominatif en date du 30 mai 2011.
IV. Qu'il apparaît de la liste de présence que cinq (5) actionnaires, détenant ensemble quatre cent vingt-trois mille huit
cent cinquante six (423.856) actions sur sept cent cinquante-six mille sept cent trente-neuf (756.739) actions émises,
c'est-à-dire approximativement cinquante-six pour cent (56 %) du capital émis de la Société sont présents ou représentés.
V. Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
VI. Que le Projet Commun de Fusion a été rédigé suivant acte du soussigné notaire en date du 20 mai 2011 confor-
mément aux dispositions de l'article 271 de la Loi de 1915, aux termes duquel la Société sera absorbée par la société
HSBC International Select Fund, une société d'investissement à capital variable, constituée et régie selon les lois du Grand-
99725
L
U X E M B O U R G
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.174,
constituée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le 26 octobre 2001, publié au
Mémorial N°1031 du 19 novembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 31 juillet 2009, suivant
acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial,
numéro 1987 du 12 octobre 2009 (la «Société Absorbante»).
VII. Que le Projet Commun de Fusion a été publié, conformément aux dispositions de l'article 262 de la Loi de 1915,
au Mémorial du 30 mai 2011.
VIII. Que le Projet Commun de Fusion ne mentionnait pas l'existence de la classe I EUR du compartiment L Multi
Select – L Multi Select European Equity Fund et plus particulièrement les informations suivantes:
- le rapport d'échange d'une action de classe I EUR du compartiment L Multi Select – L Multi Select European Equity
Fund résultera de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe I EUR calculée le 29 juin 2011 dans ce
compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe I (EUR) dans le compartiment HSBC International
Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
- la valeur nette d'inventaire par action de classe I (EUR) de HSBC International Select Fund – MultiAlpha Europe Equity
(«Compartiment Absorbant») sera calculée en EUR, de la même manière que la valeur nette d'inventaire par action de
classe I EUR de L Multi Select – L Multi Select European Equity Fund («Compartiment Absorbé»). Par conséquent, aucun
taux de change ne devra être appliqué pour calculer le nombre d'actions de classe I (EUR) du Compartiment Absorbant
à émettre le 30 juin 2011, date effective de la Fusion, en échange des actions de classe I EUR existantes du Compartiment
Absorbé.
Ces informations ont été néanmoins toutes reprises en détail dans (i) l'avis aux actionnaires de la Société, (ii) les
rapports explicatifs établis par le conseil d'administration de la Société et de la Société Absorbante et (iii) les avis de
convocation à la présente assemblée envoyés par lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif en date du 30 mai
2011.
IX. Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend acte du dépôt au siège social de la Société des
documents prévus à l'article 267 de la Loi de 1915, un mois avant la présente assemblée.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale approuve les termes du rapport explicatif établi et émis conformément à l'article 265 de la Loi
de 1915 par le conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») le 30 mai 2011 expliquant et justifiant
juridiquement et économiquement la Fusion par absorption entre la Société, en tant que société absorbée, et HSBC
International Select Fund, en tant que société absorbante et en particulier les rapports d'échange.
Une copie du rapport explicatif du Conseil d'Administration restera annexée au présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale approuve les termes du rapport établi et émis le 30 mai 2011 par PricewaterhouseCoopers S.à
r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, agissant en qualité d'expert indépendant aux
termes de la Fusion.
Le rapport de l'expert indépendant restera annexé au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'approuver la Fusion conformément aux termes du Projet Commun de Fusion publié au
Mémorial du 30 mai 2011, qui ont été dûment complétés par des informations supplémentaires reflétées dans (i) l'avis
aux actionnaires de la Société, (ii) les rapports explicatifs établis par le conseil d'administration de la Société et de la
Société Absorbante et (iii) les avis de convocation à la présente assemblée envoyés par lettre recommandée à chaque
actionnaire nominatif en date du 30 mai 2011, tel qu'établi conjointement par la Société et la Société Absorbante, et en
particulier:
- le rapport d'échange de une (1) action de classe A EUR du compartiment L Multi Select – L Multi Select European
Equity Fund pour 6,395547 action(s) de classe A (EUR) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha
Europe Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe A EUR calculée le 29 juin 2011
dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe A (EUR) dans le compartiment HSBC Inter-
national Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
- le rapport d'échange de une (1) action de classe A USD du compartiment L Multi Select – L Multi Select European
Equity Fund pour 6,395547 action(s) de classe A (USD) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha
Europe Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe A USD calculée le 29 juin 2011
dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe A (USD) dans le compartiment HSBC Inter-
national Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
99726
L
U X E M B O U R G
- le rapport d'échange de une (1) action de classe I EUR du compartiment L Multi Select – L Multi Select European
Equity Fund pour 6,868714 action(s) de classe I (EUR) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha
Europe Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe I EUR calculée le 29 juin 2011
dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe I (EUR) dans le compartiment HSBC Interna-
tional Select Fund – MultiAlpha Europe Equity;
- le rapport d'échange de une (1) action de classe A EUR du compartiment L Multi Select – L Multi Select US Equity
Fund pour 5,327331 action(s) de classe A (EUR) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha
North America Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe A EUR calculée le 29
juin 2011 dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe A (EUR) dans le compartiment HSBC
International Select Fund – MultiAlpha North America Equity;
- le rapport d'échange de une (1) action de classe A USD du compartiment L Multi Select – L Multi Select US Equity
Fund pour 5,327331 action(s) de classe A (USD) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha
North America Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe A USD calculée le 29
juin 2011 dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe A (USD) dans le compartiment HSBC
International Select Fund – MultiAlpha North America Equity;
- le rapport d'échange de une (1) action de classe I EUR du compartiment L Multi Select – L Multi Select US Equity
Fund pour 5,520509 action(s) de classe I (EUR) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha North
America Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe I EUR calculée le 29 juin 2011
dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe I (EUR) dans le compartiment HSBC Interna-
tional Select Fund – MultiAlpha North America Equity;
- le rapport d'échange de une (1) action de classe I USD du compartiment L Multi Select – L Multi Select US Equity
Fund pour 6,183363 action(s) de classe I (USD) dans le compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha North
America Equity, résultant de la division de la valeur nette d'inventaire par action de classe I USD calculée le 29 juin 2011
dans ce compartiment par la valeur nette d'inventaire par action de classe I (USD) dans le compartiment HSBC Interna-
tional Select Fund – MultiAlpha North America Equity.
L'assemblée générale décide en outre d'approuver les effets de plein droit et simultanés de la Fusion tels que prévus
à l'article 274 de la Loi de 1915, à savoir:
a) la transmission universelle, tant entre la Société et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du
patrimoine actif et passif de «L Multi Select – L Multi Select US Equity Fund» et «L Multi Select – L Multi Select European
Equity Fund», les deux compartiments restants de la Société étant respectivement contribués à deux compartiments de
la Société Absorbante, à savoir «HSBC International Select Fund – MultiAlpha North America Equity» et «HSBC Inter-
national Select Fund – MultiAlpha Europe Equity»;
b) la Société cessera d'exister; et
c) l'annulation des actions de la Société;
ainsi que toutes autres conséquences énumérées dans le Projet Commun de Fusion.
L'assemblée générale décide en outre d'approuver l'attribution de 4.596.686,724 actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale à émettre par la Société Absorbante, selon les rapports d'échange d'actions décrits dans le Projet
Commun de Fusion, en rémunération de la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la
Société à la Société Absorbante.
Les 4.596.686,724 actions nouvellement émises par la Société Absorbante relatives au compartiment HSBC Interna-
tional Select Fund – MultiAlpha North America Equity et au compartiment HSBC International Select Fund – MultiAlpha
Europe Equity seront inscrites au nom de chaque actionnaire nominatif de la Société au registre des actionnaires de la
Société Absorbante à la date effective de la Fusion et donneront les mêmes droits que les actions existantes, notamment
en ce qui concerne les droits aux dividendes, à compter du 30 juin 2011.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale déclare, que par l'apport de tous les avoirs et engagements de la Société à HSBC International
Select Fund avec effet au 30 juin 2011, la Société cessera d'exister à partir de cette date, étant la date effective de la
Fusion, conformément à l'article 274 de la Loi de 1915.
L'approbation de la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante, HSBC
International Select Fund, n'est pas nécessaire dans la mesure où les conditions prévues par l'article 264 de la Loi de 1915,
ont été remplies; nonobstant ce fait, les actionnaires de HSBC International Select Fund, représentant au moins cinq pour
cent (5%) du capital social, peuvent néanmoins convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin
d'approuver la Fusion, conformément à cet article 264, auquel cas le conseil d'administration de HSBC International Select
Fund s'est engagé à en informer le notaire soussigné au plus tard le 1
er
juillet 2011 à 18.00 heures.
<i>Cinquième résolutioni>
Après avoir attentivement examiné les états financiers de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2011 au 29
juin 2011, l'assemblée générale décide de les approuver.
99727
L
U X E M B O U R G
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide qu'il sera mis fin au mandat de Mme Monique Erbeia, M. Vincent de Palma et M. Jean-
Michel Starck, en tant qu'administrateurs de la Société, à partir de la date où la Fusion deviendra effective entre la Société
et la Société Absorbante.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de la démission de Mr. Daniel Roy, en tant que président et
membre du Conseil d'Administration avec effet au 14 mai 2011 (la «Date de Démission»).
L'assemblée générale décide enfin de donner décharge pleine et entière à M. Daniel Roy jusqu'à la Date de Démission
ainsi qu'à Mme Monique Erbeia, M. Vincent de Palma et M. Jean-Michel Starck pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la
date où la Fusion deviendra effective entre la Société et la Société Absorbante.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale décide qu'il sera mis fin au mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 400, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, en tant que réviseur de la Société, à partir de la date où la Fusion
deviendra effective entre la Société et la Société Absorbante.
L'assemblée générale décide en outre de donner décharge pleine et entière à PricewaterhouseCoopers S.à r.l. pour
l'exécution de son mandat jusqu'à la date où la Fusion deviendra effective entre la Société et la Société Absorbante.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié le respect des conditions énumérées aux articles 257 et suivants de la Loi
de 1915, et constate que la Fusion a été décidée conformément aux exigences légales.
Toutes les résolutions ont été prises séparément et par vote unanime.
Aucun point n'étant plus à l'ordre du jour, l'assemblée est aussitôt close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d'une traduction en français; à la demande de ces mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu à l'assemblée, aux membres du bureau de l'assemblée, tous connus du notaire par leur nom, prénom,
état civil et résidence, ces mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant
souhaité signer.
Signé: M. KEMP, M.-L. MARTINET, X. ROUVIERE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30133. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Référence de publication: 2011100252/402.
(110112816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.
Leeverg Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 155.483.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011098482/10.
(110111917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Liquiditätsfluss No.1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.749.
<i>Extrait des minutes du conseil d'administration tenu au siège social de la société le 11 juillet 2011 à 13h00i>
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc
d'Activité Syrdall L - 5365 Munsbach, enregistrée sous le numéro B 47771 au Registre de Commerce et des Sociétés du
99728
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, en tant que Réviseur Externe de la Société pour l'audit des comptes annuels se clotûrant le 31 décembre
2010 et pour l'audit des comptes annuels se clotûrant le 31 décembre 2011.
A Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011098483/16.
(110111861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Liquiditätsfluss No.2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.750.
<i>Extrait des minutes du conseil d'administration tenu au siège social de la société le 11 juillet 2011 à 14h00i>
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 7, Parc
d'Activité Syrdall L - 5365 Munsbach, enregistrée sous le numéro B 47771 au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg, en tant que Réviseur Externe de la Société pour l' audit des comptes annuels se clotûrant le 31 décembre
2010 et pour l'audit des comptes annuels se clotûrant le 31 décembre 2011.
A Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011098484/16.
(110111862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
LKE International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.287.
Les comptes annuels pour la période du 23 août 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098514/12.
(110112346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
GER LOG 1 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.371.670,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 113.075.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la sociétéi>
<i>tenue en date du 31 mai 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010i>
<i>Le conseil d'administration:i>
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur A;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Administrateur A;
4. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, administrateur
B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2011.
99729
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011099854/20.
(110113063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2011.
Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 216.430.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.778.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098486/11.
(110111396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Lafayette S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Génistre.
R.C.S. Luxembourg B 3.042.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011098490/10.
(110112147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Langers et Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 28.573.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011098491/10.
(110112320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
LDMadgency, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.372.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098497/9.
(110111339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
New Star International Property (Luxembourg 4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 127.466.
Veuillez noter que la dénomination correcte de l'associé unique est la suivante:
New Star International Property (Luxembourg Three) S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
99730
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 14 juillet 2011.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011098579/14.
(110112013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Mirabaud Select Equities, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 53.392.
L'an deux mille onze, le vingt-sept juin.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous le régime d'une société
d'investissement à capital variable MIRABAUD SELECT EQUITIES, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 53392, constituée suivant acte notarié, en date
du 4 janvier 1996, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 62 du 3 février 1996.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Grégory FOUREZ, employé de banque, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg,
qui nomme secrétaire Monsieur Christian JEANROND, employé de banque, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Aurélie FREY, employée de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par
lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires en date du 17 juin 2011.
II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décider de la liquidation de la Société.
2.- Nommer Alter Domus Liquidation Services S. à r.l., représenté par M. Gérard Becquer, en qualité de liquidateur
(le "Liquidateur") et définir ses pouvoirs et sa rémunération.
3.- Autoriser le Liquidateur à procéder à la distribution en nature ou en espèces du produit de liquidation tel que
mentionné dans l'avis.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
IV. - Que suivant la liste de présence, 426.886,161 actions sur les 513.011,046 actions en circulation sont représentées
à la présente Assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre
du jour.
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Première résolution:i>
L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur à compter de ce jour: Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.,
représenté par Monsieur Gérard Becquer, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, RCS Luxem-
bourg B 142389.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
99731
L
U X E M B O U R G
Le liquidateur est autorisé à verser aux actionnaires des acomptes sur le boni de liquidation, en numéraire ou en nature
tel qu'indiqué dans l'avis de convocation.
<i>Troisième résolution:i>
L'Assemblée décide d'autoriser le liquidateur à procéder à la distribution en nature ou en espèces du produit de
liquidation tel que mentionné dans l'avis de convocation et dans les procurations des actionnaires.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: G. FOUREZ, C. JEANROND, A. FREY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juillet 2011. Relation: LAC/2011/29904. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098528/66.
(110112123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Eiffel Titrisation S.A., Société Anonyme de Titrisation,
(anc. LDIGTL SA).
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 151.286.
In the year two thousand and eleven, on the fourth day of July.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LDIGTL S.A., a public company
limited by shares (société anonyme) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 151286 (the Company). The Company was incorpo-
rated on January 12
th
, 2010 pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 605 dated March 22
nd
, 2010. The articles of
association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER,
notary residing in Luxembourg, on November 26
th
, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations under number 154 of January, 26
th
2011.
The Meeting is chaired by Mr. Jean-Pascal CARUSO, residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appointed as Secretary Mr. Jan Carel KINGMA, residing in the Netherlands (the Secretary). The Meeting
elected as scrutineer Mrs. Marilyne GOERGEN, residing in Luxembourg (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The Bureau formed, the Chairman declared and requested the undersigned notary to state that:
I. The sole shareholder of the Company, Eiffel Investment Group BV (previously named Louis Dreyfus Investment
Group BV), a private limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office
at WTC H-25, Zuidplein 208, 1077XV Amsterdam, The Netherlands, registered with Chamber of Commerce and In-
dustries under number 24438957 0000 (the Sole Shareholder) and the number of shares held by it are indicated on an
attendance list. This list, after having been signed by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed for registration purposes.
II. This attendance list shows that the seventeen thousand (17,000) ordinary shares (the Ordinary Shares), the eleven
thousand (11,000) compartment A shares, the one thousand (1,000) compartment B shares, the one thousand (1,000)
compartment C shares and the one thousand (1,000) compartment D shares representing the entire subscribed share
capital of the Company, are represented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the issues
of the agenda which are known to the Sole Shareholder.
III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Change of the Company's name into Eiffel Titrisation S.A. and subsequent amendment of article 1 of the Articles of
association;
2. Miscellaneous.
99732
L
U X E M B O U R G
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted
by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to change the Company's name into "Eiffel Titrisation S.A." and as a consequence thereof resolves
to amend article 1 of the Articles, which will henceforth reads as follows:
" Art. 1. Name. The name of the company is "Eiffel Titrisation S.A." (the Company). The Company is a public company
limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and, in particular, the law
of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Company Law), the Law of March 22, 2004 on securi-
tisation (the Securitisation Law) and these articles of incorporation (the Articles)."
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to authorise and grant power to any director of the Company to execute, and to the extent
necessary, sign, deliver, issue any document, deed, instrument, agreement, notice, acknowledgment, declaration, certifi-
cate, which may be necessary, required or useful in connection with the above resolution.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately seven hundred and fifty euro (EUR 750).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and, in case of discrepancies between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le quatre juillet.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique de LDIGTL S.A., une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le
RCS) sous le numéro B 151286 (la Société). La Société a été constituée le 12 janvier 2010 suivant un acte de Maître Henri
HELLINCKX, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°605 du 22 mars 2010. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 26 novembre 2010, publié au Mémorial C numéro 154 du 26 janvier 2011
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal CARUSO, demeurant à Luxembourg (le Président).
Le Président a nommé comme Secrétaire Monsieur Jan Carel KINGMA, demeurant aux Pays-Bas (le Secrétaire).
L'Assemblée a élu Madame Marilyne GOERGEN, demeurant à Luxembourg comme scrutatrice (la Scrutatrice).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Le Bureau ainsi constitué, le Président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. L'actionnaire unique de la Société, Eiffel Investment Group BV (anciennement Louis Dreyfus Investment Group BV),
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à WTC H-25, Zuidplein
208, 1077XV Amsterdam, les Pays-Bas, immatriculée à la Chambre de Commerce et d'Industrie sous le numéro 24438957
0000 (l'Actionnaire Unique) ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste, après avoir été signée par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
les formalités de l'enregistrement.
II. Cette liste de présence indique que les dix-sept mille (17.000) actions ordinaires (les Actions Ordinaires), les onze
mille (11.000) actions de compartiment A, les mille (1.000) actions de compartiment B, les mille (1.000) actions de
compartiment C et les mille (1.000) actions de compartiments D représentant l'intégralité du capital social souscrit de la
Société, sont représentées à la présente Assemblée de sorte que l'Assemblée puisse statuer valablement sur tous les
points de l'ordre de jour dont L'Actionnaire Unique a eu connaissance.
III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en Eiffel Titrisation S.A. et modification subséquente de l'article
1 des Statuts.
2. Divers.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l'unanimité des voix:
99733
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en "Eiffel Titrisation S.A." et en conséquence
modifie l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 1
er
. Dénomination sociale. Le nom de la société est "Eiffel Titrisation S.A." (la Société). La Société est une
société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), par la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la Loi sur
la Titrisation) et ainsi que par les présents statuts (les Statuts)."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'autoriser et donner pouvoir à tout gérant de la Société pour exécuter, et si nécessaire, signer,
émettre, délivrer tout document, acte, instrument, contrat, notice, reçu, déclaration, certificat, qui serait nécessaire,
requis ou utile en rapport avec la résolution ci-dessous.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
du présent acte sont estimés à environ sept cent cinquante euros (EUR 750,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, à la requête de la partie comparante
ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais
et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante
a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: N. GLOESENER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30525. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098495/119.
(110111290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Coditel Holding Lux II Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 228.000,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 160.999.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of June.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public residing in Eschsur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
There appeared:
- Deficom Telecom S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 160.937 (the “Contributor 1”); and
- Codilink S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 5, avenue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 160.883 (the “Contributor 2”),
(the Contributor 1 and the Contributor 2 are together referred to as the "Contributors"),
Hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal.
Such proxies after having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing parties are the shareholders of “Coditel Holding Lux II S.à r.l.”, a Luxembourg “société à responsabilité
limitée” incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 37, rue d'Anvers,
L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Jean Seckler on 12 May
99734
L
U X E M B O U R G
2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 160.999 (the “Company”).
II. That the 37,000 (thirty-seven thousand) shares of a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, representing the
whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda,
of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 191,000.- (one hundred ninety-one thousand
Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 37,000.- (thirty-seven thousand Euro) to EUR 228,000.- (two
hundred twenty-eight thousand Euro) by the issue of 191,000 (one hundred ninety-one thousand) new shares with a
nominal value of EUR 1.- (one Euro) each, subject to the payment of a global share premium of EUR 1,076,000.- (one
million seventy-six thousand Euro), out of which an amount of EUR 22,800.- (twenty-two thousand eight hundred Euro)
shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in cash;
3. Subscription and payment by Deficom Telecom S.à r.l. and Codilink S.à r.l. of the new shares by way of a contribution
in cash;
4. Amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect
the capital increase; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders
acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deli-
berate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 191,000.- (one hundred ninety-one
thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 37,000.- (thirty-seven thousand Euro) to EUR 228,000.-
(two hundred twenty-eight thousand Euro) by the issue of 191,000 (one hundred ninety-one thousand) new shares with
a nominal value of EUR 1.- (one Euro) (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium of EUR
1,076,000.- (one million seventy-six thousand Euro), out of which an amount of EUR 22,800.- (twenty-two thousand eight
hundred Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company.
The New Shares will be subscribed and paid-up and the Share Premium will be paid by the Contributors through a
contribution in cash by the Contributors amounting to EUR 1,267,000.- (one million two hundred sixty-seven thousand
Euro).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares and the payment of
the Share Premium by the contribution in cash of an amount of EUR 1,267,000.- (one million two hundred sixty-seven
thousand Euro) (the “Contribution”).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
1) Thereupon intervenes the Contributor 1, here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, by virtue of a
proxy given under private seal, who declares to subscribe to 114,600 (one hundred fourteen thousand six hundred) New
Shares through a contribution in cash and subject to the payment of the Share Premium amounting to EUR 645,600.- (six
hundred forty-five thousand six hundred Euro).
2) Thereupon intervenes the Contributor 2, here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, by virtue of a
proxy given under private seal, who declares to subscribe to 76,400 (seventy-six thousand four hundred) New Shares
through a contribution in cash and subject to the payment of the Share Premium amounting to EUR 430,400.- (four
hundred thirty thousand four hundred Euro).
Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary, so that the amount of EUR 1,267,000.- (one
million two hundred sixty-seven thousand Euro) is now at the disposal of the Company.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the
shareholding of the Company is now composed of:
- Deficom Telecom S.à r.l.: 136,800 (one hundred thirty-six thousand eight hundred) shares; and
99735
L
U X E M B O U R G
- Codilink S.à r.l.: 91,200 (ninety-one thousand two hundred) shares.
The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are re-
presented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is unanimously resolved to amend article 6, paragraph 1 of the Company's articles of association so that to read as follows:
“ Art. 6. The share capital is set at EUR 228,000.- (two hundred twenty-eight thousand Euro) represented by 228,000
(two hundred twenty-eight thousand) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each”.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand seven hundred euro (€
1,700.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuvième jour de juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
- Deficom Telecom S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son
siège social sis au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 160.937 (l'«Apporteur 1»); et
- Codilink S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social
sis au 5, avenue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 160.883 (l'«Apporteur 2»),
(l'Apporteur 1 et ensemble avec l'Apporteur 2, les «Apporteurs»),
Ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing
privé.
Lesdites procurations après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I - Les parties comparantes sont les associés de «Coditel Holding Lux II S.à r.l.», une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié reçu par Maître Jean Seckler en date du 12 mai 2011, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.999 (la «Société»).
II – Que les 37.000 (trente-sept mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, repré-
sentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points de l'ordre du jour, dont les associés reconnaissent avoir été dûment préalablement informé.
III- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 191.000 EUR (cent quatre-vingt-onze mille Euro) afin
de le porter de son montant actuel de 37.000 EUR (trente-sept mille Euro) à 228.000 EUR (deux cent vingt-huit mille
Euro) par l'émission de 191.000 (cent quatre-vingt-onze mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR
(un Euro) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 1.076.000 EUR (un million
soixante-seize mille Euro) dont un montant de 22.800 EUR (vingt-deux mille huit cent Euro) sera alloué à la réserve légale
de la Société, le tout devant être payé au moyen d'un apport en numéraire;
99736
L
U X E M B O U R G
3. Souscription et paiement par Deficom Telecom S.à r.l. et Codilink S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'un
apport en numéraire;
4. Modification du première paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital;
et
5. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que les associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été vala-
blement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il
est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des associés dans un délai suffisant
afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 191.000 EUR (cent quatre-vingt-onze mille
Euro), afin de le porter de son montant actuel de 37.000 EUR (trente-sept mille Euro) à 228.000 EUR (deux cent vingt-
huit mille Euro), par l'émission de 191.000 (cent quatre-vingt-onze mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant
total de 1.076.000 EUR (un million soixante-seize mille Euro) (la «Prime d'Emission»), dont un montant de 22.800 EUR
(vingt-deux mille huit cent Euro) sera alloué à la réserve légale de la Société.
La souscription des Nouvelles Parts Sociales et leur paiement ainsi que le paiement de la Prime d'Emission seront
payées par les Apporteurs par voie d'un apport en numéraire d'un montant de 1.267.000 EUR (un million deux cent
soixante-sept mille Euro).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts Sociales et le paiement
de la Prime d'Emission au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 1.267.000 EUR (un million deux cent soixante-
sept mille Euro) (l'«Apport»).
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
1) Intervient ensuite l'Apporteur 1, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da-Chao Conde, prénommée, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire à 114.600 (cent quatorze mille six cents) Nouvelles Parts
Sociales par voie d'un apport en numéraire et moyennant le paiement de la Prime d'Emission d'un montant de 645.600
EUR (six cent quarante-cinq mille six cent Euro).
2) Intervient ensuite l'Apporteur 2, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da-Chao Conde, prénommée, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire à 76.400 (soixante-seize mille quatre cents) Nouvelles Parts
Sociales par voie d'un apport en numéraire, moyennant le paiement de la Prime d'Emission d'un montant de 430.400 EUR
(quatre cent trente mille quatre cent Euro).
La preuve de l'Apport a été donnée au notaire soussigné, de sorte que le montant de 1.267.000 EUR (un million deux
cent soixante-sept mille Euro) est désormais à la disposition de la Société.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et du paiement complet de l'Apport, la participation au
capital de la Société est désormais composé de:
- Deficom Telecom S.à r.l.: 136.800 (cent trente-six mille huit cents) parts sociales; et
- Codilink S.à r.l.: 91.200 (quatre-vingt-onze mille deux cents) parts sociales.
Le notaire établit que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessous, représentant l'intégralité du capital social de
la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et de l'Apport décrit ci-dessus, il est unanimement décidé
de modifier l'article 6, paragraphe 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital de la Société est fixé à 228.000 EUR (deux cent vingt-huit mille Euro), représentés par 228.000
(deux cent vingt-huit mille) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune.»
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ mille sept cents euros (€ 1.700,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
99737
L
U X E M B O U R G
A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9122. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Line Gerard.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011100917/200.
(110114775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Les Papillons S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg B 128.739.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098500/9.
(110111411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Lesswood S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 251, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 145.782.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098501/9.
(110111340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Lilac Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 849.747,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 131.967.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juin 2011i>
<i>Résolution:i>
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant
lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 comme suit:
Fiduciaire MEVEA Luxembourg Sàrl, 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011098508/18.
(110111983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
99738
L
U X E M B O U R G
MERRILL LYNCH (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.250.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 31.070.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des l'associés de la Société en date du 24 septembre 2009i>
En date du 24 septembre 2009, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de ne pas renouveler le mandat de Deloitte S.A., Réviseur d'Entreprises, avec siège social au 560, rue de Neudorf,
L-2220, Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au
Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que réviseur d'entreprises externe de la société;
* de nommer PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises externe pour un durée de un an jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2010 et sera appellée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098551/18.
(110111421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Salisbury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 200.000,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 143.238.
In the year two thousand eleven, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared
at the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company (the Meeting):
Railway Pension Nominees Limited, a company incorporated in England and Wales, having its registered office at 2
nd
Floor, Camomile Court, 23 Camomile Street, London EC3A 7LL, United Kingdom, registered under company number
00948374 with the United Kingdom Company House (the Sole Shareholder),
here represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given
under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. Railway Pension Nominees Limited is the sole shareholder of Salisbury S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg and re-
gistered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 143.238, incorporated pursuant
to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on November 26, 2008, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of December 17, 2008 number 2981 (the Company). The articles of association of
the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Blanche Moutrier, notary residing
in Esch-sur-Alzette, on June 28, 2011, which is not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
II. The Company's share capital is currently set at two hundred thousand British Pounds (GBP 200,000) represented
by eight thousand (8,000) shares in registered form with a par value of twenty-five British Pounds (GBP 25) each;
III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of State Street Services (Luxembourg) S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary
liquidation of the Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration,
all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance of their res-
pective mandates; and
6. Miscellaneous.
99739
L
U X E M B O U R G
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy-holder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint State Street Services (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability
company (société anomyme), with its registered office at 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 88.409, as Liquidator in relation to the voluntary
liquidation of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the
Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the perfor-
mance of their respective mandates.
There being no further business on the agenda, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,300.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trentième jour du mois de juin.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
Railway Pension Nominees Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social à 2
nd
Floor, Camomile Court,
23 Camomile Street, Londres EC3A 7LL, immatriculée sous le numéro 00948374 au registre des sociétés du Royaume-
Uni (l'Associé Unique),
Ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Railway Pension Nominees Limited est l'associé unique de Salisbury S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.283, constituée suivant un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations du 17 décembre 2008, numéro 2981 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
99740
L
U X E M B O U R G
fois suivant un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2011, qui n'est pas
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à deux cent mille livres Sterling (GBP 200.000) représenté par
huit mille (8.000) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq livres Sterling (GBP 25)
chacune;
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination de State Street Services (Luxembourg) S.A. en tant que liquidateur en rapport avec la liquidation vo-
lontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de charger le Liquidateur de réaliser, dans les meilleures conditions possibles et pour la meilleure contre-
partie possible, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
5. Décision d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs;
et
6. Divers.
Sur ce, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'enregistrer les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer State Street Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 6, rue Philippe II, L2340 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.409, en tant que Liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de
la Société. Le Liquidateur a le pouvoir de faire tout de ce qui est requis pour la liquidation de la Société et de disposer
des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de ses fonctions.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur aura le droit d'effectuer tous les actes et de réaliser toutes les opérations, y compris celles et ceux qui
sont visés à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur peut, sous sa propre
responsabilité, déléguer, pour des opérations ou des tâches spécifiquement déterminées, quelques-uns de ses pouvoirs
à une ou plusieurs personnes ou entités.
Le Liquidateur sera autorisé à faire des paiements anticipés sur le boni de liquidation à l'Associé Unique, conformément
à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de charger le Liquidateur de réaliser, dans les meilleures conditions possibles et pour la
meilleure contrepartie possible, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs
mandats respectifs.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
du présent acte s'élèvent à environ EUR 1.300.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente, qu'à la requête de la partie
comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de cette même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante
a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30947. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
99741
L
U X E M B O U R G
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 18 juillet 2011.
Référence de publication: 2011101262/145.
(110114777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
Lithonia Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.793.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LITHONIA HOLDING S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2011098512/11.
(110111487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Lizard Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 127.586.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098513/9.
(110112503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
LK1 Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 149.271.
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2011 que G.T. FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social
à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg est nommé commissaire aux comptes de LK1 Project S.A. en remplacement
de FBK AUDIT S.àr.l., démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire se terminera lors de l'assemblée générale qui
se tiendra en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2011.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011098515/16.
(110111820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Nanosa, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 112.515.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 13 juillet 2011i>
Ont été ré-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Jos HEMMER, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Madame Martine KAPP, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Monsieur Eric LECLERC, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, Président.
A été ré-élu commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2015:
- Monsieur Pascal FABECK, demeurant à 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
99742
L
U X E M B O U R G
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2011098588/18.
(110111711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Lorfinance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 94.329.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098516/10.
(110112124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
LSP (Leidwanger Stéphane Participations) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 147.962.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011098519/9.
(110111337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Lusonia Services S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 155.600.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011098520/10.
(110112356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
MAS Luxinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 148.473.
<i>Auszug aus dem Protokolli>
der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
im Großherzogtum Luxemburg am 07. Juni 2011 um 15.00 Uhr abgehalten wurde.
<i>Vierter Beschlussi>
a) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Annahme des Rücktrittsgesuches des Herrn Jürgen Kautz zum 07.
Juni 2011.
b) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Kooptierung des Herrn Dr. Thomas Goergen, geboren am 08. März
1969 in Trier, privatansässig in Mühlenflur 10, 54340 Riol, zum 07. Juni 2011.
Herr Dr. Thomas Goergen soll den Vorsitz des Verwaltungsrates übernehmen.
c) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Beibehaltung der Verwaltungsratsmitglieder Herr Ralf Funk, Herr
Thies Clemenz und Herr Michael Lange.
d) Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die
im Jahr 2012 stattfinden wird.
e) Die Gesellschafterversammlung bestellt PricewaterhouseCoopers S.àr.l., mit Sitz in Luxemburg, zum Abschluss-
prüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches am 31. März 2012 endet.
99743
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 7. Juni 2011.
Ralf Funk
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Référence de publication: 2011102213/25.
(110115621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
McKey Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 787.525,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 101.381.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098522/11.
(110111483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Meridian Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.555.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Référence de publication: 2011098524/10.
(110111701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Mermaid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 66.340.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Mermaid S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011098525/11.
(110111803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2011.
Supermarché MASSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 24, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 92.868.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 21 juillet 2011.
FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Stroos
L-9991 WEISWAMPACH
Signature
Référence de publication: 2011108222/14.
(110119217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
99744
Coditel Holding Lux II Sàrl
Cronos Invest
Eiffel Titrisation S.A.
Finathem Europe
Fondation Nicolas et Jean-Paul Lanners
GER LOG 1 S.A.
Imdlux S.A.
Immobilière Grün S.à.r.l.
Immo D.A. S.à.r.l.
Institut de beauté Selma S.à r.l.
Insurance Market Research S.A.
Intelligent Engineering S.à r.l.
Iona Management S.à r.l.
Ja.Ita
JP Commercial XI S.à r.l.
K Beta S.à r.l.
Koliphi Investissement S.à r.l.
Kravid S.àr.l.
KSM Participations Mobilières et Immobilières S.A.
Kunstkammer Corporation S.à r.l.
KWISTUM Administration S.à r.l.
Laboratoire de Biotechnologie du Luxembourg
Lafayette S.A.
La Foncière du Capitole S.A.
Langers et Co S.A.
LDIGTL SA
LDMadgency
Leeverg Luxembourg S.A.
Les Papillons S.à r.l.
Lesswood S.à r.l.
Lilac Holding Lux S.à r.l.
Liquiditätsfluss No.1 S.A.
Liquiditätsfluss No.2 S.A.
Lithonia Holding S.A.
Lizard Investment S.A.
LK1 Project S.A.
LKE International Holding S.à r.l.
L Multi Select
Lorfinance S.A.
LSP (Leidwanger Stéphane Participations) S.A.
Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.
Lusonia Services S.A.-SPF
Madeleine Finance S.A.
MAS Luxinvest S.A.
Massiv-Passiv S.A.
McKey Luxembourg S.à r.l.
Mercury Properties S.A.
Meridian Holding S.à r.l.
Mermaid S.A.
MERRILL LYNCH (Luxembourg) S.à r.l.
Mirabaud Select Equities
Nanosa
New Star International Property (Luxembourg 4) S.à r.l.
Orion Investment Partners Luxembourg S.à r.l.
Salisbury S.à r.l.
Seamer Holding S.à r.l.
Supermarché MASSEN S.A.
TDL Financing Luxembourg Sàrl