This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2005
31 août 2011
SOMMAIRE
ABN AMRO Multi-Manager Funds . . . . . . .
96196
Action Oil Luxembourg SPF S.A. . . . . . . . .
96202
Afschrift S.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96194
Aggmore Kaufmann Ventures S.à r.l. . . . .
96231
ALVA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
96194
Amber Trust Management S.A. . . . . . . . . .
96232
AnBeVir S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96227
Antan Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96199
AXA Assurances Luxembourg . . . . . . . . . .
96226
AXA Assurances Luxembourg . . . . . . . . . .
96227
AXA Assurances Vie Luxembourg . . . . . . .
96233
Beaucette S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96199
Bevis Marks 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96240
BNP Paribas Flexi I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96197
BNP Paribas Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96199
CM-Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96221
Cobrilux S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96202
Confédération luxembourgeoise d'oeuvres
catholiques de charité et de solidarité as-
sociation sans but lucratif . . . . . . . . . . . . . .
96235
Crescendo SIF Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96206
Dany et Susana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96240
Delta Lloyd L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96202
DJE Strategie II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96206
Dumatin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96234
Go S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96236
Instore Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96218
Jaguar Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
96226
Jarden Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
96222
Key-Way S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96228
Lexfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96225
Lex Investments Holdings S.A. . . . . . . . . . .
96225
Lux Multi Plus SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . .
96206
L.V.M.D., Location Vente Matériel Décon-
tamination S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96227
Magma Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96203
MAN Umbrella SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . .
96203
Maybach S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96230
MGT 1 & 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96198
MHREC Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
96230
Midgard Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96231
Midgard Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96231
ML Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96231
Motion Connect S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .
96232
MS Design S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96233
Najac-Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96234
N.C. Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
96233
Nikky Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96228
Nordic Investment Consulting S. à r.l. . . .
96238
Nordic Investment Consulting S. à r.l. . . .
96235
Nouvelle Société Vins du Portugal S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96230
Nova Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96234
Novator Telecom Finland S.à r.l. . . . . . . . .
96234
NTG Holdings S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
96238
NTR Lux Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96239
Nubil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96239
Orangenburger SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
96200
Orion Asset France III S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96239
PG Europe 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96224
Regionaler Städteverlag RSV GmbH . . . . .
96236
Repco 22 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96225
Resinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96239
Schafsstrachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96235
Schroder International Selection Fund . . .
96195
SF (Lux) Sicav 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96201
Valauchanrus Sopaneer S.C.A. . . . . . . . . . .
96201
Ygrec S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96194
96193
L
U X E M B O U R G
Afschrift S.E., Société Européenne.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 125.811.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 octobrei> à 11.00 heures par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
dont l'étude est sise à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social à L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900 et modification subséquente de l'article 2 des statuts;
2. Mise en liquidation de la Société;
3. Désignation de BIG GRIZZLY S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs et rémunération.
Les Actionnaires sont avisés que le point 2 de l'ordre du jour est soumis aux quorums de présence et de vote prévus
à l'article 38 des statuts.
Cette assemblée est convoquée suite à l'assemblée générale extraordinaire de carence qui s'est tenue le 24 août 2011.
<i>Le Conseil de direction.i>
Référence de publication: 2011121254/18.
ALVA Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 131.956.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 octobre 2011i> à 11.30 heures par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-
bourg, dont l'étude est sise à L-1319 Luxembourg, 101 rue Cents.
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social à L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts;
Cette assemblée est convoquée suite à l'assemblée générale extraordinaire de carence qui s'est tenue le 24 août 2011.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011121255/15.
Ygrec S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 72.632.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue Extraordinairement, qui aura lieu le <i>16 septembre 2011i> à 13.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2008, 31 décembre 2009 et 31 décembre
2010, et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat du 31
décembre 2008 au 31 décembre 2010.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2011122237/1023/20.
96194
L
U X E M B O U R G
Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 8.202.
L'exigence de quorum stipulant que 50 % des Actions en circulation de Schroder International Selection Fund (la
«Société») doivent être représentées n'a pas été respectée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui
s'est tenue le 16 août 2011 à 11.00 heures, heure du Luxembourg.
Le présent avis tient lieu de convocation à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social de la Société le mardi <i>11 octobre 2011i> à 11.00 heures,
HEC, (l'«Assemblée»), afin de délibérer de la résolution suivante à l'ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Approuver les amendements des statuts de la Société (les «Statuts») comme suit:
1. Modification de l'article 5 afin, entre autres:
i. de clarifier les dispositions sur les fusions et les réorganisations des Catégories d'Actions;
ii. de disposer que (i) l'assemblée spécifique à une Catégorie d'Actions puisse décider d'apporter les éléments d'actif
et de passif attribuables à cette Catégorie d'Actions à un autre organisme de placement collectif luxembourgeois
enregistré conformément aux dispositions de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les
organismes de placement collectif (la «Loi de 2010») en contrepartie de l'émission d'actions de cet organisme de
placement collectif et que (ii) cette assemblée spécifique à une Catégorie d'Actions puisse également décider de
réorganiser une Catégorie d'Actions en la scindant en deux Catégories d'Actions ou davantage au sein de la Société
ou dans un autre organisme de placement collectif luxembourgeois enregistré conformément à la partie I de la Loi
de 2010.
iii. de spécifier qu'à compter du 1
er
juillet 2011, les dispositions relatives aux fusions d'OPCVM précisées dans la
Loi de 2010 et tous règlements d'exécution doivent s'appliquer. Les fusions de Catégories d'Actions seront alors
décidées par le conseil d'administration de la Société (le «Conseil»), à moins que ce dernier ne décide de soumettre
la décision d'une fusion à l'assemblée de la Catégorie concernée. Aucun quorum n'est requis pour l'assemblée de
la Catégorie et les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Si, par suite d'une fusion de
Catégorie, la Société cesse d'exister, la fusion sera décidée par l'assemblée des Actionnaires statuant conformément
aux exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts telles que définies à l'article 30;
iv. de disposer que les actifs n'ayant pu être distribués à leurs bénéficiaires à la clôture de la liquidation de la
Catégorie seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le compte de leurs ayants droit.
2. Modification de l'article 10 afin d'autoriser le Conseil à tenir une assemblée générale annuelle des Actionnaires à
une date, une heure ou un lieu autres que ceux fixés dans les Statuts dans la mesure permise par et conformément
aux conditions définies par les lois et règlements luxembourgeois.
3. Modification de l'article 12 afin de prévoir une date d'échéance pouvant être utilisée pour calculer les exigences de
quorum et de majorité applicables aux assemblées générales des Actionnaires et pour déterminer les droits des
Actionnaires à participer et exercer leurs droits de vote, dans la mesure permise par et conformément aux con-
ditions définies par les lois et règlements luxembourgeois.
4. Modification de l'article 16 afin:
i. de disposer que la Société n'investira pas plus de 10 % de l'actif net de l'une de ses Catégories en parts ou actions
d'OPCVM et d'autres OPC sauf mention contraire dans les documents d'offre de la Société;
ii. d'autoriser le Conseil à (i) créer toute Catégorie ayant le statut soit d'un OPCVM nourricier soit d'un OPCVM
maître, (ii) convertir toute Catégorie existante en une Catégorie d'OPCVM nourricier ou (iii) modifier l'OPCVM
maître de l'une des Catégories de son OPCVM nourricier;
iii. déterminer qu'une Catégorie puisse investir dans une ou plusieurs autres Catégories de la Société, dans la mesure
permise par les lois et règlements luxembourgeois.
5. Modification de l'article 22 afin de disposer que:
i. la détermination de la valeur liquidative, des prix de souscription et de rachat des Actions de toute Catégorie
d'Actions spécifique ainsi que l'émission et le rachat des Actions de cette Catégorie à leur(s) Actionnaire(s) ainsi
qu'une conversion de et en Actions de cette Catégorie peuvent être suspendus au cours de toute période pendant
laquelle la détermination de la valeur liquidative par action des fonds d'investissement sous-jacents représentant
une part importante des actifs de la Catégorie concernée est suspendue;
ii. la Société peut, conformément aux dispositions de la Loi de 2010 relative aux fusions, suspendre temporairement
la souscription et le rachat des Actions, sous réserve que cette suspension soit justifiée par la protection des
Actionnaires.
6. Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres des articles 3, 5, 6, 8, 13, 20, 21, 24 et 25.
96195
L
U X E M B O U R G
<i>VOTEi>
La résolution ci-dessus ne nécessitera pas de quorum et sera adoptée à une majorité de 75 % des Actions présentes
ou représentées à l'Assemblée.
Les formulaires de procuration (veuillez voir ci-dessous, à la section «MODALITES DE VOTE») déjà reçus pour
l'assemblée qui s'est tenue le 16 août 2011 resteront valables pour l'Assemblée, sauf instructions contraires de votre part
via le nouveau formulaire de procuration joint.
<i>MODALITES DE VOTEi>
Les Actionnaires se trouvant dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration en retournant
le formulaire de procuration ci-joint à la société de gestion de la Société, Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, au plus tard le mardi 4 octobre 2011 à 17.00
heures, HEC.
Les détenteurs d'Actions au porteur qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y voter par procuration doivent déposer
leurs certificats d'Actions auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., au plus tard le mardi 4 octobre
2011 à 17.00 heures, HEC. Les Actions ainsi déposées resteront bloquées jusqu'au jour suivant l'Assemblée.
<i>Pour le compte de la Société
i>Noel Fessey, Gary Janaway
Référence de publication: 2011122241/755/75.
ABN AMRO Multi-Manager Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 78.762.
An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 2:00 p.m. on Tuesday <i>September 20, 2011i> at the premises of the Management Company
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, H2O Building, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
Update of the Articles of Association as following:
<i>Agenda:i>
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Article 4: correction of the name of Articles 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17
December 2010 concerning undertakings for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;
3. the commune of the registered office (Hesperange instead of Howald-Hesperange);
4. Article 6: redefinition of the notion of "subfund";
5. Article 7: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";
Articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term "sub-category" by "class of shares";
6. Articles 8 and 10§6: cancellation of the issuance of share certificates
Deletion of Article 9 concerning lost or damaged certificates;
7. Article 10§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;
8. Article 13§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share
buybacks;
9. Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
10. Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested
(14b) and exchange rate (14e);
Article 14(c): replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is
received for the valuation date for listed assets;
Article 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;
11. Article 15 (e) and (f): addition of the terms "categories or classes of shares" for suspensions of NAV and orders in
the event of merger or liquidation;
Article 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of
merger;
Article 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions
in the master fund;
12. Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by resolution of the Board of Directors
to determine the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the pro-
cessing of orders;
13. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
96196
L
U X E M B O U R G
14. Article 20: addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company
subfunds, as well as feeder subfunds;
15. Article 25: replacing the words "at least one-fith of the capital" by "at least one-tenth of the capital" in the second
paragraph;
16. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-
sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;
17. Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations
in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;
18. Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-
cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Article 32: Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master
funds.
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'
Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2011122239/755/65.
BNP Paribas Flexi I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 117.580.
Notice of convocation
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
Which will be held on <i>September 20, 2011i> at 2.00 p.m., at the office of BNP Paribas Investment Partners, H2O building,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follow:
1. Article 3: reference to the Luxembourg Law of 17 December 2010;
2. Redefinition of the "subfund";
3. Review of the terms "category of shares" and "class of shares" and replacement of all reference to "sub-category"
by "class of share" in the whole document;
4. Articles 8 & 10: cancellation of the share certificate issue;
5. Cancellation of Article 9 "lost or damaged certificates";
6. Article 10: possibility for the Board of Directors to reject share subscription;
7. Article 12: addition of the following paragraph "This redemption price may be rounded off to the next higher or
lower unit or fraction of the currency in question, as determined by the Board of Directors."
8. Creation of a new article 13 allowing the Board to split or consolidate the shares issue within one same class, same
category or same subfund according to the conditions set by it;
9. Amendment of article 14 as follow:
- (b)(e) reference of the valuation day as the date of determination of the value of shares or units and exchange
rate;
- (c) replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is received for
the valuation date for listed assets;
- (d) remove of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the valuation of
unlisted assets;
10. Article 15:
- (e)(f): addition of the terms "categories or classes of shares" for net asset value suspension and orders in the event
of merger or liquidation;
96197
L
U X E M B O U R G
- (f): cancellation of the maximum period of two bank business days for net asset value suspension in case of merger,
splitting or restructuring operation;
- Possibility to suspend the net asset value calculation and orders in the "feeder" subfund in case of same suspension
in the "master" subfund;
- paragraph 3 & 4: replacement of the 10% limit with a limit to be defined by the Board of Directors to determine
the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;
11. Article 17 § 5 is completed as follow "The votes cast shall not include those of directors who did not take part in
the voting, abstained, or cast a blank or void vote."
12. Article 20: possibility for the board to create subfunds investing in other Company subfunds as well as feeder
subfunds;
13. Article 27 is rewriting as follow "Unless otherwise provided for under current law or these Articles of Association,
the General Meeting of Shareholders shall validly deliberate, regardless of the portion of capital represented. Re-
solutions shall be adopted by a simple majority of votes cast. The votes cast shall not include those attached to
shares for which the shareholder did not take part in the voting, abstained, or cast a blank or void vote".
14. Articles 31 & 32: remove of any reference to the 9 month period as from the date of the liquidation regarding the
asset not distributed to a time period set by regulations in force;
15. Article 32:
- Rewriting of the article to give the Board of Directors sole authority to decide on effectiveness and terms, under
the limitation and conditions prescribed by law, for the operation of liquidation, merger and splitting;
- Addition of the liquidation of feeder subfund in the event of liquidation, merger or split of the master fund.
In compliance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended by the
Law of 7 September 1987, the Meeting's deliberations are only valid if at least one-half of the Company's capital is present
or represented.
In order to be adopted, resolutions must be carried out by at least two-thirds of the votes of the shareholders
expressed. The votes expressed do not comprise those attached to the shares for which the shareholder has not taken
part to the vote or has not voted or whose vote was considered as null or void.
Owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares at
the offices of the finance department at least five full days before the meeting.
Owners of registered shares wishing to attend or be represented at the Meeting are admitted against proof of identity,
provided that they notify their intention to attend the meeting at least five full days beforehand.
The draft new Articles of Association and current prospectus and the last periodic report are available from the
agencies stated in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2011122240/755/66.
MGT 1 & 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 125.612.
Les actionnaires de MGT 1 & 2 S.A. (la «Société») sont invités à participer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le <i>8 septembre 2011i> à 10 heures au 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice
social qui s'est terminé le 31 décembre 2010;
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2010;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'emploi de la somme de 9.772.677,08 EUR correspondant
au prix des actions de Metallum cédées par la Société aux fonds Alpha et à Capetown S.A.;
4. Affectation du résultat pour l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2010;
5. Décision concernant la décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice social qui s'est
terminé le 31 décembre 2010.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes;
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011112684/275/21.
96198
L
U X E M B O U R G
Beaucette S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.156.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>16 septembre 2011i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2011122242/1023/17.
Antan Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 80.926.
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 septembre 2011i> à 12.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2010 et 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011114917/696/15.
BNP Paribas Plan, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 77.227.
Since the presence quorum required under Article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies,
as amended by the law of 7 September 1987, i.e. at least half of the company's capital present or represented, was not
achieved for the extraordinary general meeting on August 12, 2011, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 11.00 a.m. on Friday <i>September 16, 2011i> at the premises of the Management Company
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as following:
1. Choice of English as the official language of the Articles of Association as authorised by Article 26 (2) of the
Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;
2. Articles 3 and 35: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning under-
takings for collective investment, replacing the law of 20 December 2002;
3. Article 4: correction of the name of the commune of the registered office (Hesperange instead of Howald-Hespe-
range);
4. Article 6: redefinition of the notion of "subfund";
5. Article 7: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";
Articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 24, 29, and 31: replacement of the term "sub-category" by "class of shares";
6. Articles 8 and 10§6: cancellation of the issuance of share certificates;
Deletion of Article 9 concerning lost or damaged certificates;
96199
L
U X E M B O U R G
7. Article 10§1: opening up the possibility for the Board of Directors to reject any new subscription;
8. Article 13§3: opening up the possibility of rounding off to the higher or lower unit or fraction in the event of share
buybacks;
9. Creation of a new article following Article 13 authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
10. Article 14(b) and (e): addendum to valuation date as the date of determination of the value of the funds invested
(14b) and exchange rate (14e);
Art. 14(c): replacement of the last known price in Luxembourg by the closing price on the day the order is received
for the valuation date for listed assets;
Art. 14(d): elimination of the depositary bank's consent for the appointment of the appraiser appointed for the
valuation of unlisted assets;
11. Article 15 (e) and (f): addition of the terms "categories or classes of shares" for suspensions of NAV and orders in
the event of merger or liquidation;
Art. 15 (f): elimination of the maximum time period of 2 days for suspension of NAV and orders in the event of
merger;
Art. 15: addition of the suspension of NAV and orders in a feeder subfund in the event of the same suspensions in
the master fund;
12. Article 15§3 and 4: replacement of the limit of 10% by a limit to be defined by the Board of Directors to determine
the percentage of repurchased assets requiring either a suspension or a postponement of the processing of orders;
13. Article 17§5: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
14. Article 20: addition of the possibility for the Board of Directors to create subfunds investing in other Company
subfunds, as well as feeder subfunds;
15. Article 27: The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital repre-
sented. Resolutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;
16. Articles 31 and 32: replacement of the time period of 9 months following liquidation by a reference to the regulations
in force for the depositing of undistributed assets at the Caisse de Consignation;
17. Article 32: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-
cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Art. 32: Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master
funds.
In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, this second
extraordinary general meeting's deliberations will be valid irrespective of the capital present or represented. Decisions
shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.
Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their
shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.
Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon
proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2011116179/755/66.
Orangenburger SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 20.972.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>9 septembre 2011i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011118498/795/15.
96200
L
U X E M B O U R G
Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 140.847.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 septembre 2011i> à 11:00 heures en l'étude de Me HELLINCKX sise au 101 rue Cents à Luxembourg,
avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des articles 6, 8 et 15 des statuts
2. Refonte des statuts
Les actionnaires sont avisés qu'un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur les points de l'ordre
du jour. Si le quorum n'était pas atteint, une 2
e
Assemblée portant sur ces points devra être convoquée. Les résolutions
pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil de Gérance.i>
Référence de publication: 2011118497/795/17.
SF (Lux) Sicav 3, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.252.
Die Aktionäre der SF (LUX) SICAV 3 sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Freitag, den <i>09. September 2011i> um 11:00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.
Die Generalversammlung vom 20. Juli 2011 wurde ordnungsgemäss einberufen und mangels Fertigstellung des Jahresbe-
richtes vertagt auf den 09. September 2011 mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. März 2011
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formu-
lare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2011118502/755/35.
96201
L
U X E M B O U R G
Action Oil Luxembourg SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 21.093.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>08 septembre 2011i> à 10h00 au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011119076/1031/15.
Cobrilux S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 30.320.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COBRILUX S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>8 septembre 2011i> à 14.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.03.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011119077/750/15.
Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 24.964.
The Board of Directors convenes the shareholders of DELTA LLOYD L, Sicav to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
organized under private seal to be held at the registered office of the Sicav on <i> 8 i>
<i>thi>
<i> September 2011 i> at 11.00 with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
- Decision to pay out interim dividends for the financial year 2011 for the following distribution share classes on 12
September 2011, 12 December 2011 and 12 March 2012:
Sub-fund
Share
class
ISIN
Currency
Amount
per share
DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND
A
LU0428173842
EUR
0.10
DELTA LLOYD L BOND EURO
A
LU0088035877
EUR
3
DELTA LLOYD L BOND EURO
CD
LU0614143633
EUR
0.30
DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND
A
LU0408574944
EUR
0.10
No quorum is required. The decision will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the
registered office of the Sicav.
The Shareholders who wish to attend the Meetings must inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501)
at least five calendar days before the Meeting.
Référence de publication: 2011119078/755/24.
96202
L
U X E M B O U R G
Magma Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 152.395.
According to Articles 23ff. of the Articles of Incorporation of the company, the Board of Directors hereby invites you
to attend the
ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the company on <i>8 September 2011i> , 11 a.m., at the registered office of Magma Capital with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and the Auditor on the financial statements for the financial year as per 30 June
2011.
2. Approval of the balance sheet as per 30 June 2011 and the profit and loss statement.
3. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year that elapsed.
4. Renumeration for the Members of the Board of Directors.
5. Re-election of the Auditor.
6. Miscellaneous.
In order to attend the Ordinary General Meeting and for the proper execution oft he voting rights, the shareholders
will have to deposit their shares at least five (5) days before the meeting. Only those who have submitted written notice
of the deposit to the company are admitted to attend the meeting. Each shareholder may be represented by a person
who is duly authorized by proxy. The proxies and the voting instruction forms have to be deposited at least five (5) days
before the meeting at the company's registered office. For the duly convocation of the meeting, no quorum is required.
Luxembourg, August 2011.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2011119080/1999/25.
MAN Umbrella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 53.150.
We hereby give you notice that the board of directors (the "Board of Directors") of Man Umbrella SICAV (the
"Company") has decided to convene an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of the Company on <i>September 8, 2011i> at 11.00 a.m. in Luxembourg at the offices of Arendt & Me-
dernach, 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, in order to deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Replacement of all references in the articles of incorporation to the Law of 20 December 2002 by references to
the Law of 17 December 2010 and replacement of all references to the Directive 85/611/EEC by references to the
Directive 2009/65/EC.
2. Amendment of Article 5 point 3 "Company assets" of the articles of incorporation, so as to read as follows:
The Board will assign pursuant to Article 181 (1) of the Law of 17 December 2010 a portion of the Company assets
to each class of share (such portion of the Company assets hereinafter referred to as a sub-fund) for which shares
will be issued pursuant to Article 7 of the Articles of Incorporation in the form of one or more classes of shares.
In relation to third parties, the assets of a sub-fund are only liable for such liabilities attributable to the sub-fund in
question.
3. Addition of a new point 7 under Article 8 "Redemption of shares" of the articles of incorporation, which shall read
as follows:
The Company shall have the right, if the Board so determines, and with the express consent of the relevant sha-
reholder, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in specie by allocating to the shareholder
investments from the portfolio of assets in such share class or sub-fund equal in value (as calculated in the manner
described in Article 11 hereof) as of the valuation day on which the redemption price is determined to the value
of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on
a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant share
class or sub-fund and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor appointed by the
Company pursuant to Article 22 hereof. The costs of any such transfers shall be borne by the shareholder.
4. Addition of a new point 4 of Article 11 "Net asset value per share" of the articles of incorporation, which shall read
as follows:
96203
L
U X E M B O U R G
With respect to specific share classes or sub-funds and as further specified in the sales prospectus, the Board may
determine to apply an alternative net asset value calculation method (to include such reasonable factors as they
see fit) to the net asset value per share of such share class or sub-fund. This method of valuation is intended to
pass the estimated costs of underlying investment activity of the sub-fund to the active shareholders by adjusting
the net asset value of the relevant share class or sub-fund and thus to protect long-term shareholders from costs
associated with ongoing subscription and redemption activity.
This alternative net asset value calculation method may take account of trading spreads on the investments of the
share class or sub-fund, the value of any duties and charges incurred as a result of trading and may include an
allowance for market impact.
Where the Board, based on the prevailing market conditions and the level of subscriptions or redemptions re-
quested by shareholders or potential shareholders in relation to the size of the relevant share class or sub-fund,
has determined for a particular share class or sub-fund to apply an alternative net asset value calculation method,
the share class or sub-fund may be valued either on a bid or offer basis (which would include the factors referenced
in the preceding paragraph).
5. Addition of new letters g. to k. to point 2 of Article 12 "Frequency and temporary suspension of the calculation of
the net asset value and of the issue and redemption of shares" of the articles of incorporation, which shall read as
follows:
g. following the suspension of the (i) calculation of the net asset value per share, (ii) the issue, (iii) redemption and/
or (iv) the conversion of the units / shares issued within the master fund in which a sub-fund of the Company invests
in its quality as a feeder fund of such master fund;
h. during a period where the relevant indices underlying the derivative instruments which may be entered into by
the relevant sub-funds of the Company are not compiled or published;
i. during any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company, in particular
the derivative instruments and repurchase transactions which may be entered into by the Company in respect of
any sub-fund, cannot promptly or accurately be ascertained;
j. during any period when the dealing of the shares of the relevant share class or sub-fund of the Company on the
relevant stock exchanges where the shares of the relevant share class or sub-fund of the Company are listed is
suspended or restricted;
k. during any period during which the relevant stock exchanges on which the shares of the relevant share class or
sub-fund of the Company are listed are closed.
6. Amendment of point 1 and 2 of Article 13 "The Board of Directors" of the articles of incorporation, so as to read
as follows:
1. The Company is managed by a Board comprising at least three members. The members of the Board are not
required to hold shares in the Company. They are elected by the shareholders' meeting, in particular by the sha-
reholders at their annual general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or
until their successors are elected and qualify. The shareholders' meeting also determines the number of Board
members, their remuneration and their period of office, which may run for a maximum of six years. The Board
members may be re-elected. The shareholders' meeting may assign the day-to-day running of the business in its
entirety to one or more of the persons stipulated in Article 60 of the Law of 10 August 1915.
2. Board members are elected by a simple majority of the shares present or represented at the shareholders'
meeting and shall be subject to the approval of the Luxembourg regulatory authorities.
7. Amendment of letter i) and addition of a new letter j) of Article 18 "Investment policy and investment restrictions"
of the articles of incorporation, which shall read as follows:
i) The relevant sub-fund will not invest more than in aggregate 10% of its net asset value in units of UCITS or other
UCI unless the relevant appendix of such sub-fund in the prospectus of the Company explicitly provides for a
deviant investment policy in this respect. In particular, such appendix may allow the investment in units of a master
fund qualifying as a UCITS provided that the relevant sub-fund invests at least 85% of its net asset value in units of
such master fund and that such master fund shall neither itself be a feeder fund nor hold units/shares of a feeder
fund.
j) A sub-fund may invest in shares of another sub-fund of the Company (the "Target Sub-Fund") provided that
- the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the sub-fund invested in this Target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in
aggregate in units of other Target Sub-Funds; and
- voting rights attached to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the sub-fund concerned
and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these shares are held by the sub-fund, their value will not be taken into consideration
for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the
net assets as set out in Article 5 point 7; and
- there is no duplication of management, performance, subscription or redemption fees amongst the Target Sub-
Fund and the investing sub-fund.
8. Amendment of Article 21 "Remuneration of the Board" of the articles of incorporation which shall be renamed
"Remuneration and indemnification of the Board", so as to read as follows:
96204
L
U X E M B O U R G
The remuneration for Board members is determined by the shareholders' meeting.
Every Board member, managerial employee, managing director, agent, auditor or officer of the Company and his
personal representatives shall be indemnified and secured harmless out of the assets of the relevant sub-fund(s)
against all actions, proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities ("Losses") incurred or sus-
tained by him in or about the conduct of the Company business or affairs or in the execution or discharge of his
duties, powers, authorities or discretions, including Losses incurred by him in defending (whether successfully or
otherwise) any civil proceedings concerning the Company in any court whether in Luxembourg or elsewhere. No
such person shall be liable: (i) for the acts, receipts, neglects, defaults or omissions of any other such person; or
(ii) by reason of his having joined in any receipt for money not received by him personally; or (iii) for any loss on
account of defect of title to any property of the Company; or (iv) on account of the insufficiency of any security in
or upon which any money of the Company shall be invested; or (v) for any loss incurred through any bank, broker
or other agent; or (vi) for any loss, damage or misfortune whatsoever which may happen in or arise from the
execution or discharge of the duties, powers, authorities, or discretions of his office or in relation thereto, unless
the same shall happen through his own gross negligence or wilful misconduct against the Company.
9. Amendment of Article 26 "Dissolution and merger of sub-funds" of the articles of incorporation which shall be
renamed "Dissolution of sub-funds", so as to read as follows:
Without prejudice to the powers of the Board pursuant to Article 8 point 7, the meeting of the shareholders of a
sub-fund may resolve to reduce the Company assets by dissolving the sub-fund concerned and cancelling any shares
issued in such sub-fund and to pay out to the shareholders the unit price of the shares, as determined on the
valuation day on which the resolution takes effect, less any costs incurred in connection with liquidating the sub-
fund. No quorum is required at the general meetings of sub-fund shareholders and any resolutions put to the vote
of the meeting are passed by a simple majority of the shareholders present or shares represented.
Once a sub-fund has been liquidated, any liquidation proceeds relating to shares that have not been surrendered
will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg following the date on which the liquidation pro-
ceedings were completed.
The liquidation of a sub-fund shall have no influence on any other sub-fund. The liquidation of the last remaining
sub-fund will result in the Company's liquidation.
10. Addition of a new Article 27 "Mergers" of the articles of incorporation, which shall read as follows:
1. The Board may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010) of the
Company or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions
and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the
information to be provided to the shareholders, as follows:
a. The Board may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving or absorbed UCITS, with:
- another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS"); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Company concerned as Shares of this New UCITS, or of the
relevant sub-fund thereof as applicable.
In case the Company involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the Law of 17 December
2010), solely the Board will decide on the merger and effective date thereof.
In the case the Company involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the Law of 17 December
2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders has to approve, and decide on the effective
date of such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes
cast at such meeting.
b. The Board may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010) of any
Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- another existing Sub-Fund within the Company or another sub-fund within a New UCITS (the "New Sub-Fund");
or
- a New UCITS,
and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the
New Sub-Fund as applicable.
2. Notwithstanding the powers conferred to the Board under the preceding section, the general meeting of sha-
reholders may decide to proceed with a merger (within the meaning of the Law of 17 December 2010) of the
Company or of one of the Sub-Funds, either as receiving or absorbed UCITS or Sub-Fund, subject to the conditions
and procedures imposed by the Law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the
information to be provided to the shareholders, as follows:
a. The general meeting of the shareholders may decide to proceed with a merger of the Company, either as receiving
or absorbed UCITS, with:
- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof.
The decision shall be adopted by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum requi-
rement and which will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority
of the votes validly cast at such meeting.
96205
L
U X E M B O U R G
b. The general meeting of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the Law of 17 December
2010) of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:
- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund
by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.
3. Any cost associated with the preparation and the completion of the merger shall neither be charged to the
Company nor its shareholders.
Shareholders will in any case be entitled to request, without any charge other than those retained by the Company
or the Sub-Fund to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their shares, or, where possible,
to convert them into units or shares of another UCITS pursuing a similar investment policy and managed by the
same management company or by any other company with which the management company is linked by common
management or control, or by substantial direct or indirect holding, in accordance with the provisions of the Law
of 17 December 2010.
11. Renumbering of all Articles after the new Article 27 "Mergers" of the articles of incorporation and all references
thereto.
12. Miscellaneous.
The Meeting may validly deliberate on the items of the agenda with at least half of the capital of the Company present
or represented and the resolution on each item of the agenda may validly be passed by the affirmative vote of at least
two thirds of the votes validly cast at the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2011119081/755/177.
DJE Strategie II, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié au 29 juillet 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2011.
DJE Investment S.A.
Référence de publication: 2011113159/10.
(110130075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2011.
Crescendo SIF Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion modifié au 1
er
août 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2011.
DJE Investment S.A.
Référence de publication: 2011116474/9.
(110133857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.
Lux Multi Plus SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécia-
lisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 162.998.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, am zwölften August.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar
Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,
Ist erschienen:
Credit Suisse Solution Partners AG, mit Sitz in Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich, hier vertreten durch Jennifer BURR,
Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Zürich, am 11. August 2011.
Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument
beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.
96206
L
U X E M B O U R G
Die Erschienene hat in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, die
hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Name. Zwischen dem Unterzeichneten und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen
Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé, SICAV-FIS) gemäß dem Gesetz vom
13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von 2007“) unter dem Namen "Lux Multi Plus SICAV-
SIF" (die "Gesellschaft").
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland
gegründet werden.
Sofern nach Ansicht des Verwaltungsrats außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden ha-
ben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die
Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Norma-
lisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit
der Gesellschaft keinen Einfluss haben. Die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermö-
gens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und
mit dem Ziel, den Investoren die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von
2007.
Art. 5. Gesellschaftskapital / Wertpapiere / Teilfonds. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert
repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Artikel 12 ents-
prechen. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des
Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern. Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt
und hat sich zu jedem Zeitpunkt mindestens auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu be-
laufen. Dieses Mindestgesellschaftskapital ist innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als
spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht zu erreichen.
Das Gründungskapital beträgt 31.000 Euro (einunddreißigtausend Euro) und ist in 31 (einunddreißig) Aktien ohne
Nennwert eingeteilt.
Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass neben Aktien auch Genussscheine ausgegeben werden (gemein-
sam die „Wertpapiere“). Genussscheine sind nicht Bestandteil des Gesellschaftskapitals.
Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Wertpapiere der Gesellschaft verschiedenen zu errichtenden
Anlagevermögen (die "Teilfonds") angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Währungen notiert sein können.
Der Verwaltungsrat kann außerdem bestimmen, dass innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Wertpapierklassen
mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs-oder Thesaurierungspoli-
tik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifischen Merkmale wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und
im Platzierungsmemorandum der Gesellschaft beschrieben.
Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Wertpapiere werden gemäß den Bestimmungen im Platzierungsmemorandum
der Gesellschaft entsprechend der durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der ge-
setzlich festgelegten oder durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagegrenzen angelegt.
Art. 6. Wertpapiere und Zertifikate. Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich als Namensaktien und Genuss-
scheine ausschließlich als Namenspapiere ausgegeben.
Für diese Wertpapiere wird am Firmensitz der Gesellschaft ein Aktien-und ein Genussscheinregister geführt. Diese
Register enthalten jeweils den Namen eines jeden Investors, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen
Wertpapiere sowie ggf. das Datum der Übertragung eines jeden Wertpapiers. Die Eintragung im jeweiligen Register gilt
als Nachweis der Berechtigung der eingetragenen Person an solchen Aktien bzw. Genussscheinen.
Der Verwaltungsrat wird beschließen, ob Zertifikate ausgegeben werden oder ob der Investor eine Bestätigung der
Eintragung im jeweiligen Register erhält. Sofern Zertifikate ausgegeben werden, werden diese binnen eines Monats nach
Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Wertpapiere eingegangen sind. Zertifikate
werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Eine der beiden Unterschriften kann durch eine Person
erfolgen, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde.
Inhaber von Genussscheinen verfügen über kein Stimmrecht im Rahmen der Generalversammlungen der Aktionäre.
Sie werden jedoch an den Ausschüttungen und den Netto-Liquidationserlösen im Verhältnis zu ihrem Wertpapierbesitz
an der Gesellschaft bzw. an einem Teilfonds beteiligt. Die mit Genussscheinen zusammenhängenden Rechte können nicht
ohne vorherige Zustimmung ihrer Inhaber aufgehoben oder geändert werden.
96207
L
U X E M B O U R G
Wertpapiere werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben,
d.h. an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Ei-
nordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens 125.000 Euro in die Gesellschaft investieren oder (2)
über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im
Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihren Sach-
verstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Gesellschaft angemessen beurteilen zu können,
vorlegen.
Falls ein Investor Wertpapiere der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Drit-
ten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.
Eine Übertragung von Wertpapieren ist nur möglich, wenn der Käufer ein sachkundiger Anleger im Sinne Gesetzes
von 2007 ist und wenn er voll und ganz etwaige restliche Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt. Die
Übertragung von Wertpapieren wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das jeweilige Register einge-
tragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen
unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des jeweiligen Zertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft
kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.
Jeder Investor muss der Gesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung in das jeweilige Register mitteilen. Weicht diese
von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und An-
kündigungen der Gesellschaft zugunsten von Investoren können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt
werden. Der Investor kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderungen seiner Adresse im jeweiligen Register
beantragen.
Sofern ein Investor keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das
Register eingetragen wird. Die Adresse des Investors wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein, bis der
Investor der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.
Wertpapiere werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung eingegangen ist.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Investor pro Wertpapier an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes
oder eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Wertpapierbesitz verbundenen Rechte bis zu
dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begüns-
tigten und Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Die Gesellschaft kann Wertpapierbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimm-
recht; Aktien- bzw. Genussscheinsbruchteile berechtigen zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer
pro rata-Basis.
Art. 7. Verlust oder Zerstörung von Zertifikaten. Kann ein Investor gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form
nachweisen, dass ein Zertifikat über ein ihm gehörendes Wertpapier abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird
die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der Gesellschaft auf-
gestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die
durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft unterschrieben sein
muss. Mit der Ausgabe eines neuen Zertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das
Originalzertifikat jede Gültigkeit.
Verstümmelte oder beschädigte Zertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Zertifikate ausgetauscht werden.
Die verstümmelten oder beschädigten Zertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben
sofort für ungültig erklärt.
Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Investor Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten
zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Zertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung
des Originalzertifikates entstanden sind.
Art. 8. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Wertpapiere. Wertpapiere an der Gesellschaft sind sachkundigen An-
legern im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den
Besitz ihrer Wertpapiere durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist,
dass ein solcher Besitz:
- zu Lasten der Interessen der übrigen Investoren oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird;
oder
- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
a) die Ausgabe von Wertpapieren oder deren Umschreibung im Aktien- bzw. Genussscheinregister verweigern,
b) Wertpapiere zwangsweise zurücknehmen,
c) bei Generalversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht
aberkennen.
96208
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Ausgabe von Wertpapieren. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll
einbezahlter Wertpapiere zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Investoren ein Vorrecht zur Zeichnung neu
auszugebender Wertpapiere einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds die Häufigkeit der Ausgabe von Wertpapieren einer Wertpapierklasse
Einschränkungen unterwerfen; er kann insbesondere entscheiden, dass Wertpapiere ausschließlich während einer oder
mehrerer Zeichnungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen im Platzierungsmemorandum der Gesell-
schaft ausgegeben werden.
Der Ausgabepreis ist bei Ausgabe der Wertpapiere gänzlich oder teilweise auf die Weise zu entrichten, wie sie der
Verwaltungsrat für jeden Teilfonds bestimmt und im Platzierungsmemorandum nennt und ausführlich beschreibt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für jeden Teilfonds zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beis-
pielsweise Mindestzeichnungsbeträge, die Zahlung von Ausgabeaufschlägen oder Ausgleichszinsen oder das Bestehen von
Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Platzierungsmemorandum genannt und ausführlich beschrie-
ben.
Der Verwaltungsrat kann an jeden seiner Mitglieder, jeden Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen
ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis
neu auszugebender Wertpapiere in Empfang zu nehmen und diese Wertpapiere auszuliefern.
Die Gesellschaft kann im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewer-
tungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Wertpapiere gegen Lieferung von
Wertpapieren ausgeben, sofern eine solche Lieferung von Wertpapieren der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ents-
pricht und innerhalb seiner Anlagebeschränkungen erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von
Wertpapieren gegen Lieferung von Wertpapieren sind von den betreffenden Investoren zu tragen.
Wertpapiere müssen voll eingezahlt werden. Neu ausgegebene Aktien ha-ben dieselben Rechte wie die Aktien, die am
Tage der Aktienausgabe in Umlauf waren und neu ausgegebene Genussscheine haben dieselben Rechte wie die Genuss-
scheine, die am Tage der Genussscheinausgabe in Umlauf waren.
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder je-
derzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Wertpapieren auszusetzen.
Art. 10. Rücknahme von Wertpapieren. Jeder Investor kann innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgese-
henen Grenzen die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Wertpapiere durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen
und dem Verfahren, welche im Platzierungsmemorandum für die einzelnen Teilfonds festgelegt werden, verlangen. Der
Rücknahmepreis pro Wertpapier wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche zehn
Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Ver-
waltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Zertifikate und sonstige Unterlagen zur Übertragung
von Wertpapieren bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 13 dieser Sa-
tzung.
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der entsprechenden Wertpapierklasse gemäß Artikel 12 dieser Sa-
tzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen im Platzierungsmemorandum.
Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden, gemäß
Bestimmung des Verwaltungsrates.
Sofern die Zahl oder der gesamte Anteilwert von Wertpapieren, welche durch einen Investor in einer Wertpapier-
klasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom
Verwaltungsrat als Mindestzahl bzw. -wert festgelegt wurden, kann dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten
Besitzes des Investors in dieser Wertpapierklasse behandelt werden.
Wenn des weiteren an einem Bewertungstag die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß
Artikel 11 dieser Satzung gestellten Umtauschanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwal-
tungsrat festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder
Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat unter Berück-
sichtigung der Interessen aller Investoren für erforderlich gehalten wird. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden
in diesen Fällen am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.
Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an
jeden Investor, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Investor aus dem Portfolio der Vermögenswerte,
welche der/den entsprechenden Wertpapierklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (ents-
prechend der Bestimmungen gemäß Artikel 12) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis
berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Wertpapiere zugeteilt werden. Natur und Art der zu
übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und
ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Investoren der entsprechenden Wertpapierklasse(n) bestimmt und
die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer
solchen Übertragung trägt der Zessionar.
Der Verwaltungsrat kann eine zwangsweise Rücknahme der Wertpapiere beschließen, wenn er der Ansicht ist, dass
(i) der Besitz von Wertpapieren des betroffenen Investors zu Lasten der Interessen der übrigen Investoren oder der
96209
L
U X E M B O U R G
Gesellschaft bzw. eines Teilfonds geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
mit sich ziehen kann (insbesondere, wenn es sich bei dem betroffenen Investor nicht oder nicht mehr um einen Anleger
im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen
Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Gesellschaft bzw. eines Teil-
fonds in einer anderen Art und Weise schadet.
Des weiteren kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, Wertpapiere oder Wertpapierbruchteile der
Gesellschaft in Bezug auf einen oder mehrere Teilfonds zurückzukaufen, um auf die Weise den Erlös aus dem Verkauf
von Vermögenswerten des betroffenen Teilfonds an die Investoren auszuzahlen. Die Entscheidung zum Rückkauf ist
verbindlich für alle Investoren und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Wertpapierbesitz an der Gesellschaft bzw.
eines Teilfonds.
Der Rücknahmepreis entspricht in diesen Fällen dem Anteilwert am Tag der Rücknahme.
Die von der Gesellschaft zurückgekauften Wertpapiere werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rück-
nahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknah-
mepreises ausbezahlt.
Art. 11. Umtausch von Wertpapieren. Sofern durch den Verwaltungsrat im Platzierungsmemorandum nicht ander-
weitig festgelegt, ist jeder Investor berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Wertpapiere in Wertpapiere
einer anderen Wertpapierklasse desselben Teilfonds oder in Wertpapiere eines anderen Teilfonds bzw. einer Wertpa-
pierklasse eines anderen Teilfonds zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit,
Fristen und Bedingungen des Umtauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen
von der Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.
Der Preis für den Umtausch von Wertpapieren einer Wertpapierklasse in Wertpapiere einer anderen Wertpapier-
klasse desselben Teilfonds oder in Wertpapiere eines anderen Teilfonds bzw. einer Wertpapierklasse eines anderen
Teilfonds wird auf der Grundlage des jeweiligen Anteilwertes der beiden Wertpapierklassen bzw. der Wertpapierklasse
und des anderen Teilfonds an demselben Bewertungstag beziehungsweise zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem
Bewertungstag berechnet.
Sofern die Zahl der von einem Investor in einer Wertpapierklasse oder Teilfonds gehaltenen Wertpapiere oder der
gesamte Anteilwert der von einem Investor in einer Wertpapierklasse oder Teilfonds gehaltenen Wertpapiere aufgrund
eines Umtauschantrages unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde,
kann die Gesellschaft entscheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Investor in einer
solchen Wertpapierklasse oder Teilfonds gehaltenen Wertpapiere behandelt wird.
Wertpapiere, welche in Wertpapiere einer anderen Wertpapierklasse oder eines anderen Teilfonds bzw. Wertpa-
pierklasse eines anderen Teilfonds umgetauscht wurden, werden entwertet.
Art. 12. Anteilwert. Der Anteilwert pro Wertpapier jeder Wertpapierklasse wird in der jeweiligen Teilfondswährung
- wie im Platzierungsmemorandum festgesetzt - in dem vom Verwaltungsrat bestimmten und im Platzierungsmemorandum
aufgeführten Rhythmus, mindestens jedoch einmal pro Halbjahr („Bewertungstag“) berechnet und in der Regel in der
Währung der einzelnen Wertpapierklassen ausgedrückt.
Er wird durch Division der Nettovermögenswerte der Gesellschaft, das heißt der einer solchen Wertpapierklasse
zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der dieser Wertpapierklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten, durch die
Zahl der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Wertpapiere der entsprechenden Wertpapierklasse gemäß
den nachfolgend beschriebenen Bewertungsregeln berechnet. Der Anteilwert kann auf die nächste gängige Untereinheit
der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern
seit Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten erfolgten, auf
denen ein wesentlicher Anteil der jeweiligen Wertpapierklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert
wird, kann der Verwaltungsrat im Interesse der Investoren und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine
weitere Bewertung vornehmen.
Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Wertpapierklassen wird wie folgt vorgenommen:
I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:
(1) Die im jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Zielfondsaktien;
(2) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
(3) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Ent-
gelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);
(4) alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate,
Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und
ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Ge-
sellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um
Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken
gerecht zu werden);
96210
L
U X E M B O U R G
(5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können,
vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;
(6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese
nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt
werden;
(7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung
von Wertpapieren an der Gesellschaft;
(8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
(a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsaktien werden zum letzten festgestellten und erhältlichen
Rücknahmepreis bewertet.
(b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-
bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem
jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem
Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
(c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage
des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt.
Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an
jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
(d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der
Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
(e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert
oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der ents-
prechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grund-
lage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
(f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten
Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwal-
tungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der
Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder orga-
nisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet;
sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Anteilwert bestimmt wird, nicht liquidiert
werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und ver-
nünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.
(g) Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung
der resultierenden Anlagerendite, sukzessive dem Rücknahmepreis angepasst. Bei wesentlichen Änderungen der Markt-
bedingungen muss die Grundlage für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktrenditen ausgerichtet
werden.
(h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert
bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu
bestimmen ist.
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds aus-
gedrückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt bei der Depotbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn
solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat
aufgestellten Verfahren bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse
einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.
II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:
(1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
(2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
(3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Ma-
nagementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
(4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlich-
keiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter
Ausschüttungen der Gesellschaft);
(5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am
Bewertungstag entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rückstellungen, welche
96211
L
U X E M B O U R G
vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der Verwaltungsrat im
Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen hält;
(6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berück-
sichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages
solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen,
einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Ge-
bühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und Domizilierungsstelle,
Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahl- oder Vertriebss-
tellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche
sonstigen von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren an-
gemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren
und Kosten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Gebühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der
Aufrechterhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung,
den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von Platzierungsmemoranden, Werbeschriften, periodischen Berichten
oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, die Kosten sämtlicher Berichte an die Investoren, Steuern,
Gebühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit,
einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten
für Post, Telefon und Telex. Die Gesellschaft kann Verwaltungs-und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehren-
der Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.
III. Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:
Innerhalb eines Teilfonds können eine oder mehrere Wertpapierklassen eingerichtet werden:
a) Sofern mehrere Wertpapierklassen an einem Teilfonds ausgegeben sind, werden die diesen Wertpapierklassen
zuzuordnenden Vermögenswerte gemeinsam entsprechend der spezifischen Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ange-
legt, wobei der Verwaltungsrat innerhalb eines Teilfonds Wertpapierklassen definieren kann, um (i) einer bestimmten
Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer
bestimmten Gestaltung von Verkaufs-und Rücknahmeprovision und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im
Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebüh-
ren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Investoren oder sonstiger Gebühren und/oder (v) unterschiedlichen
Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Wertpapierklasse lauten soll und welche unter Bezugnahme
auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden, und/oder (vi) der
Verwendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Währung der je-
weiligen Wertpapierklasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen Teilfonds
abzusichern und/oder (vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den
gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, zu entsprechen;
b) Die Erträge aus der Ausgabe von Wertpapieren einer Wertpapierklasse werden in den Büchern der Gesellschaft
der Wertpapierklasse beziehungsweise den Wertpapierklassen zugeordnet, welche an dem jeweiligen Teilfonds ausge-
geben sind und der betreffende Betrag soll den Anteil der Netto-Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds, welche
der auszugebenden Wertpapierklasse zuzuordnen sind, erhöhen;
c) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, welche einem Teilfonds zuzuordnen sind, werden
der (den) an diesem Teilfonds ausgegebenen Wertpapierklasse(n), vorbehaltlich vorstehend a) zugeordnet;
d) Sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögens-
wert in den Büchern der Gesellschaft derselben Wertpapierklasse beziehungsweise denselben Wertpapierklassen
zugeordnet, wie der Vermögenswert, von welchem die Ableitung erfolgte und bei jeder Neubewertung eines Vermö-
genswertes wird der Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung der oder den entsprechenden Wertpapier-
klasse(n) in Anrechnung gebracht;
e) Sofern ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einer bestimmten Wertpapierklasse
zugeordnet werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Wertpapierklassen pro rata
im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteilwert oder in einer anderen Art und Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu
und Glauben festlegt, zugeordnet, wobei (i) dann, wenn Vermögenswerte für Rechnung mehrerer Teilfonds in einem
Konto gehalten oder als separater Pool von Vermögenswerten durch einen hierzu beauftragten Vertreter des Verwal-
tungsrates gemeinschaftlich verwaltet werden, die entsprechende Berechtigung jeder Wertpapierklasse anteilig ihrer
Einlage in dem betreffenden Konto oder Pool entsprechen wird und (ii) diese Berechtigung sich, wie im Einzelnen im
Platzierungsmemorandum der Gesellschaft beschrieben, entsprechend den für Rechnung der Wertpapiere erfolgenden
Einlagen und Rücknahmen verändern wird sowie schließlich (iii) die Verbindlichkeiten zwischen den Wertpapierklassen
anteilig im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Berechtigung an dem Konto oder Pool aufgeteilt werden;
f) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Investoren einer Wertpapierklasse wird der Anteilwert dieser Wertpa-
pierklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.
Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu
treffen und auszulegen.
96212
L
U X E M B O U R G
Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang
mit der Berechnung des Anteilwertes, welcher vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen
Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Anteilwertes beauftragt getroffen wird, endgültig und für die
Gesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Investoren bindend.
IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:
1. Zur Rücknahme ausstehende Wertpapiere der Gesellschaft gemäß Artikel 10 dieser Satzung werden als bestehende
Wertpapiere behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechen-
den Bewertungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem
Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit
der Gesellschaft;
2. Auszugebende Wertpapiere werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewer-
tungstag, an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Wertpapiere behandelt. Von
diesem Zeitpunkt an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zu Gunsten der
Gesellschaft;
3. alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, welche in anderen Währungen als der
Währung der jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertbe-
rechnung geltenden Devisenkursen bewertet;
4. sofern an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich verpflichtet hat
- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbind-
lichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Gesellschaft als
Vermögenswert der Gesellschaft verzeichnet;
- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung
der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten der Gesell-
schaft aufgeführt;
wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden
Bewertungstag nicht bekannt ist, dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.
Art. 13. Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des An-
teilwertes der Wertpapiere eines Teilfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:
- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen,
eine normale Verfügung über das Nettovermögen eines Teilfonds unmöglich wird, ohne die Interessen der Investoren
schwerwiegend zu beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträcht-
lichen Teils des Nettovermögens eines Teilfonds nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung eines Teilfonds
verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.
Die Aussetzung der Berechnung der Anteilwerte wird den Investoren per Post oder E-Mail an die im jeweiligen Register
eingetragenen Adressen mitgeteilt.
Art. 14. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht, welche nicht Aktionär oder Inhaber anderer Wertpapiere an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwal-
tungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den
Aktionären im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der
Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gene-
ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.
Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates
die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Ent-
scheidung über die Ernennung treffen.
Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-
und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel
20 dieser Satzung vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.
Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu
handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftsz-
96213
L
U X E M B O U R G
weckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder
des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese
Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.
Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen im von der Gesellschaft herausgegebenen Platzierungsmemorandum bes-
chrieben, einen Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) ("Anlageberater") abschließen, welche
im Hinblick auf die Anlagepolitik der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en). Der Verwaltungsrat
kann Investmentbeiräte für jeden einzelnen Teilfonds berufen und deren Vergütung festsetzen. Diese Beiräte sollen aus
fachkundigen Personen mit entsprechender Erfahrung bestehen. Die Beiräte haben lediglich eine beratende Funktion und
treffen keinerlei Anlageentscheidungen. Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privats-
chriftliche Urkunden übertragen.
Art. 17. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er
kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwe-
senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder
im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens acht Tage vor dem entspre-
chenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt
wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikations-
mittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten
werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung mit schriftlich, per Telegramm, Telefax
oder ähnliche Kommunikationsmittel erteilter Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere
Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenz-
schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Sofern sämtliche
Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sich damit einverstanden erklären, kann auf die
ordnungsgemäße Einberufung verzichtet werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle
einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Meh-
rheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten
sind.
Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen
Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei
Stimmengleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird
schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.
Art. 18. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Un-
terschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von
Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.
Art. 19. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der General-
versammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in
Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn,
solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 20. Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in
Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlage-
grenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Platzierungsmemorandum für die
jeweiligen Teilfonds beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betref-
fenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.
96214
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist an Ihre Beschlüsse gebunden. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit
der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,
zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg-
Stadt an einem in der Einladung angegebenen Ort am ersten Mittwoch des Monats März um 14.00 Uhr abgehalten. Ist
dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg, wird die jährliche Generalversammlung am nächst-
folgenden Bankarbeitstag abgehalten.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der
entsprechenden Einladung angegeben wird.
Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage
vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktienregister eingetragene Adresse
versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht
nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die
Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.
Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per
Einschreiben erfolgen.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an
einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind
(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).
Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch
eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-
neralversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Art. 22. Generalversammlungen der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse. Die Aktionäre der Ak-
tienklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlung abhalten, um über
Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.
Darüber hinaus, können die Aktionäre einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle
Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten.
Die relevanten Bestimmungen in Artikel 21 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.
Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der
Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche
kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalver-
sammlung eines Teilfonds oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst.
Art. 23. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer
Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.
Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit
dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um inne-
rhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu
bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Inves-
toren ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 24. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschafts-
prüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft
bezahlt wird.
Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
96215
L
U X E M B O U R G
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 21. September jeden Jahres und endet am 20.
September des folgenden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 20. September 2011.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Euro,
aufgestellt.
Art. 26. Ausschüttungen. Das Recht auf Ausschüttungen, einschließlich Zwischenausschüttungen, werden vom Ver-
waltungsrat für jede Wertpapierklasse eines jeden Teilfonds wie im Platzierungsmemorandum näher beschrieben und im
Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, bestimmt.
Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensaktien und -genussrechten erfolgt an deren im jeweiligen
Register vermerkte Adressen.
Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der
Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen
und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.
Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Guns-
ten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Wertpapierklasse(n).
Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden,
erfolgen keine Zinszahlungen.
Art. 27. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und
vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 30
dieser Satzung aufgelöst werden.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Sa-
tzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalver-
sammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der auf dieser Versammlung vertretenen
Aktien.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat auch dann vorge-
legt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung
fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung kann durch
die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten
Aktien halten.
Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der
Tatsache, dass das Gesellschaftskapital unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gefallen
ist, abgehalten werden kann.
Art. 28. Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann beschließen, einen oder mehrere
Teilfonds oder Wertpapierklassen zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Teilfonds oder Wertpapierklassen auf-
zulösen, indem die betroffenen Wertpapiere entwertet werden und den betroffenen Investoren der Anteilwert der
Wertpapiere dieses oder dieser Teilfonds oder Wertpapierklassen zurückerstattet wird. Der Verwaltungsrat kann eben-
falls beschließen, einen oder mehrere Teilfonds mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von
2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) nach dem Gesetz vom 17. Dezember
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder
eines solchen OGA zu verschmelzen.
Der Verwaltungsrat ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen
- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen
Anlagen für den jeweiligen Teilfonds getätigt werden oder in denen die Wertpapiere dieses Teilfonds vertrieben werden,
oder
- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente Ver-
waltung dieses Teilfonds nicht mehr gewährleistet werden kann, oder
- im Rahmen einer Rationalisierung, oder
- sofern ein im Platzierungsmemorandum für einen Teilfonds angegebenes Zielvolumen nicht erreicht wurde bzw. es
nicht absehbar ist, dass ein solches Zielvolumen erreicht werden kann.
Der Liquidationserlös, der von Investoren nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wurde, bleibt bei der De-
potbank für den nach Luxemburger Recht erforderlichen Zeitraum deponiert und wird anschließend bei der Caisse de
Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo er nach Ablauf der gesetzlichen Fristen verfällt.
Der Beschluss des Verwaltungsrates gemäß dem ersten Absatz dieses Artikels über die Verschmelzung eines oder
mehrerer Teilfonds wird den betroffenen Investoren mitgeteilt. In diesem Fall ist es den betroffenen Investoren erlaubt,
während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rücknahme oder den
kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Wertpapiere zu dem anwendbaren Anteilwert zu beantragen. Nach
Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Investoren bindend. Im Falle der Verschmelzung einer
oder mehrerer Wertpapierklassen der Gesellschaft mit einem luxemburgischen "fonds commun de placement" ist der
96216
L
U X E M B O U R G
Beschluss jedoch nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Investoren bindend, bei allen anderen Investoren wird
davon ausgegangen, dass sie einen Antrag auf Rücknahme ihrer Wertpapiere gestellt haben.
Der Erlös aus der Auflösung von Wertpapieren, der von den Investoren nach erfolgter Auflösung einer Wertpapier-
klasse nicht gefordert wurde, wird bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo er nach Ablauf der
gesetzlichen Fristen verfällt.
Die Gesellschaft hat die Investoren durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Verwaltungsrat
zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Investoren und ihre Adressen der Gesellschaft
bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.
Art. 29. Liquidation. Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits na-
türliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über
ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.
Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Investoren im Verhältnis zu ihrem
Wertpapierbesitz verteilt. Der Verwaltungsrat kann im Platzierungsmemorandum genauer regeln, wie im Hinblick auf die
verschiedenen Wertpapierklassen verfahren wird.
Wird die Gesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Bestimmungen spezifizieren die Verteilung der Liquidationserlöse und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de
Consignation für alle Beträge vor, die bei Abschluss der Liquidation von den Investoren nicht eingefordert wurden. Be-
träge, die dort innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des
Luxemburger Rechts.
Art. 30. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserforder-
nissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen (das "Gesetz von 1915") unterliegt, geändert werden.
Art. 31. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft
oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches
Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender
Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge
abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft
oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäfts-
beziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem
Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönli-
che Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen
teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder
leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.
"Entgegengesetztes Interesse" entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit
einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unterneh-
mung umfasst, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen benannt werden.
Art. 32 Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender Ände-
rungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf EUR 4.000,- veranschlagt.
<i>Zeichnung des Gründungskapitalsi>
Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
Credit Suisse Solution Partners AG, vorgenannt, zeichnet einunddreißig (31) Aktien zum Gegenwert von einunddreißig-
tausend Euro (EUR 31.000,-).
Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-). Die Einzahlung des gesamten
Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
96217
L
U X E M B O U R G
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzü-
glich folgende Beschlüsse gefasst:
I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Eduard von Kymmel, geboren am 13. März 1973 in Jugenheim (jetzt Seeheim-Jugenheim), Deutschland, beruflich
ansässig in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
- Heinrich Hugenschmidt, geboren am 3. Juni 1964 in Basel, Schweiz, beruflich ansässig in Paradeplatz 8, CH-8070
Zürich, Schweiz;
- Jean-Paul Gennari, geboren am 25. Januar 1958 in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, beruflich ansässig
in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ersten jährlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
II. Sitz der Gesellschaft ist 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.
III. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung wird im Jahre 2012 stattfinden.
IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., mit Sitz in 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, RCS Luxembourg B 65.477.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ersten jährlichen Generalversammlung des Jahres 2012.
Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienene, welche dem unterzeichneten Notar dem
Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt ist, hat dieselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J. BURR und C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 août 2011. Relation: LAC/2011/36945. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 6. September 2011.
Référence de publication: 2011118935/672.
(110136659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.
Instore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 142.597.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third of August.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Tradegro S.à r.l., a company organised and existing in accordance with the laws of Luxembourg with registered office
at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, and registered with the number B 149.807,
here represented by Mr ADRIAN DOBBYN, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on August 23
rd
, 2011.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
existing under the name of "INSTORE HOLDINGS S.à r.l.", R.C.S. Luxembourg Number B 142.597, with its registered
office address at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître
Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated October 14, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Number 2737 of 11 November, 2008.
- The Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500)
shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1.1 To transfer the registered office of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Gibraltar with effect
from the date of this meeting (or as soon thereafter as the present meeting may be held) without the Company being
dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;
1.2 To adopt the legal form of a Gibraltar Private Company with the name “Instore Holdings Limited” under the
Gibraltar Companies Act. The change of nationality and the transfer of the registered office does not legally give rise to
the dissolution of the Company or the incorporation of a new company, provided that the Company will be registered
with the Gibraltar Companies House;
96218
L
U X E M B O U R G
1.3 To adopt new Memorandum and Articles of Association in compliance with the laws of Gibraltar and to authorise
TRIAY STAGNETTO NEISH, Barristers & Solicitors, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar to execute the new Me-
morandum and Articles of Association on behalf of the Company;
1.4 To approve the balance sheet of the Company as at 31 July 2011;
1.5 To acknowledge the resignation of Mr Hermanus Roelof Willem Troskie as manager of the Company and to give
full discharge to him for the performance of his duties;
1.6 To acknowledge the resignation of Mr Gabriel Jacobus Minnaar as manager of the Company and to give full discharge
to him for the performance of his duties;
1.7 To acknowledge the resignation of Mr Cornus Moore as manager of the Company and to give full discharge to
him for the performance of his duties;
1.8 To appoint Mr Cornus Moore as director of the Company in Gibraltar;
1.9 To appoint Mr Louis B. Triay as director of the Company in Gibraltar;
1.10 To establish the registered office of the Company at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar; and
1.11 To appoint Trilex Secretaries Limited as secretary of the Company in Gibraltar.
The sole shareholder then passed the following resolutions with unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company is transferred from the Grand Duchy of Luxembourg to Gibraltar with effect
from the date of this meeting without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal
continuance.
<i>Second resolutioni>
The Company adopts the legal form of a Gibraltar Private Company with the name “Instore Holdings Limited” under
the Gibraltar Companies Act. The change of nationality and the transfer of the registered office does not legally give rise
to the dissolution of the Company or the incorporation of a new company, provided that the Company will be registered
with the Gibraltar Companies House.
<i>Third resolutioni>
The Company adopts new Memorandum and Articles of Association in compliance with the laws of Gibraltar and
authorise TRIAY STAGNETTO NEISH, Barristers & Solicitors, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar to execute the
new Memorandum and Articles of Association on behalf of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Company approves the balance sheet of the Company as at 31 July 2011.
<i>Fifth resolutioni>
The Company acknowledges the resignation of Mr Hermanus Roelof Willem Troskie as manager of the Company and
gives full discharge to him for the performance of his duties.
<i>Sixth resolutioni>
The Company acknowledges the resignation of Mr Gabriel Jacobus Minnaar as manager of the Company and gives full
discharge to him for the performance of his duties.
<i>Seventh resolutioni>
The Company acknowledges the resignation of Mr Cornus Moore as manager of the Company and to give full discharge
to him for the performance of his duties.
<i>Eighth resolutioni>
The Company appoints Mr Cornus Moore as director of the Company in Gibraltar.
<i>Ninth resolutioni>
The Company appoints Mr Louis B. Triay as director of the Company in Gibraltar.
<i>Tenth resolutioni>
The Company establishes its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.
<i>Eleventh resolutioni>
The Company appoints Trilex Secretaries Limited as secretary of the Company in Gibraltar.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
96219
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, this person signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-trois août.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Tradegro S.à r.l., une société organisée et existante suivant la loi de Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 149.807
et avec siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
ici représentée par Monsieur Adrian DOBBYN, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 23 août 2011.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «INSTORE
HOLDINGS S.à r.l.», R.C.S. Luxembourg Numéro B 142.597, ayant son siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg (la «Société»), constituée suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 14 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2737 du 11 novembre
2008.
- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entière-
ment libérées.
- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1.1 Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers Gibraltar avec effet à partir de la date
de cette assemblée (ou aussi rapidement après que la présente assemblée sera tenue) sans dissolution de la société mais
au contraire avec pleine continuation sociale et légale;
1.2 Adoption de la forme légale d'une Société Privée de Gibraltar sous la dénomination de “Instore Holdings Limited”
sous le «Gibraltar Companies Act». Le changement de nationalité et le transfert du siège social n'entraînent pas légalement
la dissolution de la Société ou la constitution d'une nouvelle société, sous réserve que la Société soit inscrite au registre
des Sociétés à Gibraltar;
1.3 Adoption d'un nouveau Mémorandum et de nouveaux Statuts en conformité avec la loi de Gibraltar et autorisation
à donner à TRIAY STAGNETTO NEISH, Barristers & Solicitors, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar pour exécuter
le nouveau Mémorandum et les nouveaux Statuts pour le compte de la Société;
1.4 Approbation du bilan au 31 juillet 2011;
1.5 Acceptation de la démission de Monsieur Hermanus Roelof Willem Troskie de son poste de gérant de la société
et pleine décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat;
1.6 Acceptation de la démission de Monsieur Gabriel Jacobus Minaar de son poste de gérant de la société et pleine
décharge à lui accorder pour l'exécution de son mandat;
1.7 Acceptation de la démission de Monsieur Cornus Moore de son poste de gérant de la société et pleine décharge
à lui accorder pour l'exécution de son mandat;
1.8 Nomination de Monsieur Cornus Moore comme directeur de la société à Gibraltar;
1.9 Nomination de Monsieur Louis B. Triay comme directeur de la société à Gibraltar;
1.10 Etablissement du siège social de la société au Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar; et
1.11 Nomination de Trilex Secretaries Limited comme secrétaire de la société à Gibraltar.
L'actionnaire unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Le siège social de la Société est transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers Gibraltar avec effet à partir de la date
de cette assemblée sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation sociale et légale.
<i>Deuxième résolutioni>
La Société adopte la forme légale d'une Société Privée de Gibraltar sous la dénomination de “Instore Holdings Limited”
sous le «Gibraltar Companies Act». Le changement de nationalité et le transfert du siège social n'entraînent pas légalement
la dissolution de la Société ou la constitution d'une nouvelle société, sous réserve que la Société soit inscrite au registre
des Sociétés à Gibraltar.
96220
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
La Société adopte un nouveau Mémorandum et de nouveaux Statuts en conformité avec la loi de Gibraltar et autorise
TRIAY STAGNETTO NEISH, Barristers & Solicitors, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar pour exécuter le nouveau
Mémorandum et les nouveaux Statuts pour le compte de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
La Société approuve le bilan au 31 juillet 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
La Société accepte la démission de Monsieur Hermanus Roelof Willem Troskie de son poste de gérant de la Société
et lui donne pleine décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Sixième résolutioni>
La Société accepte la démission de Monsieur Gabriel Jacobus Minaar de son poste de gérant de la Société et lui donne
pleine décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Septième résolutioni>
La Société accepte la démission de Monsieur Cornus Moore de son poste de gérant de la société et lui donne pleine
décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Huitième résolutioni>
La Société nomme Monsieur Cornus Moore comme directeur de la Société à Gibraltar.
<i>Neuvième résolutioni>
La Société nomme Monsieur Louis B. Triay comme directeur de la Société à Gibraltar.
<i>Dixième résolutioni>
La Société établit son siège social au Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar.
<i>Onzième résolutioni>
La Société nomme Trilex Secretaries Limited comme secrétaire de la Société à Gibraltar.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; et qu'à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: A. Dobbyn et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 août 2011. LAC/2011/37938. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2011.
Référence de publication: 2011121047/168.
(110139200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2011.
CM-Equity, Fonds Commun de Placement.
AUFLÖSUNG
Gemäß Beschluss des Vorstandes der Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. vom 8. August 2011 wurde das
Sondervermögen CM-Equity geschlossen, da innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten kein Geld in den Fonds
geflossen ist.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, im August 2011.
<i>Für den Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2011122238/1346/10.
96221
L
U X E M B O U R G
Jarden Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 36.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 152.067.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of June.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appears:
Jarden Corporation, a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, the United States of America,
having its address at 555 Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York 10580, the United States of America
(the “Sole Shareholder”).
Here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established in Luxembourg on June 20
th
, 2011.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the Sole Shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
existing in Luxembourg under the name of “Jarden Lux Holdings S.à r.l.” (the “Company”), registered with the Luxembourg
Trade and Company Register, section B, under number 152.067, with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on March 19
th
, 2010 published in the Mémorial
C – Recueil des Sociétés et Associations, number 920, on May 3
rd
, 2010. The articles of association have been amended
for the last time by a deed of the undersigned notary on May 18
th
, 2011, not yet published in the Mémorial C – Recueil
des Sociétés et Associations.
II. The Sole Shareholder resolved to change the powers of the managers so that the Company shall obligatory be
bound by the signature of all its managers. Premier feuillet
III. Pursuant to the above resolution, article 11 of the articles of association of the Company is amended and shall
henceforth be read as follows:
“ Art. 11. Powers of the Manager(s) In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager or, in case of plurality
of managers, by the signature of all the managers of the Company. In case the managers are split in two categories, the
Company shall obligatorily be bound by the signature of all the category A and the category B managers.
If the managers are temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole shareholder or, in
case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.
The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxyholders, selected from its members or not either shareholders or not”.
IV. The Sole Shareholder further resolved to amend article 13 of the articles of association of the Company which
shall henceforth be read as follows:
“ Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The board of managers may elect a chairman from among its members.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication
including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
The board of managers can only validly debate and make decisions if all of its members is present or represented by
proxies. In case the managers are split in two categories, all the category A and the category B managers shall be present
or represented. Any decisions made by the board of managers shall require the unanimous vote of the category A and
the category B Managers.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 below, the quorum requirement shall apply without taking into
account the affected manager or managers.
96222
L
U X E M B O U R G
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.
A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board
of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the board of managers”.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by his Surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Jarden Corporation, une société constituée sous le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
au 555 Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York 10580, Etats-Unis d'Amérique («l'Associée Unique»).
Ici représentée par Madame Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 juin 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'Associée Unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «Jarden Lux Holdings S.à r.l.» (la «Société»), ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152.067, con-
stituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 2010, publié au Mémorial C – Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 920, le 3 mai 2010. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du
notaire soussigné, en date du 18 mai 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. L'Associée Unique décide de modifier les pouvoirs des gérants afin que la Société soit obligatoirement engagée par
la signature de tous ses gérants.
III. Suite à la résolution ci-dessus, l'article 11 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
« Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir
au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du conseil de gérance.
Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature de tous ses gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société sera
obligatoirement engagée par la signature de tous les gérants de catégorie A et de catégorie B.
Si les gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en
cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés
parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas».
IV. L'associée unique décide également de modifier l'article 13 des statuts de la Société pour que celui-ci ait désormais
la teneur suivante:
« Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le
président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
96223
L
U X E M B O U R G
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si tous ses membres sont présents
ou représentés par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, tous les gérants de
catégorie A et de catégorie B devront être présents ou représentés.
Toute décision du conseil de gérance doit être prise à l'unanimité.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre
en compte le ou les gérants concernés.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de l'entité comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même entité et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 juin 2011. Relation: ECH/2011/1042. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 1
er
juillet 2011.
Référence de publication: 2011090946/147.
(110102588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2011.
PG Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.008,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 71.259.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique le 28 juin 2011i>
L'associé unique de la société décide d'élire Ernst & Young, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, comme réviseur d'entreprise avec effet immédiat et pour une période prenant fin lors de
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PG Europe 1 S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2011094737/15.
(110106814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
96224
L
U X E M B O U R G
Lex Investments Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 93.496.
Le bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 4 July 2011.
Leslie PERLMAN / Egbert LE ROUX
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011094113/12.
(110106500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.
Lexfin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 93.497.
Le bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 4 July 2011.
Leslie PERLMAN / Egbert LE ROUX
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011094114/12.
(110106493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2011.
Repco 22 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 203.540,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 114.185.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2011i>
1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel demeurant
professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7
Juin 2011.
2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz demeurant
professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7
Juin 2011.
3. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac demeurant
professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de ses fonctions d'"Administrateur A" avec effet au 7
Juin 2011.
4. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Pii Ketvel demeurant professionnellement à 2,
rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur"avec effet au 7 Juin 2011.
5. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Bernd Janietz demeurant professionnellement
à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur"avec effet au 7 Juin 2011.
6. L'assemblée générale extraordinaire de la Société nomme Monsieur Michael Chidiac demeurant professionnellement
à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en qualité' d'"Administrateur"avec effet au 7 Juin 2011.
Le conseil d'administration de la Société' se compose désormais comme suit:
- Monsieur Pii Ketvel (Administrateur)
- Monsieur Bernd Janietz (Administrateur)
- Monsieur Michael Chidiac (Administrateur)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Juillet 2011.
Référence de publication: 2011100733/30.
(110114053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.
96225
L
U X E M B O U R G
AXA Assurances Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 53.466.
<i>Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2008i>
Démissions et nominations:
L'Assemblée Générale prend acte de la démission des administrateurs:
M.Christophe DUPONT-MADINIER
Mme Christine LEFEBVRE
L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateurs:
M. Noël RICHARDSON (en remplacement de M.Christophe DUPONT-MADINIER), adresse privée: Avenue des
Coccinelles 2 à B-1170 Bruxelles / Belgique;
M. Georges HENGEN, adresse privée: Rue Auguste Liesch 44 à L-1937 Luxembourg.
Leurs fonctions prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes 2008.
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de la Sàrl PriceWaterhouseCoopers aux fonctions de réviseurs indépen-
dants. Leurs fonctions prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2008.
Pour extrait conforme
Claudine FRUTSAERT
<i>Secrétaire de l'Assemblée Généralei>
Référence de publication: 2011097486/24.
(110111039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Jaguar Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 293, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 12.727.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 mai 2011.i>
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué, à savoir:
- Monsieur Willy VAN GORP, administrateur de sociétés, résidant à B-3060 Bertem, BOSSTRAAT 127.
Monsieur Willy VAN GORP est nommé président du conseil d'administration.
- Monsieur Pierre Henriet, administrateur de sociétés, résidant à L-1459 Luxembourg, 4, Ancienne Côte d'Eich.
- Monsieur Jean-Louis RIGAUX, administrateur de sociétés, résidant à L-8147 Bridel, 11, rue des Prés.
Monsieur Jean-Louis RIGAUX est nommé administrateur délégué.
- Monsieur Giovanni ROSSI, administrateur de sociétés, résidant à L-8211 Mamer, 87, roule d'Arlon.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les résultats de l'exercice se clôturant au
31.12.2011.
L'assemblée décide de renouveler, à la fonction de commissaire aux comptes et jusqu'à l'Assemblée Générale statuant
sur les résultats de l'exercice se clôturant au 31.12.2011:
- La société HRT Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2011.
<i>Pour JAGUAR LUXEMBOURG S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2011097637/25.
(110110821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
96226
L
U X E M B O U R G
AnBeVir S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 38, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 113.453.
<i>Décisions collectives des associées prises en date du 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2011i>
L’an deux mille onze, le 1
er
juillet, les associées représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité
limitée AnBeVir S.àr.l., susvisée, ont pris la résolution suivante:
La démission de la gérante, Madame Belen Munoz est acceptée à compter du 1
er
juillet 2011.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2011.
<i>Les associéesi>
Référence de publication: 2011094270/13.
(110107150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
L.V.M.D., Location Vente Matériel Décontamination S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm.
R.C.S. Luxembourg B 110.145.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011094605/9.
(110106987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
AXA Assurances Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 53.466.
<i>Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2011i>
Démissions et nominations:
L'Assemblée Générale approuve la décision de cooptation comme administrateur et Président:
- M. Jacques de Vaucleroy (pour poursuivre le mandat d'Alfred Bouckaert), adresse privée: avenue de la Faisanderie
1/A à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre/Belgique
Décision prise par le Conseil d'administration en date du 8 juin 2010, l'échéance de leur mandat est prévue à l'issue
de l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'année 2012.
L'Assemblée Générale approuve la décision de cooptation comme administrateur:
- M. Patrick Lemoine (pour poursuivre le mandat de Noël Richardson), adresse professionnelle: boulevard du Souverain
25 à B-1170 Bruxelles/Belgique
Décision prise par le Conseil d'administration en date du 19 septembre 2010, l'échéance de leur mandat est prévue à
l'issue de l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'année 2012.
L'Assemblée Générale acte la démission du mandat d'administrateur de:
M Noël Richardson en date du 30 août 2010,
M Georges Hengen en date du 31 décembre 2010,
M François Lemonnier en date du 24 mars 2011,
M François Robinet en date du 24 mars 2011.
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de la sàrl PriceWaterhouseCoopers aux fonctions de réviseurs indépen-
dants. Leurs fonctions prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'année
2011.
Pour mentions aux fins de la publications au Mémorial, au Recueil des sociétés et associations.
Luxembourg, le 04 juillet 2011.
Pour extrait conforme
Claudine FRUTSAERT
<i>Secrétaire de l'Assemblée Généralei>
Référence de publication: 2011097483/32.
(110111039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
96227
L
U X E M B O U R G
Nikky Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.539.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 9 mai 2011i>
- La démission de DELOITTE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- FIN-CONTRÔLE S.A., ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, est nommée
Commissaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE S.A. Son mandate viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de 2012.
Luxembourg, le 9 mai 2011.
Certifié sincère et confome
NIKKY INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur de Catégorie Bi> / <i>Administrateur de Catégorie Bi>
Référence de publication: 2011094675/17.
(110106661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Key-Way S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass.
R.C.S. Luxembourg B 162.023.
STATUTS
L'an deux mille onze, le premier juillet.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1. La société anonyme "MGD-Participations S.A.", établie et ayant son siège social à L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 134.451, valablement
représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Guy DEGEY;
2. La société anonyme "TKMB-PARTICIPATIONS S.A.", établie et ayant son siège social à L-8720 Rippweiler, 14,
Haaptstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 83.363,
valablement représentée par Monsieur Jean-Guy DEGEY, qualifié ci-avant, agissant en vertu d'une procuration sous seing
privé donnée par ses deux administrateurs-délégué Madame Brigitte BERNARD et Monsieur Mathias HENN à Rippweiler,
le 30 juin 2011, laquelle procuration, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement;
3. Madame Kato Rina PAPP, commerçante, épouse BRASSEUR, née le 28 août 1964 à Schaerbeek (B), demeurant à
B-4520 Moha, 18, rue Georges Hubin.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer
entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «KEY-WAY S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Winseler. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le commerce en général et plus spécifiquement le commerce de meubles meublants de
magasins avec toutes les activités connexes et annexes.
La société peut en outre exercer toutes opérations industrielles, hypothécaires, commerciales ou financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille six cents euro (12.600.-EUR) divisé en quarante-deux (42)
parts sociales de trois cents euro (300.-EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le
consentement exprès des autres associés.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
96228
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un des associés. En cas de décès d'un
des associés, la société continuera entre le ou les associé(s) survivant(s) et les héritiers de l'associé décédé. La société
ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un
d'eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions
légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.
<i>Souscription:i>
Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:
La société anonyme "MGD-Participations S.A.", prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 parts sociales
La société anonyme "TKMBPARTICIPATIONS S.A." prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 parts sociales
Madame Kato Rina BRASSEUR-PAPP, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 parts sociales
La libération du capital social a été faite par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille six cents
euro (12.600.EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille euro (1.000.-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants qualifiés ci-avant représentant l'intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à trois dont deux gérants administratifs et un gérant technique.
2.- Sont nommés comme gérants administratifs:
1. La société anonyme "MGD-Participations S.A.", et la société anonyme "TKMB-PARTICIPATIONS S.A.", désignées
ci-avant.
Est nommé comme gérant technique:
- Madame Kato Rina PAPP, épouse BRASSEUR, prénommée
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants. Pour tous les engagements du domaine
technique la signature du gérant technique est obligatoire.
3.- L'adresse du siège social est fixée à L-9638, Pommerloch, 5, an der Gaass.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.
Signé: Degey, Papp, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30363. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 11 juillet 2011.
Référence de publication: 2011097648/84.
(110110324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
96229
L
U X E M B O U R G
Maybach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 67.848.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2011094650/10.
(110106825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
MHREC Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 115.575.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MHREC REAL ESTATE S.à.r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2011094656/11.
(110106931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Nouvelle Société Vins du Portugal S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4640 Differdange, 19, avenue d'Obercorn.
R.C.S. Luxembourg B 107.382.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2011i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession de parts
<i>Résolution prise:i>
<i>Les associés:i>
1) Monsieur Michel ALVES RIBEIRO, commerçant, né à Differdange, le 13 octobre 1980, demeurant à L-4591 Differ-
dange, 1, rue des Jardins (98 parts sociales)
2) Monsieur Alexandrino ALVES RIBEIRO, ouvrier, né à Teixeira Baiao, Portugal, le 8 janvier 1983, demeurant à L-4591
Differdange, 1, rue des Jardins (2 parts sociales)
de la société à responsabilité limitée NOUVELLE SOCIETE VINS DU PORTUGAL, ayant son siège social à L-4640
Differdange, 19, avenue d'Oberkorn,
ont pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
1) Monsieur Michel ALVES RIBEIRO, propriétaire de 98 parts de la société à responsabilité limitée NOUVELLE SO-
CIETE VINS DU PORTUGAL, établie et ayant son siège social à Differdange;
Monsieur Michel ALVES RIBEIRO cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, à Monsieur Alexandrino
ALVES RIBEIRO, qui accepte, 74 parts sociales de la société dont il s'agit.
Après la cession mentionnée ci-dessus (résolution unique), le capital social de la société NOUVELLE SOCIETE VINS
DU PORTUGAL S.à r.l., représenté par cent (100) parts sociales, est réparti comme suit:
Monsieur Michel ALVES RIBEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
Madame Alexandrino ALVES RIBEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
96230
L
U X E M B O U R G
<i>Prixi>
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Monsieur Michel
ALVES RIBEIRO reconnaît avoir reçu et en donnant quittance.
Fait à Differdange, le 29 juin 2011, en 2 exemplaires.
Michel ALVES RIBEIRO / Alexandrino ALVES RIBEIRO.
Référence de publication: 2011098897/33.
(110110976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Midgard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 110.996.
EXTRAIT
L'associé unique de la société a décidé de révoquer avec effet immédiat M. Eric Assimakopoulos de son poste de gérant.
Luxembourg, 6 juillet 2011.
Référence de publication: 2011094658/10.
(110106668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Midgard Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 110.996.
Le siège social de l'associé Breevast Midgard (ancienn. Midgard Holding) est dorénavant au Kaya Richard J. Beaujon Z/
N, Curaçao, Antilles Néerlandaises.
Luxembourg, le 6 juillet 2011.
Référence de publication: 2011094659/10.
(110106668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
ML Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 17, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 129.380.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832
L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011094661/13.
(110106602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Aggmore Kaufmann Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 136.277.
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique du 16 juin 2011i>
En date du 16 juin 2011, l'associé unique a décidé que:
1. Les démissions de Xenia KOTOULA et Jorge PÉREZ LOZANO, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, en tant que gérants de classe C de la Société sont acceptées avec effet à partir du 16 juin 2011;
2. Les nominations de Matthijs BOGERS, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays-Bas, et Julien FRANÇOIS, né le
18 juin 1976 à Messancy, Belgique, tous deux avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en tant que gérants de classe C de la Société sont acceptées avec effet à partir du 16 juin 2011 et pour une période
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
96231
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 4 juillet 2011.
<i>Pour Aggmore Kaufmann Ventures S.à r.l.
i>Représentée Matthijs BOGERS
<i>Gérant de classe Ci>
Référence de publication: 2011094994/21.
(110106789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Amber Trust Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.025.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires en date du 30 juin 2011i>
A/ L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé de renouveler le mandat des membres du Conseil de
Surveillance:
- Mr. Ian Hague, ayant son adresse professionnelle au 152, West 57
th
Street, 24
th
floor, New York, NY 10019 (États-
Unis d'Amérique);
- Mr. Michael Nellemann Pedersen, ayant son adresse professionnelle au 8 Rønvej, DK - 2600 Glostrup (Danemark);
- Mrs. Majken Hauge Johansen, ayant son adresse professionnelle au 22 Folkets Alle, Frederiksberg, DK 2000 (Dane-
mark);
- Mrs. Joanne Tuckman, ayant son adresse professionnelle au 152, West 57
th
Street, 24
th
floor, New York, NY 10019
(États-Unis d'Amérique);
- Mr. Lars Eigen Møller, ayant son adresse professionnelle au 76, Kajerødvej, Birkerød, DK - 3460 (Danemark);
- Mr. Clyde Anderson, ayant son adresse professionnelle au 402, Industrial Lane, Birmingham, AL 35211 (Etats-Unis
d'Amérique)
Jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en vue d'approuver les comptes au 31 décembre
2011.
B/ L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé de renouveler le mandat des membres du Conseil du
Directoire:
- Mr. Klaus Ebert, ayant son adresse professionelle au 13, rue Edward Steichen, L-2011 Luxembourg;
- Mr. Harvey Sawikin, ayant son adresse professionelle au 152, West 57
th
Street, 24
th
floor, New York, NY 10019
(États-Unis d'Amérique);
- Mr. Kustaa Äimä, ayant son adresse professionelle au 14C, Kalevankatu, 00100 Helsinki (Finlande);
- Mr. Martynas Cesnavicius, ayant son adresse professionelle au 6-6, A. Smetonos, 01115 Vilnius (Lituanie).
Jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en vue d'approuver les comptes au 31 décembre
2011.
C/ L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:
- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand-Duché de Luxem-
bourg)
Jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en vue d'approuver les comptes au 31 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Amber Trust Management S.A.
Référence de publication: 2011097471/37.
(110110496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Motion Connect S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 142.941.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L’Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011094663/10.
(110107239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
96232
L
U X E M B O U R G
MS Design S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 149.008.
Le bilan de la société au 31/12/2010 (bilan rectificatif en remplacement du bilan déposé le 17/06/2011 – n°L110094195)
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011094666/13.
(110107112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
AXA Assurances Vie Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 53.467.
<i>Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2011i>
Démissions et nominations:
L'Assemblée Générale approuve la décision de cooptation comme administrateur et Président:
- M. Jacques de Vaucleroy (pour poursuivre le mandat d'Alfred Bouckaert), adresse privée: avenue de la Faisanderie
1/A à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre/Belgique
Décision prise par le Conseil d'administration en date du 8 juin 2010, l'échéance de leur mandat est prévue à l'issue
de l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'année 2012.
L'Assemblée Générale approuve la décision de cooptation comme administrateur:
- M. Patrick Lemoine (pour poursuivre le mandat de Noël Richardson), adresse professionnelle: boulevard du Souverain
25 à B-1170 Bruxelles/Belgique
Décision prise par le Conseil d'administration en date du 19 septembre 2010, l'échéance de leur mandat est prévue à
l'issue de l'Assemblée Générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'année 2012.
L'Assemblée Générale acte la démission du mandat d'administrateur de:
M Noël Richardson en date du 30 août 2010,
M Georges Hengen en date du 31 décembre 2010,
M François Robinet en date du 24 mars 2011.
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de la sàrl PriceWaterhouseCoopers aux fonctions de réviseurs indépen-
dants. Leurs fonctions prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'année
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 juillet 2011.
Pour extrait conforme
Claudine FRUTSAERT
<i>Secrétaire de l'Assemblée Généralei>
Référence de publication: 2011097490/31.
(110111038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
N.C. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.129.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011094668/10.
(110107474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
96233
L
U X E M B O U R G
Nova Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.173.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011094671/9.
(110107559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Novator Telecom Finland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.214.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011094672/9.
(110107558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Dumatin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 38.194.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2011 que le mandat des organes sociaux étant
venu à échéance, ont été:
a) renommés administrateurs
- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont
- Monsieur Nicolas SCHAEFFER jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue
de la Porte-Neuve.
b) nommé administrateur
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, en remplacement de Madame Gabrielle SCHNEIDER,
b) renommée commissaire aux comptes
- INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 4 juillet 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2011097551/26.
(110110940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Najac-Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 113.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NAJAC-CORP S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2011094673/11.
(110107206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
96234
L
U X E M B O U R G
Nordic Investment Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 140.418.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 31 mai 2011, que:
Monsieur Kim DENGLER JENSEN démissionne de sa fonction de gérant.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2011094676/11.
(110106512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Confédération Caritas Luxembourg A.s.b.l., Confédération luxembourgeoise d'oeuvres catholiques de
charité et de solidarité association sans but lucratif, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg F 1.192.
<i>Changements de statuts, approuvés par l'Assemblée générale du 20 juin 2011i>
Les changements, c.-à-d. les phrases ajoutées sont marquées en jaune:
Ajoute à l'article 1
er
:
I. Dénomination, Siège et Objet
Art. 1
er
. L'association prend la dénomination «Confédération luxembourgeoise d'œuvres catholiques de charité et
de solidarité, association sans but lucratif», en abrégé «Confédération Caritas Luxembourg asbl». Elle est désignée ci-
après: «la confédération».
Dans toutes ses activités, la confédération a aussi le droit d'utiliser l'une des dénominations suivantes: «Lëtzebuerger
Caritas-Verband»; «Luxemburger Caritas-Verband»; «Confederação Caritas Luxemburgo».
Son siège social est établi à Luxembourg. Sa durée est illimitée.
Ajoute à l'article 8:
Art. 8. Le conseil d'administration dirige la confédération et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudi-
ciaires, poursuite et diligence de son président.
Chaque administrateur pourra se faire accompagner par un membre du personnel dirigeant de son association.
Le conseil est compétent pour tous les actes d'administration et de disposition, y compris les aliénations, les consti-
tutions d'hypothèques, les prêts et emprunts, les opérations commerciales et bancaires, les mainlevées des privilèges ou
hypothèques avant ou après paiement.
Il peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à une ou à plusieurs personnes, administrateurs ou non. A l'égard
des tiers, la confédération est en toutes circonstances valablement engagée par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs.
Le conseil d'administration établit tous les règlements d'ordre interne de la confédération qu'il juge utiles.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.
Françoise Thoma / Erny Gillen
<i>Administratricei> / <i>Présidenti>
Référence de publication: 2011097990/32.
(110110929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Schafsstrachen, Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-2510 Luxembourg, 31, rue Schafsstrachen.
R.C.S. Luxembourg B 77.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011101698/9.
(110115100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
96235
L
U X E M B O U R G
Go S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 161.228.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assembléei>
<i>générale extraordinaire de la Société en date du 30 juin 2011i>
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 30
juin 2011 que
la démission de Monsieur Georges Wirtz, né le 22 février 1979 à Luxembourg, demeurant à L-2680 Luxembourg, 48,
rue de Vianden, en sa qualité d'administrateur de la Société avec effet au 29 juin 2011 a été acceptée,
ont été nommés comme administrateurs
de la catégorie A:
- Monsieur Lam Fat Kwong LAM THUON MINE, dit Maurice LAM, conseiller économique, demeurant à L-2567
Luxembourg, 1, rue Léopold Sédar Senghor; et
de la catégorie B:
- Monsieur Benoît Schaus, salarié, demeurant à B-6690 Vielsalm, 64, Neuville,
- Monsieur Eric van de Kerkhove, salarié, demeurant à L-1364 Luxembourg, 2, rue de Crécy,
jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire statuant sur les comptes sociaux de la Société pour l'année 2015, devant
se tenir en 2016.
Le siège social de la Société est transféré de L-1645 Luxembourg, 6, Montée du Grund vers le L-1660 Luxembourg,
30, Grand-rue, avec effet au 30 juin 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2011.
<i>Pour GO S.A.
i>Georges Wirtz
Référence de publication: 2011097606/29.
(110110899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Regionaler Städteverlag RSV GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 161.961.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend elf, den 30. Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Gerd Wolfgang SCHULZ, geboren 12 August 1962 in Kaiserslautern, wohnhaft in: Bismarkstrasse 4 D-67655
Kaiserslautern
Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche
er als alleiniger Anteilseigner oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2.
1. Gegenstand der Gesellschaft ist Vermarktung, Mediendesign und Produktion, Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Werbung, die Planung und Durchführung von Werbeaktionen, die Gestaltung von Werbemitteln aller Art, insbesondere
die Erstellung und Verbreitung von Kartographien, Landkarten, Stadt, Land-u.a. Verkehrsplänen sowie Magazine und Bro-
schüren für Gewerbetreibende, Industrie, öffentliche Einrichtungen wie Behörden und Hilfsorganisationen, deren Einkauf
und Verwaltungen. Es werden ausserdem Kurse angeboten, in denen die jeweiligen Werbe- und Marketingmassnahmen
besprochen und optimiert werden können, die Verwertung von Waren-und Markenzeichen (Merchandising) sowie jede
damit im Zusammenhang stehende Tätigkeit. Des Weiteren ist Gegenstand des Unternehmens die Beteiligung an anderen
Gesellschaften, Projekt- und Seminarplanung, Produktleasing und Produktentwicklung.
2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die dazu geeignet sind, dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar
zu dienen.
96236
L
U X E M B O U R G
3. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im In-und Ausland errichten, erwerben und/oder ihr gehörige Unter-
nehmen Verpachten.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist „Regionaler Städteverlag RSV GmbH“.
Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Bereldange. Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt
werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) eingeteilt in einhundert (100)
Anteile mit einem Nennwert von einhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,00) pro Anteil.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zus-
timmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals. Im Falle des Todes eines Gesellschafters unterliegt
die Abtretung an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals der
überlebenden Gesellschafter. In jedem Fall haben die verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, welches sie binnen
dreissig Tagen nach Ablehnung des Verkaufs an einen Nichtgesellschafter ausüben müssen.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-
kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.
Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet welche keine Gesellschafter sein
müssen und welche von der Generalversammlung bestimmt werden.
Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft
zu handeln.
Sollte ein Geschäftsführer zeitweise verhindert sein, kann die Gesellschaft durch den alleinigen Anteilseigner geführt
werden. Falls es mehrere Anteilseigner gibt, können diese die Gesellschaft gemeinsam vertreten.
Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandats keine persönliche Verpflichtung ein. Als Ver-
treter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandats haftbar.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner
Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Beschlüsse
welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fün-
fundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember
eines jeden Jahres.
Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.
Art. 21. Solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, besteht die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft, gemäß Artikel
179 (2) des Gesellschaftsgesetzes. In diesem Falle sind unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 des Gesetzes an-
wendbar.
Art. 22. Alles was nicht durch gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2011.
96237
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Sämtliche 100 (einhundert) Anteile wurden gezeichnet und zu ihrem vollen Wert in Höhe von 12.500,00 Euros (€
zwölftausendfünfhundert) eingezahlt durch: Gerd Wolfgang SCHULZ.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten in welcher Art auch immer die aus der Gründung der Gesellschaft
entstanden sind, werden abgeschätzt auf ungefähr Eintausend Euros (€ 1.000.-).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bestimmungen von Artikel 18 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt wurden.
<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschaftersi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum Geschäftsführer mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen wird ernannt:
Herr Gerd Wolfgang SCHULZ, geboren 12. August 1962 in Kaiserslautern,
Der Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtlich verpflichten.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, ihre Vollmachten und Befugnisse festlegen und sie abberufen.
Das Mandat des Geschäftsführers endet anlässlich der Generalversammlung welche übe das erste Geschäftsjahr
beschließt. Sie können wiedergewählt werden.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in
L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige
Urkunde.
Signé: G. W. SCHULZ, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30346. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2011.
Référence de publication: 2011096224/104.
(110109099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.
Nordic Investment Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 140.418.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 juillet 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011094677/14.
(110106516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
NTG Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 17.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
96238
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27 juin 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011094678/11.
(110107020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
NTR Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 126.914.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les actionnaires en date du 2 mars 2011i>
Les actionnaires ont décidé:
- D’accepter la démission de Rory O’Connor à la fonction de gérant avec effet au 2 mars 2011.
- Et de nommer Marie Joyce née le 31 mars 1973 à Galway, Irlande, ayant son siège sociale au 18 Burton Court, Burton
Hall Road, Dublin, Irlande à la fonction de gérante pour une durée indéterminée avec effet au 3 mars 2011.
Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Référence de publication: 2011094679/13.
(110107509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Resinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 98.597.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 21 mars 2011 a approuvé les résolutions
suivantes:
- La démission de Marjoleine van Oort, en tant que Gérant B de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au "15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg", est élu nouveau
Gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Référence de publication: 2011094761/16.
(110107139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Nubil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 52.829.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NUBIL S.A.
Robert REGGIORI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011094680/12.
(110106587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Orion Asset France III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 123.009.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011094681/10.
(110107365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2011.
96239
L
U X E M B O U R G
Dany et Susana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4552 Niederkorn, 4, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 139.188.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2011i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession de parts
<i>Résolution prise:i>
<i>L'associé unique:i>
1) Madame Paula Susana GONCALVES COELHO, née le 10 mai 1977 à Aguada de Cima (Portugal), demeurant à
L-4552, Niederkorn, 20, rue de l'Eglise (100 parts sociales)
de la société à responsabilité limitée Dany et Susana, ayant son siège social à L-4552, Niederkorn, 4, rue de l'Eglise
a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
1) Madame Paula Susana GONCALVES COELHO, propriétaire de 100 parts de la société à responsabilité limitée Dany
et Susana, établie et ayant son siège social à Niederkorn;
Madame Paula Susana GONCALVES COELHO cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame
Anabela DA MOTA MENDES, née le 29 juillet 1973 à Mondim de Bastos (Portugal), demeurant à L-4684 Differdange,
11, rue Batty Weber, qui accepte 76 parts sociales de la société dont s'agit.
Après la cession mentionnée ci-dessus (résolution unique), le capital social de la société Dany et Susana S.à r.l, repré-
senté par cent (100) parts sociales, est répartie comme suit:
Madame Paula Susana GONCALVES COELHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 parts sociales
Madame Anabela DA MOTA MENDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
<i>Prixi>
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix nominal des parts, montant que Madame Paula Susana
GONCALVES COELHO reconnait avoir reçu et en donnant quittance.
Fait à Differdange, le 30 juin 2011, en 2 exemplaires.
Paula Susana GONCALVES COELHO /
Anabela DA MOTA MENDES.
Référence de publication: 2011098868/32.
(110110978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Bevis Marks 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 158.640.
EXTRAIT
En date du 8 juillet 2011 l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Sylvie Reisen en tant que gérant de la Société avec effet au 7 juillet 2011.
- d'approuver la nomination de
* Mr. Michael Kidd, né à Basingstoke (Royaume-Uni) le 18 avril 1960, domicilié au 28, rue Puert, L-5433 Niederonven;
* Mr. Laurent Vouin, né à Langon (France) le 17 août 1966, domicilié professionnellement au Coeur Défense Tour B,
100, Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, France
* Mr. Steven Craig Willingham, né à Boston, (Royaume-Uni) le 7 octobre 1969 domicilié professionnellement au 60
Sloane avenue, SW3 3XB Londres, Royaume-Uni.
en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Bevis Marks 1 S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2011101409/20.
(110113918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96240
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Action Oil Luxembourg SPF S.A.
Afschrift S.E.
Aggmore Kaufmann Ventures S.à r.l.
ALVA Luxembourg S.A.
Amber Trust Management S.A.
AnBeVir S.àr.l.
Antan Holding S.A.
AXA Assurances Luxembourg
AXA Assurances Luxembourg
AXA Assurances Vie Luxembourg
Beaucette S.A., SPF
Bevis Marks 1 S.à r.l.
BNP Paribas Flexi I
BNP Paribas Plan
CM-Equity
Cobrilux S.A. - SPF
Confédération luxembourgeoise d'oeuvres catholiques de charité et de solidarité association sans but lucratif
Crescendo SIF Fund
Dany et Susana S.à r.l.
Delta Lloyd L
DJE Strategie II
Dumatin S.A.
Go S.A.
Instore Holdings S.à r.l.
Jaguar Luxembourg S.A.
Jarden Lux Holdings S.à r.l.
Key-Way S.à r.l.
Lexfin S.A.
Lex Investments Holdings S.A.
Lux Multi Plus SICAV-SIF
L.V.M.D., Location Vente Matériel Décontamination S.à r.l.
Magma Capital
MAN Umbrella SICAV
Maybach S.A.
MGT 1 & 2 S.A.
MHREC Real Estate S.à r.l.
Midgard Luxembourg
Midgard Luxembourg
ML Invest S.à r.l.
Motion Connect S.A. SPF
MS Design S.A.
Najac-Corp S.A.
N.C. Management S.à r.l.
Nikky Investments S.A.
Nordic Investment Consulting S. à r.l.
Nordic Investment Consulting S. à r.l.
Nouvelle Société Vins du Portugal S.àr.l.
Nova Holding S.à r.l.
Novator Telecom Finland S.à r.l.
NTG Holdings S.A. SPF
NTR Lux Finance S.à r.l.
Nubil S.A.
Orangenburger SPF S.A.
Orion Asset France III S.à r.l.
PG Europe 1 S.à r.l.
Regionaler Städteverlag RSV GmbH
Repco 22 S.A.
Resinvest S.à r.l.
Schafsstrachen
Schroder International Selection Fund
SF (Lux) Sicav 3
Valauchanrus Sopaneer S.C.A.
Ygrec S.A., SPF