logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1873

17 août 2011

SOMMAIRE

Aberdeen Money Market Fund (Lux)  . . . .

89864

Aber Diamond Marketing S.à r.l.  . . . . . . . .

89886

AEIF LH Sub 05 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89891

Ageo Patrimoine (Luxembourg) S.à r.l.  . .

89895

Airtech G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89898

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89886

Alzette Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89858

Anoa Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89897

ArcelorMittal Energy S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

89871

Auster Real Estate Opportunities S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89897

Becom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89896

Castelerand Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

89900

Causerman Investissements S.A.  . . . . . . . .

89859

Charter Hall Retail Poland S.à r.l.  . . . . . . .

89899

Citimmo Projects S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

89887

Coach & Win  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89899

CO.LU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89889

COMPUTER RESOURCES INTERNA-

TIONAL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

89895

Creutz & Partners, Global Asset Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89898

CSC Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89902

Deka Multi Asset Investors Luxembourg

SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89864

Duna Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89888

Electricité & Maintenance Sàrl  . . . . . . . . . .

89900

European Walls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89900

Exane Funds 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89901

Future Invest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89863

Goodman European Business Park Fund

(Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89888

Interba S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89889

Jardines Inmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89901

J.B.C. Viandes Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89900

Jef Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89860

J.P.Morgan Specialised Investment Fund I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89902

Kilrush  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89895

Life One  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89858

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF  . . . . .

89860

"Lux-Portfolio" SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89862

Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89864

Magical S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89863

Medical Trials Analysis S.A.  . . . . . . . . . . . . .

89890

MGP Artemis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89889

MMB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89859

Mobitrading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89904

Mosaic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89862

Niramore International S.A.  . . . . . . . . . . . .

89890

Omega Venture Capital  . . . . . . . . . . . . . . . .

89901

OSS CCS II S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89899

Parvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89861

Peabody Boetie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89890

Pearson Luxembourg N°. 2.  . . . . . . . . . . . . .

89882

Real Impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89894

Rosny S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89863

Sani Cover Corporate S.A. . . . . . . . . . . . . . .

89904

SK Participation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

89896

Sunningdale Properties II S.A. . . . . . . . . . . .

89891

T.C.G. Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89893

Tiburon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89894

Tiburon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89895

89857

L

U X E M B O U R G

Alzette Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 124.750.

The shareholders of the company are convened for a

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

that will take place on Tuesday <i> 13 

<i>th

<i> September 2011  at 2.30 p.m. at the following address: 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg (CENTRALIS S.A.). The agenda and proposed resolutions are as follows:

<i>Agenda:

1. Resolution to pursue Mr. Michael TAGGART for the misuse of corporate asset(s) and to seek concrete proposals

for compensation and reimbursement from him

2. Discussion of the operations carried out by the board in order to save the interests of the company against further

damages that may be committed

3. Vote on the possible appointment of new members of the Board
4. Miscellaneous
The shareholders have to be equipped with the proof of their shareholder's quality by presentation of a share certificate.

**********

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE

de la société ALZETTE PROPERTIES S.A. qui se tient à 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg (CENTRALIS S.A.) en

date du mardi, le <i>13/09/2011 à 14.30 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Aveu formel à recueillir de la part de Monsieur Michael TAGGART, sur les abus de biens sociaux commis par lui

et propositions concrètes de remboursement

2. Discussion sur les opérations effectuées par le conseil d'administration en place dans le but de sauver les intérêts

de la société contre de nouveaux détournements susceptibles d'être commis

3. Vote sur la nomination éventuelle de nouveaux membres du conseil d'administration
4. Divers
Mesdames et Messieurs les Actionnaires voudront se doter de la preuve de leur qualité d'actionnaire par présentation

d'un certificat d'actions.

Référence de publication: 2011114919/32.

Life One, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 102.356.

Hiermit wird mitgeteilt, dass die

ORDENTLICHE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

der Anteilinhaber der Life One SICAV ("die Gesellschaft") am <i>26. August 2011 um 11.00 Uhr MESZ am Gesellschaftssitz

6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg stattfinden wird, um die folgenden Angelegen-
heiten zu erörtern und darüber abzustimmen:

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer sowie Verabschiedung des Jahresabs-

chlusses und der Verwendung der Erträge (ggf.) für das Geschäftsjahr bis 30. April 2011.

2. Entlastung des Verwaltungsrats von seiner Verantwortung für alle Maßnahmen, die im Rahmen seines Mandats

während des Geschäftsjahres bis 30. April 2011 ergriffen wurden.

3. Wiederwahl der Herren Jean-Christoph Arntz, Gerrit Weber sowie Daniel Lehmann als Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wiederwahl von BDO Audit, Luxemburg, zum Abschlussprüfer.
5. Beschluss über sonstige Angelegenheiten, die ordnungsgemäß auf der Versammlung vorgebracht werden.

<i>Abstimmung:

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung können ohne Quorum mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst

werden.

89858

L

U X E M B O U R G

<i>Abstimmungsregelung:

Zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind Anteilinhaber, die dem Administrator Allianz Global

Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg bis spätestens zum Geschäftsschluß
des 23. August 2011 eine Bestätigung ihres Depotinstituts vorlegen können, aus der die Anzahl der Anteile im Besitz des
Anteilinhabers  hervorgeht,  einschließlich  einer  Bestätigung,  dass  die  Anteile  bis  zum  Tag  nach  der  Versammlung  der
Anteilinhaber gesperrt sind.

Alle Anteilinhaber, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter

ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtsformular ist nur gültig, wenn es ordnungsgemäß ausgefüllt und
eigenhändig vom ernennenden Anteilinhaber oder von dessen Bevollmächtigtem unterzeichnet wird (oder, falls der Stell-
vertreter  von  einer  Gesellschaft  ernannt  wird,  mit  dem  Firmensiegel  oder  der  Unterschrift  eines  ordnungsgemäß
bevollmächtigten Angestellten versehen ist) und bis spätestens zum Geschäftsschluß des 23. August 2011 beim Adminis-
trator Allianz Global Investors Luxembourg S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg eingegangen
ist.

Vollmachtsformulare erhalten eingetragene Anteilinhaber beim Administrator Allianz Global Investors Luxembourg

S.A., 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Eine zum Stellvertreter ernannte Person muss kein Antei-
linhaber der Gesellschaft sein. Durch die Ernennung eines Stellvertreters ist ein Anteilinhaber nicht von der Teilnahme
an der Versammlung ausgeschlossen.

Luxemburg, im Juli 2011.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011112665/755/40.

MMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 29.898.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, le vendredi <i>2 septembre 2011 à 10.00

heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2010;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011114921/317/16.

Causerman Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 52.637.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le jeudi 9 juin 2011 à 10.00 heures n'ayant pu délibérer sur l'agenda

ci-dessous, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 septembre 2011 à 10.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs, au Président et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011116714/755/20.

89859

L

U X E M B O U R G

Jef Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 50.124.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 septembre 2011 à 11.00 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs, au Président et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011116715/755/19.

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 152.733.

We hereby invite you to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company to be held in Luxembourg at 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf, on <i>September

<i>19, 2011 at 11.00 a.m. (CET) to deliberate and vote on the following agenda, as the planned extraordinary general meeting
on August 4, 2011 was without quorum to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Change of the financial year of the Company, so that the current financial year, which started on January 1 

st

 , 2011

shall end on September 30 

th

 , 2011. The subsequent financial year shall then begin on the 1 

st

 of October and end

on the 30th of September of the following year and therefore change of paragraph 1 of article 27 of the articles of
incorporation, subject to the approval of the CSSF.

2. Change of paragraph 6 of article 24 of the articles of incorporation: At the moment, the annual general meeting

shall be held in Mamer, either at the Company's registered office or at any other location in Mamer, to be specified
in the notice of the meeting, on the third Thursday of the month of May at 3.00 pm (Luxembourg time). If this day
is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next banking day.
In the future, the annual general meeting shall be held either at the Company's registered office or at any other
location, to be specified in the notice of the meeting on the third Thursday of the month February at 3.00 pm
(Luxembourg time). If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next banking day, subject to the approval of the CSSF.

3. Miscellaneous.
Each shareholder - individually or by proxy - will be able to participate in the extraordinary general meeting if his shares

have been deposited until Wednesday, September 14, 2011 at the latest at HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt (International)
SA,  Luxembourg,  and  leaves  them  there  until  the  end  of  the  extraordinary  general  meeting.  Each  shareholder,  who
complies with this requirement, will be admitted to the extraordinary general meeting.

In this extraordinary general meeting, no quorum is required. But in order to be effective, decisions must be passed

by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

<i>From the board of directors.

Référence de publication: 2011116716/755/33.

89860

L

U X E M B O U R G

Parvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 33.363.

An EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

shall be held on Friday, <i>26 August 2011 at 11.30 a.m., at the premises of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

Building H2O, Block A, Ground Floor, located at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

<i>Agenda:

Full recasting of the Articles of Association including the following main changes:

1. Choice  of  English  as  the  official  language  of  the  Articles  of  Association  as  authorised  by  Article  26  (2)  of  the

Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment;

2. Article 1: making the Company subject to the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for

collective investment, replacing the law of 20 December 2002;

3. Article 4: changing the third paragraph to authorise the Board of Directors to transfer the registered office either

within the commune or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the Grand Duchy
of Luxembourg;

4. Article 5§1: replacing the minimum capital of EUR 1,250,000 by the minimum foreseen by the Luxembourg law;

Article 5§4: redefinition of the notion of "subfund";
Articles 5§5 and 6§1: redefinition of the notions of "category of shares" and "class of shares";

5. Article 6: cancellation of the issuance of share certificates;

Deletion of Article 10 concerning lost or damaged certificates;

6. Article 11: simplification of the definition and condition to the restrictions on holding of the Company's shares;
7. Creation of a new article authorizing the Board of Directors to split or regroup shares;
8. Article 12: Rewriting of the article to give the Board of Directors the broadest powers insofar as decisions con-

cerning the effectiveness and conditions for merger, liquidation, demerger of subfunds, categories or classes of
shares within the restrictions and conditions provided for by the Luxembourg law of 17 December 2010;
Addition of the liquidation of feeder subfunds in the event of liquidation, merger or demerger of master funds.

9. Article 13.4): the unlisted securities shall be valued by a qualified professional appointed by the Board of Directors;

Article 13.5) and 6): derivative financial instruments shall be valued according to the rules decided by the Board of
Directors, described in the Prospectus, and previously approved by the Company's auditor and supervisory au-
thorities;
Addition of a new paragraph fixing to 5% of their average net assets the maximum of the total amount of annual
fees payable by a subfund, a category, or a class of shares;

10. Article 14: addition of the suspension of NAV and orders in case of 1) a merger, partial business transfer, splitting

or any restructuring operation and 2) for a "Feeder", when the NAV and orders in the "Master" are suspended;
Addition of the possibility for the Board of Directors, in the interest of shareholders, and in the event of subscrip-
tion, redemption or conversion applications exceeding a percentage of a sub-fund's net assets as determined by
the Board of Directors, to not determine the value of a share until such time as the required purchases and sales
of securities have been made on behalf of the sub-fund. In that event, subscription, redemption and conversion
applications in the pipeline will be processed simultaneously on the basis of the net asset value so calculated;

11. Article 15§3: the general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company or in any

other place in the Grand Duchy of Luxembourg decided by the Board of Directors and mentioned in the convening
notice;
The General Shareholders' Meeting shall validly deliberate regardless of the portion of capital represented. Reso-
lutions shall be taken by a simple majority of the votes cast;

12. Article 17§3: the decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of the votes cast;
13. Article 19: addition of the possibility for the Board of Directors 1) to create subfunds investing in other subfunds

of the Company, and 2) to create "Feeder" subfunds;
Addition of the limitation of investments in other UCITS or UCIs to 10% of the assets of each subfund, except if
other restrictions mentioned in the investment policy of the concerned subfund exist;

14. Deletion of the articles 21 and 24;
15. Complete reformulation of the Company's articles of association to bring them into line with the provisions of the

Law of 17 December 2010 which came into force on 1 

st

 July 2011.

In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders'

Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented.
Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their

shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

89861

L

U X E M B O U R G

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon

proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the
meeting.

The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available

from the bodies listed in the prospectus.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2011111919/755/66.

"Lux-Portfolio" SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 66.907.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, à Luxembourg, 1, rue Zithe,

le mercredi <i>7 septembre 2011 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30

juin 2011.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2011; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg:
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Banque Raiffeisen S.C.
Fortuna Banque S.C.

Pour l'Allemagne:
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011116717/755/33.

Mosaic, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.223.

Mosaic's  (hereinafter  the  "Fund")  extraordinary  general  meeting  that  was  held  on  12  August  2011  was  unable  to

deliberate because the quorum conditions were not met. A new

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will thus be held at the Fund's registered office located at 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on <i>19 September

<i>2011 at 4:00 p.m., to vote and resolve on same following agenda:

<i>Agenda:

Complete revision of the articles of incorporation of the Fund, in replacement of the existing consolidated articles
of incorporation dated 22 August 2007.

89862

L

U X E M B O U R G

Shareholders are informed that, at this meeting, resolutions shall be passed without a quorum requirement by a two-

thirds majority of the votes cast. Each share gives its holder the right to one vote.

Shareholders who are unable to attend the meeting in person may be represented by means of a proxy available at

the Fund's registered office, which must be duly completed, signed, and returned by no later than 16 September 2011 to
the attention of Pictet Funds (Europe) S.A., by fax on (00 352) 22 02 29 and by post to 3, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.

The previously sent proxy will still remain valid.
The text of the new articles of incorporation may be viewed on demand free of charge at the Fund's registered office.

<i>On behalf of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011116718/755/23.

Future Invest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.499.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 août 2011 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011113294/1023/18.

Magical S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 34.821.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 août 2011 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011113529/1023/17.

Rosny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 34.826.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 août 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.

89863

L

U X E M B O U R G

2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

mars 2011.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011113532/1023/17.

Aberdeen Money Market Fund (Lux), Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion consolidé au 29 novembre 2010 de «Aberdeen Money Market Fund (Lux)» (anciennement

«Credit Suisse Money Market Fund (Lux)»), a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
The consolidated management regulations as from 29 November 2010 of “Aberdeen Money Market Fund (Lux)” (for-

merly “Credit Suisse Money Market Fund (Lux)”), were deposited with the Registre de commerce et des sociétés.

For publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Aberdeen Global Services S.A.

Référence de publication: 2011062683/12.
(110070799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2011.

Deka Multi Asset Investors Luxembourg SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 144.544.

Les comptes annuels au 31.05.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29.06.2011.

Wolfgang Dürr / Patrick Weydert.

Référence de publication: 2011096042/11.
(110109100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2011.

Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 162.599.

In the year two thousand eleven, on the twenty-sixth day of July
Before the undersigned Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Macquarie Bank Limited, an Australian limited company with its registered office at Mezzanine Level, 1 Martin Place,

Sydney NSW 2000, Australia,

here represented by Marc-Oliver Scharwath, lawyer, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg,

by virtue of a proxy, given on 26 July 2011.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is declared organized and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose – Duration – Name – Registered office

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Macquarie

Private Markets Fund GP S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in Macquarie Private Markets Fund S.C.A.,

SICAV-FIS, a Luxembourg specialised investment fund, incorporated as a partnership limited by shares and to act as its
general partner and shareholder with unlimited liability.

89864

L

U X E M B O U R G

The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment

of its purposes.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital – Shares

Art. 5. The Company's share capital is set at eighteen thousand US Dollars (USD 18,000.-) represented by one hundred

eighty (180) shares with a par value of one hundred US Dollars (USD 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. Joint coowners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder

is subject to the approval of such transfer given by shareholders representing at least three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided

by law.

Art. 9. The death, legal incapacity, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any similar event

regarding the sole shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
by a 75% quorum of the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the collective signature of any two managers and by the signature of any duly authorised signatory within the
limits of such authorisation.

Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among

its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail

89865

L

U X E M B O U R G

or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at
a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting; in case of tied votes, the chairman shall have a casting vote.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or, in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on

the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

D. Supervision of the company

Art. 16. The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditors, which need not be

shareholders. The general meeting of shareholders may appoint one or more statutory auditor(s) and determines the
term of its (their) office. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the general meeting of
shareholders will appoint one or more statutory auditor(s).

If the Company exceeds the limits of two of the three criteria determined by article 35 of the law of 19 December

2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings for a
period as set out by article 36 of the same law, the institution of statutory auditor(s), if any, is suppressed and one or
more independent auditor(s) (réviseur d’entreprise) chosen among the members of the Institut des Réviseurs d’Entre-
prises will be designated by the general meeting of shareholders, which fixes their number and the term of their office.

E. Decisions of the sole shareholder – Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the “general
meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as
applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

89866

L

U X E M B O U R G

F. Financial year – Annual accounts – Distribution of profits

Art. 20. The Company's financial year commences on 1 April and ends on 31 March of the following year.

Art. 21. Each year on 31 March, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

G. Dissolution – Liquidation

Art. 23. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who need not be shareholders, and who are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

H. Final clause – Governing law

Art. 24. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg

law.

All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

Macquarie Bank Limited, aforementioned one hundred and eighty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 shares

All the shares subscribed are fully paid-up in cash so that the amount of eighteen thousand US Dollars (USD 18,000.-)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of this deed of the Company and shall terminate on 31 March 2012.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.-.

<i>General meeting of shareholders

The shareholders, representing the entire share capital of the Company, have immediately passed the following reso-

lutions:

1. The registered office of the Company shall be at 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg;
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an undertermined period:
- Mike Siebert, born in Marburg (Germany) on 8 June 1974, professionally residing at Promenadeplatz 8, 80333 Munich,

Germany;

- Harald Strelen, born in Oldenburg (Germany) on 1 February 1974, professionally residing at 21, Avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg;

- Kai Braun, born in Freiburg im Breisgau (Germany) on 26 March 1978, professionally residing at 21, Avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the party appearing, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the party appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes

Im Jahr zweitausendelf, am sechsundzwanzigsten Juli,
vor dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

89867

L

U X E M B O U R G

Ist erschienen:

Macquarie Bank Limited, eine Australische Limited, mit Gesellschaftssitz in Mezzanine Level, 1 Martin Place, Sydney

NSW 2000, Australien,

hier vertreten durch Marc-Oliver Scharwath, Rechtsanwalt, geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la Liberté, L-1931

Luxemburg,

aufgrund einer am 26. Juli 2011 ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht,
Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei und

den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird und deren Satzung wie folgt
lautet:

A. Zweck – Dauer - Name – Sitz

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen

Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l. (nachstehend die „Gesellschaft“) welche den Bestimmungen des Gesetzes
über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz über Handelsgesellschaften“)
und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten einer Beteiligung des Macquarie Private Markets Fund

S.C.A., SICAV-FIS, einem spezialisierten Investmentfonds nach Luxemburger Recht, gegründet als Kommanditgesellschaft
auf Aktien und das Agieren als dessen Komplementär und unbeschränkt haftender Gesellschafter.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten gewerblicher oder finanzieller Natur vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer

Zwecke förderlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen ausgeben.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz

kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Be-
schluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,

durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaft-

liche  oder  gesellschaftliche  Entwicklungen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen
Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Nor-
malisierung der Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf
die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxem-
burgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital – Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausend US Dollar (USD 18.000,-), aufgeteilt in einhundertachtzig (180)

Anteile zu je einhundert US Dollar (USD 100,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei

viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften geändert
werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu,

so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters können die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an einen Dritten nur mit

Zustimmung der Inhaber von Anteilen, die drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und im Übereinstimmung
mit unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden. Eine derartige Zustimmung
ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, jedoch höchstens vierzig (40), sofern sich gesetzlich

nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist.

89868

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch Geschäftsunfähigkeit, noch durch Entmündigung, Auflösung,

Bankrott oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter, oder irgendein ähnliches Ereignis betreffend den Alleinge-
sellschafter, aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müs-

sen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,

unter allen Umständen unbeschränkt befugt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Die Geschäftsführer werden durch den Alleingesell-
schafter bzw. durch die Gesellschafter bestellt, welche(r) die Dauer ihrer Amtszeit festlegt(festlegen). Die Bestellung eines
Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von einer 75% Mehrheit
der Gesellschafter widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier beliebiger Geschäftsführer und durch die Unterschrift eines jeden
ordnungsgemäß Bevollmächtigten im Rahmen dieser Bevollmächtigung verpflichtet.

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Rat der Geschäftsführer geleitet,

welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie
kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle
der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung
wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen
anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt

ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einla-
dungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für
Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäfts-
führungsbeschluss festgesetzt wurden.

Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle

Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben er-
forderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten
lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon-oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel  teilnehmen,  sofern  dieses  den  an  der  Sitzung  teilnehmenden  Personen  eine  ununterbrochene
Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine
derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Ge-

schäftsführer  bei  einer  Sitzung  anwesend  oder  vertreten  ist.  Beschlüsse  der  Geschäftsführung  werden  mit  einfacher
Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle,
die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen

der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als
solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

89869

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Der Geschäftsführer oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer kann

entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von dem oder den Geschäftsführer(n) erstellten vorläufigen Ab-
schlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die
auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht
um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die
aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten
dürfen.

D. Beaufsichtigung der gesellschaft

Art. 16. Die Geschäfte der Gesellschaft können der Beaufsichtigung durch einen oder mehrere satzungsgemäße Rech-

nungsprüfer unterstellt sein, die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung kann einen
oder mehrere Rechnungsprüfer ernennen und ihre Amtszeit festlegen. Sofern die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig
(25) Gesellschafter hat, muss die Hauptversammlung einen oder mehrere satzungsgemäße Rechnungsprüfer ernennen.

Falls die Gesellschaft zwei der drei in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels-und Gesell-

schaftsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmten Kriterien innerhalb des in
Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraumes überschreitet, wird das Amt des satzungsgemäßen Rechnungsprü-
fers abgeschafft und ein oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer (réviseur d’entreprise) unter den Mitgliedern des
Institut des Réviseurs d’Entreprises durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche auch die Anzahl
sowie deren Amtszeit festlegen.

E. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters – Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 18. Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die durch Gesetz und diese Satzung verliehenen Befugnisse.

Sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt, werden gemeinsame Beschlüsse nur wirksam gefasst,
soweit sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet werden.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt

XII  des  Gesetzes  über  Handelsgesellschaften  verliehenen  Befugnisse  aus.  In  diesem  Fall  ist  jede  Bezugnahme  auf  die
„Hauptversammlung der Gesellschafter“ je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als eine Bezugnahme auf den
Alleingesellschafter zu verstehen und die der Hauptversammlung der Gesellschafter verliehenen Befugnisse werden von
dem Alleingesellschafter ausgeübt.

F. Geschäftsjahr – Konten – Ausschüttung von gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. April und endet am 31. März des folgenden Jahres.

Art. 21. Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der

Geschäftsführer erstellt eine Bestandsaufnahme, die Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in diese Bestandsaufnahme und die Bilanz
nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

G. Gesellschaftsauflösung – Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der

Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung be-
stimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die weitestgehenden
Befugnisse im Hinblick auf die Realisierung der Vermögenswerte und die Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft.

Der Überschuss, der aus der Realisierung der Vermögenswerte und der Begleichung der Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesell-
schaftskapital aufgeteilt.

H. Schlussbestimmungen – Anwendbares recht

Art. 24. Auf diese Satzung sollen die Gesetze Luxemburgs Anwendung finden, nach welchen sie errichtet und ausgelegt

werden soll.

Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz über Handelsgesellschaften, in seiner jeweils

gültigen Fassung geregelt.

89870

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Zahlung der anteile

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Macquarie Bank Limited, vorbenannt: einhundertachtzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Anteile

Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurde vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von achtzehntausend US Dollar (USD 18.000,-) ab sofort zur Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachge-
wiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2012.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. EUR 2.000.-geschätzt.

<i>Hauptversammlung der Gesellschafter

Der Gesellschafter, das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertretend, haben unmittelbar anschließend an die

Gründung der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg.
2. Als Geschäftsführer der Gesellschaft werden bestellt für eine unbestimmte Dauer:
- Mike Siebert, geboren am 8. Juni 1974 in Marburg (Deutschland), geschäftlich ansässig am Promenadeplatz 8, 80333

München, Deutschland;

- Harald Strelen, geboren am 1. Februar 1974 in Oldenburg (Deutschland), geschäftlich ansässig in 21, Avenue de la

Liberté, L-1931 Luxemburg;

- Kai Braun, geboren am 26. März 1978 in Freiburg im Breisgau (Deutschland), geschäftlich ansässig in 21, Avenue de

la Liberté, L-1931 Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt
der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienen Partei, welcher dem Notar mit Name, Vorname und

Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Partei unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: M.-O. SCHARWATH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2011. Relation: LAC/2011/34012. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 2. August 2011.

Référence de publication: 2011110978/385.
(110127194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2011.

ArcelorMittal Energy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 162.754.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of July.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) “ArcelorMittal”, a public limited company (société anonyme) having its registered office at L-2930 Luxembourg, 19,

Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg (“RCS”) under number B
82454,

represented by Mr Fabrice MAGAR, Legal Counsel, with professional address 19, avenue de la Liberté, L-2930 Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 22 July 2011 and

89871

L

U X E M B O U R G

2) “AM Global Holding”, a private limited liability company, (société à responsabilité limitée), having its registered office

at L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg
(“RCS”) under number B B 102898,

represented by Mr Fabrice MAGAR, previously named, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 22 July 2011.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the above notary to draw up the articles

of incorporation of a partnership limited by shares (“société en commandite par actions”) which is herewith established
as follows:

Chapter I - Form, Name, Object, Registered office, Duration

Art. 1. The Company is a Luxembourg société en commandite par actions (corporate partnership limited by shares)

It has two (2) unlimited shareholders (actionnaires commandités), namely:

- “ArcelorMittal”, a public limited company (société anonyme) having its registered office at L-2930 Luxembourg, 19,

Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg (“RCS”) under number B
82454 and

- “AM Global Holding”, a private limited liability company, (société à responsabilité limitée), having its registered office

at L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, registered with the Register of commerce and companies, Luxembourg
(“RCS”) under number B 102898.

AM Global Holding will in addition hold shares as a limited partner. It is understood and agreed that, by reason of the

aggregation of its status as a general partner and as a limited partner, and in application of the statutory provisions in
respect of limited partnerships with shares (sociétés en commandite par actions), AM Global Holding will not enjoy, vis-
à-vis third parties, any limitation of liability for the losses of ArcelorMittal Energy S.C.A. Consequently, it will be subject
in this regard to the rules governing the liability of general partners.

Art. 2. The name of the Company shall be "ArcelorMittal Energy S.C.A.”.
In every document emanating from the Company, this name shall be followed by the words “société en commandite

par actions”, written in full, or by the abbreviation “SCA”, without prejudice to any other particulars required by law.

Art. 3. The object of the Company shall be, in particular, to engage in the following activities in Europe and the rest

of the world, for the benefit of companies within the ArcelorMittal Group:

– the purchase and sale of energy, including electricity, natural gas and industrial gases (oxygen, nitrogen, argon and

others);

– the purchase, sale, hiring out and direct or indirect exploitation of all kinds of industrial equipment (and the provision

of services connected therewith) in relation to the production, transformation, transportation and capturing of sources
of energy, including renewables;

– all operations relating to optimisation, in respect of any technical solution, whether such solution already exists or

has yet to be devised;

– the carrying-out of such operations in relation to greenhouse gases (in particular, CDM/Joint Implementation).
The Company may take up any interests by any means whatsoever and in particular by means of purchase, contribution,

acquisition of holdings, merger or alliance in any other company, entity or undertaking pursuing an object that is similar,
analogous or complementary to its own or conducive to the attainment of that object.

It may carry out all operations in general and whatsoever, whether commercial, industrial, financial or involving movable

or immovable property, relating directly or indirectly to its object or capable of facilitating the attainment thereof.

Art. 4. The Company’s registered office shall be established in Luxembourg.
The Manager, or in case of plurality, any Manager, may establish administrative seats, branches or offices both in the

Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the Manager, or in case of plurality, any Manager, determines that extraordinary political, economic

or social developments, or, more generally, cases of force majeure, have occurred or are imminent, that are liable to
interfere with normal activities at the registered office or with the ease of communication either with that office or from
that office to places abroad, the Manager, or in case of plurality, any Manager, may temporarily transfer the registered
office abroad until the complete cessation of those abnormal circumstances; however, such temporary measure shall have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall
remain a Luxembourg company.

Art. 5. The Company is formed for an unlimited duration.

89872

L

U X E M B O U R G

Chapter II - Share capital, Shares

Art. 6. The subscribed share capital is fixed at two million Euro (EUR 2,000,000.-). It is represented by two thousand

(2,000) shares, namely:

- one thousand nine hundred and ninety-eight shares with unlimited liability (“actions de commandité”) . . . . 1,998
- two shares with limited liability (“action de commanditaire”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

with no designation of nominal value, all fully paid up. A share with unlimited liability may be transferred only with the

unanimous consent of all limited and unlimited shareholders.

The shares are and shall remain in registered form.

Art. 7. In case a shareholder proposes to transfer all or part of its limited shares, it must first offer such shares to the

other shareholders in proportion to the number of limited shares held by such other shareholders.

In the event of a persistent disagreement of the shareholders on the sales price two weeks after an offer shall have

been made to the other shareholders, the sales price shall be determined by a committee of three experts, who will value
the shares on the basis of their intrinsic market value. The shareholder(s) intending to transfer shares and the shareholder
(s) proposing to acquire such shares shall each designate an expert, the third expert being designated jointly by all such
shareholders. In case of disagreement regarding the designation of, or failure to designate, one or more experts, such
expert or experts shall be appointed by the President of the Luxembourg District Court (Tribunal d’Arrondissement de
et a Luxembourg) upon request of the most diligent party. The Company shall communicate the conclusions of the expert
report to the shareholders by registered mail, inviting the shareholders to declare within four weeks whether they intend
to purchase or transfer the shares at the price so determined. The absence of a response by a shareholder within that
period shall be deemed a refusal.

If only some shareholders or only one shareholder declare(s) an intention to purchase shares, the shares proposed

to be sold shall be offered to such shareholder(s) in the proportion the number of limited shares held by each such
shareholder bears to the total number of limited shares held by all such shareholders together.

If at the end of the above mentioned procedure, not all the shares offered for sale have been taken up, the shareholder

intending to transfer shares may offer the shares not taken up to non-shareholders, provided each of the other share-
holders may still exercise a pre-emption right in proportion to its shareholding within a period of two weeks from the
date of communication of the agreement with non-shareholders and at the terms and conditions of such agreement. The
third paragraph of this article shall apply and each such shareholder shall have the right to take up, on a pro rata basis,
any shares not taken up by other shareholders. This pre-emption right must be exercised by one or more shareholders
on all the shares offered to be sold, failing which the shareholder proposing to transfer the shares shall be free to transfer
them to the afore mentioned non-shareholders.

The provisions of this article shall not apply to the unlimited shares, which may be transferred only in accordance with

the conditions laid down in article 6, paragraph 2.

Chapter III - Management

Art. 8. The Company shall be managed by one or more unlimited shareholder(s). In case of plurality of Managers, each

Manager shall have the authority to manage and bind the Company alone.

The unlimited shareholders and Managers of the Company are:
- “ArcelorMittal”, société anonyme, a public limited company governed by the laws of Luxembourg, having its registered

office at 19, Avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered with the Luxembourg commercial and companies
register under number B 82454 and

- “AM Global Holding”, société à responsabilité limitée, a private limited liability company, having its registered office

at 19, Avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered with the Luxembourg commercial and companies register
under number B102898.

The replacement of the Manager, or in case of plurality of any Manager, and the appointment of additional Managers

shall be subject to the unanimous consent of all the limited and unlimited shareholders.

Art. 9. The Manager shall, or in case of plurality, any Manager, shall each have the broadest powers to carry out all

acts of administration and disposition in relation to the Company. All powers not reserved by law or by these articles of
association to the general meeting of shareholders or the Supervisory Board shall fall within the competence of the
Manager, or in case of plurality, any Manager.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents by the Manager, or in

case of plurality, by any Managers.

Before 31 May and 30 November in each year, the Managers shall jointly submit, for approval by the Supervisory Board,

a projected halfyearly budget.

Art. 10. The Manager, or in case of plurality, any Manager, acting through its authorised signatories duly appointed by

the board of directors (fondés de pouvoir) shall represent the Company vis-à-vis third parties and in judicial proceedings.

89873

L

U X E M B O U R G

Chapter IV - Supervisory Board

Art. 11. The operations and business of the company as well as its financial situation, including in particular its books

and accounts, shall be supervised by a Supervisory Board composed of at least three members, who are not shareholders.

The Supervisory Board shall:
– report to the general meeting of shareholders any irregularities which it finds in the accounts;
– verify the company's accounts to make sure that they are in order;
– assess ex post facto the appropriateness of the management decisions and strategic orientations of the Managers;
– before 30 June and 31 December in each year, issue its prior approval of the budget for the half-year to come, as

jointly submitted to it by the Managers before 31 May and 30 November respectively.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall also

determine their number and the length of their term of office (a period not exceeding six years), and they shall remain
in office until their successors are elected. They may be re-elected and they may be dismissed at any time, with or without
cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

The members of the Supervisory Board which are corporate entities, shall be represented by such individuals as they

shall designate.

In addition to the powers mentioned in the first paragraph of this article, the Supervisory Board shall be consulted on

all matters submitted to it by any Manager.

Art. 12. The Supervisory Board shall choose a chairman from amongst its members. It shall also appoint a secretary

who does not need to be a member of the Supervisory Board and who shall be responsible for taking the minutes of the
meetings of the Supervisory Board.

The Supervisory Board may also arrange to be assisted by any person whose services it considers to be useful.
The Supervisory Board shall meet upon call by its chairman or by any shareholder representing at least one third of

the shares. A meeting of the Supervisory Board must also be convened if any two members or any Manager so request.

All meetings of the Supervisory Board shall be presided by the chairman, or, in his absence, by another member of the

Supervisory Board acting pro tempore appointed by a simple majority vote of the members present and represented at
the meeting.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given by letter, e-mail or fax to all members at least

five days prior to the date scheduled for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of the
emergency shall be set out in the notice of meeting. The notice of meeting shall indicate the place of the meeting and set
out the agenda.

Prior notice may be waived by the consent in writing (including consent given by letter, e-mail or fax) of each member

of the Supervisory Board. No separate notice is required for meetings to be held at dates, times and places determined
by a resolution previously adopted by the Supervisory Board.

Any member of the Supervisory Board may arrange to be represented at any meeting of the Supervisory Board by

appointing another member in writing (including by letter, e-mail or fax) to act as his proxy. The Supervisory Board may
not validly deliberate or act unless three of its members are present or represented. Decisions shall be taken by a simple
majority of the votes of members present or represented at the meeting. One or more members may participate in a
meeting by means of a telephone conference or by any other means of communication enabling all persons participating
in the meeting to hear each other and speak to each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical
presence at the meeting. Written resolutions signed by all the members shall be proper and valid as if adopted at a duly
convened and held meeting of the Supervisory Board. Written resolutions may be documented in a single written do-
cument or by several separate written documents with identical content.

Art. 13. The minutes of every meeting of the Supervisory Board shall be signed by the chairman of the meeting and

the secretary. Proxies shall remain annexed thereto.

Copies or excerpts of such minutes which are intended to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be

signed by the chairman or by the secretary.

Chapter V - Independent auditors

Art. 14. Without prejudice to the supervision carried out by the Supervisory Board, the audit of the annual accounts

and the verification of the consistency of the management report with the accounts shall be entrusted to one or more
independent auditors appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding three years.

The independent auditor or auditors may be re-elected.
The provisions of the two preceding paragraphs shall apply even if the appointment of an independent auditor is not

required by law.

89874

L

U X E M B O U R G

Chapter VI - General meetings of shareholders

Art. 15. Any duly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of the

shareholders, whether they hold unlimited or limited shares. Each unlimited share and each limited share entitles to one
vote, without distinction.

Without prejudice to the powers of the Manager(s) powers, the general meeting of shareholders shall have the widest

powers to carry out or ratify all acts affecting the Company. The general meeting of shareholders shall however adopt
and  ratify  measures  concerning the  Company vis-à-vis  third  parties or amending the articles  of  association with  the
agreement of the Manager(s) only. The shareholders shall decide on the allocation of the results and the distribution of
dividends upon proposal of the Manager(s) without its consent being required.

Art. 16. The annual general meeting shall meet in Luxembourg, at the registered office, on the second Tuesday of the

month of April at 3.00 PM. If such day is a legal public holiday, the annual general meeting shall take place on the next
following business day.

Art. 17. The Manager, or in case of plurality, any Manager, each unlimited shareholder and the Supervisory Board shall

be entitled to convene a general meeting as often as they consider it necessary in the interest of the Company. The
Manager, or in case of plurality, any Manager, and the Supervisory Board are obliged to convene the general meeting so
that it is held within one month where one or more shareholders representing at least 10% (ten per cent) of the share
capital so request in writing while indicating the agenda.

Notices convening to any general meeting shall contain the agenda. Notice shall be given in accordance with the

provisions of the law.

When all shareholders are present or represented at a general meeting, they may waive the prior notice.

Art. 18. An attendance list shall be drawn up at any general meeting.
It shall contain the names of the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them.

The attendance list shall be signed by all the shareholders present and by the representatives of the shareholders repre-
sented and certified by the chairman of the meeting.

One or more shareholders may participate in a general meeting (whether an ordinary or an extraordinary meeting)

by conference call or by any other means of communication enabling all participants to be heard and to speak. Such
participation shall be regarded as equivalent to physical presence at the meeting. The attendance list mentioned in the
previous paragraph must be signed after the event by those shareholders who took part in the meeting without being
physically present thereat.

Each member of the general meeting shall have a number of votes equal to the number of shares which he holds and

represents.

Art. 19. The general meeting shall be chaired by the Manager acting through one of its authorised signatories duly

appointed by the board of directors (fondés de pouvoir). In case of plurality of Managers, the Chairman will be appointed
by the General Meeting.

Unless otherwise determined by the general meeting, the general meeting shall be held without scrutineers.
The person chairing the meeting shall appoint a secretary.
However, where all the shareholders are present or represented, they may decide to proceed without a chairman

and without a secretary.

Art. 20. Save as otherwise provided by law or in the present articles of association, the general meeting shall validly

deliberate by a majority of the shares present or represented and decisions shall be taken by a simple majority of the
votes validly cast.

Art. 21. The deliberations of each general meeting shall be recorded in minutes signed by the chairman and the secretary

of the general meeting, if there are such, and by the shareholders present and the representatives of shareholders who
are represented.

Copies or extracts of such minutes shall be certified as true copies or extracts by any Manager, the chairman of the

Supervisory Board or by two members of the Supervisory Board.

Chapter VII - Financial year, Company accounts, Profits, Distributions

Art. 22. The Company’s financial year shall commence on 1 

st

 January and end on 31 

st

 December of each year.

As at 31 

st

 December of each year, the Manager(s), shall draw up an inventory and the annual accounts in accordance

with the law. The Manager(s), shall submit such documents, together with the management report, at least one month
prior to the annual general meeting, to the Supervisory Board and to the independent auditor, who have to draw up their
reports.

Art. 23. Fifteen days before the general meeting, the shareholders may consult the following documents at the regis-

tered office

89875

L

U X E M B O U R G

1. the annual accounts;
2. the list of public funds, shares, bonds and other corporate securities making up the portfolio;
3. the reports of the Supervisory Board and of the independent auditor.
The annual reports and the reports mentioned in item 3 above shall be addressed to the registered shareholders along

with the convening notice of the general meeting.

Art. 24. The general meeting shall hear the management report and acknowledge the reports of the Supervisory Board

and the independent auditor. It shall deliberate on the annual accounts and, if it thinks fit, approve them.

Upon approval of the annual accounts, the general meeting shall deliberate by a special vote on the discharge of the

Manager(s). That discharge shall only be valid if the annual accounts contain no omission or misstatement concealing the
real situation of the Company and, as regards acts carried out which fall outside the scope of the articles of association,
if they have been specifically indicated in the convening notice of the general meeting.

Art. 25. The Company’s net profit shall be allocated as follows:
1. at least five per cent shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall be made as long as such allocation

is required by law; and

2. the remainder shall be at the disposal of the general meeting.
To the extent permitted and in accordance with the conditions laid down by law, the Manager(s) are authorised to

pay interim dividends.

Chapter VIII - Dissolution, liquidation

Art. 26. With the agreement of the Manager(s), the Company may be dissolved by decision of the shareholders voting

at the same quorum and majority conditions as required for the amendment of these articles of association.

The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators (who may be legal entities or individuals)

appointed by the shareholders who will determine their powers.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by article 103 of the law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

The capital has been subscribed as follows:

Name of Subscribers

Number of subscribed shares

1. “ArcelorMittal”, pre-named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . one (1) share with unlimited liability (“action de

commandité”)

2. “AM Global Holding”, pre-named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . one thousand nine hundred ninety seven (1997)

shares with unlimited liability (“actions de
commandité”) two (2) shares with limited
liability (“actions de commanditaire”)

The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of two million euro (EUR 2,000,000.-) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses Evaluation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately three thousand euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will start on the day of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2011.
The first shareholders' meeting will thus be held in the year 2012.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1) Resolved to fix at three (3) the number of the members of the Supervisory Board and further resolved to elect the

following as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be
held in 2012:

1. Mr Fabrice MAGAR, with professional address at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.
2. Mr Eric NIEDZIELA, with professional address at 22, rue de la Digue, B-4400 Flemalle, Belgium.
3. Mrs Luisa PEREZ, with professional address at 24-26, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg.
2) Resolved to set the Company's registered office at 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.

89876

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the beginning thereof.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-sept juillet.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) «ArcelorMittal», société anonyme, ayant son siège social à L2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 82454,

ici représentée par Monsieur Fabrice MAGAR, Legal Counsel, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté,

L-2930 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 juillet 2011.

2) «AM Global Holding», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de

la Liberté, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102898,

ici représentée par Monsieur Fabrice MAGAR, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22

juillet 2011.

Les prédites procurations signées par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants agissant en leur capacité exposée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi

qu'il suit les statuts d'une société en commandite par actions qu'il va constituer par les présentes:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Dénomination. Objet, Siège social, Durée

Art. 1 

er

 .  La Société est une société en commandite par actions luxembourgeoise.

Elle compte deux (2) associés commandité, à savoir:
- «ArcelorMittal», société anonyme, ayant son siège social à L2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 82454.

- «AM Global Holding», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la

Liberté, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102898.

AM Global Holding disposera en outre de parts d’associé commanditaire. Il est entendu que, du fait du cumul de sa

qualité de commandité et de commanditaire, et par application des dispositions légales sur les sociétés en commandite
par action, cette société dernière ne bénéficiera pas à l’égard des tiers des limitations de responsabilité aux pertes d’Ar-
celorMittal Energy S.C.A. Elle sera par conséquent soumise sur ce point au régime de responsabilité des commandités.

Art. 2. La Société a pour dénomination «ArcelorMittal Energy S.C.A.».
Dans tout document émanant de la Société, cette dénomination sera suivie de la mention «société en commandite

par actions», écrite en toutes lettres, ou la mention «SCA», sans préjudice d’autres mentions exigées par la loi.

Art. 3. La société a pour objet notamment, en Europe et dans le reste du monde, au profit des sociétés du groupe

ArcelorMittal:

- L’achat et la vente d’énergie en ce compris l’électricité, le gaz naturel, les gaz industriels (oxygène, azote, argon, et

autres),

- L’achat, la vente, la mise en location, l’exploitation directe ou indirecte, de toute équipement industriel (et prestations

de services associées) relatif à la production, transformation, transport, captation d’énergies, y compris énergies renou-
velables,

- Toutes opérations relatives à l’optimisation portant sur toute solution technique existante ou à créer,
- La réalisation de ces mêmes opérations portant sur les gaz à effet de serre (CDM-Joint Implementation notamment).
La société pourra s’intéresser par tous moyens et notamment par voie d’achat, apport, prise de participation, fusion

ou alliance, à toute autre société, entité ou entreprises poursuivant un objet similaires, analogue ou complémentaire au
sien ou de nature à la favoriser.

Elle peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielle, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, pourra établir des sièges administratifs, agences, suc-

cursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

89877

L

U X E M B O U R G

Au cas où le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, estimerait que des événements extraordinaires,

d’ordre politique, économique ou social, ou plus généralement des cas de force majeure, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits
ou sont imminents, le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, pourra transférer provisoirement le
siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura tou-
tefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. - Capital social, Actions

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-). Il est représenté par deux mille

(2.000) actions à savoir:

- mille neuf cents quatre-vingt-dix-huit actions de commandité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.998
- deux actions de commanditaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Une action de commandité ne peut être cédée qu’avec le consentement unanime de tous les associés, commandités

et commanditaires.

Les actions sont et resteront nominatives.

Art. 7. Si un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions de commanditaire, il doit les offrir aux

autres actionnaires proportionnellement à leurs participations dans le total des actions de commanditaire détenues par
ces autres actionnaires.

En cas de désaccord persistant des actionnaires sur le prix après un délai de deux semaines, la valeur de cession sera

fixée par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des actions. Le ou les actionnaires qui entendent
céder les actions et le ou les actionnaires qui se proposent de les acquérir désigneront de part et d’autre un expert, un
troisième expert étant nommé conjointement par ces actionnaires. En cas de désaccord ou de carence quant à la nomi-
nation d’un ou plusieurs experts, celui-ci (ou ceux-ci) sera (seront) nommé(s) par le Président du Tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg à la requête de la partie la plus diligente. La Société communique par lettre recommandée le résultat
de l’expertise aux actionnaires en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter
ou céder les actions au prix arrêté. Le silence de la part des actionnaires pendant ce délai équivaut à un refus.

Si certains actionnaires seulement ou un seul déclarent vouloir acquérir des actions, les actions proposées à la vente

seront offertes aux actionnaires qui entendent les acquérir en proportion de leurs participations dans le total des actions
de commanditaire détenues par les actionnaires intéressés à l’achat.

Si à l’issue de cette procédure, la totalité des actions n’a pas trouvé preneur, l’actionnaire qui entend les céder peut

les offrir à des non-associés étant entendu qu’un droit de préemption est encore réservé aux autres actionnaires en
proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l’accord
avec des non-associés et suivant les conditions de celui-ci. L’alinéa 3 qui précède est d’application. La préemption des
autres actionnaires doit porter sur la totalité des actions à défaut de quoi l’actionnaire qui entend les céder est libre de
les céder aux prédits non-associés.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actions de commandité qui ne peuvent être cédées que dans

les conditions précisées à l’article 6 alinéa 2.

Chapitre III. - Gestion

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs associé(s) commandité(s). En cas de pluralité de Gérants, chaque Gérant

dispose seul du pouvoir de gérer et d’engager la Société.

Les associés commandité et Gérants sont:
- «ArcelorMittal», société anonyme, ayant son siège social à 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 82454 et

- «AM Global Holding», société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 19, avenue de la Liberté, L-2930

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 102898.

Le remplacement du Gérant, ou en cas de pluralité, de l’un ou l’autre des Gérants, ainsi que la nomination de Gérants

supplémentaires ne peuvent intervenir que du consentement unanime de tous les actionnaires commandités et com-
manditaires.

Art. 9. Le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre d’entre eux, a les pouvoirs les plus larges pour effectuer tous

les actes d’administration et de disposition de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou par les
présents statuts à l’Assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance appartiennent au Gérant, ou en
cas de pluralité, à l’un ou l’autre d’entre eux.

Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être conférés à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par l’un ou l’autre des Gérant(s).

89878

L

U X E M B O U R G

Les Gérants remettent en commun à l’approbation du Conseil de Surveillance un budget semestriel prévisionnel avant

le 31 mai et le 30 novembre de chaque année.

Art. 10. Le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre d’entre eux, par l’intermédiaire de ses fondés de pouvoir,

représente la Société à l’égard des tiers et en justice.

Chapitre IV. - Conseil de Surveillance

Art. 11. Les opérations et affaires de la Société et sa situation financière, comprenant en particulier ses livres et comptes,

sont contrôlées par un Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres non-actionnaires.

Le Conseil de Surveillance:
- fait rapport à l’Assemble Générale des irrégularités qu’il constate dans les comptes
- contrôle la régularité des comptes sociaux
- apprécie a posteriori l’opportunité des décisions de gestion et des orientations stratégiques des Gérants
- donne avant le 30 juin et le 31 décembre un accord préalable sur le budget pour le semestre à venir que lui présentent

en commun les Gérants respectivement avant le 31 mai et le 30 novembre.

Les  membres  du  Conseil  de  Surveillance  sont  élus  par  l’Assemblée  générale  des  actionnaires,  qui  détermine  leur

nombre, la durée de leur mandat pour une période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que
leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles; ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une
résolution adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.

Pour autant que les membres du Conseil de Surveillance sont des personnes morales, celles-ci sont représentées par

des personnes physiques qu’elles désignent.

Outre les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article, le Conseil de Surveillance donne son avis sur

toutes les questions que le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, lui soumet.

Art. 12. Le Conseil de Surveillance choisit parmi ses membres un président. Il choisit également un secrétaire qui n’a

pas besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui est responsable de la tenue des procès verbaux des réunions
du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance peut également se faire assister par toute personne qu’il estimera utile.
Le Conseil de Surveillance se réunit sur la convocation du président ou de l’un des actionnaires représentant au moins

un tiers des actions. Une réunion du Conseil doit en outre être convoquée si deux membres ou le Gérant , ou en cas de
pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, le demandent.

Le président préside toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désigne à la majorité simple des voix des membres présents à cette réunion un autre membre du Conseil de Surveillance
comme président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance est donné par lettre, e-mail ou télécopie à tous les membres

au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence est
mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indique le lieu de la réunion et contient l’ordre du jour.

Il peut être renoncé à cette convocation à la suite de l’assentiment écrit (y compris par lettre, e-mail ou télécopie) de

chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale n’est pas requise pour les réunions se tenant aux
jours, heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant

par écrit, y compris par lettre, e-mail ou télécopie, un autre membre comme son mandataire. Le Conseil de Surveillance
ne peut délibérer et agir valablement que si 3 de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à
la majorité simple des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion. Un ou plusieurs membres peuvent
participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes
les personnes participantes de s’entendre et de se parler. Une telle participation est considérée comme équivalant à une
présence physique à la réunion. Une décision écrite signée par la totalité des membres est régulière et valable comme si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 13. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance sont signés par le président de la réunion et

par le secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président ou

par le secrétaire.

Chapitre V. - Réviseur d’entreprises

Art. 14. Sans préjudice du contrôle effectué par le Conseil de Surveillance, le contrôle des comptes annuels et de la

concordance du rapport de gestion avec les comptes est confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par
l’Assemblée générale des actionnaires pour une période ne pouvant dépasser trois ans.

Le ou les réviseurs d’entreprises sont rééligibles.

89879

L

U X E M B O U R G

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables même si la désignation de réviseur(s) d’entreprises

n’est pas légalement obligatoire.

Chapitre VI. - Assemblées générales des actionnaires

Art. 15. Toute Assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des

actionnaires, qu’ils détiennent des actions de commandité ou des actions de commanditaire. Chaque action de comman-
dité et chaque action de commanditaire donne droit à une voix, indistinctement.

Sous réserve des pouvoirs du/des Gérant(s), l’Assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus larges pour

faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la Société à l’égard des
tiers ou qui modifient les statuts que d’accord avec le/les Gérants. Les actionnaires décideront de l’affectation du résultat
et de la distribution de dividendes sur proposition du/des Gérant(s), mais sans que le consentement de celui-ci ne soit
requis.

Art. 16. L’Assemblée générale annuelle se réunit au siège social, le deuxième mardi du mois d’avril à quinze heures. Si

ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, chaque actionnaire commandité ainsi que le

Conseil de Surveillance sont en droit de convoquer l’Assemblée générale aussi souvent qu’ils jugent que les intérêts de
la Société le nécessitent. Le Gérant, ou en cas de pluralité, l’un ou l’autre des Gérants, et le Conseil de Surveillance sont
obligés de la convoquer de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois lorsqu’un ou plusieurs actionnaires représentant
10% (dix pour cent) du capital social au moins le demandent par écrit en indiquant l’ordre du jour.

Les convocations pour toute Assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites conformément aux

dispositions légales.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’Assemblée générale, ils peuvent renoncer à la convo-

cation préalable.

Art. 18. A chaque réunion de l’Assemblée générale, il est tenu une liste de présence.
Elle contient les dénominations des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions possédées par

chacun d’eux. Cette feuille est signée par tous les actionnaires présents et les représentants des actionnaires représentés
et certifiée par le président.

Un ou plusieurs actionnaires peuvent participer à une réunion de l’Assemblée Générale (tant en la forme Ordinaire

qu’Extraordinaire) par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les
personnes participantes de s’entendre et de se parler. Une telle participation est considérée comme équivalant à une
présence physique à la réunion. La feuille de présence mentionnée à l’alinéa précédent devra être signée a posteriori par
les actionnaires ayant assisté à la réunion sans présence physique.

Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d’actions.

Art. 19. L’Assemblée est présidée par le Gérant agissant par l’intermédiaire d’un de ces fondés de pouvoir dûment

nommés par le Conseil d’administration. En cas de pluralité de Gérants, le Président sera nommé par l’Assemblée générale.

Sauf décision contraire prise par elle, l’Assemblée siège sans scrutateurs.
Celui qui préside l’Assemblée nomme un secrétaire.
Toutefois, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils peuvent décider de siéger sans président et

sans secrétaire.

Art. 20. Sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts en disposent autrement, l’Assemblée générale délibère

valablement à la majorité des actions présentes ou représentées et les décisions sont prises à la majorité simple des voix
valablement exprimées.

Art. 21. Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président

et le secrétaire de chaque assemblée, s’il y en a, ainsi que par les actionnaires présents et les représentants des actionnaires
représentés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par l’un des Gérants, le président du Conseil

de Surveillance ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre VII. - Exercice social, Comptes sociaux, Bénéfices, Répartitions

Art. 22. L’exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Au 31 décembre de chaque

année, le/les Gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le(s) Gérant(s) remet(tent) ces pièces ainsi que le rapport de gestion, un mois au moins avant l’Assemblée générale

annuelle, au Conseil de Surveillance et au réviseur d’entreprises qui doivent faire leurs rapports.

Art. 23. Quinze jours avant l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:
1. des comptes annuels;
2. de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille,

89880

L

U X E M B O U R G

3. des rapports du Conseil de Surveillance et du réviseur d’entreprises.
Les comptes annuels et les rapports mentionnés au point 3. qui précède sont adressés aux actionnaires nominatifs en

même temps que la convocation.

Art. 24. L’Assemblée générale entend le rapport de gestion et prend connaissance des rapports du Conseil de Sur-

veillance et du réviseur d’entreprises. Elle discute les comptes annuels et, si elle l’estime approprié, les adopte.

Après l’adoption des comptes annuels, l’Assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge du/des

Gérant(s).  Cette  décharge  n’est  valable  que  si  les  comptes  annuels  ne  contiennent  ni  omission,  ni  indication  fausse,
dissimulant la situation réelle de la Société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.

Art. 25. Le bénéfice net de la Société est utilisé comme suit:
1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu’aussi longtemps qu’il sera

légalement obligatoire.

2. Le surplus est à la disposition de l’Assemblée générale.
Le(s) Gérant(s) est/sont autorisés, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, à procéder à des versements

d’acomptes sur dividendes.

Chapitre VIII. - Dissolution, Liquidation

Art. 26. Avec l’accord des Gérant(s), la Société peut être dissoute par une décision des actionnaires votant dans les

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour les modifications statutaires, sauf disposition con-
traire de la loi.

La liquidation de la Société s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales)

nommés par les actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 103 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, tel que modifié, ont été remplies.

<i>Souscription et paiement

Le capital a été souscrit comme suit:

Nom des Souscripteurs

Nombre d’actions souscrites

1. “ArcelorMittal”, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Une (1) action de commandité
2. «AM Global Holding», prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mille neuf cent quatre-vingt-sept (1997) actions

de commandité Deux (2) actions de
commanditaire

Les  actions  ainsi  souscrites  sont  entièrement  libérées,  de  sorte  que  la  somme  de  deux  millions  d’euros  (EUR

2,000,000.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ trois mille euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le 31 décembre 2011.
L'assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2012.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les

résolutions suivantes:

1) A décidé de fixer à trois (3) le nombre de membres du Conseil de Surveillance et décide encore de nommer les

personnes suivantes comme membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l'assemblée gé-
nérale ordinaire à tenir en 2012:

1. Monsieur Fabrice MAGAR, avec adresse professionnelle au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.
2. Monsieur Eric NIEDZIELA, avec adresse professionnelle au 22, rue de la Digue, B-4400 Flemalle, Belgique.
3. Madame Luisa PEREZ, avec adresse professionnelle au 24-26, boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg.
2) A décidé de fixer le siège social de la Société au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg.

89881

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MAGAR, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 juillet 2011. Relation: EAC/2011/10226. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tania THOMA.

Référence de publication: 2011114479/562.
(110131464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Pearson Luxembourg N°. 2., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.125.500,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 100.148.

In the year two thousand and ten, on the eighth of December
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “Pearson Luxembourg N° 2. S.à r.l.” (the “Com-

pany”),  a  Luxembourg  "société  à  responsabilité  limitée",  having  its  registered  office  at  17,  rue  Glesener,  L-1631
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register with the
number B 100.148, incorporated by a notarial deed of the notary Joseph Elvinger enacted on 31 March 2004, whose
articles of incorporation have been published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 575 of
4 June 2004, lastly amended on 2 July 2010 by notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, published in the Memorial
C n° 2059 of 1 November 2010.

The meeting is presided by Solange Wolter, notary clerk, with professional address at Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Arlette Siebenaler, notary clerk, with professional address at Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, and the meeting elects as scrutineer Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
these minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the 16,060 (sixteen thousand and sixty) shares of USD 100 (one hundred

United States Dollars) each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly states that he has been duly informed
beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1,519,500 by the issue of 15,195 new shares

with a nominal value of USD 100 each in favour of Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch subject to the payment
of a share premium amounting to USD 616,718,550 and subject to the allocation of USD 151,950 to the legal reserve;

3. Intervention of the subscriber, subscription and payment by Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch of the

15,195 new shares issued by the Company by way of a contribution of a claim amounting to USD 618,390,000;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article eight of the articles of association of the Company relating to the share capital in

order to reflect the new share capital of the Company amounting to USD 3,125,500 pursuant to the above resolutions;
and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

89882

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives his right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agree to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully
each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1,519,500 (one million five hundred

nineteen thousand five hundred United States Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 1,606,000 (one
million six hundred and six thousand United States Dollars) to USD 3,125,500 (three million one hundred twenty five
thousand five hundred United States Dollars) by the issue of 15,195 (fifteen thousand one hundred and ninety five) new
shares with a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars each (the “New Shares”) in favor of Em-
bankment Finance Ltd – Luxembourg branch, a Luxembourg branch with address at 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number
B 153822 (the “Contributor”), acting as the Luxembourg branch of Embankment Finance Ltd, a company incorporated
under the laws of England and Wales, having its registered office at 80, Strand, London WC2R 0RL, United Kingdom,
subject to the payment of a share premium of USD 616,718,550 (six hundred sixteen million seven hundred eighteen
thousand five hundred and fifty United States Dollars) (the “Share Premium”) and subject to the allocation of USD 151,950
(one hundred fifty-one thousand nine hundred and fifty United States Dollars) to the legal reserve, the whole to be fully
paid up through a contribution in kind consisting in a claim for a total amount of 618,390,000 (six hundred eighteen million
three hundred ninety thousand United States Dollars) (the “Claim”) (the “Contribution”).

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor by means of the Contribution of the

New Shares.

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Régis Galiotto, prenamed. The Contributor declares to

subscribe the New Shares in the Company and to pay them up entirely by a contribution in kind hereafter described,
subject to the payment of a share premium for an amount of USD 616,718,550 (six hundred sixteen million seven hundred
eighteen thousand five hundred and fifty United States Dollars) and subject to the allocation of USD 151,950 (one hundred
fifty-one thousand nine hundred and fifty United States Dollars) to the legal reserve.

The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Contributor through a contribution in

kind consisting in the Claim.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, the pre-named company, consists in the Claim in exchange of the issuance

of the New Shares.

The total value of the contribution in kind made by the Contributor to the Company amounts globally to 618,390,000

(six hundred eighteen million three hundred ninety thousand United States Dollars) and is allocated as follows:

- USD 1,519,500 (one million five hundred nineteen thousand and five hundred United States Dollars) to the share

capital;

- USD 616,718,550 (six hundred sixteen million seven hundred eighteen thousand five hundred and fifty United States

Dollars) to the share premium; and

- USD 151,950 (one hundred fifty-one thousand nine hundred and fifty United States Dollars) to the legal reserve.

<i>Evaluation

The net value of the Contribution is evaluated at USD 618,390,000 (six hundred eighteen million three hundred ninety

thousand United States Dollars).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 8 December 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the

shareholding of the Company is now composed of:

- Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch, holding 31,255 (thirty-one thousand two hundred fifty five) shares.

89883

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is

resolved to amend the first paragraph of article eight (the second paragraph remaining the same) of the articles of asso-
ciation of the Company to be read as follows:

Art. 8. The Company's capital is set at USD 3,125,500 (three million one hundred twenty five thousand and five

hundred United States Dollars), represented by 31,255 (thirty-one thousand two hundred fifty five) shares of a nominal
value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated deed are estimated at approximately seven thousand Euros (7,000.-EUR).

There being no further business, the meeting is declared closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le huit décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de «Pearson Luxembourg N° 2. S.à r.l.» (la

«Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 17, rue Glesener, L-1631
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 100.148, constituée par un acte notarié du notaire Joseph Elvinger en date du 31 mars 2004,
dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 575 du 4 juin 2004, modifié
pour la dernière fois le 2 juillet 2010 par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, publié au Mémorial C n° 2059 du 1
novembre 2010.

L’assemblée est présidée par Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

Le président élit comme secrétaire Arlette Siebenaler, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg et l’assemblée élit comme scrutateur Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son
adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.– L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont inscrits sur une liste de

présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 16.060 (seize mille soixante) parts sociales de 100 USD (cent dollars

américains) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’associé unique reconnaît expressément
avoir été dûment informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 1.519.000 USD par l’émission de 15.195 nouvelles

parts sociales d’une valeur nominale de 100 USD chacune en faveur de Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch
moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant de 616.718.550 USD et l’allocation de 151.950 USD à la
réserve légale;

3. Intervention du souscripteur, souscription et paiement par Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch, des

15.195 nouvelles parts sociales émises par la Société au moyen d’un apport d’une créance d’un montant de 618.390.000
USD;

4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l’article huit des statuts de la Société relatif au capital social afin de refléter le nouveau

capital social de la Société d’un montant de 3.125.500 USD conformément aux résolutions ci-dessus; et

6. Divers.

89884

L

U X E M B O U R G

Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée

générale; l’associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère être valablement con-
voqué à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les
points portés à l’ordre du jour. De plus il est décidé que toute la documentation présentée lors de la réunion a été mise
à la disposition l’associé unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant 1.519.500 USD (un million cinq cent dix-neuf mille

cinq cents dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 1.606.000 USD (un million six cent six mille
dollars américains) à 3.125.500 USD (trois million cent vingt-cinq mille cinq cents dollars américains) par l’émission de
15.195 (quinze mille cent quatre-vingt-quinze) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars
américains) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») en faveur de Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch, une
succursale luxembourgeoise ayant son siège social au 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153822 (l’ «Apporteur»),
agissant en tant que succursale luxembourgeoise de Embankment Finance Ltd, une société constituée selon le droit de
l’Angleterre et du Pays des Galles, ayant son siège social à 80, Strand, London WC2R 0RL, Royaume-Uni, moyennant le
paiement d’une prime d’émission de 616.718.550 USD (six cent seize million sept cent dix-huit mille cinq cent cinquante
dollars américains) (la «Prime d’Emission») ainsi que l’allocation de 151.950 USD (cent cinquante-un mille neuf cent
cinquante dollars américains) à la réserve légale, la totalité devant être totalement libérée par un apport en nature con-
sistant en une créance d’un montant total de 618.390.000 USD (six cent dix-huit million trois cent quatre-vingt dix mille
dollars américains) (la «Créance») (l’«Apport»).

<i>Troisième résolution:

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts Sociales par l’Apporteur au moyen de

l’Apport.

<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Intervient alors l’Apporteur, ici représenté par Régis Galiotto, précité. L’Apporteur déclare souscrire aux Nouvelles

Parts Sociales de la Société et les payer entièrement au moyen d’un apport en nature ci-après décrit, moyennant le
paiement d’une prime d’émission d’un montant de 616.718.550 USD (six cent seize million sept cent dix-huit mille cinq
cent cinquante dollars américains) ainsi que l’allocation de 151.950 USD (cent cinquante-un mille neuf cent cinquante
dollars américains) à la réserve légale.

Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d’Emission ont été intégralement payées par l’Apporteur au moyen

d’un apport en nature consistant en la Créance.

<i>Description de l’apport

L’apport effectué par l’Apporteur, la société précitée, consiste en la Créance en échange de l’émission des Nouvelles

Parts Sociales.

La valeur totale de l’apport en nature effectué par l’Apporteur à la Société s’élève globalement à 618.390.000 USD

(six cent dix-huit million trois cent quatre-vingt dix mille dollars américains) et est allouée comme suit:

-1.519.500 USD (un million cinq cent dix-neuf mille cinq cents dollars américains) au capital social;
- de 616.718.550 USD (six cent seize million sept cent dix-huit mille cinq cent cinquante dollars américains) en prime

d’émission; et

- 151.950 USD (cent cinquante-un mille neuf cent cinquante dollars américains) à la réserve légale.

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport est évaluée à 618.390.000 USD (six cent dix-huit million trois cent quatre-vingt dix mille

dollars américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport

en date du 8 décembre 2010, qui restera ci-annexée pour être enregistrée avec le présent acte.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’Apport ayant été entièrement réalisé, l’actionnariat

de la Société sera dorénavant composé de:

- Embankment Finance Ltd – Luxembourg branch, détenant 31.255 (trente-et-un mille deux cent cinquante cinq) parts

sociales.

89885

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l’apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l’article huit (le second paragraphe restant inchangé) des statuts de la Société qui devra
être lu comme suit:

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 3.125.500 USD (trois million cent vingt-cinq mille cinq cents dollars

américains), représenté par 31.255 (trente-et-un mille deux cent cinquante-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de
100 USD (cent dollars américains) chacune.»

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués approximativement à la somme de sept mille Euros (7.000.-EUR).

Aucune autre affaire n’ayant à être traitée, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente que sur demande du comparant le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55211. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011114779/222.
(110131253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 27.856.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de corriger comme suit la première ligne de l'acte publié dans le Mémorial C n° 1018 du 17 mai 2011, page

48858:

au lieu de: «Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Balance wurde beim Handels- und Gesellschafts-

register von Luxemburg hinterlegt.»,

lire: «Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Substanz wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.»

Référence de publication: 2011116182/13.

Aber Diamond Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.921.800,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 84.154.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 mai 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Cyrille Baudet, avec adresse professionnelle au 8, Chemin du Tourbillon, 1228 Plan-Les-Ouates (Suisse) est élu

nouveau gérant de la société avec effet au 9 mai 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Référence de publication: 2011084469/14.
(110095279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

89886

L

U X E M B O U R G

Citimmo Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4551 Niederkorn, 6, rue des Ecoles.

R.C.S. Luxembourg B 161.504.

STATUTS

L'an deux mille onze, le quinze juin.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Joël BESCH, employé privé, né à Luxembourg, le 22 juillet 1960
demeurant à L-5222 Sandweiler, 6, an der Kettenbach.
2.- La société anonyme "GETRAL S.A." établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg B 96.608, ici représentée par deux de ses administrateurs,
respectivement administrateurs-délégués, à savoir:

- Monsieur Fabio MAROCHI, administrateur, demeurant à L-4513 Niederkorn, 76A, route de Bascharage,
- Monsieur Marco SGRECCIA, administrateur, demeurant à L-2533 Luxembourg, 77, rue de la Semois,
comparaît à l'acte Monsieur Fabio MAROCHI, prénommée, agissant également au nom de Monsieur Marco SGRECCIA,

également prénommée, en vertu d'une procuration annexée.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une

société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

CITIMMO PROJECTS S. à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la location, l'échange d'immeuble bâtis et non bâtis, la construction, la

transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour le compte
de tiers, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège social est établi à Niederkorn.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

89887

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Joël BESCH, prénommé CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société anonyme GETRAL S.A, prénommée CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS EUROS (€ 900,-).

<i>Décisions

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité

des voix ils ont pris les décisions suivantes:

I.- Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Joël BESCH, prénommé
- La société anonyme "GETRAL S.A." prénommée
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
III.- Le siège social de la société se trouve à L-4551 Niederkorn, 6, rue des Ecoles.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Besch, Marochi, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 juin 2011. Relation: EAC/2011/7936. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011084543/79.
(110095297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Duna Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 115.767.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

<i>tenue au siège social de la société le 15 juin 2011 à 14.00 heures

L'Assemblée générale décide d'accepter la demission de Madame Béatrice Niedercorn de son poste d'administrateur

et nomme en remplacement, Monsieur Alfonso Garcia, demeurant au 5, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, jusqu'au
jour de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2011085730/15.
(110095231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.025,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.572.

<i>Extraits des résolutions prises par les associés en date du 1 

<i>er

<i> mai 2011:

1. Il est mis fin au mandat de gérant:
a) M. Fardan Al Fardan, gérant de catégorie B, fin de mandat en date du 1 

er

 mai 2011.

89888

L

U X E M B O U R G

2. Le gérant suivant est nommé pour une durée illimitée:
a) M. Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi, né le 15 juillet 1977 à Abu Dhabi, Emirats Arabes, de résidence

personnelle au Z-4 Plot No 17 Mohamed Bin Zayed City, Abu Dhabi, Emirats Arabes, est nommé gérant de catégorie B,
début du mandat en date du 1 

er

 mai 2011.

1. Le conseil de Gérance se compose comme suit:
M. Dominique Prince - Catégorie A
M. Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi - Catégorie B
M. Salem Khamis Al Darmaki - Catégorie B
M. Daniel Peeters - Catégorie B
M. Marcus Shepherd - Catégorie B
M. Ben Stirling - Catégorie B

<i>Pour la Société
Lorna Ros
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011084620/25.
(110095289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Interba S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.610.

<i>Extrait des résolutions prises lors de

<i>l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2011

- La démission de Madame Nicole THIRION de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Kevin DE WILDE, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg est nommé nouvel Administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2011.

Certifié sincère et conforme
INTERBA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011084647/17.
(110095283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

MGP Artemis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 134.654.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d'agent domiciliataire de la société "MGP Artemis

S.à r.l. SICAR", immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 134 654
avec effet au jour de la publication de cet avis dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2011.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2011085748/12.
(110094913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

CO.LU S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 24, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 145.132.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

89889

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2011087048/12.
(110096563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Medical Trials Analysis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 70.480.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62056 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011084706/10.
(110095294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Niramore International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 44.463.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2011

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur François LANNERS, employé privé demeurant au 57A, Route d'Arlon,

L-7513 Mersch, de Madame Céline BONVALET, employée privée demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch,
L-2086 Luxembourg, et de Madame Servane PAOLONI, employée privée demeurant professionnellement au 412F, Route
d'Esch, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2017.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes, la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme ayant son siège social

au 12, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six
ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2011.

Certifié sincère et conforme
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011084725/21.
(110095217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Peabody Boetie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 93.360.

EXTRAIT

Par un contrat de cession d'actions, daté du 7 avril 2011, la société Constructa Asset Management SA, une société

anonyme de droit français, ayant son siège social à 75, rue de Miromesnil, F-75008 Paris, France, et inscrite auprès du
Registre de Commerce de Paris sous le numéro B 424 387 223, a cédé vingt-cinq (25) parts sociales de catégorie B de
la Société à la société PI Europe 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de EUR 1.468.259,- et
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71.260.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Peabody Boetie S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011084736/18.
(110095292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

89890

L

U X E M B O U R G

Sunningdale Properties II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 79.197.

En date du 6 juin 2011, l’assemblée générale à pris acte de la démission comme administrateur de Monsieur Jacques

Wolter et a nommé comme nouveaux administrateurs Monsieur Tom Wagner et Monsieur Luc Tapella, tous deux avec
adresse professionnelle à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin avec l’assemblée générale de 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Sunningdale Properties II SA

Référence de publication: 2011084805/13.
(110095205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

AEIF LH Sub 05 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 135.798.

In the year two thousand and eleven, on the first day of June.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

AEIF Luxembourg Holdings S.àr.l., a private limited company governed by the laws of Luxembourg, having its registered

office at 6, rue Jean Monnet, Luxembourg, L-2180 registered under number B 129.159 and holder of 600 (six hundred)
shares of the Company,

hereby represented by Mrs Pascale Haine, employee, residing professionally at L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet,
by virtue of a proxy given under private seal on 1 

st

 June 2011.

Such proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of AEIF LH Sub 05 S.àr.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Jean Monnet in L-2180 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 135.798, incorporated pursuant to a deed of Maître
Paul Decker, notary residing in Luxembourg, on 16 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Number 491 on 26 

th

 February 2008, modified by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxem-

bourg, on 25 September 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2523 on 28

th

 December 2009, (the Company).

II. That the 600 (six hundred) shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, repre-

senting the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the sole shareholder, represented as stated here above, considering himself as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 500.- (five hundred euro)

so as to raise it from its present amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand euro) represented by 600 (six hundred) shares
of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, to an amount of EUR 15,500.- (fifteen thousand
five hundred euro), by the creation and issuance of 20 (twenty) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty five
euro) each, each, having the same rights and privileges as the existing shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to admit to the subscription of the new shares the sole shareholder of the Company.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the pre-named subscriber, represented as aforesaid, declares to subscribe to the new shares, the number

to which he has been admitted, and to make payment in full for the twenty new shares thus subscribed by a contribution

89891

L

U X E M B O U R G

in cash (hereinafter referred to as the "Contribution´) amounting totally to EUR 1,068,000.- (one million sixty-eight
thousand euro) towards the Company, it being understood that an amount of EUR 500.- (five hundred euro) shall be
allocated to the Company's share capital and an amount of EUR 1,067,500.- (one million sixty-seven thousand five hundred
euro) shall be allocated to the share premium account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary, who expressly recorded such proof.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of Article 6 of the

Articles of Association of the Company which shall forthwith read as follows:

"The share capital is set at EUR 15,500.- (fifteen thousand five hundred Euro) represented by 620 (six hundred twenty)

shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, all of which are fully paid up.´

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the company and Mrs Pascale Haine to proceed on behalf of the Company to
the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Expenses

All the expenses and remunerations which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated

at approximately EUR 2,400.- (two thousand four hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Rambrouch, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de texte qui précède:

L'an deux mille onze, le premier juin.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AEIF Luxembourg Holdings S.àr.l., une société de droit de luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.159,
propriétaire de 600 (six cents) parts sociales de la Société,

ici représentée par Madame Pascale Haine, employée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, 6, rue

Jean Monnet,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 1 

er

 juin 2011.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentant, demeurent annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est la seule associée de AEIF LH Sub 05 S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.798, constituée suivant un acte de Maître Paul Decker,
notaire de résidence à Luxembourg du 16 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 491 du 26 février 2008, et modifiée suivant un acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg
du 25 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2523 du 28 décembre 2009
(la Société).

II. Que les 600 (six cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui a pris les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, se considérant dûment convoquée, déclare avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué en avance.

89892

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 500,- (cinq cents euros), afin de

porter le capital social de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) représenté par 600 (six cents) parts
sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 15.500,-
(quinze mille cinq cents euros) par la création et l'émission de 20 (vingt) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'admettre à la souscription des parts sociales nouvelles la seule associée de la Société.

<i>Intervention - Souscription – Libération

Ensuite, le souscripteur pré-désigné, représenté comme ci-avant, déclare souscrire aux parts sociales nouvelles, le

nombre pour lequel il a été admis, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire (l'«Apport») d'un montant
total de EUR 1.068.000,- (un million soixante-huit mille euro), dont EUR 500,- (cinq cents euro) seront imputés au capital
social de la Société, et le solde de EUR 1.067.500,- (un million soixante-sept mille cinq cents euro) seront imputés sur le
compte prime d'émission de la Société.

Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au

notaire instrumentant, lequel constate expressément cette preuve.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l'Assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 15.500,- (quinze mille cinq cents euros) représenté par 620 (six cent vingt) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement libé-
rées.»

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier le registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et de

donner pourvoir et autoriser à tout gérant de la Société et à Mme Pascale Haine de procéder au nom de la Société à
l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la Société à raison des présentes sont évalués à la somme de EUR 2.400,-

(deux mille quatre cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: P. Haine, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 6 juin 2011. Relation: RED/2011/1090. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 16 juin 2011.

Référence de publication: 2011083595/134.
(110094184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

T.C.G. Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 67.822.

<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire

<i>de l'Actionnaire Unique qui s'est tenue le 18 avril 2011

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de TCG Gestion S.A. (la "Société"), tenue le 18 avril 2011

il a été décidé comme suit:

- De démissionner Deloitte S.A. de son mandat de Réviseur d'Entreprises avec effet immédiat;

89893

L

U X E M B O U R G

- De nommer CAS Services S.A. ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que Com-

missaire aux Comptes de la société avec effet au 18 avril 2011, son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale Annuelle
des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Catherine Noens &amp; Fabio Spadoni
<i>Fondés de Pouvoirs A

Référence de publication: 2011084807/18.
(110094967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Tiburon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.818.

Berichtigte Bilanz Referenznummer: L100076891 eingereicht am 02/06/2010

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011084815/11.
(110094933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Real Impact, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 161.490.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée

<i>générale des associés tenue en date du 17 juin 2011

L’assemblée prend acte des cessions de parts sociales intervenues ce jour entre:
- DELTA LOGIC S.A. et Monsieur Loïc JACOBS van MERLEN, pour 49 parts
- DELTA LOGIC S.A. et Monsieur Sébastien DELETAILLE, pour 49 parts
- DELTA LOGIC S.A. et Monsieur Didier BACLIN, pour 2 parts
Suite à ces cessions de parts la nouvelle répartition du capital social est la suivante:
- Monsieur Loïc JACOBS van MERLEN, né le 18 avril 1984 à Grabs (Suisse), demeurant au 1, avenue des Hespérides

à B-1180 BRUXELLES, est propriétaire de 49 parts

- Monsieur Sébastien DELETAILLE, né le 22 octobre 1984 à Uccle (Belgique), demeurant au 32, rue aux Laines à B-1000

BRUXELLES, est propriétaire de 49 parts

- Monsieur Didier BACLIN, né le 18 octobre 1983 à Charleroi (Belgique), demeurant 6, rue de l’Ouest à L-2273

Luxembourg, est propriétaire de 2 parts

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Nico HANSEN avec effet immédiat de ses fonctions de gérant

de la société.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Sébastien DELETAILLE, né à UCCLE (Belgique) le 22 octobre 1984, de-

meurant au 32, rue aux Laines à B-1000 BRUXELLES aux fonctions de gérant technique de la société avec effet immédiat
pour une durée indéterminée.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Loïc JACOBS van MERLEN, né à GRABS (Suisse) le 18 avril 1984, demeurant

au 1, avenue des Hespérides à B-1180 BRUXELLES aux fonctions de gérant administratif de la société avec effet immédiat
pour une durée indéterminée.

L’Assemblée décide que la société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique ou par

la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.

Référence de publication: 2011084755/31.
(110095290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

89894

L

U X E M B O U R G

Tiburon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.818.

<i>Berichtigte Bilanz Referenznummer: L100076890 eingereicht am 02/06/2010

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011084816/11.
(110094934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 36.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.
HRT REVISION S.A.
Signature

Référence de publication: 2011087049/12.
(110096560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Ageo Patrimoine (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 142.844.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011087186/9.
(110098628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

Kilrush, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.754.

EXTRAIT

En date du 21 juin 2011, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. La démission de Giovanni La Forgia, en tant que gérant B de la société, est acceptée avec effet immédiat.
2. Sonja van der Chijs, née le 27 décembre 1974 à Arnhem, Pays-Bas et avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indé-
terminée.

Le conseil de gérance est maintenant composé comme suit:
- Ivo Hemelraad, gérant A;
- Wim Rits, gérant A;
- Kees-Jan Avis, gérant B;
- Ciaran Burns, gérant B;
- Sonja van der Chijs, gérant B;
- Michael Kearns, gérant B;
- Donal Mulcahy, gérant B;
- Donal O’Neill, gérant B.

89895

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2011.

Référence de publication: 2011091870/25.
(110103244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

SK Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.881.525,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 93.454.

Suite à un transfert de parts sociales sous seing privé, le capital de la société SK PARTICIPATION Sàrl se répartit de

la manière suivante à dater du 24 mars 2011:

TRISTAR CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urbanizacion Obarrio
Torre Swiss
Calle 53
Panama City
Republic of Panama

535 939 parts

Cyril ABECASSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29, Chemin Jean-Achard
CH-1231 CONCHES

6 170 parts

Emmanuel SEBAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10, Bruton Street - 5 

th

 floor

GB-W1J 6PX LONDON

18 452 parts

Jean-Jacques MURRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10, Bruton Street - 5 

th

 floor

GB-W1J 6PX LONDON

34 688 parts

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 249 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2011.

Certifié sincère et conforme
SK PARTICIPATION S.à r.l.

Référence de publication: 2011084790/30.
(110095282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Becom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R.C.S. Luxembourg B 101.025.

Im Jahre zwei tausend elf.
Den siebenundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Arno BECHEL, Radio-und Fernsehtechniker, wohnhaft in D-54298 Gilzem, 14, Eisenacherstrasse.
Welcher Komparent erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BECOM S.à

r.l. ist, mit Sitz in L-6437 Echternach, 16, rue Ermesinde, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 101.025 (NIN 2004 2410 110).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse LENTZ, mit dem

damaligen Amtssitze in Remich, am 10. Mai 2004, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 761 vom 23. Juli 2004, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar
Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze in Niederanven, am 30. März 2010, veröffentlicht im Memorial C Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 1059 vom 20. Mai 2010.

Dass das Kapital der Gesellschaft sich augenblicklich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500,-) beläuft, eingeteilt

in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125,-), alle zugeteilt Herrn Arno BECHEL.

89896

L

U X E M B O U R G

Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Echternach nach Betzdorf zu verlegen, und dem-

gemäss den ersten Absatz von Artikel 4 der Statuten abzuändern wie folgt:

Art. 4. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in Betzdorf.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre

Werner.

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Echternach. Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. BECHEL, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 28 juin 2011. Relation: ECH/2011/1077. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels-und Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 01. Juli 2011.

Référence de publication: 2011090642/39.

(110102854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

Auster Real Estate Opportunities S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 158.948.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé en date du 8 juin 2011

L'associé a accepté la démission avec effet immédiat de Mme Marie-Sibylle WOLF et a nommé en remplacement, avec

effet immédiat et pour une durée indéterminée, M. Simon BARNES, résidant professionnellement au 6, rue Philippe II,
L-2340 Luxembourg, née le 2 décembre 1962 à Liverpool, Royaume-Uni, en tant que gérant.

Le conseil de gérance de la société se compose dorénavant comme suit:
M. Robert Quinn, gérant,
M. Simon Barnes, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011084991/19.
(110095020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Anoa Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1645 Luxembourg, 6, Montée du Grund.

R.C.S. Luxembourg B 155.833.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011084999/11.
(110095270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

89897

L

U X E M B O U R G

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.437.

<i>Auszug aus dem 43. Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates

<i>vom 1. April 2011 und der 13. Ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2011

Es wurde u.a. beschlossen,
1) mit Wirkung zum 1. Mai 2011, den Rücktritt von Frau Gaëtane CREUTZ-DOMMEL, wohnhaft in B-4700 EUPEN,

Lascheterfeld  18,  von  ihrer  Funktion  als  geschäftsführendes  Verwaltungsratsmitglied  anzunehmen.  Frau  Gaëtane
CREUTZ-DOMMEL wird weiterhin ihr Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ausüben.

2) mit Wirkung zum 1. Mai 2011, Herrn Alexander COLONERUS, Referent Compliance &amp; Risk Management, wohnhaft

in B-4783 St. Vith, Galhausen 2, zum täglichen Geschäftsführer, zu ernennen. Das Mandat von Herrn COLONERUS endet
am Tage der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.

3) die Gesellschaß KPMG Audit, mit Sitz in L-2520 LUXEMBURG, allée Scheffer 31, zum Wirtschaftsprüfer für das

Geschäftsjahr 2011 zu ernennen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 26. Mai 2011.

<i>Für Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.
Der Verwaltungsrat
Marcel CREUTZ / Lars SOERENSEN
<i>Präsident des Verwaltungsrates / <i>Verwaltungsratsmitglied

Référence de publication: 2011087172/24.
(110094956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Airtech G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9168 Mertzig, 3, Tonnheck.

R.C.S. Luxembourg B 110.116.

DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

a comparu:

Monsieur Piet VERMAAT, ingénieur, né à Haarlem (Pays-Bas) le 18 août 1950 (matr. 1950 08 18 517), demeurant à

L-9168 Mertzig, 3, Tonnheck.

Lequel comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée "AIRTECH, GmbH" (matr. 2005 24 22 052),

avec siège social à L-9168 Mertzig, 3, Tonnheck,

constituée suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 5 août 2005, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 44 du 7 janvier 2006,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B110.116,
lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social de la susdite société, a requis le notaire d'acter:
I. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrit et libéré.

L’associé représentant l’intégralité du capital social déclare:
II. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
III. être le propriétaire de l'ensemble des parts de la société et, en tant qu’associé représentant l’intégralité du capital

social, déclare expressément procéder à la dissolution de la société;

IV. que ladite société a cessé toute activité commerciale;
V. que l'ensemble des dettes de la société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la société, et reconnaît

qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la société après sa dissolution;

VI. en conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par l’associé au gérant de la société

pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour;

VII. les livres et comptes de la société seront conservés pendant cinq ans à l’adresse privée de l’associé.

89898

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge du comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Vermaat, Probst
Enregistré à Diekirch, Le 22 juin 2011. Relation: DIE/2011/6071. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011090569/41.

(110101996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2011.

OSS CCS II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.142.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2011.

OSS CCS II S.à r.l.
M.C.J. Weijermans
<i>Gérant B

Référence de publication: 2011087120/14.
(110096490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

Charter Hall Retail Poland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.888.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011085019/11.
(110095267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Coach &amp; Win, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 110.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Karine REUTER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011085026/11.
(110095218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

89899

L

U X E M B O U R G

Electricité &amp; Maintenance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3598 Dudelange, 149, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg B 51.514.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 9 juin 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant

en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation:

- société à responsabilité limitée ELECTRICITE &amp; MAINTENANCE Sàrl, avec siège social à L-3598 Dudelange, 149,

route de Zoufftgen, (N° R.C.S. B 51.514).

Pour extrait conforme
Emilie MELLINGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011085043/16.
(110095061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

J.B.C. Viandes Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange,

R.C.S. Luxembourg B 20.249.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 9 juin 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant

en matière commerciale, après avoir entendu le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation:

- société à responsabilité limitée J.B.C. VIANDES Sàrl, avec siège social à Dudelange, sans adresse précise, (N° R.C.S.

B 20.249).

Pour extrait conforme
Emilie MELLINGER
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2011085083/16.
(110095064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Castelerand Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 113.651.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011087043/10.
(110096596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

European Walls, Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 143.144.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Karine REUTER
<i>Notaire

Référence de publication: 2011085051/11.
(110095226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

89900

L

U X E M B O U R G

Omega Venture Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.401.

Veuillez noter qu’à la suite de leur cession en date du 30 juin 2011, les parts sociales sont détenues comme suit:
- Ancienne situation associé:

parts

sociales

Intertrust (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

- Nouvelle situation associé:

parts

sociales

M. Amadou ARONA SY, né à Dakar (Sénégal), le 17 septembre 1970,
demeurant à Dakar, Sénégal, Immeuble Fayçal, suite 801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Veuillez noter que les gérants suivants ont démissionné de leur fonction:
1. Mme. Virginie DOHOGNE a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme. Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérante.
3. M. Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat de gérant.

Luxembourg, le 30 juin 2010.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour OMEGA VENTURE CAPITAL
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011091975/25.
(110103679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Exane Funds 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 114.732.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011085052/11.
(110095248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

Jardines Inmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.671.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des

<i>actionnaires tenue extraordinairement le 30 mai 2011 à 10.00 heures au siège social

L'Assemblée décide
- d'accepter la démission de Mme Béatrice Niedercorn de son poste d'administrateur et de nommer comme nouvel

administrateur, Monsieur Alfonso Garcia, demeurant au 5, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, avec expiration du
mandat lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- de prolonger les mandats des administrateurs, Mme Beatriz Garcia et Mme Colette Wohl, demeurant au 5, boulevard

Royal à L-2449 Luxembourg, jusqu'au jour de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016;

- de prolonger le mandat du commissaire aux comptes, Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie S.à.r.l., RCS B 60.219, de-

meurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, jusqu'au jour de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

89901

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2011085084/20.
(110095128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2011.

CSC Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 71.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CSC INVESTMENTS
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011087050/12.
(110096537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2011.

J.P.Morgan Specialised Investment Fund I, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 143.184.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth of May.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “J.P.Morgan Specialised Investment Fund I”, (the

“Company”), a société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé in the form of a public limited
liability company (société anonyme), established and having its registered office in 31, Z.A.I. Bourmicht , L-8070 BER-
TRANGE, (R.C.S. Luxembourg, section B number 143184), incorporated by a notarial deed on November 21, 2008,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2952 of 12 December 2008.

The Extraordinary General Meeting is presided over by Mr Stéphane Charlier, private employee, with professional

address in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Sébastien Wiander, private employee, with professional address

in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Stéphane Charlier, private employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Presentation and approval of the annual accounts as at March 31, 2010 and March 31 2011
2) Discharge of the Directors for their duties up to this date
3) Decision to put the company into liquidation.
4) Appointment of the Liquidator and definition of its powers.
II.- The Sole Shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder, and the number of shares

owned by the shareholder are shown on an attendance-list which, signed by the shareholders or its proxy and by the
bureau  of  the  meeting,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  to  be  filed  at  the  same  time  with  the  registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder, signed «ne varietur» by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire subscribed share capital of the

Company are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder approves the annual accounts as at 31 March 2010 and

at 31 March 2011.

89902

L

U X E M B O U R G

The Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the Directors of the

Company for the accomplishment of their respective mandate up to this date

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder resolves to proceed to the immediate dissolution of the

Company “J.P.Morgan Specialised Investment Fund I”.

The Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder resolves to pronounce its liquidation as of today.

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder resolves to appoint as sole liquidator of the company:
Mr Bernard Herman, Company Director, with professional address in Luxembourg, 41, avenue de la Liberté, born at

Haine-Saint-Paul (Belgium), on July 15, 1956.

<i>Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting of the Sole Shareholder resolves to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated

laws on commercial companies as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of

the Sole Shareholder if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-

mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.

Nothing else being on the agenda, the Chairman closed the meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing persons, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the
English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-cinq mai.
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire Unique de «J.P.Morgan Specialised Investment Fund

I», (la «Société»), une société d'investissement à capital variable -fonds d'investissement spécialisé sous la forme d'une
société anonyme, établie et ayant son siège social au 31, Z.A.I. Bourmicht , L-8070 BERTRANGE (R.C.S. Luxembourg,
section B numéro 143184), constituée suivant acte notarié en date du 21 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2952 du 12 décembre 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane Charlier, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire de l'Assemblée Monsieur Sébastien Wiander, employé privé, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Charlier, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation des comptes annuels au 31 mars 2010 et 31 mars 2011;
2) Décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'à cette date
3) Dissolution anticipée de la Société.
4) Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant l'actionnaire unique présent ou représenté, ainsi que le nombre

des actions qu'il détient, laquelle, après avoir été signée par l'associé ou son mandataire et par les membres du Bureau,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire représenté, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, restera

également annexée au présent acte.

89903

L

U X E M B O U R G

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la Société

sont présentes ou représentées à l'Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire Unique approuve les comptes annuels au 31 mars 2010 et au

31 mars 2011.

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière aux Administrateurs

pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'à cette date.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire Unique décide de procéder à la dissolution immédiate de la

Société «J.P.Morgan Specialised Investment Fund I».

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire Unique décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Bernard Herman, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 41, avenue de la

Liberté, né à Haine-Saint-Paul (Belgique), le 15 juillet 1956.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Actionnaire Unique décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale de l'Actionnaire Unique dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur la demande du
même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. CHARLIER, S. WIANDER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mai 2011. Relation: LAC/2011/24366. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 juin 2011.

Référence de publication: 2011082310/129.
(110092111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.

Mobitrading S.A., Société Anonyme,

(anc. Sani Cover Corporate S.A.).

Siège social: L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 107.194.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011092361/11.
(110103621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

89904


Document Outline

Aberdeen Money Market Fund (Lux)

Aber Diamond Marketing S.à r.l.

AEIF LH Sub 05 S.à r.l.

Ageo Patrimoine (Luxembourg) S.à r.l.

Airtech G.m.b.H.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Alzette Properties S.A.

Anoa Capital S.A.

ArcelorMittal Energy S.C.A.

Auster Real Estate Opportunities S.à r.l.

Becom S.à r.l.

Castelerand Finance S.A.

Causerman Investissements S.A.

Charter Hall Retail Poland S.à r.l.

Citimmo Projects S.à r.l.

Coach &amp; Win

CO.LU S.à r.l.

COMPUTER RESOURCES INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.

CSC Investments

Deka Multi Asset Investors Luxembourg SICAV-FIS

Duna Investments S.A.

Electricité &amp; Maintenance Sàrl

European Walls

Exane Funds 2

Future Invest S.A., SPF

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l.

Interba S.A.

Jardines Inmo S.A.

J.B.C. Viandes Sàrl

Jef Financière S.A.

J.P.Morgan Specialised Investment Fund I

Kilrush

Life One

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF

"Lux-Portfolio" SICAV

Macquarie Private Markets Fund GP S.à r.l.

Magical S.A., SPF

Medical Trials Analysis S.A.

MGP Artemis S.à r.l.

MMB S.A.

Mobitrading S.A.

Mosaic

Niramore International S.A.

Omega Venture Capital

OSS CCS II S.àr.l.

Parvest

Peabody Boetie S.à r.l.

Pearson Luxembourg N°. 2.

Real Impact

Rosny S.A., SPF

Sani Cover Corporate S.A.

SK Participation S.à r.l.

Sunningdale Properties II S.A.

T.C.G. Gestion S.A.

Tiburon S.A.

Tiburon S.A.