This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1811
9 août 2011
SOMMAIRE
3W Power Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
86916
Artelis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86920
Artemia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86927
AS24 Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86927
Atelier Métallique Antonio Campos Sàrl,
en abrégé AMAC/Elvange Sàrl . . . . . . . . .
86927
Circuit Foil Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
86920
Clement Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86922
Controlgroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86920
DesCap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86917
D.S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86921
Egos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86917
Financière Daunou 13 S.A. . . . . . . . . . . . . . .
86885
Financière Daunou 15 S.A. . . . . . . . . . . . . . .
86885
Financière Piesa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86921
Fiver S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86922
JPMorgan Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86892
NaCoal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86882
Naiad Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86883
NC+S Acquisition Corporation S.à r.l. . . .
86882
New Life Settlement Scenarios S.A.- So-
ciété de Titrisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86883
Noosphere S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86883
Pfizer Continental Holdings Sàrl . . . . . . . . .
86882
Pfizer Europe Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . .
86884
Pfizer Global Investments Sàrl . . . . . . . . . .
86885
Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl . . . . . . . .
86885
Pfizer Investment Holdings S. à r.l. . . . . . .
86884
Pfizer Transactions Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86882
Prêtres du Sacré Coeur Couvent de Cinq-
fontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86917
Seed Box S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86883
Segeco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86928
Société de Gestion Hotelière et de Com-
merces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86890
Société Générale des Assaisonnements
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86890
Solar Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86884
Soleo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86891
SPXA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86891
Stam Re III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86891
Stam Re III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86891
Struwwelbuscht s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86892
Subsea 7 Lending S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86903
SU Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86884
SU Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86892
SU Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86903
TGR Trocken- und Innenausbau S.à r.l. . .
86909
Triodos Sicav I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86928
UBS (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
86904
UK Tissue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86904
Unionkey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86905
Uranus International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
86904
URSA Mortgage Finance S.A. . . . . . . . . . . .
86906
Valex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86906
VCL No. 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86906
Villa Arena S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86908
Villa Bianca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86908
VL. Logistik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86909
Voxel International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
86910
Wagner Management SA . . . . . . . . . . . . . . .
86910
Wave Quest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86910
WDI Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86911
Web4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86911
White Bear S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86913
Yaborandi SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86913
Yaborandi SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86916
Zum Immo Promotion S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86913
Zum Immo Promotion S.C.I. . . . . . . . . . . . .
86913
86881
L
U X E M B O U R G
Pfizer Transactions Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.075.
RECTFICATIF
<i>Extraiti>
Concernant le dépôt L110076167, Il convient de modifier l’organe du gérant de la Société, Monsieur Jean-Pol LEBLON
de Conseil de gérance en Collège de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083290/15.
(110093389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Pfizer Continental Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.007.
RECTFICATIF
<i>Extraiti>
Concernant le dépôt L110066645, il convient de modifier l’organe du gérant de la Société, Monsieur Jean-Pol LEBLON
de Conseil de gérance en Collège de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083299/15.
(110092774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
NC+S Acquisition Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 124.840.
Le bilan de la société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083275/13.
(110093217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
NaCoal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 154.263.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
Référence de publication: 2011083262/10.
(110092992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86882
L
U X E M B O U R G
New Life Settlement Scenarios S.A.- Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 158.693.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 mai 2011 au siège sociali>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 20 mai 2011, que le
Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
Transfert, avec effet immédiat, du siège social de la société du 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 1, rue Nicolas
Simmer L-2538 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011083263/14.
(110092662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Noosphere S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8449 Steinfort, 3, rue des Sports.
R.C.S. Luxembourg B 135.912.
<i>Décision collective prises par les associés en date du 25 mai 2011i>
L’an deux mille onze, le vingt-cinq mai, les associés représentant l’intégralité du capital social de la société à respon-
sabilité limitée NOOSPHERE SARL, susvisée, ont pris la résolution suivante:
Les associés décident de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante à compter de ce jour:
3, rue des Sports
L-8449 Steinfort
Steinfort, le 14.06.2011.
<i>Pour la société NOOSPHERE SARL
Le géranti>
Référence de publication: 2011083264/16.
(110093017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Naiad Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 79.612.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Naiad Property S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011083265/13.
(110093248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Seed Box S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 129.710.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011083362/10.
(110093342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86883
L
U X E M B O U R G
Pfizer Investment Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.600.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Concernant le dépôt L110076170, Il convient de modifier l’organe du gérant de la Société, Monsieur Jean-Pol LEBLON
de Conseil de gérance en Collège de gérance
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083289/15.
(110092814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Pfizer Europe Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.006.
RECTFICATIF
<i>Extraiti>
Concernant le dépôt L110069590, Il convient de modifier l’organe du gérant de la Société, Monsieur Jean-Pol LEBLON
de Conseil de gérance en Collège de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083300/15.
(110092775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Solar Investments S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 93.988.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083372/12.
(110093428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
SU Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 131.034.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083379/11.
(110093104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86884
L
U X E M B O U R G
Pfizer Global Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.370.
RECTFICATIF
<i>Extraiti>
Concernant le dépôt L110069593, il convient de modifier l’organe des gérants de la Société, Monsieur Jean-Pol LE-
BLON et Monsieur Christophe PLANTEGENET de Conseil de gérance en Collège de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083301/15.
(110093390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 136.369.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Concernant le dépôt L110066665, il convient de modifier l’organe du gérant de la Société, Monsieur Jean-Pol LEBLON
de Conseil de gérance en Collège de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083302/15.
(110092817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Financière Daunou 13 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 124.286.
Financière Daunou 15 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 125.436.
PROJET COMMUN DE FUSION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambourch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
(1) Mr Rémy BONNEAU, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting on behalf of the Board of Directors of Financière Daunou 15 S.A., a société anonyme governed by the laws of
Luxembourg, having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.436 (hereinafter
referred to as the "Absorbing Company") and incorporated following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, of February, 20, 2007, published in the Mémorial C number 954 of May, 23, 2007, which articles of
incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, of February 27, 2007, published in the Mémorial C number 1545 of July, 25, 2007,
by virtue of powers conferred on the basis of resolutions of the Board of Directors of the Absorbing Company dated
30 June 2011.
(2) Mr Rémy BONNEAU, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
acting on behalf of the Board of Directors of Financière Daunou 13 S.A., a société anonyme governed by the laws of
Luxembourg, having its registered office 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
86885
L
U X E M B O U R G
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.286 (hereinafter referred
to as the "Absorbed Company") and incorporated in form of a société à responsabilité limitée following a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of January, 21, 2007, published in the Mémorial C number 644 of April,
18, 2007, which became a société anonyme following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
of February, 15, 2007, published in the Mémorial C number 1007 of May, 30, 2007, which articles of incorporation of the
Company have been amended for the last time following a deed of Maître Joseph Elvinger, of February 27, 2007, published
in the Mémorial C number 1697 of August, 10, 2007,
by virtue of powers conferred on the basis of resolutions of the Board of Directors of the Absorbed Company dated
30 June 2011.
Excerpts of the relevant Board of Directors' resolutions, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed.
The appearing parties represented as stated hereabove have requested the undersigned notary to record the following
joint merger proposal (the "Joint Merger Proposal"):
1. Financière Daunou 15 S.A. The Absorbing Company is existing under the name Financière Daunou 15 S.A. and is a
société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of six million one hundred and forty-six
thousand euro (EUR 6,146,000.-), having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.436.
The Absorbing Company's corporate object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans,
advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however
without taking advantage of the Act of July 31
st
, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
The subscribed share capital of the Absorbing Company is set at six million one hundred and forty-six thousand euro
(EUR 6,146,000.-) divided into six million one hundred and forty-six thousand (6,146,000) shares with a nominal value of
one euro (EUR 1.-) per share and all of which are fully paid up.
2. Financière Daunou 13 S.A. The Absorbed Company is existing under the name Financière Daunou 13 S.A. and is a
société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of six million one hundred thousand euro
(EUR 6,100,000.-), having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.286.
The Absorbed Company's corporate object is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings. The Company may provide
any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing
of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. The Company may also use its funds to invest
in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form. The Company
may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or similar debt instruments. In a general fashion the Company
may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
The subscribed share capital of the Absorbed Company is set at six million one hundred thousand euro (EUR
6,100,000.-) divided into six million one hundred thousand (6,100,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-)
per share and all of which are fully paid up.
3. Merger. The Absorbing Company contemplates to merge with and absorb its fully controlled subsidiary the Absorbed
Company (both companies together being referred to as "Merging Companies") under the simplified merger procedure
regime (the "Merger") provided for in articles 278 and seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the "Law").
The purpose of the Merger is internal to the group of companies to which the Merging Companies belong and con-
templates to simplify the current structure of this group of companies.
The merger proposal in relation to the merger of the Absorbing Company and the Absorbed Company has been
approved on 30 June 2011 by the Merging Companies.
4. Effective Date. The Merger will be realised on the day that the Absorbing Company has acknowledged that the
Merger has become effective, which will be on or around one calendar month after the day of publication of the present
Joint Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Effective Date"). The Merger shall
be effective vis-à-vis third parties on the day of publication of the acknowledgment of effectiveness of the Merger.
For accounting purposes, the merger shall be deemed effective as from 1 January 2011.
86886
L
U X E M B O U R G
5. Financial Accounts. The Absorbing Company's annual accounts for the last three years have been approved by the
shareholders of the Absorbing Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.
The Absorbed Company's annual accounts for the last three years have been approved by the shareholder of the
Absorbed Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.
6. Assets and Liabilities contributed. Pursuant to the Merger, the Absorbed Company, following its dissolution without
liquidation, transfers all its assets and liabilities, including for the avoidance of doubt with any encumbrances or charges
thereon, to the Absorbing Company. The assets and liabilities are transferred at accounting book value on the Effective
Date.
7. Advantages granted to the Directors or Auditors. No special advantages are granted to the members of the Board
of Directors or to the Statutory Auditors of the Merging Companies. The Merging Companies have the following Statutory
Auditor: ERNST & YOUNG, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
8. Mandates granted by the Absorbed Company. The mandate of the Directors and of the Auditors of the Absorbed
Company will automatically cease on the Effective Date and full discharge is hereby granted to the Directors and the
Auditors of the Absorbed Company for the duties performed by them.
9. Convertible instruments issued by the Absorbed Company. Other than its shares, the Absorbed Company has
issued Mandatory Convertible Preferred Equity Certificates (MCPECs) to the Absorbing Company which will be cancelled
as a result of the Merger, the Absorbing Company becoming both the debtor and the creditor.
10. Consultation of documentation. All the shareholders of the Absorbing Company are entitled to inspect the do-
cuments specified in article 267, paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Law at the registered office of the Absorbing Company
at least one month before the Merger takes effect. The documents referred to under this paragraph are the joint merger
proposal, the annual accounts as well as the report on such accounts of the Board of Directors of the Absorbed Company
for the past three financial years. Each shareholder may obtain a copy of the above referred documents upon request
and free of charge.
11. General meeting of shareholders of the Absorbing Company. In compliance with article 279 of the Law, one or
more of the shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% in the subscribed share capital of the Absorbing
Company are entitled to require that a general meeting of shareholders of the Absorbing Company be called in order to
resolve on the approval of the Merger. The meeting must be convened so as to be held within one month of the request
for it to be held.
There is no requirement that a general meeting of the shareholders of the Absorbed Company be called in order to
resolve on the approval of the Merger as the Absorbed Company is wholly owned by the Absorbing Company.
12. Merger formalities. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities including such announcements as
are prescribed by law, which are necessary or useful to carry and to effect Merger and the transfer and assignment of
the assets and liabilities of the Absorbed Company in accordance with article 274 of the Law.
13. Dissolution of the Absorbed Company. The Merger will result in the dissolution without liquidation of the Absorbed
Company as of the Effective Date.
The mandate of the Directors of the Absorbed Company will come to an end on the Effective Date.
14. Corporate Records of the Absorbed Company. All corporate documents, files and records of the Absorbed
Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company for the duration prescribed by law.
15. Issued capital of the Absorbing Company following the Merger. The Merger will not entail a modification of the
issued capital of the Absorbing Company.
16. Expenses. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Com-
pany.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the joint merger proposal and of all acts, docu-
ments and formalities incumbent upon the Merging Companies pursuant to article 271 (2) of the Law.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Merging Companies
are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
86887
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt et unième jour de juillet.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
(1) Monsieur Rémy BONNEAU, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant pour le compte du conseil d'administration de Financière Daunou 15 S.A., une société anonyme, ayant son
siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.436 (ci-après la «Société Absorbante») et constituée
suivant un acte Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 20 février 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 954 du 23 mai 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 27 février 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1545 du 25 juillet 2007,
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante en
date du 30 juin 2011.
(2) Monsieur Rémy BONNEAU, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant pour le compte du conseil d'administration de Financière Daunou 13 S.A., une société anonyme, ayant son
siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.286 (ci-après la «Société Absorbée») et constituée
sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant un acte Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg,
en date du 15 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 644 du 18 avril 2007,
devenue une société anonyme par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 15
février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1007 du 30 mai 2007, dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, en date du
27 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1697 du 10 août 2007,
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du conseil d'administration de la Société Absorbée en date
du 30 juin 2011.
Les extraits des décisions desdits conseils d'administration, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte.
Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun
de fusion (le «Projet Commun de Fusion») suivant:
1. Financière Daunou 15 S.A.. La Société Absorbante existe sous le nom Financière Daunou 15 S.A. et revêt la forme
d'une société anonyme, ayant un capital social de six millions cent quarante-six mille Euros (EUR 6.146.000,-), ayant son
siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.436.
L'objet social de la Société Absorbante est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à six millions cent quarante-six mille Euros (EUR 6.146.000,-),
représentés par six millions cent quarante-six mille (6.146.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune
et toutes entièrement libérées.
2. Financière Daunou 13 S.A.. La Société Absorbée existe sous le nom Financière Daunou 13 S.A. et revêt la forme
d'une société anonyme, ayant un capital social de six millions cent mille Euros (EUR 6.100.000,-), ayant son siège social
au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.286.
L'objet social de la Société Absorbée est la prise de participations et la détention de participations dans toutes entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations. La
Société peut fournir toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société,
y compris, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut employer ses
fonds en investissant dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier
sous quelque forme que ce soit. La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou
d'instruments de dette similaires.
86888
L
U X E M B O U R G
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera
utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Le capital social souscrit de la Société Absorbée est fixé à six millions cent mille Euros (EUR 6.100.000,-), représentés
par six millions cent mille (6.100.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et toutes entièrement
libérées.
3. Fusion. La Société Absorbante prévoit de fusionner et d'absorber sa filiale entièrement contrôlée la Société Absorbée
(les deux sociétés ensembles étant mentionnées ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes») selon la procédure de
fusion simplifiée (la «Fusion») prévue aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»).
L'objet de la Fusion est interne au groupe de sociétés auquel les Sociétés Fusionnantes appartiennent et permettra de
simplifier la structure actuelle de ce groupe de sociétés.
Le projet de fusion relatif à la fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée a été approuvé le 30 juin 2011
par les Sociétés Fusionnantes.
4. Date de Prise d'Effet. La Fusion juridique sera réalisée le jour où la Société Absorbante a constaté que la Fusion
était effective, lequel sera environ un mois calendaire suivant le jour de la publication du présent Projet Commun de
Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date de Prise d'Effet»). La Fusion sera effective vis-à-vis
des tiers le jour de la publication du constat d'effectivité de la Fusion.
Comptablement la fusion sera réputée effective à partir du 1
er
janvier 2011.
5. Comptes Annuels. Les comptes annuels de la Société Absorbante pour les trois derniers exercices ont été approuvés
par les actionnaires de la Société Absorbante et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l'actionnaire de
la Société Absorbée et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
6. Actifs et Passif apportés. En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée, suivant sa dissolution sans liquidation,
transmet tous ses actifs et son passif, incluant pour éviter toute incertitude tous les droits et charges les grevant, à la
Société Absorbante. Les actifs et le passif sont transmis à la valeur comptable à la Date de Prise d'Effet.
7. Avantages accordés aux administrateurs, gérants ou aux auditeurs. Il n'est pas accordé d'avantages spéciaux aux
membres du conseil d'administration et de gérance des Sociétés Fusionnantes. Les Sociétés Fusionnantes ont pour com-
missaire aux comptes: ERNST & YOUNG, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
8. Mandat accordé par la Société Absorbée. Le mandat des administrateurs et des commissaires aux comptes de la
Société Absorbée cessera automatiquement à la Date d'Effet et décharge est donnée par les présentes aux administrateurs
et aux commissaires aux comptes de la Société Absorbée pour l'accomplissement de leurs mandats.
9. Instruments convertibles émis par la Société Absorbée. A part ses actions, la Société Absorbée a émis des Mandatory
Convertible Preferred Equity Certificates (MCPECs) à la Société Absorbante qui seront annulés par l'effet de la Fusion,
la Société Absorbante devenant à la fois débiteur et créancier.
10. Consultation de la documentation. Tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit d'inspecter les
documents mentionnés à l'article 267, alinéa 1 (a), (b) et (c) de la Loi au siège social de la Société Absorbante au moins
un moins avant la prise d'effet de la Fusion. Les documents mentionnés dans cet alinéa sont le projet de fusion, les comptes
annuels ainsi que le rapport sur ces comptes du conseil d'administration de la Société Absorbée pour les trois derniers
exercices comptables. Chaque actionnaire peut obtenir copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande et gra-
tuitement.
11. Assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante. Conformément à l'article 279 de la Loi, un ou
plusieurs actionnaires de la Société Absorbante détenant au mois 5% du capital souscrit de la Société Absorbante ont le
droit de requérir que l'assemblée générale de la Société Absorbante soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation
de la Fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Il n'est pas requis qu'une assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée soit convoquée afin de se pro-
noncer sur l'approbation de la Fusion dans la mesure où la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société
Absorbante.
12. Formalités liées à la Fusion. La Société Absorbante devra exécuter elle-même toutes les formalités incluant les
publications telles que prescrites par la loi, qui sont nécessaire ou utiles à l'exécution et à la prise d'effet de la Fusion et
à la transmission et cession des actifs et du passif de la Société Absorbée conformément à l'article 274 de la Loi.
13. Dissolution de la Société Absorbée. La Fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée à
partir de la Date de Prise d'Effet.
Le mandat des directeurs de la Société Absorbée prendra fin à la Date de Prise d'Effet.
14. Documents Sociaux de la Société Absorbée. Tous les documents sociaux, livres et documents comptables de la
Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prescrite par la Loi.
86889
L
U X E M B O U R G
15. Capital social de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion. La Fusion n'entraînera pas de modification du capital
émis de la Société Absorbante.
16. Frais. Tous les frais, dépenses, honoraires et charges résultant de la Fusion devront être supportés par la Société
Absorbante.
Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du projet de fusion et de tous les actes, documents, et formalités
incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 271 (2) de la Loi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille cent Euros (EUR 1.100,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: R. Bonneau, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 juillet 2011. Relation: RED/2011/1572. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Max ELS.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 25 juillet 2011.
Edouard DELOSCH.
Référence de publication: 2011112669/268.
(110127769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2011.
Société de Gestion Hotelière et de Commerces, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 60.341.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011083370/10.
(110092652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
SO.GE.AS., Société Générale des Assaisonnements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 38.798.
Par décision du Conseil d'administration tenu le 1
er
juin 2011 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, résidant professionnellement au 19/21,
Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur.
- De coopter comme nouvel administrateur, Monsieur Antonio FORTE, employé privé, résidant professionnellement
au 19/21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Générale des Assaisonnements S.A.
«SO.GE.AS S.A.»
Signatures
Référence de publication: 2011083371/16.
(110092731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86890
L
U X E M B O U R G
Soleo S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 161.316.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 15 juin 2011i>
L’actionnaire unique a nommé le mandat suivant avec effet immédiat et prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle en relation avec les comptes de l’exercice se clôturant au 31/12/2011:
Mazars, société anonyme, siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B56248: commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083373/15.
(110093320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
SPXA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 114.127.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2011083375/13.
(110093464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Stam Re III, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 135.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011083377/10.
(110092708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Stam Re III, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 135.144.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises en date du 14 juin 2011 que l’Associé Unique a décidé de nommer en tant que gérant
de la Société Monsieur Jean-Robert Bartolini avec effet au 14 juin 2011 et ce pour une durée indéterminée.
De telle sorte que le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur Antoine de Broglie, ayant son adresse professionnelle au 35, avenue de l’Opéra, F-75002 Paris (France)
- Monsieur Luca Gallinelli, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg (Grand-duché
de Luxembourg)
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg (Grand-
duché de Luxembourg)
86891
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083376/19.
(110092707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Struwwelbuscht s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7610 Larochette, 7, place Bleiche.
R.C.S. Luxembourg B 57.540.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L -1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011083378/14.
(110093225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
SU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 131.032.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg,
le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083380/12.
(110093091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
JPMorgan Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.478.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Funds (hereafter referred to
as the "Company"), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 8 478), incor-
porated by notarial deed on the 14
th
April 1969, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial") of 20
th
June 1969 under number 97. The Articles were last amended by a deed of Maître Karine Reuter on
15 February 2008, published in the Mémorial of 18 March 2008 under number 664.
The Meeting was opened with Ms Pam Steenfeldt-Kristensen, private employee, professionally residing in Luxembourg
as chairman of the Meeting (the "Chairman").
The Chairman appointed as secretary, Mr Xavier Rouvière, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Sven Birster, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company (the "Articles") in order to provide that
the Board of Directors of the Company (the "Board") may transfer the registered office of the Company to any other
municipality in the Grand Duchy of Luxembourg to the extent permitted by Luxembourg laws and regulations.
2. Amendment of Article 5 of the Articles to provide that the Company may create any master/feeder UCITS class,
convert any existing class into a feeder/master UCITS class or change the master UCITS of any of its feeder UCITS class,
if permitted and in accordance with the Luxembourg laws and regulations.
86892
L
U X E M B O U R G
3. Amendment of Article 6 of the Articles, inter alia, to
- provide that no bearer shares will be issued anymore;
- allow the Board to decide to compulsory exchange bearer shares in issue for registered shares and to precise that
after this decision holders of bearer shares will have to request their inscription in the register of shareholders before
they can exercise other rights attached to their shares;
- provide that where title to the shares has been provided to the subscriber but good settlement of purchase price
has not been effected, the Company shall be entitled to cancel the shares at the cost and expense of the subscriber
without prior notice and transfer of shares will not be permitted until receipt of the purchase price;
- provide that if the Company becomes aware that the address provided by the shareholder to be registered in the
register of shareholders is no longer the shareholder’s current/valid address, the Company may permit a notice to this
effect to be entered in the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Company; and
- specify that it is the shareholder's responsibility to ensure that its data inscribed on the register of shareholders is
kept up to date.
4. Amendment of Article 8 of the Articles, inter alia, to:
- extend the power of the Board (i) to refuse to issue or register any transfer of a share, (ii) to redeem compulsory
any existing shareholder, (iii) to impose such restrictions or (iv) to demand additional information in circumstances which
might result in the Company or any of its delegates suffering any sanction, penalty, burden or other disadvantage (whether
pecuniary administrative or operational);
- allow the Board to withhold any transfer request and any payment of the proceeds of any redemption request that
has been processed, without interest accruing, until a demand for further information made for antimoney laundering
purposes (or other similar purposes) has been satisfied.
5. Amendment of Article 10 of the Articles to allow the Board to decide to hold the annual general meeting of
shareholders at another date, time or place than those set forth in the Articles to the extent permitted by the Luxembourg
laws and regulations.
6. Amendment of Article 12 of the Articles, inter alia, to:
- remove the references and provisions relating to bearer shares;
- provide that a Record Date may be used to calculate the quorum and majority requirement applicable to general
meetings of shareholders and to determine the rights of shareholders to participate and exercise their voting rights, to
the extent permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations;
- provide that notices may be sent to shareholders either in writing, by facsimile transmission or such other electronic
means capable of evidencing delivery of such notice, to the extent permitted under Luxembourg law and regulations from
time to time.
7. Amendment of Article 16 of the Articles, inter alia, to provide that a class may invest in one or more other classes
of the Company, to the extent permitted by the Luxembourg laws and regulations.
8. Amendment of Article 21 of the Articles inter alia:
- to provide that the redemption price will be determined taking into account fiscal charges, redemption charge, dealing
charge or any other charge as the prospectus of the Company may provide;
- to remove the 1% limit of the redemption charge;
- to provide that redemption request may be satisfied in kind;
- to provide that the Board may decide that any partial redemption of bearer shares will result in the remaining balance
being converted to registered shares;
- to allow the Board, in certain circumstances provided for in the Articles, to close down one class by contribution
into an European Economic Area based undertaking for collective investment offering equivalent protection to the one
offered to the shareholders in the Company; and
- to specify that upon the transposition in Luxembourg laws and regulations of the provisions of the European Directive
2009/65/EC of 13 July 2009 and of its implementing directive which are applicable to the mergers of UCITS, such provisions
will replace the current provisions of the Articles regarding mergers.
9. Amendment of Article 22 of the Articles, inter alia, to provide that the determination of the net asset value and the
issue, redemption and conversion of shares may be suspended during any circumstances where a failure to do so might
result in the Company or its shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or
other detriment to which the Company or its shareholders might not otherwise have suffered.
10. Amendment of Article 23 of the Articles, inter alia:
- to provide that the net asset value per share may be adjusted to reflect any dealing costs, to implement swing pricing
techniques as further disclosed in the prospectus of the Company and as the Board may consider appropriate to take
into account.
- to include management company's fees and director's fees in the list of liabilities borne by the Company.
86893
L
U X E M B O U R G
11. Amendment of Article 24 of the Articles, inter alia, to provide that:
- the price at which shares shall be offered shall be the net asset value per share plus such fiscal charge, dealing charges,
any commission and other charges as the prospectus of the Company may provide; and
- shares in the Company may be issued against contributions in kind of transferable securities and other assets con-
sidered acceptable by the Board.
12. Amendment of Article 26 of the Articles, inter alia, to provide that dividends may be paid in cash, in kind or may
be reinvested in exchange for which additional shares in the Company will be issued and may include such amounts
whether representing revenue, capital gains or otherwise as may be permitted by law.
13. Amendment of Article 27 of the Articles to provide that liquidation proceeds may be paid either in kind or in cash.
14. General update of the Articles by amending, inter alia, articles 3, 5, 9, 11, 13, 14, 17 and 20 of the Articles.
II. That the extraordinary general meeting convened for 17 November 2010 could not validly deliberate for lack of
quorum and that the present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by mail to the registered
shareholders on 14 January 2011 and published in the Mémorial and the Luxemburger Wort on 12 and 31 January 2011.
III. That no quorum is required in order to hold validly this Meeting and that the resolutions on the agenda may only
be validly taken if approved by at least 2/3 of the votes cast at the Meeting.
IV. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
V. It appears from the attendance list that, out of the 3,186,486,860 shares in issue, 368,870,418 shares are represented
at the meeting.
VI. That pursuant to the provisions of Article 22 of the law of December 9
th
, 1976 on the organisation of the notarial
profession, the undersigned notary informed the appearers of the fact that the insertions of the notices have not been
effected in two Luxembourg newspapers, but only on one Luxembourg newspaper, and that consequently they did not
respect the provisions of Article 67-1(2) of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies.
After approval of the statement of the Chairman, the meeting, after deliberation, stated that the non respect of the
insertions of the notices in two Luxembourg newspapers was the result of a material mistake and resolved sovereignty
to examine the agenda and to pass the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting with 367,138,486 votes in favour and 689,089 votes against decides to add a second paragraph in article
4 of the Articles so as to read as follows:
"To the extent permitted by Luxembourg laws and regulations, the Board may transfer the registered office of the
Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg."
<i>Second resolutioni>
The Meeting with 365,247,494 votes in favour and 784,124 votes against decides to amend article 5 of the Articles so
as to read as follows:
"The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total
net assets of the Company as defined in Article 23 hereof.
The minimum capital of the Company shall be the equivalent in United States Dollars of one million two hundred and
fifty thousand Euro (EUR 1,250,000). The Board is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time in
accordance with Article 24 hereof at the price determined based on the Net Asset Value or the respective Net Asset
Values per share determined in accordance with Article 23 hereof without reserving to the existing shareholders a
preferential right to subscription of the shares to be issued.
The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares and performing any
other formalities required in the context of the issue of such shares.
Where the term ‘person’ or ‘persons’ is used within these Articles, such term shall refer to both legal and physical
persons as the context so permits.
Such shares may, as the Board shall determine, be of different classes and the proceeds of issue of each class of shares
shall be invested pursuant to Article 3 hereof in transferable securities and/or other liquid financial assets as well as other
assets permitted by the Law corresponding to such investment policy as the Board shall from time to time, with reference
to the current law, regulation and practice, determine in respect of each class of shares.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not
expressed in U.S. Dollars be translated into U.S. Dollars and the capital shall be the total net assets of all the classes.
If permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations, the Board
may, at any time it deems appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations,
86894
L
U X E M B O U R G
but in accordance with the provisions set forth in the prospectus and any other information documents of the Company
required by Law (the "Prospectus"), (i) create any class qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii)
convert any existing class into a feeder UCITS class or master UCITS class or (iii) change the master UCITS of any of its
feeder UCITS classes.
The Board may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose assets will be
commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific sales and
redemption charge structure, hedging policy or other specific feature is applied to each sub-class.
In these Articles, any reference to “class” or “classes” shall also mean a reference to “sub-class” or “sub-classes”, as
the case may be, unless the context otherwise requires."
<i>Third resolutioni>
The Meeting with 366,886,116 votes in favour and 779,720 votes against decides to amend article 6 of the Articles so
as to read as follows:
"The Company will issue shares in registered form. In the case of registered shares, unless a shareholder elects to
obtain share certificates, he will receive a statement or statements during the year to confirm his shareholding.
For the avoidance of doubt, the Company will not issue new bearer shares. The Board may also, at any time, decide
to compulsorily exchange the bearer shares in issue for registered shares. Any such decision will be published before the
exchange date determined by the Board and shareholders who do not exchange their shares on the exchange date will
have to request their inscription in the register of shareholders before they can exercise the rights attached to their
shares.
If an existing bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations, he
may be charged the cost of such exchange if the Board so decides from time to time.
If a registered shareholder desires that more than one share certificate be issued for his shares, the cost of such
additional certificates may be charged to such shareholder. Bearer share certificates shall be signed by two directors.
Both such signatures may be either manual, printed, by facsimile or electronic. However, one of such signatures may be
by a person delegated to this effect by the Board. In such latter case, it shall be manual to the extent required by law.
The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may from time to time determine.
Shares are normally issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The
subscriber will normally receive title to the shares purchased by him following the acceptance of the subscription and
receipt of the purchase price which shall be evidenced by either the delivery of a definitive share certificate in registered
form or in the case of dematerialised shares confirmation of the subscription in the form of a contract note. However,
where title to the shares has been provided to the subscriber but good settlement of the purchase price has not been
effected, the Company shall be entitled to cancel the shares at the cost and expense of the subscriber without prior
notice. Any shortfall between the purchase price and the cancellation price will be required to be paid by the subscriber
to the Company upon demand in writing. Pending receipt of the purchase price, the transfer of the relevant shares is not
permitted.
All issued shares of the Company, other than bearer shares, shall be inscribed in the register of shareholders, which
shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall
contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile, the number of shares held by
him. Every transfer of a registered share shall be entered in the register of shareholders.
Transfer of bearer shares shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates. Transfer of registered
shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing
such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (b), if no share
certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and
signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.
In the case of registered shares the Company shall consider the person in whose name the shares are registered in
the register of shareholders, as having full title and ownership of the Shares.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will also be entered in the register of shareholders.
In the event that such shareholder does not provide such an address or the Company becomes aware that the address
provided is no longer the shareholder’s current/valid address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered in the register of shareholders and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall
be provided to the Company by such shareholder. It is the shareholder’s responsibility to ensure that their data inscribed
in the register is kept up to date and may, at any time, change his address as entered in the register of shareholders by
means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the
Company from time to time.
If payment made by any subscriber results in a fractional entitlement to one share, such fractional entitlement shall not
be entitled to vote but shall, if and to the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled
to participate in the profits of the Company on a pro rata basis."
86895
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting with 365,590,844 votes in favour and 2,245.698 votes against decides to amend article 8 of the Articles,
so as to read as follows:
"The Board shall have power (i) to refuse to issue or register any transfer of a share, or (ii) to redeem compulsorily
any existing shareholding, or (iii) to impose such restrictions or (iv) to demand such information as it may think necessary
for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (directly or indirectly) (a) any person
in breach of the law, regulation or requirement of any country or governmental authority or (b) any person in circums-
tances which in the opinion of the Board or its designate might result in the Company or any of its delegates incurring
any liability to taxation or suffering any sanction, penalty, burden or other disadvantage (whether pecuniary, administrative
or operational) which the Company or its delegates might not otherwise have incurred or suffered or (c) any person
who may entail that any limit, to which his shareholding is subject, is exceeded.
More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, and
without limitation, by any “U.S. person”, as defined hereafter.
Where it appears to the Company or its designate that any person who is precluded from holding shares or a certain
proportion of the shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of
shares, the Company may compulsorily redeem from any such shareholder all or part of shares held by such shareholder
in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder holding such
shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to
be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect
of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The
said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates
representing the shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on the date specified
in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by
him shall be cancelled;
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (hereinafter called the "re-
demption price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant
class, determined in accordance with Article 23 hereof less a redemption charge as provided in Article 21 hereof;
3) Payment of the redemption price will be made to the owner of such shares in U.S. Dollars or such currency as the
Board or its designate shall determine. The redemption price will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg
or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate
representing the shares, if any, specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in
the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim
against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof
to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or
certificates, if issued, as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and
The Company may decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at
any meeting of shareholders of the Company in respect of such shares which such person is precluded to hold.
Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" shall include a national or resident of the United States of
America and a partnership or company organised or existing in any state, territory or possession of the United States of
America.
Where it appears that a shareholder of a class restricted to Institutional Investors (within the meaning of Article 129
of the Law) is not an Institutional Investor, the Company may either redeem the relevant shares or convert such shares
into shares of a class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a class with similar
characteristics) and notify the relevant shareholder of such conversion.
Where a demand for further information is made on a shareholder for anti-money laundering purposes or other similar
purposes as further disclosed in the Prospectus, the Company may decide to withhold any transfer request and any
payment of the proceeds of any redemption request that has been processed, without interest accruing, until such in-
formation demand has been satisfied."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting with 367,058,651 votes in favour and 773,474 votes against decides to add a third paragraph in article 10
of the Articles so as to read as follows:
86896
L
U X E M B O U R G
"To the extent permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations,
the annual general meeting of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the first
paragraph above, which date, time or place are to be decided by the Board."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting with 366,888,085 votes in favour and 777,446 votes against decides to amend article 12 of the Articles
so as to read as follows:
"Shareholders will meet upon notice given by the Board in accordance with Luxembourg laws.
To the extent permitted by and in accordance with the conditions set forth under Luxembourg laws and regulations,
the notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general
meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the
general meeting (the “Record Date”), and the right of shareholders to participate at a general meeting of shareholders
and to exercise the voting rights attached to their shares will be determined by reference to the shares held by this
shareholder as at the Record Date.
Notices may be sent to shareholders either in writing, by facsimile transmission or such other electronic means capable
of evidencing delivery of such notice to the extent permitted under Luxembourg law and regulations from time to time."
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting with 365,265,409 votes in favour and 769,609 votes against decides to amend article 16 of the Articles
as follows:
- Amendment of the first, second and third paragraphs so as to read as follows:
"The Board has the power to determine the investment policies and strategies of the Company, based upon the
principle of risk spreading, and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, within the
restrictions as shall be set forth within Part I of the Law and applicable regulation.
The Board may decide that investments of the Company be made (i) in transferable securities and money market
instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) in transferable securities and money
market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates
regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments admitted
to official listing on a stock exchange in any other country in Europe, Asia, Oceania, Australia, the American continents
and Africa, or dealt in on another regulated market in the countries referred to above, provided that such market is
regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and
money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official
listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is
secured within one year of issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions
as shall be set forth by the Board in compliance with the Law and applicable regulations and disclosed in the Prospectus.
The Board may decide to invest up to 100% of the assets of each class of shares of the Company in different transferable
securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the European Union, its local
authorities, a non Member State of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and
disclosed in the Prospectus, or public international bodies of which one or more of such Member States of the European
Union are members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold,
on behalf of the class concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not
account for more than 30% of the total assets of such class."
- Amendment of the fifth and sixth paragraphs as follows:
"Reference in these articles to “investments” and “assets” shall mean, as appropriate, either investments made and
assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsi-
diaries. The Board may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including
equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and/ or financial derivative
instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by
Article 41 (1) of the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company
may invest according to its investment objectives as disclosed in the Prospectus.
The Board may decide that investments of a class of shares be made with the aim to replicate a certain stock or bond
index provided that the relevant index is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to
which it refers and is published in any appropriate manner in accordance with the provisions of the Law. Unless otherwise
provided for in the Prospectus, the Company will not invest more than 10% of the assets of any class of shares in
undertakings for collective investment as defined in Article 41 (1) (e) of the Law."
- Insertion of a seventh paragraph:
"To the extent permitted by the Luxembourg laws and regulations, any class may, in accordance with the provisions
set forth in the Prospectus, invest in one or more other classes of the Company."
86897
L
U X E M B O U R G
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting with 365,070,850 votes in favour and 955,698 votes against decides to amend article 21 of the Articles
so as to read as follows:
"As is more especially prescribed herein below, the Company has the power to redeem its own shares at any time
within the sole limitations set forth by law.
Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company subject to the rules set forth
below.
The redemption price shall be paid no later than ten business days in Luxembourg after the date on which the applicable
Net Asset Value per share was determined or on the date the share certificates have been received by the Company, if
later, except as provided below and shall be equal to the Net Asset Value per share for the relevant class as determined
in accordance with the provisions of Article 23 thereof less any fiscal charges, redemption charge, dealing charge or any
other charge as the Prospectus may provide.
Authentication procedures may be put in place by the Company or its delegates to comply with relevant laws or
regulations or to mitigate the risk of error and fraud for the Company, its delegates or the shareholders as further
described in the Prospectus. The processing of payment instructions may be delayed until such procedures have been
satisfied.
The Board may, with respect to any class of shares of the Company, extend the period for repayment of redemption
proceeds to such period, not exceeding 50 business days, as may be required by settlement and similar constraints
prevailing in the markets in which a substantial part of the assets attributable to such class of shares shall be invested. For
the same reasons the Board may also, in respect of any class of shares, determine a notice period required to request
for redemption, which notice together with any applicable period to receive redemption proceeds as described in the
preceding sentence shall not exceed 50 business days. Any such request must be filed by such shareholder in written
form or such other electronic means acceptable to the Company at the registered office of the Company in Luxembourg
or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares. The Board may
determine a minimum amount for redemption or conversion requests from time to time. The certificate or certificates
for such shares in proper form if any and proper evidence of transfer or assignment to the Company must be received
by the Company or its agent appointed for that purpose before the redemption price may be paid.
With the consent of the shareholder(s) concerned or at its request, the Board may (subject to the principle of equal
treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming share-
holders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value per share attributable to the shares to be
redeemed as described in the Prospectus.
To the extent required by Luxembourg law, such redemption will be subject to a special audit report by the auditor
of the Company confirming the number, the denomination and the value of the assets which the Board will have deter-
mined to be contributed in counterpart of the redeemed shares.
If as a result of any such redemption request the value holding of a shareholder of shares of any class in the Company
would fall below the minimum holding as the Board shall determine from time to time, then this request may be treated
as a redemption request for the full balance of his holding of shares of such class. The Board may, at any time, compulsorily
redeem all shares from shareholders whose holding is less than the level as determined by the Board. In such case, the
shareholder will receive one month prior notice so as to be able to increase his holding.
Upon the decision of the Board, any partial redemption of bearer shares will result in the remaining balance being
converted to registered shares.
If and when for any reason, the total number of shares of any class or the net asset value attributable to any class is
less than an amount determined by the Board to be the minimum level for such class to be operated in an economically
efficient manner, or if a change in the economical or political situation relating to the class concerned has occurred which
would justify it, or in order to proceed to an economic rationalisation or if the interest of the shareholders would justify
it, the Board may decide to redeem all the shares of that class at the net asset value determined on a Valuation Day
following that decision, in which case the Board may proceed as described in article 8 points 1),2) and 3). Where notice
of the redemption is provided to shareholders in advance of the Valuation Day on which the redemption of all the shares
of that class will take place, the Board or their designate may decide to realise the portfolio of the class on a progressive
basis leading up to the Valuation Day so as to ensure an efficient and rapid redemption process in the interests of
shareholders. In addition in such circumstances the Board may decide to liquidate the relevant class of shares.
Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the redemption of the class will be deposited with
the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries in compliance with Luxembourg law and regulations.
Under the same circumstances as provided above, the Board may decide to close down one class by contribution into
another class. Such decision will be notified or published as appropriate and the notification or publication as appropriate
will contain information in relation to the new class. Such notification or publication as appropriate will be made within
one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable shareholders to request redemption
of their shares, free of charge, before the operation involving contribution into another class becomes effective.
86898
L
U X E M B O U R G
The Board may also, under the same circumstances as provided above, decide to close down one class of shares by
contribution into another collective investment undertaking governed by Part I of the Law or into an European Economic
Area based undertaking collective investment offering equivalent protection to the one offered to the shareholders in
the Company.
Such decision will be notified or published as appropriate, and the notification or publication as appropriate will contain
information in relation to the other collective investment undertaking. Such notification or publication as appropriate will
be made one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable shareholders to request
redemption of their shares, free of charge, before the operation involving contribution to another collective investment
undertaking becomes effective. In case of contribution to another collective investment undertaking of the mutual fund
type, the merger will be binding only on shareholders of the relevant class who will expressly agree to the merger.
Under the same circumstances as provided above, the Board may decide the reorganisation of one class of shares, by
means of a division into two or more classes. Such decision will be notified or published as appropriate one month before
the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request redemption of
their shares, free of charge before the operation involving division into two or more classes becomes effective.
Any of the aforesaid decisions of the Board to liquidate, merge or reorganise by means of a division, a class or sub-
class may also be decided by a separate class meeting of the shareholders of the class or sub-class concerned at which
meeting no quorum is required and the relevant decision is taken at the simple majority of the votes cast.
Upon the transposition in the Luxembourg laws and regulations of the provisions of the EU Directive 2009/65/CE of
13 July 2009 and of its implementing directive which are applicable to the mergers of UCITS (the “provisions on mergers
of UCITS”), the provisions set forth in the preceding paragraphs which are applicable to the mergers of classes and to
the merger of the Company with another Luxembourg or foreign collective investment undertaking qualifying as UCITS
or sub-fund thereof shall no longer be applicable and the provisions on mergers of UCITS shall be applicable instead. In
that case, mergers of a class may be decided by the Board. The Board may however also decide to submit the decision
for a merger to a meeting of shareholders of the class concerned, for which meeting no quorum is required and decisions
are taken at the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a class where, as a result, the Company ceases
to exist, the merger must be decided by a meeting of shareholders; at such meeting, the required quorum and majority
shall be the same as that required to effect a change to these Articles.
The Company reserves the right not to be bound to redeem or switch on any one Valuation Day more than 5 per
cent by sale of shares of any class then in issue. In these circumstances, the Board may declare that part or all of such
redemption or switching requests will be deferred for a period not exceeding 10 Valuation Days and will be dealt with
on the basis of the Net Asset Value per share prevailing on the Valuation Day on which the shares are redeemed or
switched less any redemption or switching charges. On such Valuation Day, these requests for redemption or switching
will be complied with in priority to later requests.
Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Any shareholder may request switching of whole or part of his shareholding of one class into new shares of another
class attached to him at a certain formula to be decided by the Board, provided that the Board may impose such restrictions
as to, inter alia, frequency of switching, the ability to switch between classes, and may make switching subject to payment
of such charge, as it shall consider to be in the interest of the Company and its shareholders generally.
Where the shareholder of any class of shares holds within a subclass of a class of shares, less than the minimum holding
requirements (as the Board may determine from time to time) the Board may, in its sole discretion, convert shares of
one sub-class of a class of shares into shares of a sub-class within the same class of shares that has a lesser minimum
holding threshold so as to meet the minimum holding requirements even if the charges and/or fee load are higher, subject
to a prior notice being given to the relevant shareholder."
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting with 363,801,602 votes in favour and 2,236,015 votes against decides to amend article 22 of the Articles
so as to read as follows:
"The Net Asset Value per share of shares in the Company shall be determined as to the shares of each class of shares
by the Company from time to time, but in no instance less than twice a month, as the Board by regulation may direct,
every such day or time for determination of Net Asset Value per share being referred to herein as a “Valuation Day”.
Valuation Day shall be as defined from time to time by the Board and shareholders shall be informed accordingly.
The Company may suspend the determination of the Net Asset Value per share of shares of any particular class and
the issue and redemption of the shares in such class from the shareholders as well as conversion from and to shares of
such classes:
(i) while any exchange or market, on which a substantial portion of the Company’s investments is traded, is closed or
while dealings on any such exchange or market are restricted or suspended;
(ii) while any transfer of funds involved in the realisation or acquisition disposal of investments or payments due on
redemption of such Shares by the Company cannot, in the opinion of the directors, be effected at normal prices or rates
of exchange or be effected without seriously prejudicing the interests of the shareholders or the Company;
86899
L
U X E M B O U R G
(iii) during any breakdown in the communications normally employed in valuing any of the Company’s assets or when
for any reason the price or value of any of the Company’s assets cannot be promptly and accurately ascertained;
(iv) if the Company is being or may be wound-up on or following the date on which notice is given of the meeting of
shareholders at which a resolution to wind-up the Company is proposed;
(v) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation
of investments of the relevant class of shares by the Company is impracticable;
(vi) if the directors have determined that there has been a material change in the valuation of a substantial proportion
of the investments of the Company attributable to a particular class of shares and the directors have determined, in order
to safeguard the interest of the Shareholders and the Company, to delay the preparation or use of a valuation or carry
out a later or subsequent valuation;
(vii) while the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;
(viii) during any other circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Company or its
shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment to which
the Company or its shareholders might not otherwise have suffered.
Any such suspension shall be notified to investors requesting issue, redemption or switching of their shares by the
Company at the time of the application for such issue, redemption and switching and shall be publicized by the Company
if in the opinion of the Board, it is likely to exceed fourteen days."
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting with 365,120,173 votes in favour and 914,377 votes against decides to amend article 23 of the Articles
as follows: -Amendment of the first paragraph:
"The net asset value per share (the “Net Asset Value per share”) of each class of shares in the Company shall be
expressed in the currency of the relevant class of shares and shall be determined as a per share figure and shall be
determined on any Valuation Day by dividing the total net assets of the Company corresponding to each class of shares,
being the value of the assets of the Company corresponding to such class less its liabilities attributable to such class, by
the number of shares outstanding adjusted to reflect any dealing costs, to implement swing pricing techniques as further
disclosed in the Prospectus and as the Board considers appropriate to take into account and by rounding the resulting
sum up or down to the nearest decimal places as the Board shall decide."
- Amendment of item A. d):
"d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company;"
- Amendment of item A. (v):
"(v) Units or shares in open-ended undertakings for collective investments shall be valued on the basis of their last net
asset value, as reported by such undertakings."
- Amendment of the last paragraph under item A.:
"In addition, in circumstances where the interests of the Company or its shareholders so justify, the Board may take
any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology to adjust the value of the Company's assets,
as further described in the Prospectus."
- Amendment of item B. e):
"e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the
Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the
Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its management company, investment managers,
accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent representatives in places
of registration, any other agent employed by the Company and director's fees, fees related to listing of shares of the
Company on any stock exchange and to obtain a quotation on another regulated market, fees for legal and auditing
services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and
printing of prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, taxes or governmental charges, and all other
operating expenses, including the cost of buying and selling assets, foreign exchange margins and exchange transactions,
interest, bank charges and brokerage, postage, telephone, facsimile transmission and other electronic means. The Com-
pany may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly
or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period."
- Amendment of item C. e):
"e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any class of shares, the
Net Asset Value per share of such class of shares shall be reduced by the amount of such dividends."
- Amendment of item C. 3.:
"3. A Participating Fund's participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units (“Units”) of
equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the Board shall in their discretion determine the initial
value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropriate, and shall allocate to each
Participating Funds Units having an aggregate value equal to the amount of cash ( or value of other assets) contributed.
Fractions of Units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit shall
86900
L
U X E M B O U R G
be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the number of units
subsisting."
- Amendment of items D. a) and D. c):
"a) shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until
paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
c) all investments, cash, balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the currency
in which the Net Asset Value per share is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of
exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value per share and"
<i>Eleventh resolutioni>
The Meeting with 365,247,364 votes in favour and 787,110 votes against decides to amend article 24 of the Articles
so as to read as follows:
"Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered
and sold, shall be the Net Asset Value per share plus such fiscal charge, dealing charges and any commissions and other
charges and rounding (all together not to exceed 8.5 per cent of the Net Asset Value) as the Prospectus may provide.
The price so determined shall be payable within such period as the Board by regulation shall determine, but in any event,
not later than eleven business days after the date on which the applicable net asset value was determined.
Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contributions in kind of transferable securities
and other assets considered acceptable by the Board and compatible with the investment policy and the investment
objective of the Company. Any such subscription in kind will be valued in a report prepared by the Company's auditor
to the extent required by Luxembourg law. Any expenses incurred in connection with such contributions shall be borne
by the shareholders concerned or other party as agreed by the Management Company."
<i>Twelfth resolutioni>
The Meeting with 367,066,119 votes in favour and 772,714 votes against decides to amend article 26 of the Articles
so as to read as follows:
"Within the limits provided for by law, a general meeting of shareholders of each class, shall, upon the proposal of the
Board in respect of such class of shares, determine dividends to be paid or other distributions to be made.
Dividends, if any, will be declared on the number of shares of the class concerned outstanding at the dividend record
date, as that date is determined by the Board in the case of an interim dividend, or by the general meeting of shareholders
of the Company in any case of the final dividend, and will be paid to the holders of such shares within two months of such
declaration. Dividends may be paid in cash, in kind or may be reinvested in exchange for which additional shares in the
Company will be issued as further disclosed in the Prospectus and may include such amounts whether representing
revenue, capital gain, or otherwise as may be permitted by law.
Subject to the conditions fixed by law, the Board may pay out an advance payment on dividends on the shares of any
class of shares. The Board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment in respect of each class
of shares. Upon the creation of a class of shares, the Board may decide that all shares of such class shall be capitalization
shares and that, accordingly, no dividends will normally be distributed in respect of the shares of such class as further
disclosed in the Prospectus of the Company. The Board may also decide that there shall be issued, within the same class
of shares, two or more sub-classes where each sub-class is represented by capitalization shares or by dividend shares.
No dividends shall normally be declared in respect of capitalization shares issued as aforesaid.
The dividends declared may be paid in U.S. Dollars or any other currency or currencies in which the Net Asset Value
per share of the shares of any class is expressed and may be paid at such places and times as may be determined by the
Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the
currency of their payment.
Dividends not cashed within five years will be forfeited and will accrue for the benefit of the Company.
Payment of dividends may be made to shareholders in respect of registered shares, at their address in the register of
shareholders or such other address as a shareholder indicates in writing to the Company and, in respect of bearer shares,
upon presentation of the relevant dividend coupons. Amounts below the minimum distributable amount as determined
from time to time by the directors at their discretion will be automatically reinvested."
<i>Thirteenth resolutioni>
The Meeting with 365,259,618 votes in favour and 779,749 votes against decides to amend article 27 of the Articles
so as to read as follows:
"In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The liquidation proceeds (either in kind as further disclosed in the
Prospectus or in cash) relating to a given class of shares shall be distributed by the liquidators to the shareholders in
proportion of their holding of shares in the relevant class."
86901
L
U X E M B O U R G
<i>Fourteenth resolutioni>
The Meeting with 366,862,033 votes in favour and 943,053 votes against decides to update the Articles as follows:
- Amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles so as to read as follows:
"The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and/or in other
liquid financial assets as well as other assets permitted by Part I of the law of 20
th
December 2002 on undertakings for
collective investment, as amended or replaced (the “Law”) with the purpose of spreading investment risks and affording
its shareholders the results of the management of its assets. If the Law is replaced then the corresponding articles in the
replaced law will be substituted mutatis mutandis with those numbered articles currently mentioned herein as may be
appropriate."
- Amendment of article 9 of the Articles so as to read as follows:
"Any regularly constituted general meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company. It shall have the
broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company."
- Amendment of article 11 of the Articles so as to read as follows:
"The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of the general meetings of
shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share of whatever class and regardless of the Net Asset Value per share is entitled to one vote subject to the
limitations imposed by these Articles.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or
by facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a general meeting of shareholders
duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares
in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid
vote.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any
general meeting of shareholders."
- Amendment of the second and third paragraphs of article 13 of the Articles so as to read as follows:
"The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general
meeting and until their successors are elected, provided, however, that a director may be removed with or without cause
and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders."
- Amendment of the first and second paragraphs of article 14 of the Articles so as to read as follows:
"The Board will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more
deputy chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon notice being given by the
chairman or by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the deputy chairman
shall preside; in their absence the shareholders or the Board may appoint a chairman pro tempore."
- Amendment of the sixth paragraph of article 14 of the Articles so as to read as follows:
"The Board can deliberate or act validly only if at least two directors are present at a meeting of the Board. For the
calculation of quorum and majority, the directors participating at the meeting of the Board by video conference or by
other telecommunication system which allows for them to be identified may be deemed to be present. Such system shall
satisfy technical characteristics which ensure an effective participation at the meeting of the Board whose deliberations
should be online without interruption. Such a Board meeting held at distance by way of such communication system shall
be deemed to have taken place at the registered office of the Company. Decision shall be taken by a majority of the votes
of the directors present or represented at such meeting. The Chairman does not have any casting vote."
- Amendment of the second and third paragraphs of article 17 of the Articles so as to read as follows:
"In the event that any director or officer of the Company may have a personal interest in any transaction of the
Company, such director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote
on any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding general meeting of shareholders. This paragraph shall not apply where the decision of the Board relates
to current operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving JPMorgan Chase & Co. and its subsidiaries and affiliates world-wide, or such
other company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion."
- Amendment of article 20 of the Articles so as to read as follows:
86902
L
U X E M B O U R G
"The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one
or several auditors, who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional expe-
rience and who shall carry out the duties prescribed by the Law. The auditors shall be elected by a general meeting of
shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successor
is appointed."
There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English in accordance with Article 26(2) of the 2002 Law.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: X. ROUVIERE, S. BISTER, P. STEENFELD-KRISTENSEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 février 2011. Relation: LAC/2011/8377. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 avril 2011.
Référence de publication: 2011074110/617.
(110082560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.
SU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 131.032.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083381/11.
(110093092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Subsea 7 Lending S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.780.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.284.
<i>Extract of the resolution taken by the sole Shareholder as of 09/05/2011i>
- Mr Graeme Murray, born on September 1
st
, 1968 at Aberdeen, General Councel, with professional address at 200
Hammersmith Road London W6 7DL (UK), is appointed as A Manager of the Company with immediate effect and for
an unlimited period in replacement of Mr. Alistair Peel
Suit la traduction de ce qui précède
<i>Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 09/05/2011i>
- M. Graeme Murray, né 1
er
septembre 1968 à Aberdeen, Directeur du service juridique, résidant professionnellement
au 200 Hammersmith Road London W6 7DL(GB), est nommé Gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée, en remplacement de M. Alistair Peel.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2011083382/18.
(110093211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86903
L
U X E M B O U R G
UBS (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 11.142.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg.
Suite à un changement de dénomination de rue, le siège social d'Ernst & Young (commissaire aux comptes de la Société),
se situe désormais au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
UBS (Luxembourg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2011083403/15.
(110093371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
UK Tissue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 88.795.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10 juini>
<i>2011i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur SARTI Francesco et Monsieur DONATI Régis sont renommés adminis-
trateurs.
Monsieur DONATI Régis est nommé Président du Conseil d'administration.
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.
<i>Pour extrait sincère et conforme
i>UK TISSUE S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011083404/18.
(110093439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Uranus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 122.604.
L'an deux mille onze,
le dix juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Alphonsus A. SCHIRRIS, indépendant, demeurant Middenweg 21, NL-1703 RA HEERHUGOWAARD (Pays-
Bas),
ici représenté par:
Madame Annie DRUANT, employée privée, avec adresse professionnelle au 2 rue Pletzer, L-8080 Bertrange,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 7 juin 2011,
laquelle procuration, après avoir été signé "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en sa qualité de seul et unique associé
de la société "URANUS INTERNATIONAL S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social actuel au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, au capital social entièrement libéré de VINGT MILLE
DOLLARS US (20.000,- USD),
constituée, suivant acte notarié dressé en date du 1
er
décembre 2006, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 162 du 12 février 2007 et page 7764;
86904
L
U X E M B O U R G
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis sa création.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B sous le numéro 122.604;
prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société du
60, Grand-Rue, L-660 Luxembourg au 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ce transfert de siège social, l'associé unique DECIDE de modifier en conséquence l'article TROIS (3)
premier alinéa des statuts de la Société, lequel premier alinéa aura désormais la teneur suivante:
Art. 3. (premier alinéa). "Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg."
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique DECIDE de modifier l'objet social de la Société par le rajout des activités de location de voitures
internationales.
Suite à ce rajout, l'associé unique DECIDE que l'objet social et concomitamment l'article premier (1
er
) des statuts
de la Société seront à modifier et auront désormais la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. "La société a pour objets:
- la création, la participation, le financement, la direction et l'administration d'autres entreprises;
- l'agence internationale d'affaires, c'est-à-dire le commerce, l'import et l'export de tous produits à l'exclusion de toute
vente de matériel militaire ainsi que la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing et
commerce à l'exclusion de toute activité rentrant dans le domaine des conseils économiques;
- la location de voitures internationales;
- l'exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- l'octroi de cautions et d'autres sûretés au profit d'autres sociétés et entreprises du même groupe;
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la
prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contre-
partie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire."
DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jours,
mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la mandataire de la partie comparante prémentionnée a signé
avec Nous, le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. DRUANT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 juin 2011. Relation: EAC/2011/7685. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011083406/65.
(110093218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Unionkey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.828.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 3 juin 2011i>
La démission de Monsieur Mohammed KARA de son poste d'administrateur et président du conseil d'administration
de la société est acceptée.
Monsieur Robert REGGIORI, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel admi-
nistrateur et président du conseil d'administration de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'an 2012.
86905
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
UNIONKEY S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011083405/17.
(110093438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
URSA Mortgage Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.545.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011083407/10.
(110092781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Valex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 119.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011083408/10.
(110092649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
VCL No. 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 121.667.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth of the month of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
STICHTING LAURIET, a foundation incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at
Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, the Netherlands, (the “Shareholder”),
here represented by Maître Anthony Braesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 10,
2011,
which proxy after being initialed “ne variatur” by the person appearing and the undersigned notary, will remain attached
to the original of these minutes in order to be registered at the same time.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder (100%) of VCL N°9 S.A., a société anonyme governed
by the laws of Luxembourg, having its registered office at 9B boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated
on November 6, 2006 pursuant to a deed received by Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in
the Mémorial C n° 2429 of December 29, 2006, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under section B, number 121.667 (the “Company”), requested the undersigned notary to document the following.
The Shareholder has been fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to dissolve the Company and put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator and determination of his powers.
The Shareholder has then taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to dissolve the Company and put the Company into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint Mr. Anthony Braesch, lawyer, residing in Luxembourg, as liquidator of the Com-
pany. The liquidator will have the broadest powers to perform its duties under the law of August 10, 1915 on commercial
86906
L
U X E M B O U R G
companies, as amended (the “Law”), including those referred to in Article 145 of the Law without requesting the prior
consent of the Shareholder.
The liquidator is relieved from the obligation of drawing-up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his own responsibility, for special or specific operations, delegate such part of his powers
and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
present deed are estimated at eight hundred Euros (EUR 800.-).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed was worded in English followed by a French translation. On request of the
same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will
prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day set at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, first name, civil status and
residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le seize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
A comparu:
STICHTING LAURIET, une fondation régie par le droit néerlandais ayant son siège social à Amsteldijk 166, 1079 LH
Amsterdam, Pays-Bas, (l'»Actionnaire»),
représentée par Maître Anthony Braesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée le 10 mai 2011, laquelle procuration après avoir été paraphée «ne variatur» par le mandataire du comparant et
le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
La partie comparante, agissant en sa qualité de seul actionnaire (100%) de la société VCL N°9 S.A., une société anonyme
de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9B boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et constituée suivant
acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 novembre 2006, publié au Mémorial
C n° 2429 du 29 décembre 2006, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 121.667 (la «Société»), a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit.
L'Actionnaire reconnait être parfaitement informé de la teneur des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
L'Actionnaire a alors pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire décide de dissoudre la Société et décide de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire décide de nommer aux fonctions de liquidateur Monsieur Anthony Braesch, avocat, résidant à Luxem-
bourg, qui aura, pour réaliser la liquidation, les pouvoirs les plus étendus tels que prévus par la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»), y compris ceux prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recueillir
l'autorisation préalable de l'Actionnaire.
Le liquidateur est dispensé de son obligation de devoir dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la
Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.
<i>Frais et Dépensi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société et mis à sa charge en raison des
présentes, sont évalués à la somme de huit cents Euros (EUR 800,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du mandataire du com-
parant ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une version française. A la requête du même comparant,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
86907
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite au mandataire du comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. BRAESCH, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 mai 2011. Relation: LAC/2011/22399. Reçu douze euros (12.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 24 mai 2011.
Référence de publication: 2011083409/91.
(110092762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Villa Arena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 137.082.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société du 14 juin 2011 que le gérant unique suivant de la Société a
été révoqué:
- Duet Trust and Fiduciary Services S.A., une société anonyme constituée selon le droit du Grand-Duché du Luxem-
bourg, ayant un capital social s'élevant à EUR 40.000, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg
et enregistrée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 89.325, gérant.
Il résulte des mêmes résolutions que:
- Monsieur Alexander Schmid, né le 11 août 1968 en Allemagne, demeurant professionnellement à 19 Dammstrasse,
6300, Zug, Switzerland, est nommé gérant unique avec effet au 14 juin 2011 et pour une durée illimitée.
Il résulte des mêmes résolutions que:
- le siège social de la Société est transféré avec effet au 14 juin 2011 à L-2121 Luxembourg, 231 Val des Bons-Malades.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083411/21.
(110093045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Villa Bianca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 137.083.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société du 14 juin 2011 que le gérant unique suivant de la Société a
été révoqué:
- Duet Trust and Fiduciary Services S.A., une société anonyme constituée selon le droit du Grand-Duché du Luxem-
bourg, ayant un capital social s'élevant à EUR 40.000, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg
et enregistrée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 89.325, gérant.
Il résulte des mêmes résolutions que:
- Monsieur Alexander Schmid, né le 11 août 1968 en Allemagne, demeurant professionnellement à 19 Dammstrasse,
6300, Zug, Switzerland, est nommée gérant unique avec effet au 14 juin 2011 et pour une durée illimitée.
Il résulte des mêmes résolutions que:
- le siège social de la Société est transféré avec effet au 14 juin 2011 à L-2121 Luxembourg, 231 Val des Bons-Malades.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083412/21.
(110093044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86908
L
U X E M B O U R G
TGR Trocken- und Innenausbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. VL. Logistik S.à r.l.).
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 151.347.
Im Jahre zweitausendelf, am zehnten Juni.
Vor der unterzeichnenden Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch-Alzette.
IST ERSCHIENEN:
Herr Dieter Alfons Jakobus RAUBER, Kaufmann, geboren am 26. April 1958 zu Oberthal (Bundesrepublik Deuts-
chland), wohnhaft in D-66629 Freisen, Lindenbornstrasse 12.
Der vorgenannte Komparent erklärt dass er der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ''VL.
Logistik S.à r.l.'', mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der
Nummer B 151347, ist.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit Amtssitz in Echter-
nach, vom 4. Februar 2010, veröffentlicht im Memorial C Nummer 648 vom 26. März 2010.
Sodann ersuchte der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu
beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter bitten die amtierende Notarin, folgende Anteilsabtretung zu beurkunden:
Abtretung von EINHUNDERT (100) Anteilen aufgrund einer Anteilsabtretung von Gesellschaftsanteilen unter Pri-
vatschrift aufgenommen am 8. Juni 2011, welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben enregistriert
zu werden, zum Kaufpreis von EINEM EURO (€ 1,-) durch Frau Verena LAASE, geborene WAGNER, Grundschullehrerin,
wohnhaft in D-66822 Lebach-Aschbach, Koblenzer Strasse 34, an den dies annehmenden Gesellschafter, Herrrn Dieter
Alfons Jakobus RAUBER, Kaufmann, geboren am 26. April 1958 zu Oberthal (Bundesrepublik Deutschland), wohnhaft in
D-66629 Freisen, Lindenbornstrasse 12, welche die gegenwärtigen Abtretung annimmt.
Der Anteilseigner bekennt den Kaufpreis der Anteile vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde und in Abwe-
senheit der amtierenden Notarin gemäss der beiliegenden Vereinbarungen gezahlt zu haben.
Der Anteilseigner tritt ab sofort in den Besitz und Genuss der ihm übertragenen Anteile und ist ab sofort in die Rechte
und Pflichten des vorherigen Eigners eingesetzt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Durch den vorhergehenden Beschluss, ist Artikel sechs (6) der Satzung wie folgt zu lesen:
" Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (€ 12.500,-), aufgeteilt in EIN-
HUNDERT (100) Anteile von je EINHUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125,-)."
<i>Dritter Beschlussi>
Der Rücktritt des Geschäftsführers, Herrn Helge LAASE, Trockenbauer, wohnhaft in D-66822 Lebach-Aschbach, Ko-
blenzer Strasse 34, wird angenommen.
Durch Spezialvotum wird ihm Entlastung erteilt für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage.
Es wird zu neuem Geschäftsführer ernannt:
Herr Dieter Alfons Jakobus RAUBER, Kaufmann, geboren am 26. April 1958 zu Oberthal (Bundesrepublik Deuts-
chland), wohnhaft in D-66629 Freisen, Lindenbornstrasse 12.
Der Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Dauer ernannt.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft von ''VL. Logistik S.à r.l.'' in ''TGR Trocken- und
Innenausbau S.à r.l.'' umzuwandeln, sodass Artikel zwei (2) der Satzung wie folgt zu lesen ist:
" Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "TGR Trocken- und Innenausbau S.à r.l.". ".
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue nach L-8010
Strassen, 148, route d'Arlon zu verlegen, sodass Artikel drei (3) der Satzung wie folgt zu lesen ist:
" Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen. Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter
in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. ".
86909
L
U X E M B O U R G
<i>Bescheinigungi>
Die unterzeichnende Notarin bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Versammlung
für geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Esch/Alzette, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, hat der Komparent zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Signé: D.A.J.Rauber, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 juin 2011. Relation: EAC/2011/7758. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): A.Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083413/69.
(110092767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Voxel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 134.140.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011083414/10.
(110093355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Wagner Management SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 41.434.
En date du 6 juin 2011, l’assemblée générale à pris acte des démissions comme administrateurs de Messieurs Jacques
Wolter et Claude Arrensdorff et a nommé comme nouveaux administrateurs Messieurs Tom Wagner, Jerry Wagner,
Luc Tapella et Romain Hartmann, tous avec adresse professionnelle à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin avec l’assemblée générale de 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Wagner Management SAi>
Référence de publication: 2011083415/13.
(110093291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Wave Quest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 97.976.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2011083416/10.
(110092645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
86910
L
U X E M B O U R G
WDI Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 25.331.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011083418/10.
(110093455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Web4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 109.478.
In the year two thousand and eleven, on the eighth of June
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of
"WEB4 S.A." (formerly MOBILE SIGNAL S.A.), R.C.S Number B 109.478, with its registered office in Luxembourg, in-
corporated pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg, dated 15 July
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1313 of 2 December 2005. The Articles
of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 2 June 2008, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1674 dated 8 July 2008.
The meeting begins with Mr. Raymond THILL, private employee, with professional addres in Luxembourg, being in the
Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Germaine SCHWACHTGEN, private employee, with pro-
fessional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Mrs Sabine PERRIER, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 10.000 (ten
thousand) shares representing the total issued share capital are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all
the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. To change the statutory financial year end from May 31
st
to December 31
st
effective with the financial statements
starting June 1
st
, 2011 and ending December 31
st
. 2011;
2. To change accordingly the date of the General Meeting of the Shareholders from the fourth Tuesday of November
at 10 a.m. to the fourth Tuesday of June at 1pm;
3. Miscellaneous.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting decides to change its statutory financial year end from 31
st
of May to 31
st
of December, so
that the financial year which begun on the 1
st
of June 2011 shall end on 31 December 2011, and that the following financial
year shall begin on the 1
st
of January 2012 and end on the 31
st
of December 2012.
As a consequence, Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as
follows in its English version:
" Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of the same year".
<i>Second resolutioni>
The date of the Annual General Meeting is changed from the fourth Tuesday of November at 10 a.m. to the fourth
Tuesday of June at 1 p.m.
As a consequence, Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as
follows in its English version:
86911
L
U X E M B O U R G
" Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the fourth Tuesday of June at 1 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day."
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of differences between the English and the French texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le huit juin
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme WEB4 S.A. (anciennement
MOBILE SIGNAL S.A.), société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 109.478, constituée suivant acte reçu par Maître
André SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 juillet 2005, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1313 du 2 décembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés en
dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 juin 2008, acte paru au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1674 du 8 juillet 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, employé privé, deumeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademe Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur, Madame Sabine PERRIER, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau étant dûment constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'il appert de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions représentant l'intégralité du capital social émis
et libéré sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut
valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:
1. Modification de la fin de l'année sociale du 31 mai au 31 décembre avec pour effet que l'année financière ayant
commencé le 1
er
juin 2011 se terminera le 31 décembre 2011;
2. Modification en conséquence de la date de l'assemblée générale annuelle du quatrième mardi du mois de novembre
à 10.00 heures au quatrième mardi du mois de juin à 13.00 heures;
3. Divers.
L'assemblée, après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée Générale décide de changer la fin de son exercice social du 31 mai au 31 décembre, de sorte que l'exercice
social commencé le 1
er
juin 2011 se terminera le 31 décembre 2011 et que l'exercice social suivant commencera le 1
er
janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012.
En conséquence, l'article 8 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante, dans sa version
Française:
" Art. 8. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et
un décembre de la même année."
<i>Deuxième résolutioni>
La date de l'Assemblée Générale Annuelle est déplacée du quatrième mardi du mois de novembre à 10.00 heures au
quatrième mardi du mois de juin à 13.00 heures.
En conséquence, l'article 9 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante, dans sa version
Française:
" Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à
tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième mardi du mois de juin à 13.00 heures.
86912
L
U X E M B O U R G
Si le jour précité est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable."
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.
Signé: R. Thill, G. Schwachtgen, S. Perrier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juin 2011. LAC/2011/26978. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083420/113.
(110093220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
White Bear S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 73.475.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011083421/10.
(110092654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Yaborandi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.627.
Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
YABORANDI SPF S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011083424/12.
(110092713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Zum Immo Promotion S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Zum Immo Promotion S.C.I.).
Siège social: L-6463 Echternach, 5, rue Maximilien.
R.C.S. Luxembourg B 161.441.
L'an deux mille onze, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Samir LEKOVIC, ouvrier, demeurant à L-6463 Echternach, 5, rue Maximilien.
2.- Monsieur Asmir LEKOVIC, ouvrier, demeurant à L-6463 Echternach, 5, rue Maximilien.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société civile immobilière «ZUM IMMO PROMOTION
S.C.I.», avec siège social à L-6463 Echternach, 5, rue Maximilien, inscrite au registre du commerce et des sociétés de sous
le numéro E 4.305, a été constituée suivant acte sous seing privé, en date du 1
er
juin 2010, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1516 du 23 juillet 2010.
Le capital de trois mille euros (3000.- €) représentée par cent parts sociales de trente euros chacune, est actuellement
reparti comme suit:
- Monsieur Samir LEKOVIC, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts
- Monsieur Asmir LEKOVIC, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts
86913
L
U X E M B O U R G
Ceci exposé, lesdits comparants réunis en assemblée générale extraordinaire ont requis le notaire soussigné d'acter
leurs déclarations comme suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1.) Augmentation du capital social à concurrence de neuf mille cinq cents euros (9.500.- €).
2.) Modification de l’objet social et modification de l’article 2 des statuts.
3.) Transformation de la société civile immobilière en société à responsabilité limitée.
4.) Adoption de nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions.
5.) Nomination d’un gérant technique et d’un gérant administratif et détermination de leurs pouvoirs vis à vis des tiers,
fixation de l’adresse sociale de la société.
6.) Divers.
II.- Après délibération, l'assemblée extraordinaire prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide:
a) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.500.-)
pour le porter de son montant actuel de TROIS MILLE EUROS (3.000.- €) à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12.500.- €);
b) cette augmentation de capital est réalisée par apport en espèces de NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.500.-
€) ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément;
c) de supprimer les cent parts sociales (100) existantes et de créer CENT PARTS SOCIALES (100) nouvelles de cent
vingt cinq euros (125 €) de nominal chacune. La souscription et la libération de ces parts sociales est faite à parts égales
par les deux prédits associés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l’objet social de la société et de modifier
par conséquent l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre
compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l’exécution
ou le développement de son objet social. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et
indivisible vis-à-vis de tierces personnes.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les précédentes résolutions.
L'assemblée des associés décide de transformer la société ZUM IMMO PROMOTION S.C.I. en société à responsabilité
limitée en continuation de la société‚ sous une autre forme, sans qu'il y ait création d'une société nouvelle et ont requis
le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont con-
stituer entre eux, par la transformation de la prédite société ZUM IMMO PROMOTION S.C.I.
L’assemblée décide de transformer la société ZUM IMMO PROMOTION S.C.I. en société à responsabilité limitée,
conformément à la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette transformation ne doit pas être accompa-
gnée d'un changement des bases essentielles du pacte social. Il y aura attribution des parts sociales de la société à
responsabilité limitée aux associés de la société civile immobilière à la valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €)
en raison d'une part sociale pour une part d’intérêts de la société civile immobilière et la nomination d’un gérant pour
être en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales et la refonte des statuts.
Comme suite à la transformation de la prédite société ZUM IMMO PROMOTION S.C.I., en société à responsabilité
limitée décidée ci-avant, les comparants décident de procéder à une refonte des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
Statuts
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-
mination de "ZUM IMMO PROMOTION S.àr.l.".
Art. 2. Le siège social est établi à Echternach.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.
86914
L
U X E M B O U R G
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, l’échange, la promotion et la mise en valeur, tant pour son propre
compte que pour compte de tiers, de tous biens immobiliers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement auxdites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l’exécution
ou le développement de son objet social. En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et
indivisible vis-à-vis de tierces personnes.
Art. 4. La société est constitué pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) représenté par CENT PARTS
SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125.-) EUROS, chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- Monsieur Samir LEKOVIC, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2.- Monsieur Asmir LEKOVIC , prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer à compter de ce jour pour une durée indéterminée:
a) dans la fonction de gérant technique: Monsieur Samir LEKOVIC, prédit.
b) dans la fonction de gérant administratif: Monsieur Asmir LEKOVIC, prédit.
c) Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux
gérants.
c) de fixer l’adresse sociale de la société à L-6463 Echternach, 5 rue Maximilien.
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Samir Lekovic, Asmir Lekovic, Biel A.
86915
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2011. Relation: EAC/2011/6966. Reçu: soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2011.
Référence de publication: 2011083428/131.
(110092980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
Yaborandi SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.627.
Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
YABORANDI SPF S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011083425/12.
(110092714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
3W Power Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.423.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 19 mai 2011i>
En date du 19 mai 2011, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs avec effet immédiat et ce pour une durée
déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre
2011:
* Monsieur Gerhard HENSCHEL, né le 25 juin 1964 à Hambourg, Allemagne et ayant comme adresse professionnelle:
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
* Monsieur Lawrence LAVINE, né le 20 septembre 1951 à Rhode Island, Etats-Unis d'Amérique et ayant comme adresse
professionnelle: 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- de prolonger le mandat des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce
pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes clôturés
au 31 décembre 2011:
* Monsieur Roland BERGER
* Monsieur Robert John HULJAK
* Monsieur Bruce ALTON BROCK
* Monsieur Harris WILLIAMS
* Monsieur Chris MINNETIAN
* Monsieur Thomas MIDDELHOFF
* Monsieur Mark Matthias Wolfgang WÖSSNER
* Monsieur Horst Jörg KAYSER
* Monsieur Keith BADEN CORBIN
- de prolonger le mandat de KPMG AUDIT en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2011.
Le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Roland BERGER
- Monsieur Robert John HULJAK
- Monsieur Bruce ALTON BROCK
- Monsieur Harris WILLIAMS
- Monsieur Chris MINNETIAN
- Monsieur Thomas MIDDELHOFF
86916
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Mark Matthias Wolfgang WÖSSNER
- Monsieur Horst Jörg KAYSER
- Monsieur Keith BADEN CORBIN
- Monsieur Gerhard HENSCHEL
- Monsieur Lawrence LAVINE
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2011.
3W Power S.A. (Anciennement "3W Power Holdings S.A.")
Signature
Référence de publication: 2011083430/47.
(110093214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2011.
DesCap S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 86.512.
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
Je soussigné, Oscar DELLA SCHIAVA, demeurant au 13, rue Th. Speyer L-2545 HOWALD, actionnaire unique de la
société DESCAP S.A., décide par la présente:
- de prolonger pour une durée de 6 ans les mandats des administrateurs:
* Monsieur Oscar DELLA SCHIAVA, prénommé;
* Madame Elisabeth GUIDI demeurant au 13, rue Th. Speyer L-2545 HOWALD.
- de nommer Monsieur Gionvanni MARTINI, né le 23 mars 1972 à Chivasso (Italie), demeurant à I-15121 Alessandria
(AL), Via Don Giovine 67, en remplacement de Monsieur Paolo ZANONI.
Fait à Luxembourg, le 24 mars 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083433/18.
(110091628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.
Egos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5730 Aspelt, 12, rue de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 118.628.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> mars 2011i>
<i>Résolutions prisesi>
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
<i>Unique résolutioni>
Est nommé administrateur pour une durée de 6 ans, Monsieur Fabien ZUILI, né le 19 janvier 1967 à PortoVecchio
(Corse du Sud) France, demeurant à L-8328 Capellen, 35, rue du Kiem, et ce à partir du 1
er
février 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011083434/15.
(110091626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.
Prêtres du Sacré Coeur Couvent de Cinqfontaines, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9902 Cinqfontaines, Maison 5.
R.C.S. Luxembourg F 8.769.
STATUTS
Chapitre 1
er
. Siège, Dénomination et Objet
Art. 1
er
. L'association prend la dénomination de <Prêtres du Sacré Cœur Couvent de Cinqfontaines> avec siège à
L-9902 Cinqfontaines, maison 5, commune de WINCRANGE.
86917
L
U X E M B O U R G
Art. 2. L'association a pour objet, à l'exclusion de tout but lucratif, la vie religieuse en commun et le service du culte
catholique par l'exercice du ministère sacerdotal et apostolique se manifestant particulièrement:
a) par la prédication des missions, retraites et autres exercices spirituels;
b) par les missions catholiques à l'étranger;
c) par des conférences, l'impression et la vente de livres et revues scientifiques et autres, l'organisation d'expositions,
de séances avec projections en faveur des missions étrangères;
d) l'association peut conférer tous soutien et assistance, morale et matérielle, à des œuvres, congrégations et asso-
ciations ayant un but analogue ou similaire.
Chapitre 2. Membres
Art. 3. L'association se compose de membres associés, de membres honoraires et de membres coopérateurs.
Art. 4. Le nombre des associés est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Art. 5. Toutes personnes qui accordent à l'association leur soutien moral peuvent devenir membres honoraires.
Art. 6. Toutes personnes qui soutiennent par leur action l'œuvre de l'association peuvent devenir membres coopérants.
Art. 7. Les membres honoraires et les membres coopérants sont admis et démis par le Conseil d'Administration. Ils
ne participent pas aux assemblées.
Art. 8. Tout membre est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
L'exclusion d'un membre associé ne peut être prononcée que par l'assemblée générale des associés et à la majorité des
deux tiers des voix.
Art. 9. Un associé démissionnaire ou exclu et les ayants-droit d'un membre décédé n'ont aucun droit sur le fonds
social. Ils ne peuvent notamment réclamer ou requérir ni relevé de comptes, ni reddition de comptes, ni apposition de
scellés, ni inventaire.
Chapitre 3. Administration
Art. 10. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de cinq
membres au plus. Ils sont nommés et révocables par l'assemblée générale.
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs administrateurs, les membres restants du conseil d'administration
resteront en fonctions avec leurs mêmes attributions, à condition que le nombre des membres restants dépasse deux.
La durée des fonctions des membres du Conseil d'Administration est indéterminée et prend fin par démission, exclu-
sion ou décès.
Art. 11. Le Conseil d'Administration élit en son sein un président ou un vice -président; Il peut déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs de ses membres. Il choisit en son sein ou au dehors un secrétaire ou un trésorier.
En cas d'empêchement du président ou du vice-président, leurs pouvoirs appartiennent au plus ancien des membres.
Art. 12. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante.
Art. 13. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour la gestion et l'administration de l'association.
Il représente l'association en justice et extrajudiciairement. Il peut en particulier, sans que la présente énumération soit
limitative, et sans préjudice de tous autres pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et les statuts, faire et signer tous
actes et contrats, transiger, acheter ou vendre des biens mobiliers et immobiliers, hypothéquer les biens et droits réels
de l'association, faire et accorder des prêts, contracter des engagements avec ou sans hypothèques, renoncer à des
privilèges, gages, droits de résolution ainsi qu'à leur inscription, accorder mainlevée ou radiation avant ou après paiement,
faire des baux de durée indéterminée, accepter des legs, dons et donations, renoncer à tous droits réels et autres, donner
des procurations à des associés ou non-associés.
Art. 14. Toutes conventions qui engagent l'association en dehors des affaires quotidiennes courantes, seront, à défaut
de mission spéciale du Conseil d'Administration, signées par le président ou un membre délégué du Conseil d'Adminis-
tration sans que le signataire ne soit tenu à l'égard des tiers d'apporter la preuve du mandat lui conféré par le Conseil
d'Administration.
Dans tous les actes judiciaires, l'Association sera représentée en demandant et en défendant par le président ou un
membre délégué du Conseil d'Administration.
Art. 15. Les affaires d'administration courantes quotidiennes sont accomplies valablement par un ou plusieurs membres
du Conseil d'Administration; le cas échéant, également par des membres ou non-membres à qui le Conseil d'Adminis-
tration a donné un mandat afférent.
86918
L
U X E M B O U R G
Chapitre 4. Assemblée générale
Art. 16. Chaque année aura lieu au siège de l'Association, au jour et heure déterminés par le Conseil d'Administration,
l'assemblée générale des membres de l'association.
Art. 17. La convocation aura lieu, soit par information personnelle aux membres, soit par lettre envoyée par la poste.
Art. 18. Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par d'autres membres ou par des tiers qui
seront agrées par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration a le droit de faire représenter à son gré des membres, dans l'assemblée générale, qui n'ont
pas manifesté une intention contraire.
Art. 19. L'assemblée générale est composée réglementairement et peut décider valablement à la majorité des voix,
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, nonobstant les cas d'exception prévus par la loi.
Art. 20. L'assemblée générale ordinaire est seule compétente pour délibérer des points suivants:
a) les modifications des statuts, conformément à la loi du 21 avril 1928,
b) la nomination et la révocation des administrateurs,
c) l'exclusion des membres,
d) l'approbation du budget et des comptes
e) la dissolution de l'association
f) elle a en outre tous les pouvoirs lui conférés par la loi.
Art. 21. Les décisions de l'assemblée générale sur:
a) la modification des statuts
b) l'exclusion d'un membre
c) la dissolution volontaire de l'association
Ne peuvent être prises que conformément aux dispositions des articles 8,12 et 20 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 22. Moyennant l'accord du Conseil d'Administration, l'assemblée peut décider des questions qui ne sont pas
prévues à l'ordre du jour.
Art. 23. A la demande d'au moins deux associés, les votes se feront au scrutin secret.
Art. 24. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou en cas d'empêchement par
le vice-président.
Celui qui préside désigne le secrétaire.
Art. 25. Les décisions de l'assemblée générale sont inscrites dans le registre des délibérations, qui restera déposé au
siège de l'association, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Chapitre 5. Bilan de fin d'année
Art. 26. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
Art. 27. Le conseil d'administration établit le bilan de l'année écoulée, ainsi que le budget du prochain exercice. Le
conseil les soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Chapitre 6. Dissolution de l'association.
Art. 28. En cas de dissolution de l'association, pour quelque cause que ce soit, l'actif restant, après paiement de toutes
les dettes, accomplissement de tous engagements revient normalement à l'association sans but lucratif <Prêtres du Sacré
Cœur HOWALD > qui appartient à la même congrégation ou à défaut de celle-ci au généralat de la Congrégation des
Prêtres du Sacré Cœur avec siège social à 20, Via CASALE San PIO V, I-00165 ROMA.
Chapitre 7. Publications
Art. 29. Le conseil d'administration prend soin des publications prévues aux articles 3, 9, et 11 de la loi.
Etabli à Cinqfontaines, le 1
ier
juin 2011.
Père Fridolin LENZ
<i>Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2011083435/105.
(110091174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.
86919
L
U X E M B O U R G
Artelis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 112.173.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de artelis s.a. (la Société) tenue à Luxembourg 14 avrili>
<i>2011i>
L'Assemblée constate et accepte la démission de M. Leo Petry, M. Engelbert Muller et de M. Eric Mauer de leur poste
d'administrateur avec effet au 14 avril 2011.
L'Assemblée accepte de reconduire le mandat d'administrateur de M. Max Häring pour 6 années supplémentaires
jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale ordinaire se tenant en 2017.
L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs avec effet au 14 avril 2011 jusqu'à l'assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice 2017 Monsieur Hanno Dornseifer, Fasanenweg 20 b, D-66424 Homburg, Monsieur
Thomas Christian Buchbinder, Rückertstraße 1, D-66121 Saarbrücken et Monsieur Marc Adler, 26, rue de la Montée,
L-3362 Leudelange.
L'assemblée nomme comme réviseur d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2011 PriceWaterhouseCoopers Sàrl, avec
siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 65.477
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
artelis s.a.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011083436/24.
(110092355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
Circuit Foil Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 94.668.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Catherine Sonnet.
Référence de publication: 2011083438/10.
(110091857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
Controlgroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 143.847.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Controlgroup SA qui s'est tenue à Luxembourg le 14 juini>
<i>2011i>
<i>Sixième résolutioni>
Le mandat du réviseur d'entreprise arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de le renouveler jusqu'à l'assem-
blée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Luxembourg, le 14 juin 2011.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Marco Sterzi / Francesca Docchio
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011083440/17.
(110092419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
86920
L
U X E M B O U R G
Financière Piesa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 112.976.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinairei>
L'an deux mille onze, le 16 juin,
A Luxembourg,
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat:
1) des trois administrateurs à savoir, Monsieur Lex THIELEN, Monsieur Thierry BICHEL et Madame Magalie HILCHER
et ce, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017
2) du commissaire aux comptes, la société Saint Gérant INVESTISSEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social au
10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg et immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 87.458 et ce,
jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017.
Luxembourg, le 16 juin 2011.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011083443/19.
(110092142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
D.S.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 97, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 101.424.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendelf, den zwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Pierre PROBST, Notar mit Amtssitz in Ettelbrück.
Ist erschienen:
Herr Eckhardt JÜNGST, geboren in Burgsteinfurt (Deutschland), am 29. Mai 1942, wohnhaft in D-54579 Üxheim-
Niederehe, Marienhof 1,
hier vertreten durch Herrn Klaus JÜNGST, geboren in Weidesheim (Deutschland) am 5. August 1963, wohnhaft in
D-57579 Üxheim-Niederehe, Stroheicher Straße 30,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in Heinerscheid am 11. Mai 2011.
Diese Vollmacht bleibt nach gehöriger «ne varietur» Unterzeichnung durch die Parteien und den verhandelnden Notar
bei gegenwärtiger Urkunde, um mit ihr einregistriert zu werden.
Die erschienene bzw. vertretene Partei bittet den Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft D.S.L. (Matrikel 1995 2409 312), mit Firmensitz in L-9735 Heinerscheid, Hauptstrooss 97, wurde
gegründet unter dem Namen D.V. LUX S.à r.l, gemäß notarieller Urkunde, erstellt durch Notar Martine Weinandy, mit
dem Amtssitz in Clerf, am 24. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
659, vom 28. Dezember 1995, zum letzten Mal abgeändert laut notarieller Urkunde des Notars Anja HOLTZ, mit Amtssitz
in Wiltz, am 11. April 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1381 vom 6. Juli 2007,
eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburgs unter der Nummer B 101.424, mit einem Gesellschaftskapital
von zwöftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR,) eingeteilt in fünfhundert Anteile. (500) von je fünfundzwanzig Euro
(25,- EUR)
- dass der vertretene Komparent der einzige Teilhaber der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist
und die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft beschließt;
- dass, nachdem die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva und Passiva auf den Komparenten
als einziger Eigentümer sämtlicher Anteile andurch übertragen werden;
- dass die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- dass dem alleinigen Geschäftsführer vollständige Entlastung für die Ausübung seines Mandates gewährt wird;
- dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz
verwahrt werden.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbrück, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienen, dem Notar nach Namen gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
86921
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: E. JÜNGST, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 25 mai 2011. DIE/2011/5170. Reçu soixante-quinze euros, (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Ettelbruck, den 30. Mai 2011.
Pierre PROBST
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2011083441/46.
(110092389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
Fiver S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 39.018.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 3 mai 2011 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>23, avenue de la Porte - Neuvei>
- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Joseph WINANDY Administrateur et Pré-
sident, de Monsieur Koen LOZIE, Administrateur et de COSAFIN S.A., Administrateur dont le siège social est situé 1
rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg (représentée par Monsieur Jacques BORDET, 1 rue Joseph Hackin L-1746 Lu-
xembourg), ainsi que du Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31/12/2011.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011083445/18.
(110092133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
Clement Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.108.
STATUTS
L'an deux mil onze, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., RCS Luxembourg B 78.967 ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 113,
route d'Arlon,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Jean Naveaux, demeurant professionnellement à L-1140
Luxembourg, 113, route d'Arlon,
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts
(ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et qu'elle a arrêté comme suit:
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «CLEMENT INVEST
S.A.» (ci-après, la Société).
La Société peut avoir un associé unique (l'"Associé Unique") ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être
dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration
de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.
86922
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22. ci-après.
Art. 4. Objet Social. La société a pour objet l'audit et le management des risques, conseil en organisation et stratégie,
traduction et toutes activités de conseil et de formation auprès des entreprises et collectivités.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 100
(cent) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 310 (trois cent dix euros) chacune.
Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée
Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22. ci-après.
Art. 6. Actions. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats
représentatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans
lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Obligations. Les obligations peuvent aussi être nominatives ou au porteur.
Art. 9. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique
aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie
de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée
Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la
Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le premier vendredi
de juin à 12:00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblé Générale pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer, la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum
requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où
il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électro-
nique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.
86923
L
U X E M B O U R G
Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à
l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des
actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.
Art. 11. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un associé unique.
Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique
qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux
administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administra-
teurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque
la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désignée un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi lu-
xembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra être
rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)
parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le
Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'As-
semblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en
désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.
Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs autres membres empêchés du Conseil d'Admi-
nistration à la condition qu'au moins deux membres du Conseil d'Administration soient physiquement présents ou
assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication qui est conforme aux
exigences du paragraphe qui suit.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.
86924
L
U X E M B O U R G
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la
présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur
Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil
d'Administration.
Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-
tionnaire ou non membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation
préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 16. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la seule signature d'un administrateur de la Société, ou (ii) dans le cas d'un admi-
nistrateur unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par l'unique signature de toute personne à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur
auront été conférés.
Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne
délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société
est administrée par un Administrateur Unique.
Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront
décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lequelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-
nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.
Art. 18. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.
86925
L
U X E M B O U R G
Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.
Art. 19. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de chaque année.
Art. 20. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et
devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
Art. 22. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 23. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2011.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il a souscrit les 100 (cent) actions représentant
la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions ont été libérées par l'Associé Unique à hauteur de 32,26 % par paiement en numéraire, de sorte
que le montant de EUR 10.000.-(dix mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi
sur les Sociétés de 1915, et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont
conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi sur les Sociétés de 1915.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.200.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à 1 (un);
2. est nommé Administrateur Unique de la Société la personne suivante:
Monsieur Jean Naveaux, né le 30 avril 1943 à Villers-la-Loue (Belgique), demeurant professionnellement à L-1140
Luxembourg, 113, route d'Arlon.
3. est nommé commissaire aux comptes de la Société:
MONTEREY AUDIT S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, RCS Luxembourg B
78.967.
4. le mandat de l'Administrateur Unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de la décision annuelle
statutaire de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2016; et
5. le siège social de la société est fixé au L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
86926
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. NAVEAUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mai 2011. Relation: LAC/2011/24359. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 30 mai 2011.
Référence de publication: 2011074885/260.
(110083234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Artemia S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 118.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011082633/13.
(110091828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
AS24 Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 53.072.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 28 Janvier 2011 à 10 heuresi>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- L'Assemblée accepte la démission d'un membre du Conseil d'Administration:
- Monsieur MENGUS Marc, Administrateur, né le 18 Avril 1962 à Saverne (France), demeurant au 3, Rue Huchette -
F- 44100 Nantes (France).
L'Assemblée élit en remplacement:
- Monsieur VANVERTS François, Administrateur, né le 02 Janvier 1956 à Nevers (France), demeurant au 454, Chemin
du Deffend -F- 13650 Meyrargues (France).
2- Le mandat du nouveau membre du Conseil d'Administration prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2013.
Mr Pierre-Yves SACHET / Mr. Stefan De Ganck / Mr François VANVERTS
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2011082634/19.
(110091887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
Atelier Métallique Antonio Campos Sàrl, en abrégé AMAC/Elvange Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange.
R.C.S. Luxembourg B 50.345.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2011082635/13.
(110091844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
86927
L
U X E M B O U R G
Triodos Sicav I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.549.
L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 20 avril 2011 a:
- pris note de la démission de Monsieur Peter Kok, Independent, CFO of Delta Lloyd Group, Spaklerweg 4, PO Box
1000, NL-1000 BA Amsterdam, en tant qu'administrateur,
- décidé de nommer Monsieur Emiel Roozen, CFO Delta Lloyd Groep, Amstelplein 6, NL -1096 BC Amsterdam, en
tant qu'administrateur,pour une période allant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Odilon De GROOTE, Papestraat 3, B-9320 NIEUWERKERKEN
Monsieur Pierre AEBY, CFO Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, NL-3700 AB ZEIST
Monsieur Olivier MARQUET, Managing Director, Triodos Bank Belgium, Hoogstraat 139, bus 3, B-1000 BRUXELLES.
Monsieur Patrick GOODMAN, Triodos Sicav II, 69 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Monsieur Joan Sebastiaan RÜTER, Managing Director, Triodos Fonds Management BV, Nieuweroordweg 1, PO Box
55, NL-3700 AB ZEIST
en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an allant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2012.
de renouveler le mandat de KPMG Audit S.à.r.l en tant que Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an allant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Suite à ce changement, le Conseil se compose comme suit:
Madame Marjolein Elings-Van Hooidonk, Independent, Notary public, Woudenbergseweg 5, Postbus 70, NL-3700 AB
Zeist (nommé en 2010 pour une période jusqu'à l'AGO 2016)
Monsieur Albert Van Zadelhoff, Managing Director Triodos Bank Private Banking, Nieuweroordweg 1, NL 3700 AB
Zeist (nommé en 2010 pour une période jusqu'à l'AGO 2014)
Monsieur Emiel Roozen, CFO Delta Lloyd Groep, Amstelplein 6, NL -1096 BC Amsterdam
Monsieur Odilon De GROOTE, Papestraat 3, B-9320 NIEUWERKERKEN
Monsieur Pierre AEBY, CFO Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, NL-3700 AB ZEIST
Monsieur Olivier MARQUET, Managing Director, Triodos Bank Belgium, Hoogstraat 139, bus 3, B-1000 BRUXELLES.
Monsieur Patrick GOODMAN, Independent, Innpact, 7, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Monsieur Joan Sebastiaan RÜTER, Managing Director, Triodos Fonds Management BV, Nieuweroordweg 1, PO Box
55, NL-3700 AB ZEIST
<i>Pour TRIODOS SICAV I SICAV
i>RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2011082599/39.
(110091461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.
Segeco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 56, rue Kohlenberg.
R.C.S. Luxembourg B 58.501.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2011082457/13.
(110091710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
86928
3W Power Holdings S.A.
Artelis S.A.
Artemia S.A.
AS24 Luxembourg S.A.
Atelier Métallique Antonio Campos Sàrl, en abrégé AMAC/Elvange Sàrl
Circuit Foil Service S.à r.l.
Clement Invest S.A.
Controlgroup S.A.
DesCap S.A.
D.S.L.
Egos S.A.
Financière Daunou 13 S.A.
Financière Daunou 15 S.A.
Financière Piesa S.A.
Fiver S.A., SPF
JPMorgan Funds
NaCoal S.A.
Naiad Property S.à r.l.
NC+S Acquisition Corporation S.à r.l.
New Life Settlement Scenarios S.A.- Société de Titrisation
Noosphere S.à r.l.
Pfizer Continental Holdings Sàrl
Pfizer Europe Holdings Sàrl
Pfizer Global Investments Sàrl
Pfizer Holdings Luxembourg Sàrl
Pfizer Investment Holdings S. à r.l.
Pfizer Transactions Luxembourg S.à r.l.
Prêtres du Sacré Coeur Couvent de Cinqfontaines
Seed Box S.A.
Segeco S.A.
Société de Gestion Hotelière et de Commerces
Société Générale des Assaisonnements S.A.
Solar Investments S.A.
Soleo S.A.
SPXA S.A.
Stam Re III
Stam Re III
Struwwelbuscht s.à r.l.
Subsea 7 Lending S.à r.l.
SU Finance S.à r.l.
SU Holdings S.à r.l.
SU Holdings S.à r.l.
TGR Trocken- und Innenausbau S.à r.l.
Triodos Sicav I
UBS (Luxembourg) S.A.
UK Tissue S.A.
Unionkey S.A.
Uranus International S.à r.l.
URSA Mortgage Finance S.A.
Valex S.A.
VCL No. 9 S.A.
Villa Arena S.à r.l.
Villa Bianca S.à r.l.
VL. Logistik S.à r.l.
Voxel International S.à r.l.
Wagner Management SA
Wave Quest S.A.
WDI Reinsurance S.A.
Web4 S.A.
White Bear S.A.
Yaborandi SPF S.A.
Yaborandi SPF S.A.
Zum Immo Promotion S.à r.l.
Zum Immo Promotion S.C.I.