logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1771

4 août 2011

SOMMAIRE

Abrantes Martins S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

84994

Altoona Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

84983

Arlene S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85002

Asars Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

84990

ATEEL - Allied Technology Experts Enter-

prise of Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

84983

BN D&G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84993

Breakingresearch.com S.A.  . . . . . . . . . . . . .

84993

Calypsis Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85003

Calypsis Equity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85001

Carbofer Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85001

Carbofer Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84979

CBRail S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84993

Centre Européen de Géodynamique et de

Séismologie (ECGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84977

CMC Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85001

Copper Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

84996

Copper Blade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84996

Copper Management S.à r.l. & Partners

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85000

Dexia Life & Pensions Luxembourg  . . . . . .

84991

Direl LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84995

Druster HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

85005

E.F.IM. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84978

E.RE.A.S. Finance S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

85002

Euro-Deal International S.A.  . . . . . . . . . . . .

85002

Fidji S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85006

FIS International SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85001

Freesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85005

Future Energy Management Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85000

Greenman Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

85006

Hacienda S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84996

H'Air S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84983

Holding Akemis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

85006

I.B.F. Informatique Bancaire et Financière

S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85007

INHALUX.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85008

Inverlog S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85001

Island Group Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

85008

KGC Networks Luxembourg S.A.  . . . . . . .

84998

Le Premier 3 JD S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84994

Luxredange S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84982

Manwin Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .

85006

Mast Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85002

Med Call S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84980

Parkettcenter S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84981

Parquet Böhm S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

84977

Partners Group (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

84978

Partners Group Secondary 2011 (EUR)

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84962

Pimco Luxembourg III S.A.  . . . . . . . . . . . . .

84982

Premium Capital Energie Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84979

RBS (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

84982

Regional MSME Investment Fund for Sub-

Saharan Africa S.A., SICAV-SIF  . . . . . . . .

84982

Resol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85001

ROLLINGER Toiture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85005

Support Science Global S.à r.l.  . . . . . . . . . .

84991

The Glove Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84981

Transcom WorldWide S.A.  . . . . . . . . . . . . .

85007

Triton III LuxCo B 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

85008

VALARTIS FUNDS (Lux. I)  . . . . . . . . . . . . .

85000

Westley International  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84990

Xenos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84979

84961

L

U X E M B O U R G

Partners Group Secondary 2011 (EUR) S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 161.270.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh of May.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Partners Group Management II S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with its registered

office at 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, represented by Mr Sami Nummela, employee, professionally residing
in Luxembourg, pursuant to a proxy; and

2. Partners Group Finance EUR IC Limited, Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, GY1 6BD Guernsey, represented

by Mr Sami Nummela, prenamed, pursuant to a proxy.

The proxies signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

association of a société en commandite par actions which they form between themselves (the "Articles"):

Art. 1. Establishment. There exists among the subscribers and all those who become owners of Shares hereafter issued,

a corporation in the form of a société en commandite par actions with variable capital qualifying as investment company
in risk capital under the law of 15 

th

 June 2004, as amended, (the "2004 Law") under the name of "Partners Group

Secondary 2011 (EUR) S.C.A., SICAR" (the "Corporation").

Art. 2. Term. The Corporation is established for a period expiring on 31 

st

 December 2024, provided that the Cor-

poration by Shareholder Resolution (according to the term defined thereafter) taken under the conditions for amend-
ments of these Articles may be dissolved prior to this date or continued for up to 3 (three) additional one-year periods.

Art. 3. Purpose.
(a) The object of the Corporation is to invest in Partners Group Secondary 2011 (EUR), L.P. (the "Fund"), representing

risk capital within the meaning of article 1 of the 2004 Law, in order to provide its Investors with the benefit of the result
of the management of its assets in consideration of the risk which they incur.

(b) The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development

and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the 2004 Law, provided that the other provisions of
these Articles will be complied with.

(c) The Corporation may not undertake any other investment activities except for investing in the Fund, holding short-

term bank deposits and short-term borrowing of funds pursuant to Article 13 (c).

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand-

Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established in Luxembourg by resolution of the Manager. If and
to the extent permitted by law, the Manager may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg.

Art. 5. Share Capital.
(a) The share capital of the Corporation shall be represented by Shares without par value and shall at all times be equal

to the Corporation's total net assets.

(b) The Corporation is incorporated with the minimum share capital provided by law.
(c) The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Corporation or to any other duly authorized

person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares issued.

(d) The share capital of the Corporation shall be represented by the following classes of Shares:
(i) Ordinary Shares issued to Investors, generally for a subscription price of one thousand EUR (EUR 1,000); and
(ii) Manager Shares issued to the Manager, generally for a subscription price of one EUR cent (EUR 0.01).
(e) No preferential subscription rights are granted.
(f) The Manager may fully or partially return to Shareholders the amounts paid in connection with the subscription of

Shares, provided that such amounts may be recallable at times and under the conditions determined by the Manager.

(g) The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder are referred to as "Contributions".
(h) The Manager will determine the dates of the share offerings of the Corporation for the admission of additional

Investors (each a "Share Offering"), and may hold further Share Offerings over a period of eighteen months following the
initial Share Offering. The Share Offering period may, in the discretion of the Manager, be extended by up to 12 months.

84962

L

U X E M B O U R G

(i) The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings,

drawdowns and payments upon drawdown.

(j) The minimum capital, as defined in the 2004 Law, which must be achieved within twelve months after the date on

which the Corporation has been authorised as a société d'investissement en capital à risque under Luxembourg law, shall
be one million EUR (EUR 1,000,000).

Art. 6. The Manager.
(a) The "associé-gérant-commandité" of the Corporation shall be Partners Group Management II S.à r.l., a corporation

organised under the laws of Luxembourg (the "Manager").

(b) The Manager is jointly and severally liable for all liabilities to third parties which cannot be met out of the assets

of the Corporation. The Manager shall not be liable on its own assets for the payment of (i) any distributions to Share-
holders or (ii) the return of Contributions to Shareholders.

Art. 7. Liability of Investors.
(a) The Investors are not permitted to act on behalf of the Corporation in any manner or capacity other than by

exercising their rights at Shareholder meetings.

(b) The Investors shall be solely liable for payment to the Corporation of (i) the subscription price on any Ordinary

Shares and any Undrawn Commitment(according to the term defined hereafter), (ii) the return of distributions, and (iii),
if applicable, an Entry Charge (according to the term defined hereafter).

Art. 8. Share Register.
(a) All issued Shares of the Corporation shall be recorded in the Shareholder register (the "Register"). The Register

shall contain the name of each Shareholder, their residence, registered office or elected domicile, the number and class
of Shares held, the amount paid in on the Shares, and the banking account details of the Shareholders.

(b) Until notices to the contrary have been received by the Corporation, it may treat the information contained in the

Register as accurate and up-to-date and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and
announcements and the inscribed banking account details for the making of any payments.

(c) The Manager will appoint an entity responsible for the maintenance of the Register.
(d) Transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register upon delivery to the Corporation

of a completed transfer form together with evidence that the purchaser has assumed all obligations in connection with
the Undrawn Commitment relating to the respective Interest and such other documentation as the Corporation may
require.

(e) Investors may transfer fully paid Ordinary Shares to Eligible Investors (according to the term defined hereafter).

Their Undrawn Commitment (according to the term defined hereafter) may be transferred to the extent the transferee
is (i) creditworthy, as determined by the Manager, and (ii) eligible in accordance with the provisions of the 2004 Law.

To the extent that, and as long as, a respective Interest is part of a German insurance company's or a German pension

fund's "committed asset" ("Sicherungsvermögen") as defined in Sec. 66 of the German Insurance Supervisory Act, as may
be  amended  from  time  to  time  ("Versicherungsaufsichtsgesetz")  or  "other  committed  asset"  ("Sonstiges  gebundenes
Vermögen" as defined in Sec. 54 para 1 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended from
time to time), such Interest shall not be disposed of without the prior written consent of the trustee ("Treuhänder")
appointed in accordance with Sec. 70 of the German Insurance Supervisory Act, as may be amended from time to time,
or by the trustee's authorized deputy.

However, notwithstanding the above, any Interest that is directly or indirectly held by a German insurance company

or a German pension fund and that is part of their committed assets is freely transferable and such transfer will not require
the approval of the Manager provided the transferee is an Eligible Investor and executes the necessary documentation.
Upon the transfer of any Interest that is directly or indirectly held by a Shareholder that is a German insurance company
or German pension fund, the transferee shall accept and become solely responsible for all liabilities and obligations relating
to such Interest held and the transferor shall be released from and shall have no further liability in respect of the Cor-
poration.

(f) Fractions of Shares may be issued up to three decimal places.
(g) Shares will only be issued as registered securities.
(h) Shares will be available in book-entry form. No certificates will be issued.

Art. 9. Commitment.
(a) Investors will undertake to subscribe for Ordinary Shares in an amount as set out in the Subscription Agreement

(each a "Commitment").

(b) The minimum Commitment to the Corporation by an Investor will be five million EUR (EUR 5,000,000) although

the Manager reserves the right to admit Investors with lower Commitments.

(c) The Commitment made by each Investor will be payable in instalments by subscribing for additional Shares in the

Corporation. Prior to each Contribution, the Manager will issue a drawdown notice advising Investors of the portion of
their Commitment required to be contributed to the Corporation and the corresponding number of Shares that will be

84963

L

U X E M B O U R G

issued, whereupon such amount shall be payable within ten (10) calendar days, in cash denominated in EUR, and the
relevant number of Shares shall be issued to Investors on a pro-rata basis (each such event of drawing down capital being
a "Drawdown").

(d) Drawdowns will be made in proportion to the Commitment of each Investor, as needed to satisfy the capital

requirements of the Corporation's investments and to maintain a reserve for the operating expenses of the Corporation.

Art. 10. Eligible Investor.
(a) The Manager on behalf of the Corporation may, at its discretion, restrict or prevent the ownership of Shares in

the Corporation by any person, firm or corporate body.

(b) Only Eligible Investors shall be permitted to hold an Interest in the Corporation.
(c) The Manager may, at its discretion, delay the acceptance of any application for an Interest until such time as sufficient

documentation has been provided verifying that the applicant qualifies as an Eligible Investor.

(d) Where the Corporation determines that an Investor is not an Eligible Investor, or is in breach of its representations

and warranties or fails to make such representations and warranties as the Manager may require, the Manager may require
such Investor to sell all or part of its Interest in accordance with the following provisions:

(i) the Corporation shall serve a notice (the "Purchase Notice") upon the Investor, specifying the Interest to be pur-

chased as aforesaid, the price to be paid for such Interest (the "Purchase Price"), and the place at which the Purchase
Price in respect of such Interest is payable. Any such notice may be served upon such Investor by posting the same in a
prepaid registered envelope addressed to such Investor at its last address known to or appearing in the Register. Imme-
diately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Investor shall cease to be the owner
of the Interest specified in such notice and its name shall be removed as to the respective Shares in the Register;

(ii) the Purchase Price of the Interest shall be an amount equal to 75% of the market value of the Investor's Interest,

such value being determined by the Manager obtaining price quote(s) within the market;

(iii) payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Interest, except during periods of exchange

restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
Purchase Notice) for payment to such owner. Upon deposit of such price as aforesaid the person specified in such
Purchase Notice shall have no further interest in the Corporation, or any claim against the Corporation or its assets in
respect thereof, except the right to receive the price so deposited (without interest) from such bank.

(e) The exercise by the Corporation of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated

in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true
ownership of any Shares was otherwise than as appeared to the Corporation at the date of any Purchase Notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Corporation in good faith.

(f) In addition to any liability under applicable law, each Investor who does not qualify as an Eligible Investor, and who

holds an Interest, shall hold harmless and indemnify the Corporation, the Manager, the other Investors and Ordinary
Shareholders and the Corporation's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such
holding in circumstances where the relevant Investor had furnished misleading or untrue documentation or had made
misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Eligible Investor or had failed to notify the
Corporation of its loss of such status.

Art. 11. Annual General Meeting.
(a) The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Friday of the month of June at 4:15 p.m. (Luxembourg time) and for the first time in 2012. If such day is not
a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the preceding bank
business day.

(b) Other Shareholder meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective meeting

notices.

Art. 12. Shareholder Meetings.
(a) All Shareholder meetings shall be presided over by the Manager.
(b) Any duly convened Shareholder meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest

power to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

(c) A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by:
(i) appointing another person as its proxy in writing, or
(ii) providing written confirmation to the Manager instructing the manner in which it elects to vote on respective

agenda points provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the
relevant Shareholder, (2) the indication of the Shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda
as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the
agenda. The original voting bulletins must be received by the Corporation 24 hours before the relevant Shareholder
meeting.

84964

L

U X E M B O U R G

(d) Each Manager Share and each Ordinary Share carries one vote at all Shareholder meetings.
(e) All Shares will vote as one class unless otherwise required by law or provided in these Articles.
(f) Except as otherwise required by law or provided in these Articles, resolutions at a Shareholder meeting (a "Sha-

reholder Resolution") shall require the approval of:

(i) a simple majority of the votes cast by the Shareholders present or represented, and
(ii) the Manager.
(g) Any resolution at a Shareholder meeting deciding that the Corporation will no longer qualify as investment company

in risk capital under the 2004 Law will need to be passed by a unanimous vote of all Shareholders and the Manager and
requires prior approval by the Luxembourg supervisory authority.

(h) Whenever the limited partners of the Fund are required or permitted to take any action by vote, such matter shall

be presented to the Shareholders for their consent. The approval of the Corporation shall be based on a simple majority
of the votes cast.

(i) The Manager shall provide at least 8 days prior notice of any Shareholder meeting as required under Luxembourg

law.

(j) The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any

Shareholder meeting.

(k) Votes cast as used in these Articles shall not include votes attaching to Shares in respect of which a Shareholder

has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Art. 13. Manager Powers.
(a) The Manager has the broadest power to perform all acts of administration and disposition of the Corporation and

to investigate, pursue and conclude transactions. All powers that are not reserved by law or these Articles to the general
meeting of Shareholders are within the powers of the Manager.

(b) The Manager shall determine the investment policy and the borrowing policy of the Corporation, subject to the

restrictions established by (i) Luxembourg law, (ii) regulatory authorities, and (iii) these Articles.

(c) The Manager is authorized to borrow on behalf of the Corporation. The Manager shall only utilize borrowings for

temporary liquidity purposes (i.e. up to six months) and subject to rates commercially available for such borrowing. The
maximum borrowing on behalf of the Corporation is not allowed to exceed 10% of the aggregate Commitments to the
Corporation.

(d) The Manager may appoint investment advisors and managers, as well as any other management or administrative

agents. The Manager may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the
delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Corporation.

Art. 14. Due Authorisation. The Corporation shall be bound by the joint signatures of any duly authorised directors

or officers of the Manager or by the signature of any other persons to whom authority shall have been delegated by the
Manager.

Art. 15. Exculpation & Indemnification.
(a) No Indemnified Party (as defined below) shall be liable to the Corporation or any Investor for any act or omission

taken or suffered by such Indemnified Party in the reasonable belief that such act or omission is or is not, contrary to the
best interests of the Corporation and is within the scope of authority granted to such Indemnified Party, provided that
such acts or omissions do not constitute gross negligence or a material violation of such Indemnified Party's obligations
to the Corporation.

(b) To the fullest extent permitted by law, the Corporation shall indemnify and hold harmless the Manager or its

affiliates, and any of their respective employees, officers, directors, agents, controlling persons or representatives (each
an "Indemnified Party") from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs and expenses (including
amounts paid in satisfaction of judgments, in compromises and settlements, as fines and penalties and legal or other costs
and expenses of investigating or defending against any claim or alleged claim) of any nature whatsoever, known or unk-
nown, liquidated or unliquidated (collectively "Losses"), that are incurred by any Indemnified Party and arise out of or are
related to the affairs or activities of the Corporation, including acting as a director of a target company, or the performance
by such Indemnified Party of any of its responsibilities hereunder or otherwise in connection with being or having been
a director or officer of the Corporation; provided that an Indemnified Party shall not be entitled to indemnification
hereunder to the extent it is determined by any court or governmental body of competent jurisdiction that such Losses
resulted directly from the Indemnified Party's gross negligence, wilful misconduct, or material breach of a material term
of the Articles provided that such right of indemnification shall be reinstated in the event of such determination being
reversed (Losses shall also include all costs and expenses incurred by the Indemnified Party in connection with obtaining
a reversal of such determination).

(c) The right of any Indemnified Party to the indemnification provided herein shall be cumulative of, and in addition to,

any and all rights to which such Indemnified Party may otherwise be entitled by contract or as a matter of law or equity
and shall extend to such Indemnified Party's successors, assigns and legal representatives.

84965

L

U X E M B O U R G

(d) Any Indemnified Party shall first seek to recover under any other indemnity or any insurance policies by which

such Indemnified Party is indemnified or covered, as the case may be, but only to the extent that the indemnitor with
respect to such indemnity or the insurer with respect to such insurance policy provides (or acknowledges its obligation
to provide) such indemnity or coverage, as the case may be, on a timely basis. To the extent an Indemnified Party is
indemnified pursuant to this Article 15 and subsequently recovers an amount in relation to the same matter from such
indemnitor or insurer then such Indemnified Party shall account to the Corporation for the amount so recovered after
deduction of all costs and expenses incurred in procuring recovery and all taxes thereon. The Indemnified Party shall
obtain the written consent of the Manager prior to entering into any compromise or settlement which would result in
an obligation of the Corporation to indemnify such Indemnified Party.

Art. 16. Contribution and Recontribution Obligations.
(a) The Corporation may require Investors to (i) make Contributions, and/or (ii) recontribute to the Corporation

amounts up to the aggregate amount of distributions previously made to them, in order to satisfy indemnification or any
other obligations of the Corporation.

(b) All of the foregoing contribution or recontribution obligations shall continue until the liquidation of the Corpora-

tion. The Corporation may make provision in order to satisfy indemnification or other obligations of the Corporation
after the liquidation of the Corporation.

Art. 17. Share Redemption and Defaulting Investors.
(a) No redemption of Shares may be requested by the Shareholders.
(b) A redemption of Shares at the discretion of the Manager shall in particular be possible:
(i) in respect of the Shares issued in connection with the incorporation of the Corporation;
(ii) for the purpose of temporarily returning to Shareholders a portion of the capital paid in connection with any Share

Offering or Drawdown; and

(iii) for the purpose of distributing proceeds from investments, provided that such distributions qualify as return of

capital rather than payment of dividends.

(c) Shares will generally be redeemed for:
(i) the respective subscription price in relation to redemptions as set out in Article 17(b)(i); and
(ii) the last reported Net Asset Value (according to the term defined thereafter) in relation to redemptions as set out

in Article 17(b)(ii) and (iii).

(d) Redeemed Shares will be cancelled by the Corporation.
(e) If at any time:
(i) any representation made by an Investor to the Corporation in connection with the acquisition of Ordinary Shares

by such Investor is determined by the Manager not to be true and correct in any respect; or

(ii)  an  Investor  does  not  fulfil  its  obligations  towards  the  Corporation  and  in  particular  where  such  Investor  has

committed to subscribe for further Ordinary Shares and fails to honour its commitment to make further Contributions
within the timeframe required,

then the Manager has the authority in the absence of curing of the above defaults within a reasonable time period

determined by the Manager to (A) suspend or terminate the pecuniary rights attached to all or part of the Ordinary
Shares previously subscribed and paid for by the defaulting Investor, or (B) cause the sale and transfer to a new Investor
of the Interest held by the defaulting Investor for a price equal to the Purchase Price as detailed in Article 10, or (C)
reduce the Commitment of the defaulting Investor, or (D) apply any combination of the above or such other measure as
it deems appropriate.

(f) Each Investor expressly acknowledges the strict default provisions in the limited partnership agreement constituting

the Fund and that it has been accepted as an Investor in the Corporation in reliance upon its agreement to the provisions
of these Articles, and that where an Investor fails to fulfil its obligations to the Corporation set out in Article 17(e)(ii)
then the Manager may have no other option than to terminate a defaulting Investor's pecuniary rights in connection with
its Ordinary Shares, in particular if the general partner of the Fund terminates the respective proportionate interest in
the Fund pursuant to the relevant provisions of the limited partnership agreement of the Fund by reason of the Investor's
default.

Art. 18. Net Asset Value of Shares.
(a) The net asset value of Ordinary Shares in the Corporation (the "Net Asset Value") shall be determined on each

Valuation Day (according to the term defined hereafter)in accordance with this Article 18.

(b) The Net Asset Value in accordance with fair valuation methods shall be expressed as a per share figure and shall

be determined by:

(i) first, establishing the value of assets less the liabilities of the Corporation (including any adjustments as considered

by the Corporation to be necessary or prudent);

84966

L

U X E M B O U R G

(ii) second, allocating the portion of assets and liabilities to Ordinary Shares according to the aggregate Contributions

of Ordinary Shares, adjusted as necessary to take into consideration any additional fees or distributions to which Ordinary
Shares may be entitled; and

(iii) finally, dividing the total assets and liabilities allocated to Ordinary Shares by the total number of Ordinary Shares

on the Valuation Day.

(c) The valuation of the Corporation's assets and liabilities shall be determined in accordance with generally accepted

valuation principles in compliance with article 5 (3) of the 2004 Law:

(i) liquid assets shall be valued at their face value with interest accrued;
(ii) investments in target funds shall be valued according to the most recent valuation report received from the general

partners of the target funds adjusted for net capital activity; and

(iii) other investments and other property and assets of the Corporation shall be valued according to the applicable

accounting principles.

(d) Other fair valuation methods may be used if the Manager considers that another method better reflects the value

of the assets if circumstances and market conditions so warrant. The fair valuation methods would then be used accor-
dingly. Valuation methods will be used on a consistent basis.

(e) The Net Asset Value for Ordinary Shares will be made available to Shareholders at the registered office of the

Corporation within a period of time following the relevant Valuation Day.

(f) The determination of the Net Asset Value may be suspended during any period if, in the reasonable opinion of the

Manager, a fair valuation of the assets of the Corporation is not practical for reasons beyond the control of the Corpo-
ration.

Art. 19. Accounting Year and Auditors.
(a) The accounting year of the Corporation shall begin on 1 

st

 January and shall terminate on the 31 

st

 December of

the same year, with the exception of the first accounting year which shall begin on the date of the incorporation of the
Corporation and shall terminate on the 31 

st

 December 2011.

(b) The annual general meeting of Shareholders shall appoint independent auditors.
(c) Accounting of the Corporation shall be based on the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (Lux

GAAP).

Art. 20. Distributions.
(a) Within the limits provided by law and in respect of Ordinary Shares, the annual general meeting of Ordinary

Shareholders shall, upon the proposal of the Manager, determine how the results allocated to Ordinary Shares shall be
distributed in accordance with the provisions of these Articles.

(b) Interim distributions may be paid out on Ordinary Shares upon the decision of the Manager.
(c) The Manager shall apply the following distribution policies:
(i) Distributable proceeds derived from investments will be distributed by the Manager from time to time, provided

that the Manager may retain reasonable amounts to pay or provide reserves for expenses and other obligations of the
Corporation, including fees payable to the Manager or for reinvestment purposes; and

(ii) The Corporation may receive proceeds from the Corporation's investments in the form of marketable securities.

The Manager will seek to sell such securities and distribute the net cash proceeds; Shareholders will bear any associated
market risk and related costs incurred during the disposition process.

(iii) The Manager shall not distribute securities to Shareholders other than at the time of dissolution of the Corporation

or with the approval of a simple majority of the votes cast with respect to Ordinary Shares in issue.

(d) Distributions will be made to the Shareholders in each case in proportion to their Contributions.

Art. 21. Liquidation.
(a) In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed at a Shareholder meeting effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their remuneration.

(b) The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators to Shareholders pursuant to the rules set

forth in Article 20.

(c) The net proceeds may be distributed in kind.

Art. 22. Amendment to Articles. Subject to the prior approval by the Luxembourg supervisory authority, these Articles

may be amended from time to time by Shareholder Resolution taken under the conditions provided in articles 103 (and
the following related articles) and article 67-1 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended,

("1915 Law"). In addition, any proposed amendment to these Articles will become valid and effective only if separately
approved by a simple majority of the Ordinary Shares in issue.

84967

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Governing Regulation. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

1915 Law and the 2004 Law.

Art. 24. Definitions. These definitions form an integral part of the Articles.

Eligible Investors

Pursuant to article 2 of the 2004 Law, either a) professional or institutional investors, b)
other investors who confirm in writing that they adhere to the status of well-informed
investors and are fully aware of the risks and rewards of this type of investment within the
meaning of the 2004 Law and who either invest or are committed to invest a minimum of
125,000 EUR in the Corporation or have been subject to an assessment made by a credit
institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment firm within the
meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of
Directive 2001/107/EC certifying such investor's expertise, experience and knowledge in
adequately appraising an investment in risk capital or c) a person taking part in the mana-
gement of the Corporation.
Any investor that is a U.S. person must be an "accredited investor" as defined in Rule 501
(a) of Regulation D under the Securities Act and a "qualified purchaser" as defined in the
U.S. Investment Company Act.

Entry Charge

A charge which may be levied on an investor admitted to the Corporation subsequent to
the initial share offering.

Interest

An Investor's interest in the Corporation being its rights and obligations in connection with
any Ordinary Shares held and its related Undrawn Commitment.

Investor(s)

The investors who have acquired or have committed to acquire Ordinary Shares in ac-
cordance with the Subscription Agreement. For the avoidance of doubt, any affiliate of the
Manager who has acquired or has committed to acquire Ordinary Shares shall be deemed
an Investor.

Manager Share

A share issued by the Corporation that has been subscribed to by the Manager.

Ordinary Share

A share issued by the Corporation that has been subscribed to by an Investor.

Ordinary Shareholder

The holder of Ordinary Shares.

Shares

The Ordinary Shares and the Manager Shares.

Shareholders

The holders of Ordinary Shares and Manager Shares.

Subscription Agreement The agreement the Corporation entered into with each of the Investors in connection with

the commitment to subscribe for a certain number of Ordinary Shares.

Undrawn Commitment

The total number of Shares that an Investor has committed to acquire in the Subscription
Agreement less the number of Shares subscribed and fully paid by such Investor.

U.S. person

Shall have the meaning ascribed in Regulation S, as amended from time to time, of the
United States Securities Act of 1933, as amended ("the 1933 Act") or as in any other
Regulation or act which shall come into force within the United States of America and
which shall in the future replace Regulation S or the 1933 Act.

Valuation Day

The last day of each month.

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Corporation as a result of its organisation are estimated at approximately

EUR 4,000.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereinafter:

Subscribed

capital

Paid-in amount Number of shares

1) Partners Group Management II S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . EUR 31,000

EUR 31,000

3,100,000

Manager Shares

2) Partners Group Management II S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . .

EUR 0,01

EUR 1,000

1 Ordinary Share

3) Partners Group Finance EUR IC Limited, prenamed . . . . . . . .

EUR 0,01

EUR 1,000

1 Ordinary Share

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,002

EUR 33,000

Evidence of the above payment has been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.

84968

L

U X E M B O U R G

<i>General meeting of shareholders

The above named persons representing the entire subscribed capital and considering themselves as validly convened,

have immediately proceeded to hold a general meeting of shareholders which resolved as follows:

I. The following company is elected as independent auditor:
PricewaterhouseCoopers S.àr.l., Réviseur d'entreprises, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg (RCS Luxembourg B 65477).

The mandate shall lapse on the date of the annual general meeting in 2012.
II. The registered office of the Corporation is fixed at 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above named person, this

deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person, in case of
divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, Christian name,

civil status and residence, said appearing person signed together with us, the notary, this original deed.

Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes

Im Jahr zweitausendundelf, am siebenundzwanzigsten Mai.
Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Partners Group Management II S.à r.l., eine nach den Gesetzen Luxemburgs gegründete Gesellschaft mit Sitz in 55,

avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg, vertreten durch Herrn Sami Nummela, Angestellter, geschäftsansässig in Luxem-
burg, gemäß Vollmacht unter Privatschrift und

2. Partners Group Finance EUR IC Limited, Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, GY1 6BD Guernsey, vertreten

durch Herrn Sami Nummela, vorgenannt, gemäß Vollmacht unter Privatschrift.

Die ne varietur von allen erschienenen Parteien und vom unterzeichneten Notar unterschriebenen Vollmachten bilden

einen Anhang zu diesem Dokument, das bei dem zuständigen Registeramt hinterlegt wird.

Die erschienenen Personen haben für die von ihnen vertretenen Parteien den Notar gebeten, die Satzung einer société

en commandite par actions, die sie gemeinsam begründen, wie folgt festzuhalten (die "Satzung"):

Art. 1. Errichtung. Zwischen den zeichnenden Parteien und all jenen, die Inhaber von später ausgegebenen Aktien

werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer société en commandite par actions mit variablem Kapital, die als Invest-
mentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß Gesetz vom 15. Juni 2004, in seiner geänderten Fassung, (das "Gesetz
von 2004") qualifiziert, und als "Partners Group Secondary 2011 (EUR) S.C.A., SICAR" (die "Gesellschaft") firmiert.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine Dauer bis zum 31. Dezember 2024 errichtet, wobei die Gesellschaft

durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzung gefasst wird, vor diesem Datum auf-
gelöst werden oder um bis zu 3 (drei) zusätzliche Einjahresperioden weitergeführt werden kann.

Art. 3. Zweck.
(a) Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, in den Partners Group Secondary 2011 (EUR), L.P. (nachfolgend der

„Fonds“), der eine Anlage in Risikokapital im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes von 2004 darstellt, zu investieren, um ihren
Aktionären unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken das Ergebnis der Verwaltung der Vermögenswerte zu-
kommen zu lassen.

(b) Die Gesellschaft kann, soweit nach dem Gesetz von 2004 zulässig, alle Maßnahmen und Vorkehrungen treffen, die

sie im Hinblick auf die Zweckerfüllung als nützlich erachtet, vorausgesetzt, dass die anderen Vorschriften dieser Satzung
eingehalten werden.

(c) Neben der Anlage in den Fonds darf die Gesellschaft keine weiteren Anlagetätigkeiten ausüben. Davon ausgenom-

men sind kurzfristige Bankeinlagen sowie kurzfristige Kreditaufnahmen entsprechend Artikel 13 (c).

Art. 4. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Durch

Beschluss des Managers können in Luxemburg Zweigniederlassungen errichtet oder weitere Büros betrieben werden.
Sofern und soweit gesetzlich zulässig, kann der Manager beschließen, den Gesellschaftssitz an einen anderen Ort im
Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.

Art. 5. Aktienkapital.
(a) Das Aktienkapital der Gesellschaft besteht aus nennwertlosen Aktien und entspricht jederzeit dem Nettowert der

Gesellschaft

(b) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird die gesetzlichen Anforderungen an das Mindestkapital erfüllen.

84969

L

U X E M B O U R G

(c) Der Manager kann jedem ordnungsgemäß bevollmächtigten Gesellschaftsorgan oder jeder anderen ordnungsgemäß

bevollmächtigen Person die Pflicht auferlegen, Zeichnungen entgegenzunehmen sowie Zahlungen für ausgegebene Aktien
auszuführen oder zu empfangen.

(d) Das Aktienkapital der Gesellschaft besteht aus den folgenden Aktienklassen:
(i) Stammaktien, die an Gesellschaftsinvestoren zu einem Zeichnungsbetrag von jeweils eintausend EUR (EUR 1,000)

ausgegeben werden; und

(ii) Manager-Aktien, die an den Manager zu einem Zeichnungsbetrag von jeweils einem EUR Cent (EUR 0.01) ausge-

geben werden.

(e) Es werden keine vorrangige Aktienbezugsrechte gewährt.
(f) Der Manager kann die im Zusammenhang mit der Zeichnung von Aktien eingezahlten Beträge ganz oder teilweise

an die Gesellschaftsinvestoren zurückzahlen, wobei diese Beträge zu einem späteren vom Manager bestimmten Zeitpunkt
sowie zu von ihm festgelegten Bedingungen zurückgefordert werden kann.

(g) Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen werden als "Kapitaleinlagen"

bezeichnet.

(h) Der Manager bestimmt die Zeitpunkte, an denen die Gesellschaft Aktienangebote durchführen kann, um zusätzliche

Gesellschaftsinvestoren aufzunehmen (jeweils ein "Aktienangebot"), und kann während eines Zeitraums von achtzehn
Monaten nach dem erstmaligen Aktienangebot weitere Aktienangebote durchführen. Der Manager kann die Aktienan-
gebotsperiode nach eigenem Ermessen um bis zu 12 Monate verlängern.

(i) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei

der Aufnahme von Gesellschaftsinvestoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

(j)  Das  Mindestkapital,  wie  im  Gesetz  von  2004  definiert,  das  innerhalb  von  zwölf  Monaten  ab  Genehmigung  der

Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque nach Luxemburger Recht erreicht sein muss, beträgt EUR
1,000,000.

Art. 6. Der Manager.
(a) Der Komplementär ("associé-gérant-commandité") der Gesellschaft ist Partners Group Management II S.à r.l., eine

Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde (der "Manager").

(b) Der Manager haftet Dritten gegenüber unbeschränkt und solidarisch für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus den

Vermögenswerten der Gesellschaft befriedigt werden können. Der Manager haftet aber nicht mit seinem Vermögen für
die Zahlung von (i) Ausschüttungen an Aktionäre oder (ii) die Rückzahlung von Kapitaleinlagen an Aktionäre.

Art. 7. Haftung der Gesellschaftsinvestoren.
(a) Den Gesellschaftsinvestoren ist es untersagt, für die Gesellschaft in irgendeiner Form zu handeln, außer durch

Ausübung ihrer Rechte anlässlich von Aktionärsversammlungen.

(b) Gesellschaftsinvestoren haften einzig für folgende Zahlungen an die Gesellschaft: (i) Zeichnungsbetrag der Stamm-

aktien sowie "NichtAbgerufene-Zahlungszusagen" (gemäß definiertem Begriff), (ii) Rückzahlung von Ausschüttungen und
(iii), falls anwendbar, eine Eintrittsgebühr (gemäß definiertem Begriff).

Art. 8. Aktienregister.
(a) Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden im Aktienregister (das "Aktienregister") geführt. Das Aktien-

register enthält den Namen jedes Aktionärs, ihren Wohnsitz, Gesellschaftssitz oder Domizil, die Anzahl und Klasse der
gehaltenen Aktien, den für die Aktien einbezahlten Betrag und die Bankverbindung der Aktionäre.

(b) Solange die Gesellschaft keine gegenteiligen Instruktionen bekommen hat, darf sie die aus dem Aktienregister

ersichtlichen Angaben als zutreffend und aktuell betrachten und kann insbesondere die darin enthaltenen Anschriften für
das Versenden von Mitteilungen und Ankündigungen und die Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr benutzen.

(c) Der Manager bestimmt eine Stelle, die für das Führen des Aktienregisters verantwortlich ist.
(d) Die Übertragung von Aktien geschieht durch entsprechende Eintragung der Übertragung im Aktienregister, nach-

dem die Gesellschaft ein vollständiges Übertragungsformular zusammen mit dem Beweis, dass der Erwerber sämtliche
Verpflichtungen in Verbindung mit der Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusage, die mit der betreffenden Beteiligung in Ver-
bindung steht, erfüllt hat und jedwedes andere Dokument, das die Gesellschaft verlangt, erhalten hat.

(e) Gesellschaftsinvestoren können voll eingezahlte Stammaktien an Zulässige Investoren (gemäß definiertem Begriff)

frei übertragen. Ihre NichtAbgerufene-Zahlungszusage (gemäß definiertem Begriff) kann übertragen werden, sofern der
Erwerber (i) nach Einschätzung des Managers kreditwürdig ist und (ii) im Einklang mit den Voraussetzungen des Gesetzes
von 2004 zulässig ist.

Sofern und solange eine bestimmte Beteiligung Teil des "Sicherungsvermögens" (gemäß Definition in §66 des deutschen

Versicherungsaufsichtsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung) eines deutschen Versicherungsunternehmens oder
einer deutschen Pensionskasse oder Teil eines "sonstigen gebundenen Vermögens" (gemäß Definition in §54 Absatz 1
oder §115 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung) sind, dürfen solche Beteiligungen ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung des in Übereinstimmung mit §70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes
in seiner jeweils geltenden Fassung berufenen Treuhänders oder seines befugten Stellvertreters nicht veräußert werden.

84970

L

U X E M B O U R G

Ungeachtet  des  Vorstehenden  sind  jedoch  Beteiligungen,  die  ein  deutsches  Versicherungsunternehmen  oder  eine

deutsche Pensionskasse direkt oder indirekt hält und Teil des Sicherungsvermögens sind, frei übertragbar und eine solche
Übertragung erfordert keine Genehmigung des Managers, vorausgesetzt der Erwerber ist ein Zulässiger Investor und
erfüllt die notwendigen Dokumentationsanforderungen. Mit der Übertragung der Beteiligung, die ein Aktionär, der ein
deutsches Versicherungsunternehmen oder eine deutsche Pensionskasse ist, direkt oder indirekt hält, muss der Erwerber
alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen hinsichtlich solcher Beteiligungen akzeptieren und dafür allein verantwortlich
zeichnen und der Veräußerer soll von den Verbindlichkeiten hinsichtlich der Gesellschaft befreit werden und keine solchen
mehr haben.

(f) Aktienbruchteile können bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben werden.
(g) Die Aktien werden nur als Namensaktien ausgegeben.
(h) Die Aktien sind in elektronisch verbuchungsfähiger Form erhältlich. Es werden keine Zertifikate ausgegeben.

Art. 9. Zahlungszusage.
(a) Gesellschaftsinvestoren verpflichten sich, Stammaktien zu dem im Zeichnungsvertrag festgelegten Betrag zu zeich-

nen (jeweils eine "Zahlungszusage").

(b) Die Zahlungszusage eines Gesellschaftsinvestors an die Gesellschaft beträgt mindestens 5 Millionen EUR (EUR

5,000,000) wobei sich der Manager das Recht vorbehält, Gesellschaftsinvestoren mit geringeren Zahlungszusagen zuzu-
lassen.

(c) Die von einem Gesellschaftsinvestor gegebene Zahlungszusage ist in Raten zahlbar, indem zusätzliche Aktien der

Gesellschaft zu zeichnen sind. Der Manager versendet vor jeder Kapitaleinlage eine Abrufmitteilung an die Gesellschafts-
investoren mit dem Hinweis auf den für die Einlage an die Gesellschaft erforderlichen Teil ihrer Zahlungszusage und auf
die entsprechende Zahl der auszugebenden Aktien. Darauf ist der Geldbetrag in EUR innerhalb von zehn (10) Kalender-
tagen bar einzuzahlen und die entsprechende Zahl Aktien wird den Gesellschaftsinvestoren anteilig zugeteilt (jeder dieser
Abrufvorgänge wird als "Kapitalabruf" bezeichnet).

(d) Kapitalabrufe werden nach Maßgabe des Mittelbedarfs für die Anlagen der Gesellschaft und die Deckung der lau-

fenden Ausgaben im Verhältnis zu den Zahlungszusagen jedes Gesellschaftsinvestors getätigt.

Art. 10. Zulässiger Investor.
(a) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager kann in eigenem Ermessen den Erwerb und den Besitz von

Aktien durch irgendeine Person, Firma oder Körperschaft einschränken oder untersagen.

(b) Nur "Zulässigen Investoren" (gemäß definiertem Begriff) ist es erlaubt, eine Beteiligung an der Gesellschaft zu halten.
(c)  Der  Manager  kann  in  eigenem  Ermessen  die  Annahme  von  Anträgen  zur  Zeichnung  einer  Beteiligung  solange

aufschieben, bis ausreichend dokumentiert worden ist, dass der Antragsteller die Voraussetzungen eines Zulässigen In-
vestors erfüllt.

(d) Soweit die Gesellschaft feststellt, dass ein Gesellschaftsinvestor kein Zulässiger Investor ist oder gegen seine Zu-

sicherungen und Gewährleistungen verstößt oder die vom Manager verlangten Zusicherungen und Gewährleistungen
nicht abgeben kann, kann der Manager von einem solchen Gesellschaftsinvestor verlangen, alle oder einen Teil seiner
Beteiligung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu veräußern:

(i) Die Gesellschaft stellt dem Gesellschaftsinvestor eine Anzeige zu (die "Kaufanzeige"), auf der angegeben ist, welche

Beteiligung wie oben erwähnt zu erwerben ist, welcher Preis für diese Beteiligung zu bezahlen ist (der "Kaufpreis") und
an welchem Ort der Kaufpreis für die betreffende Beteiligung zu entrichten ist. Jede solche Anzeige kann dem jeweiligen
Gesellschaftsinvestor per Post in einem für ein Einschreiben frankierten Umschlag an dessen zuletzt bekannte oder im
Aktienregister eingetragene Adresse zugestellt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufanzeige
angegebenen Tag verliert der betreffende Gesellschaftsinvestor die Aktionärsstellung in Bezug auf die in der jeweiligen
Anzeige angegebene Beteiligung und sein Name wird entsprechend aus dem Aktienregister gelöscht;

(ii) Der Kaufpreis der Beteiligung beträgt 75% des Marktwerts der Beteiligung des Gesellschaftsinvestors, der vom

Manager nach Einholung eines oder mehrer Preisangebot(e) im Markt bestimmt wird;

(iii) Der Kaufpreis wird dem Eigentümer der Beteiligung entrichtet, außer in Zeiten von Devisenbeschränkungen, und

wird durch die Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder sonstwo (gemäß Angabe in der Kaufanzeige) zwecks
Zahlung an den Gesellschaftsinvestor hinterlegt. Nach der zuvor beschriebenen Hinterlegung des Kaufpreises hat die in
der Kaufanzeige aufgeführte Person keinerlei weitere Rechte an der Gesellschaft und diesbezüglich keinerlei Anspruch
gegenüber der Gesellschaft oder deren Vermögen, mit Ausnahme des Rechts, von dieser Bank den bei ihr hinterlegten
Betrag (ohne Verzinsung) zu erhalten.

(e) Die Ausübung der der Gesellschaft aufgrund dieses Artikels 10 erteilten Befugnisse kann keinesfalls dadurch in

Frage gestellt oder ungültig erklärt werden, dass der Nachweis über den Aktienbesitz durch irgendeine Person unzurei-
chend gewesen sei oder dass der tatsächliche Aktienbesitz von den der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufanzeige
bekannten Tatsachen abgewichen sei, vorausgesetzt dass die Gesellschaft die genannten Befugnisse in einem solchen Fall
in gutem Glauben ausgeübt hat.

(f) Neben der Haftung nach anwendbarem Recht, hat jeder Gesellschaftsinvestor, der eine Beteiligung hält, ohne die

Voraussetzungen eines Zulässigen Investors zu erfüllen, die Gesellschaft, den Manager, die übrigen Gesellschaftsinvestoren

84971

L

U X E M B O U R G

und Aktionäre und die Beauftragten der Gesellschaft schadlos zu halten und für alle Schäden, Verluste und Aufwände zu
entschädigen, die sich aus einem solchen Halten einer Beteiligung ergeben oder damit zusammenhängen, insofern der
betreffende Gesellschaftsinvestor irreführende oder unwahre Dokumentationsunterlagen eingereicht oder irreführende
oder unwahre Zusicherungen abgegeben hat, um unrechtmäßig den Status als Zulässiger Investor zu erlangen, oder es
versäumt hat, die Gesellschaft über den Verlust dieses Status zu benachrichtigen.

Art. 11. Jahreshauptversammlung.
(a) Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht jeweils am letzten

Freitag des Monats Juni um 4:15 Uhr (Luxemburger Zeit) in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen
in der Einladung zur Versammlung angegebenen Ort in Luxemburg durchgeführt, und zwar erstmals zweitausendzwölf.
Sofern dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, wird die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am vorangeh-
enden Bankarbeitstag abgehalten.

(b) Andere Aktionärsversammlungen können an den Orten und zu den Zeitpunkten, wie in der entsprechenden Ein-

ladung aufgeführt, abgehalten werden.

Art. 12. Aktionärsversammlungen.
(a) Alle Aktionärsversammlungen werden vom Manager geleitet.
(b) Jede ordnungsgemäß einberufene Aktionärsversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Der Aktionärs-

versammlung  kommt  die  umfassendste  Befugnis  zu,  im  Zusammenhang  mit  der  Geschäftstätigkeit  der  Gesellschaft
Anweisungen zu erteilen und Handlungen auszuführen oder zu ratifizieren.

(c) Ein Aktionär kann an jeder Aktionärsversammlung handeln, indem er:
(i) eine andere Person schriftlich zu seinem Bevollmächtigten bestellt oder
(ii) dem Manager eine schriftliche Bescheinigung zukommen lässt, welche die Weisung enthält, wie er sich entschieden

hat, bezüglich der verschiedenen Tagesordnungspunkte abzustimmen, sofern die schriftlichen Abstimmungsbescheini-
gungen, (1) den Nachnamen, Vornamen, die Adresse und Unterschrift des betreffenden Aktionärs, (2) die Angabe der
Aktien für die der Aktionär sein Stimmrecht ausübt, (3) die in der Einberufungsmitteilung aufgeführte Tagesordnung und
(4) die Abstimmungsweisung (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) für jeden Tagesordnungspunkt enthält. Die Originale
der Abstimmungsbescheinigungen müssen von der Gesellschaft 24 Stunden vor der betreffenden Aktionärsversammlung
empfangen werden.

(d) Bei jeder Aktionärsversammlung kommt jeder Manager-Aktie und jeder Stammaktie eine Stimme zu.
(e) Soweit durch das Gesetz oder die Satzung nicht anders bestimmt, stimmen alle Aktien als Aktien einer Klasse.
(f) Soweit durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht anders bestimmt, benötigen die an einer Aktionärsver-

sammlung gefassten Beschlüsse (ein "Aktionärsbeschluss") die Zustimmung:

(i) einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Aktionären abgegebenen Stimmen und
(ii) des Managers.
(g) Jeder in einer Aktionärsversammlung gefasste Beschluss, der entscheidet, dass die Gesellschaft nicht länger als

Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital gemäß Gesetz von 2004 qualifiziert, muss einstimmig von allen Aktio-
nären und vom Manager gefasst werden und erfordert die vorherige Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbe-
hörde.

(h) Soweit Investoren des Fonds aufgefordert oder ermächtigt werden, sich an einer Abstimmung zu beteiligen, soll

diese Angelegenheit auch den Aktionären zur Genehmigung unterbreitet werden. Die Zustimmung der Gesellschaft er-
fordert eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(i) Wie nach Luxemburger Recht vorgeschrieben, muss jede Aktionärsversammlung durch den Manager mindestens 8

Tage im Voraus angekündigt werden.

(j) Der Manager ist befugt, alle anderen Voraussetzungen zu bestimmen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an einer Aktionärsversammlung teilzunehmen.

(k) Abgegebene Stimmen, wie in dieser Satzung verwendet, beinhalten keine Stimmen betreffend Aktien, für die ein

Aktionär nicht an der Abstimmung teilgenommen oder sich enthalten oder eine inhaltslose oder ungültige Stimme abge-
geben hat.

Art. 13. Befugnisse des Managers.
(a) Dem Manager kommt die weitestreichende Befugnis zu, alle Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung

und Geschäftsführung der Gesellschaft vorzunehmen und Transaktionen zu prüfen, durchzuführen und zu vollenden. Alle
Befugnisse, die nicht durch Gesetz oder Satzung der Jahreshauptversammlung vorbehalten sind, stehen dem Manager zu.

(b) Der Manager bestimmt die Anlagepolitik und die Fremdkapitalpolitik der Gesellschaft, im Rahmen der durch (i) das

luxemburgische Recht, (ii) die Aufsichtsbehörden und (iii) diese Satzung gesetzten Grenzen.

(c) Der Manager darf im Namen der Gesellschaft Kredite aufnehmen. Der Manager darf nur zu vorübergehender

Liquiditätsbeschaffung (d.h. bis zu sechs Monate), und zu marktüblichen Konditionen Kredite aufnehmen. Die maximale
Kreditaufnahme im Namen der Gesellschaft darf 10% der gesamten gegenüber der Gesellschaft getätigten Kapitalzusagen
nicht übersteigen.

84972

L

U X E M B O U R G

(d) Der Manager kann Investmentberater und Investmentmanager bestimmen sowie auch Beauftragte für jegliche Ma-

nagement-und  Administrationsaufgaben  bestellen.  Der  Manager  ist  befugt,  mit  solchen  Personen  oder  Unternehmen
Verträge abzuschließen betreffend die Erbringung von Dienstleistungen, die Übertragung von Befugnissen und die Fest-
setzung der durch die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu tragenden Vergütung.

Art. 14. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung. Die Gesellschaft wird durch die Doppelunterschrift von ordnungsgemäß

bevollmächtigten Direktoren oder leitenden Angestellten des Managers rechtlich verpflichtet, oder durch Unterschrift
von jeglichen anderen Personen auf die der Manager die Bevollmächtigung übertragen hat.

Art. 15. Rechtfertigung &amp; Entschädigung.
(a) Keine "Entschädigungsberechtigte Person" (gemäß untenstehender Definition) ist der Gesellschaft oder den Ge-

sellschaftsinvestoren gegenüber verantwortlich für von ihr vorgenommene oder erlittene Handlungen oder Unterlas-
sungen im begründeten Glauben, dass eine solche Handlung oder Unterlassung im besten Interesse der Gesellschaft ist
oder dem nicht zuwiderläuft und im Rahmen der dieser Entschädigungsberechtigten Person erteilten Bevollmächtigung
liegt, vorausgesetzt dass solche Handlungen oder Unterlassungen keine grobfahrlässige oder materielle Verletzung der
Pflichten der Entschädigungsberechtigten Person gegenüber der Gesellschaft darstellen.

(b) Soweit rechtlich zulässig werden der Manager oder seine mit ihm verbundenen Gesellschaften und alle deren

jeweiligen Angestellten, Handlungsbevollmächtigten, Direktoren, Beauftragte, Kontrollpersonen oder Vertreter (jeder
eine "Entschädigungsberechtigte Person") von der Gesellschaft entschädigt oder schadlos gehalten im Zusammenhang mit
allen Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten und Auslagen jeder Art (einschließlich der Beträge, die
bezahlt werden zur Begleichung von Gerichtsurteilen, oder in Kompromissen und Vergleichen, als Geldbußen und strafen
sowie  rechtliche  oder  andere  Kosten  und  Auslagen  für  die  Ermittlung  oder  die  Abwehr  gegen  jegliche  Klagen  oder
angebliche Forderungen) egal welcher Natur, bekannt oder unbekannt, beziffert oder unbeziffert (zusammen "Verluste"),
die bei einer Entschädigungsberechtigten Person angefallen sind und aus den Angelegenheiten oder Aktivitäten der Ge-
sellschaft entstanden oder damit in Beziehung stehen, einschließlich der Tätigkeit als Direktor einer Zielgesellschaft, oder
der Ausübung von Pflichten hierunter oder sonstwie im Zusammenhang mit einer aktuellen oder vergangenen Tätigkeit
als Direktor oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft; vorausgesetzt dass eine Entschädigungsberechtigte Person
nicht zu einer Entschädigung hierunter berechtigt ist, sofern ein zuständiges Gericht oder eine zuständige staatliche Be-
hörde feststellt, dass sich solche Verluste direkt aus dem grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Fehlverhalten oder einer
Verletzung einer materiellen Bestimmung der Satzung durch die Entschädigungsberechtigte Person ergeben, jedoch lebt
das Recht auf Entschädigung im Falle der Aufhebung einer solchen gerichtlichen oder behördlichen Feststellung (Verluste
im hier verstandenen Sinne sollen auch alle bei der Entschädigungsberechtigten Person im Zusammenhang mit dem Er-
langen der Aufhebung einer solchen Feststellung angefallenen Kosten und Auslagen einschließen) wieder auf.

(c) Das Recht der Entschädigungsberechtigten Person auf eine Entschädigung nach dieser Bestimmung ist kumulativ im

Verhältnis zu und zusätzlich zu jeglichen Rechten, die ihr sonstwie vertraglich oder von Rechts wegen zustehen und
erstreckt sich auf die Erben, Rechtsnachfolger und Rechtsvertreter der Entschädigungsberechtigten Person.

(d) Eine Entschädigungsberechtigte Person ist gehalten, zuerst zu versuchen, eine Entschädigungsleistung aus irgend-

einer anderen Haftungsvereinbarung oder Versicherungspolice, nach der die Entschädigungsberechtigte Person entschä-
digt beziehungsweise versichert ist, zu erlangen. Dies gilt jedoch nur soweit die entschädigungspflichtige Person in Bezug
auf die Haftungsvereinbarung oder die Versicherungsgesellschaft in Bezug auf die Versicherungspolice eine solche Ent-
schädigung oder Versicherungsleistung rechtzeitig leistet (oder ihre entsprechende Verpflichtung anerkennt). Im Falle
dass eine Entschädigungsberechtigte Person gemäß diesem Artikel 15 entschädigt worden ist und daraufhin in Bezug auf
denselben Gegenstand von einer solchen entschädigungspflichtigen Person beziehungsweise Versicherungsgesellschaft
eine Entschädigungsleistung bezieht, ist sie verpflichtet, den so bezogenen Betrag zwecks Verrechnung der Gesellschaft
zu überweisen nach Abzug aller bei der Beschaffung der Rückerstattung angefallenen Kosten und Auslagen sowie aller
darauf erhobenen Steuern. Bevor die Entschädigungsberechtigte Person in einen Kompromiss oder einen Vergleich ein-
willigt, der für die Gesellschaft eine Entschädigungspflicht gegenüber der Entschädigungsberechtigten Person zur Folge
hat, muss sie beim Manager jeweils eine schriftliche Genehmigung einholen.

Art. 16. Einlage-und Rückeinlagepflichten.
(a) Um Entschädigungs-oder andere Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können, kann die Gesellschaft Gesellschafts-

investoren verpflichten, (i) Kapitaleinlagen zu leisten, und/oder (ii) Rückeinlagen in Höhe der bisher an diese entrichteten
Ausschüttungen zu leisten.

(b) Die obengenannten Einlage-und Rückeinlagepflichten bleiben bis zur Liquidation der Gesellschaft bestehen. Die

Gesellschaft kann Vorkehrungen treffen, um nach der Liquidation der Gesellschaft Entschädigungs-oder andere Pflichten
der Gesellschaft erfüllen zu können.

Art. 17. Rücknahme von Aktien und Vertragsbrüchige Gesellschaftsinvestoren.
(a) Aktionäre können keine Rücknahme von Aktien beantragen.
(b) Eine Rücknahme von Aktien im Ermessen des Managers ist insbesondere in den folgenden Fällen möglich:
(i) in Bezug auf Aktien, die im Zuge der Gründung der Gesellschaft ausgegeben werden;

84973

L

U X E M B O U R G

(ii) zum Zweck der zeitweiligen Rückgabe an die Aktionäre von Beträgen, die im Zusammenhang Aktienangeboten

oder Kapitalabrufen eingezahlt werden; und

(iii) zum Zweck der Ausschüttung von Investitionserlösen, vorausgesetzt solche Ausschüttungen stellen Kapitalrück-

zahlungen und nicht Dividenden dar.

(c) Die Rücknahme von Aktien erfolgt grundsätzlich zu dem:
(i) Zeichnungsbetrag in Bezug auf Rücknahmen gemäss Artikel 17(b)(i); und
(ii) letztausgewiesenen Nettoinventarwert in Bezug auf Rücknahmen gemäss Artikel 17(b)(ii) und Artikel 17(b)(iii).
(d) Zurückgenommene Aktien werden von der Gesellschaft annulliert.
(e) Falls zu irgendeiner Zeit:
(i) eine von einem Gesellschaftsinvestor gegenüber der Gesellschaft abgegebene Zusicherung in Bezug auf den Erwerb

von Stammaktien durch diesen vom Manager in irgendeiner Weise als unwahr oder unrichtig befunden wird; oder

(ii) ein Gesellschaftsinvestor seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt und er insbesondere zugesagt hat,

weitere Stammaktien zu zeichnen und dieser Zusage, innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens weitere Kapitaleinlagen
zu leisten, nicht nachkommt,

ist der Manager befugt, sofern die oben aufgeführten Verstöße nicht innerhalb einer vom Manager zu bestimmenden

angemessenen Frist geheilt wurden, (A) die mit einem Teil oder allen vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang
gezeichneten und einbezahlten Stammaktien verknüpften Vermögensrechte zeitweilig aufzuschieben oder zu beenden,
oder (B) den Verkauf und die Übertragung der vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor gehaltenen Beteiligung auf
einen neuen Investor zu veranlassen, zu einem Betrag, der dem in Artikel 10 beschriebenen Kaufpreis entspricht oder
(C) die Zahlungszusage des vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestors zu reduzieren oder (D) die vorgenannten Möglich-
keiten zu kombinieren oder solch andere Maßnahmen zu ergreifen, die er für angemessen hält.

(f) Jeder Gesellschaftsinvestor erkennt ausdrücklich die strengen Folgen eines Vertragsbruchs an, die das den Fonds

errichtende "Limited Partnership Agreement" vorsieht, dass er im Vertrauen auf sein Einverständnis mit dieser Satzung
als Gesellschaftsinvestor angenommen wurde und dass für den Fall, dass ein Gesellschaftsinvestor seinen Pflichten aus
Artikel 17(e)(ii) nicht nachkommt, der Manager keine andere Wahl haben könnte als die Vermögensrechte in Bezug auf
seine  Stammaktien  zu  beenden,  insbesondere  wenn  aufgrund  des  Verstoßes  des  Gesellschaftsinvestors  der  "General
Partner" des Fonds die betroffene anteilige Beteiligung am Fonds gemäß den einschlägigen Bestimmungen des "Limited
Partnership Agreements" des Fonds beendet.

Art. 18. Nettoinventarwert der Aktien.
(a) Der Nettoinventarwert einer Stammaktiender Gesellschaft (der "Nettoinventarwert") wird an jedem Bewertungs-

tag (gemäß definiertem Begriff) in Übereinstimmung mit diesem Artikel 18 bestimmt.

(b) Der Nettoinventarwert wird als Betrag pro Aktie angegeben und in Übereinstimmung mit „Fair Valuation“ Me-

thoden folgendermaßen ermittelt, indem:

(i) zuerst der Wert der Aktiva abzüglich Passiva der Gesellschaft bestimmt wird (unter Berücksichtigung von Anpas-

sungen, die die Gesellschaft als notwendig oder sinnvoll erachtet);

(ii) zweitens der den Stammaktien zuzuordnende Anteil an Aktiva und Passiva im Verhältnis zu den geleisteten Kapi-

taleinlagen  festgestellt  wird.  Nötigenfalls  sind  hierzu  Anpassungen  vorzunehmen,  um  zusätzliche  Vergütungen  und
Ausschüttungen, die im Zusammenhang mit den Stammaktien stehen, zu berücksichtigen; und

(iii) schließlich die gesamten den Stammaktien zugeordneten Aktiva und Passiva durch die Anzahl aller Stammaktien

am jeweiligen Bewertungstag geteilt werden.

(c) Die Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Be-

wertungsgrundsätzen und unter Einhaltung von Artikel 5 (3) des Gesetzes von 2004 vorgenommen:

(i) flüssige Vermögenswerte werden zu deren Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;
(ii) Investments in Zielfonds werden gemäß aktuellem Bewertungsbericht des General Partners des Zielfonds bewertet

unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Nettokapitalveränderungen; und

(iii) andere Investments und andere Vermögen und Vermögenswerte der Gesellschaft werden in Übereinstimmung

mit den anwendbaren Grundsätzen bewertet.

(d) Falls der Manager der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Wert der Vermögenswerte ange-

messener wiedergibt, können auch andere geeignete Bewertungsmethoden angewendet werden, falls die Umstände und
Marktverhältnisse dies erfordern. Solche geeigneten Bewertungsmethoden müssen dann kohärent angewendet werden.
Bewertungsmethoden werden auf konstanter Basis angewendet.

(e) Der Nettoinventarwert der Stammaktien wird den Aktionären nach dem betreffenden Bewertungstag innerhalb

einer gewissen Zeitspanne am Sitz der Gesellschaft zugänglich gemacht.

(f) Die Ermittlung des Nettoinventarwertes kann jederzeit vorübergehend aufgehoben werden, sofern nach angemes-

sener Ansicht des Managers eine faire Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft aus Gründen, die außerhalb des
Einflussbereiches der Gesellschaft liegen, nicht durchführbar ist.

84974

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Rechnungslegungsjahr und Rechnungs-prüfer.
(a) Das Rechnungslegungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres, mit

Ausnahme des Rechnungslegungsjahrs das am Zeitpunkt der Gesellschaftsgründung beginnt und am 31. Dezember 2011
endet.

(b) Die Jahreshauptversammlung bestimmt einen unabhängigen Rechnungsprüfer.
(c)  Die  Buchhaltung  der  Gesellschaft  richtet  sich  nach  den  „Luxembourg  Generally  Accepted  Accounting

Principles“ (Lux GAAP).

Art. 20. Ausschüttungen.
(a) Auf Vorschlag des Managers legt die Jahreshauptversammlung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und in Bezug

auf die Stammaktien fest, wie das den Stammaktien zugeordnete Ergebnis gemäß den Bestimmungen der Satzung ausge-
schüttet wird.

(b) Interimsausschüttungen können für Stammaktien auf Entscheid des Managers vorgenommen werden.
(c) Der Manager beachtet die folgenden Ausschüttungsgrundsätze:
(i) Verteilbare Erträge, die aus Anlagen stammen, werden vom Manager von Zeit zu Zeit ausgeschüttet. Der Manager

kann jedoch angemessene Beträge zurückhalten, die benötigt werden, um Ausgaben und andere Verpflichtungen der
Gesellschaft zu begleichen beziehungsweise um Rücklagen für deren Zahlung zu bilden, einschließlich der Bezahlung von
Managerbezügen oder für Reinvestitionen; und

(ii) Es besteht die Möglichkeit, dass die Gesellschaft von den Anlagen der Gesellschaft Erträge in Form von marktgän-

gigen  Wertpapieren  erhält.  Der  Manager  wird  bemüht  sein,  solche  Wertpapiere  zu  verkaufen  und  den  Nettoerlös
auszuschütten. Die Gesellschaftsinvestoren tragen alle damit verbundenen Marktrisiken und Kosten, die während des
Veräußerungsvorganges entstehen.

(iii) Es werden keine Wertpapiere an die Aktionäre ausgeschüttet. Ausgenommen davon sind Ausschüttungen von

Wertpapieren anlässlich der Liquidation der Gesellschaft oder falls dem eine einfache Mehrheit der in Bezug auf Stamm-
aktien abgegebenen Stimmen zugestimmt hat.

(d) Ausschüttungen an die Aktionäre werden in jedem Fall im Verhältnis ihrer Kapitaleinlage vorgenommen.

Art. 21. Liquidation.
(a) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird eine Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die entweder

natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Liquidatoren sowie deren Befugnisse und Entschä-
digung werden anlässlich der Aktionärsversammlung, an der die Auflösung der Gesellschaft beschlossen wird, eingesetzt.

(b) Die Nettoerlöse aus der Liquidation werden durch die Liquidatoren an die Aktionäre gemäß den in Artikel 20

aufgeführten Regeln ausgeschüttet.

(c) Die Nettoerlöse können in Form von Sachleistungen ausgeschüttet werden.

Art. 22. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde,

kann die Satzung von Zeit zu Zeit durch gemäβ den Bestimmungen des Artikels 103 (und den entsprechenden nachfol-
genden  Artikeln)  sowie  Artikel  67-1  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  zu  fassenden  Aktionärsbeschluss  geändert
werden. Des Weiteren wird jede vorgeschlagene Änderung dieser Satzung erst gültig und wirksam, wenn sie gesondert
von der einfachen Mehrheit der ausgegebenen Stammaktien genehmigt wird.

Art. 23. Anwendbares Recht. Sachverhalte, die durch die Satzung nicht geregelt sind, sind in Übereinstimmung mit dem

Gesetz von 1915 sowie das Gesetz von 2004 festzulegen.

Art. 24. Definitionen. Die folgenden Definitionen bilden einen integralen Bestandteil der Satzung.

Aktien

Die Stammaktien und die Manager-Aktien.

Aktionäre

Die Inhaber von Stammaktien und Manager-Aktien.

Beteiligung

Die Beteiligung eines Gesellschaftsinvestors an der Gesellschaft, die seine Rechte und
Pflichten in Verbindung mit den von ihm gehaltenen Stammaktien und seiner damit in Zu-
sammenhang stehenden NichtAbgerufene-Zahlungszusage beinhaltet.

Bewertungstag

Der letzte Tag jedes Monats.

Gesellschaftsinvestor(en) Personen, die aufgrund des Zeichnungsvertrags Stammaktien erworben beziehungsweise

sich zum Erwerb von Stammaktien verpflichtet haben. Mit dem Manager verbundene Ge-
sellschaften, die Stammaktien erworben oder sich zu deren Erwerb verpflichtet haben,
gelten als Gesellschaftsinvestoren.

Eintrittsgebühr

Eine Gebühr, die bei einem Investor erhoben werden kann, der von der Gesellschaft nach
der erstmaligen Ausgabe von Aktien zugelassen wird.

Manager-Aktie

Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben und vom Manager gezeichnet worden ist.

Nicht-Abgerufene-

Zahlungszusage

Die gesamte Anzahl der Aktien, deren Erwerb ein Gesellschaftsinvestor im Rahmen des
Zeichnungsvertrages zugesagt hat, abzüglich der Anzahl der Aktien, die dieser Gesell-
schaftsinvestor bereits gezeichnet und vollständig eingezahlt hat.

84975

L

U X E M B O U R G

Stammaktien

Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben und von einem Gesellschaftsinvestor ge-
zeichnet worden ist.

U.S. Person

Die Bedeutung des Begriffes "U.S. person" ist die, welche in "Regulation S", gemäß revi-
dierter Fassung, des "United States Securities Act of 1933", gemäß revidierter Fassung (der
"1933 Act") definiert ist, oder in einer anderen Gesetzgebung welche in den Vereinigten
Staaten von Amerika anwendbar wird und welche in der Zukunft "Regulation S" oder den
"1933 Act" ersetzen wird, definiert ist.

Zeichnungsvertrag

Der Vertrag, den die Gesellschaft mit jedem einzelnen Gesellschaftsinvestor in Verbindung
mit der Zusage der Zeichnung einer bestimmten Anzahl an Stammaktien geschlossen hat.

Zulässiger Investor

Gemäß Artikel 2 des Gesetzes von 2004 entweder a) ein professioneller oder institution-
eller Investor, b) andere Investoren, die schriftlich bestätigen, dass sie den Status eines
sachkundigen Anlegers erfüllen und sich der Risiken und Renditen einer solchen Anlage
gemäß dem Gesetz von 2004 vollständig bewusst sind und entweder mindestens 125.000
EUR in die Gesellschaft investieren oder sich verpflichtet haben zu investieren oder einer
Untersuchung durch ein Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, durch eine
Wertpapierfirma im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder durch eine Verwaltungsgesell-
schaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG unterzogen wurden, die dem Investor genügend
Sachverstand, Erfahrung und Wissen, um eine Anlage in Risikokapital abschätzen zu können,
bescheinigt oder c) eine Person, die bei der Geschäftsleitung der Gesellschaft mitwirkt.
Investoren, die jeweils als "U.S. person" gelten, müssen "accredited investors" gemäß Rule
501(a) der Regulation D im Securities Act und "qualified purchasers" gemäß U.S. Investment
Company Act sein.

<i>Kosten

Die Kosten welche von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Gründung zu tragen sind, belaufen sich auf circa 4,000 EUR.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichner haben die folgende Anzahl an Aktien gezeichnet und die folgenden Beträge eingezahlt:

Gezeichnetes

Kapital

Eingezahlter

Betrag

Anzahl der

Aktien

1) Partners Group Management II, S.à r.l., vorgenannt . . . . . . . . . . .

31,000 EUR 31,000 EUR

3,100,000

Manager-Aktien

2) Partners Group Management II, S.à r.l., vorgenannt . . . . . . . . . . .

0,01 EUR

1,000 EUR

1 Stammaktie

3) Partners Group Finance EUR IC Limited, vorgenannt . . . . . . . . . .

0,01 EUR

1,000 EUR

1 Stammaktie

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,002 EUR 33,000 EUR

Der Nachweis der Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Gründungsversammlung der Aktionäre

Die oben genannten Personen, stellvertretend für das gesamte gezeichnete Kapital und sich als gültig versammelt

erachtend, sind umgehend dazu übergegangen, eine Aktionärsversammlung abzuhalten.

I. Zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer ist ernannt:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, RCS Luxem-

bourg B 65477.

Das Mandat endet am Tag der Jahreshauptversammlung in 2012.
II. Der Gesellschaftssitz wird auf 55, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, festgelegt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben erschienenen

Person die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Wunsch
derselben erschienenen Person soll, im Falle eines Abweichens des englischen und deutschen Textes, die englische Version
maßgebend sein.

Worüber vorliegende Urkunde, in Luxemburg an dem zu Beginn dieses Dokumentes aufgeführten Tag, ausgestellt

wurde.

Die Urkunde wurde der erschienenen Person vorgelesen, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und

Wohnort bekannt ist, die erschienene Person unterzeichnete zusammen mit uns, dem Notar, die vorliegende Original-
Urkunde.

Gezeichnet: S. NUMMELA und H. HELLINCKX.

84976

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 juin 2011. Relation: LAC/2011/25941. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 8. Juni 2011.

Référence de publication: 2011079459/845.
(110088411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Parquet Böhm S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6871 Wecker, 10, Op Huefdreisch.

R.C.S. Luxembourg B 30.074.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dillingen, le 07.06.2011.

<i>Pour Parquet Böhm S.à.r.l.
STLU Steuerberatungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 40 - 66763 Dillingen
Signature

Référence de publication: 2011079114/14.
(110087443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie (ECGS), Fondation.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 24, rue Münster.

R.C.S. Luxembourg G 113.

<i>Annexe: Comptes annuels au 31.12.2008

<i>Attestation

J'ai été chargé de la revision des comptes du "CENTRE EUROPEEN DE GEODYNAMIQUE ET DE SEISMOLOGIE

(ECGS)" à Luxembourg, établissement d’utilité publique.

Pour ce faire j'ai examiné les comptes établis pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2008 avec un bénéfice de

12.119,45 EUROS.

J'ai procédé aux sondages et vérifications appropriés aux circonstances données et j'ai pris connaissance des informa-

tions et données nécessaires à l'accomplissement de ma mission.

J'ai constaté que les comptes annuels en question sont en concordance avec la comptabilité et les pièces comptables

qui m'ont été soumises.

L'analyse des dépenses me permet d'attester que les subventions reçues tant du Conseil de l'Europe que du Gouver-

nement Luxembourgeois ont été utilisées conformément à leur destination.

Luxembourg, le 20 avril 2009.

Gerhard Nellinger.

<i>Balance Générale au 31.12.2008

Période(s): 0/2008-13/2008; Solde: Tout; Monnaie locale: EUR; Compte(s): 0-6;

Y-T-D (1 /2008 - 13/2008)

Compte

Description

Ouverture

Débit

Crédit

Solde

1021

Valeur du patrimoine de départ  . . . . . . . . .

50.811,43

-50.811,43

1101

Résultats reportés (solde créditeur)  . . . . . .

-98.969,13

-98.969,13

1941

Programmes d'éducation . . . . . . . . . . . . . . .

-20.000,00

20.000,00

1944

Report Salaires (budget)  . . . . . . . . . . . . . . .

-32.000,00

32.000,00

1945

Provision Borahole-Gravimétre . . . . . . . . . .

-10.000,00

10.000,00

-8.500,00

-8.500,00

1946

Provision Frais Laboratoire  . . . . . . . . . . . . .

-15.000,00

15.000,00

1947

Provision J.L.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10.000,00 -10.000,00

1948

Provision Etudes Séismologiques . . . . . . . . .

-10.000,00 -10.000,00

40000000 Cpte Centralisateur Fournisseur . . . . . . . . .

-6.650,50

160.534,03

-157.295,56

-3.412,03

41000000 Cpte Centralisateur Client  . . . . . . . . . . . . .

5.215,00

-5.215,00

42100

Salaire Galassi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.103,57

-17.103,57

42101

Salaire Paganelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.627,31

-18.627,31

84977

L

U X E M B O U R G

42102

Salaire Oth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.905,75

-48.905,75

43100

Sécurité Sociale - CCSS . . . . . . . . . . . . . . . .

-3.225,55

28.094,76

-28.601,07

-3.731,86

44011

Ministère - Subventions . . . . . . . . . . . . . . . .

22.000,00

220.000,00

-220.000,00

22.000,00

44022

APO - Autres subventions  . . . . . . . . . . . . .

19.000,00

-17.600,00

1.400,00

44032

Commune de Walferdange - Autres subv.

850,00

-850,00

4053

Fonds National de la recherche Luxembourg

9.102,00

-7.282,00

1.820,00

44441

Adm. contr. directes - Impôts sur salaires

10,00

24.344,00

-24.354,00

44618

TVA - Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-533,05

533,05

-2.064,49

-2.064,49

4640

Provision pour frais à recevoir  . . . . . . . . . .

-9.380,00

9.380,00

-14.800,00 -14.800,00

5121

BCEE LU83 0019 1000 3143 5000  . . . . . . .

80.593,50

296.149,50

-296.947,27

79.795,73

5122

BCEE LU58 0019 0175 5884 9000 USD  . . .

142,96

-10,99

131,97

5132

BCEE LU41 0019 5412 6480 8000 COMPTE

87.423,21

2.727,13

-1,50

90.148,84

5133

BCEE LU70 0019 4812 2850 3000 LIVRET I

56.272,76

12.614,90

-50.000,00

18.887,66

5311

Caisse siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127,23

1.877,75

-1.780,79

224,19

58110

Transfert Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.797,75

-50.797,75

TOTAL GENERAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00 1.000.856,50

-988.737,05

12.119,45

TOTAL OUVERTURE  . . . . . . . . . . . . . . . .

246.569,61

-248.569,66

TOTAL ENTREPRISE  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.247.428,11

-1.235.306,71

Référence de publication: 2011080489/54.
(110089368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2011.

E.F.IM. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 128.273.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 1 

er

 juin 2011 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, résidant professionnellement au 19/21,

Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur.

- De coopter comme nouvel administrateur, Madame Hélène MERCIER, employée privée, résidant professionnelle-

ment  au  19/21  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724  Luxembourg,  son  mandat  ayant  comme  échéance  celui  de  son
prédécesseur.

- De nommer un nouveau président, Monsieur Giorgio BIANCHI, résidant professionnellement au 19-21 Bd du Prince

Henri L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31/12/2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011081316/21.
(110090646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.

Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 107.523.

Le Bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011079115/10.
(110087350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

84978

L

U X E M B O U R G

Premium Capital Energie Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 147.392.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PREMIUM CAPITAL ENERGIE LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011079117/11.
(110087645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Carbofer Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 103.205.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la Société en date du 13 mai 2011

que:

1. Sont réélus jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2012:
- Monsieur Olivier LIEGEOIS, administrateur;
- Monsieur Patrick MOINET, administrateur; et
- Monsieur Benoît BAUDUIN, administrateur.
2. La société PricewaterhouseCoopers est réélue Commissaire de la Société pour la même période.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079240/18.
(110088484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Xenos, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 63.698.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2011

L'Assemblée a reconduit, pour la durée d'un an, le mandat des Administrateurs et du réviseur d’entreprises agréé

MAZARS.

Composition du Conseil d’Administration
Guy WAGNER Président
(résidant professionnellement à L-1724 LUXEMBOURG, 7, boulevard du Prince-Henri)
Michèle BIEL Administrateur
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
Etienne LEDECQ Administrateur
(résidant professionnellement à B-1357 HELECINE, rue de Flône 18)
Pierre PAVLOVITCH Administrateur
(résidant professionnellement à B-1325 DION-VALMONT, Chemin des Glaneurs 3)
Réviseur d’Entreprises agréé
MAZARS
(ayant son siège social à L-2530 LUXEMBOURG, 10 A, rue Henri M. Schnadt)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011087494/26.
(110098307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

84979

L

U X E M B O U R G

Med Call S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 138.800.

L'an deux mille onze, le trente mai;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Yassine FAKROUNE, gérant de sociétés, né à Vesoul (France), le 27 août 1983, demeurant à F 70000

Vesoul, 7, boulevard Charles de Gaulle; et

2) Madame Soraya FAKROUNE, gérante de sociétés, née à Vesoul (France), le 26 février 1983, demeurant F 70000

Vesoul, 7, boulevard Charles de Gaulle.

Les deux sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à

L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procu-
rations, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent
acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “Rosero Investments S.àr.l.”, (la "Société"), établie et ayant son siège social à

L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 138800, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 8 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1476 du 14 juin 2008.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et
qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour

conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en “MED CALL S.à r.l.” et de modifier subséquemment l'article

er

 des statuts comme suit:

 Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée dénommée “MED CALL S.à r.l.” (la "Société"), régie par les

présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales."

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

Art. 2. La Société a pour objet:
- opérations de télémarketing;
- prospection de clientèle pour le compte de tiers;
- télévente;
- secrétariat à distance;
- émission et réception d'appel pour le compte de tiers;
- réalisation d'enquêtes et de sondages.
La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

84980

L

U X E M B O U R G

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social."

<i>Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Denis BOUR de sa fonction de gérant de la Société et lui accorde

décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'en date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée nomme, pour une durée indéterminée, Monsieur Yassine FAKROUNE, gérant de sociétés, né à Vesoul

(France), le 27 août 1983, demeurant à F 70000 Vesoul, 7, boulevard Charles de Gaulle, aux fonctions de gérant de la
Société et fixe son pouvoir de signature comme suit:

"La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 juin 2011. LAC/2011/25414. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 juin 2011.

Référence de publication: 2011078820/78.
(110087620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Parkettcenter S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5374 Munsbach, 4, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 67.324.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dillingen, le 07.06.2011.

<i>Pour Parkettcenter S.à.r.l.
STLU Steuerberatungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 40 - 66763 Dillingen
Signature

Référence de publication: 2011079118/14.
(110087441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

The Glove Technology, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 161.184.

<i>Résolutions des associés en date du 11 mai 2011

Les associés de The Glove Technology Sàrl («la Société») ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Révocation de Monsieur Patrick Hampe, de nationalité belge, né le 21 mars 1954 à Mouscron (Belgique) avec adresse

professionnelle au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, en tant que gérant unique de la Société;

2. Nomination de Madame Michèle Lefebvre, de nationalité belge, née le 21 janvier 1955 à Kortrijk (Belgique) avec

adresse professionnelle au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, en tant que gérant unique de la Société pour une durée
indéterminée.

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2011079543/16.
(110088073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

84981

L

U X E M B O U R G

Pimco Luxembourg III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.809.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011079119/10.
(110087315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme

d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 150.766.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Mélanie Smiltins / Daniel Breger

Référence de publication: 2011079126/12.
(110088045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

RBS (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 104.196.

Suite à la démission de Monsieur Scott Barton, les membres restant du Conseil d'Administration ont élu par cooptation,

Monsieur Kevin Brown demeurant au 250 Bishopsgate, London EC2M 4AA, Royaume-Uni en qualité de membre du
Conseil d'Administration à partir du 4 mai 2011, pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire
des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RBS (Luxembourg) S.A.
Lorna Cassidy / Oezguel Guelbey

Référence de publication: 2011079127/14.
(110087353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

Luxredange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 141.670.

Il résulte du P.-V. de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Contern le 5 mai 2011 que:
- Madame Lieve BUYL et Monsieur Nicolas VAN SCHAP ont démissionné de leur mandat d'administrateur.
- En remplacement des administrateurs démissionnaires sont nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire prévue

en 2014:

* CAMARO S.A. (RCS Luxembourg B 58736) avec siège social sis 66, rue de Koerich L-8437 Steinfort, représentée

par Monsieur Jean-Pol CLART, né le 24/12/1954 à Charleroi (B) et demeurant professionnellement 66, rue de Koerich
à L-8437 Steinfort.

* VALERES Project Developments NV (RC Anvers 475435206) avec siège social sis Kapelsesteenweg 195/1 à B-2180

Ekeren représentée par Monsieur Marc DIVER, né le 07/09/1963 à Mechelen (B) et demeurant professionnellement 17,
rue Edmond Reuter à L-5326 Contern.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011079425/18.
(110088751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

84982

L

U X E M B O U R G

Altoona Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, roue de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 125.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 08 juin 2011.

Référence de publication: 2011079166/10.
(110088616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6871 Wecker, 14, op Huefdreisch.

R.C.S. Luxembourg B 138.685.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079193/10.
(110088486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

H'Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.928.

STATUTES

In the year two thousand and eleven.
On the eleventh day of May.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

Mr. David Julien Philippe HOLDER, company director, born in Lille, on February 27, 1968, residing at CH-1224 Chêne

Bougeries, Switzerland, 44, chemin Grange Canal,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the

Constitutive Deed of a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed

by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is “H'Air S.à r.l.”.

Art. 3. The object of the company is the acquisition and disposal of aircrafts and their exploitation within the limits of

any granted authorizations.

The object of the company is furthermore the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of

participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

84983

L

U X E M B O U R G

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the manager

or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-

lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at thirty-eight thousand (EUR 38,000.-) represented by seven hundred and sixty

(760) sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the

amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders is free and the transfer of sharequotas inter vivos

to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter
of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional
upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital
belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their

participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting

deliberating with a majority of votes.

84984

L

U X E M B O U R G

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint

signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any
other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of
attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of

the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

In case the number of shareholders exceeds 25, the supervision of the company must be entrusted to one or more

supervisory auditor(s).

Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or

several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).

The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting

of shareholders or by the board of managers.

The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions

and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

84985

L

U X E M B O U R G

Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2011.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe

all the seven hundred and sixty (760) sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

All the seven hundred and sixty (760) sharequotas have been paid up in cash to the extent of one hundred percent

(100%) so that the amount of thirty-eight thousand Euro (EUR 38,000.-) is now at the free disposal of the company,
evidence hereof having been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i>First resolution

Mr. David Julien Philippe HOLDER, company director, born in Lille, on February 27, 1968, residing at CH-1224 Chêne

Bougeries, Switzerland, 44, chemin Grange Canal, is appointed as manager of the category A for an indefinite period.

Mr. Eric MAGRINI, company director, born in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on April 20, 1963, residing

professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager of the category
B for an indefinite period.

Mr. Xavier SOULARD, company director, born in Châteauroux (France), on August 14, 1980, residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as manager of the category B for an
indefinite period.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The  undersigned  notary  who  understands  and  speaks  English  and  French,  states  herewith  that  on  request  of  the

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and

residence, the said attorney signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze.
Le onze mai.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur  David  Julien  Philippe  HOLDER,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Lille,  le  27  février  1968,  demeurant  à

CH-1224 Chêne Bougeries, Suisse, 44, chemin Grange Canal,

ici représenté par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le comparant, représenté par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente:

84986

L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de “H'Air S.à r.l.”.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition et l'aliénation d'avions ainsi que leur exploitation dans les limites des

autorisations qui lui seront accordées.

La société a en outre pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière  que  ce  soit, dans d'autres  sociétés luxembourgeoises et étrangères.  La société pourra  aussi contracter  des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,

vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société aura pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant ou,

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-huit mille Euros (EUR 38.000,-), représenté par sept cent soixante (760) parts

sociales ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés

sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait

84987

L

U X E M B O U R G

l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par les

signatures conjointes d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la
procuration.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés

de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Si le nombre des associés dépasse 25, la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs

réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).

Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,

soit par le conseil de gérance.

Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.

84988

L

U X E M B O U R G

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, dûment représenté, déclare souscrire à toutes les sept

cent soixante (760) parts sociales ayant une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune chacune.

Toutes les sept cent soixante (760) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme

de trente-huit mille Euros (EUR 38.000,-) est dés à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent Euros.

<i>Résolutions de l'associée unique

Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur  David  Julien  Philippe  HOLDER,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Lille,  le  27  février  1968,  demeurant  à

CH-1224 Chêne Bougeries, Suisse, 44, chemin Grange Canal, est nommé comme gérant de la catégorie A pour une durée
indéterminée.

Monsieur Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril

1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé
comme gérant de la catégorie B pour une durée indéterminée.

Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé comme gérant de la
catégorie B pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

84989

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mai 2011. Relation GRE/2011/1871. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 19 mai 2011.

Référence de publication: 2011070506/361.
(110077808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

Asars Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.750,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 63.479.

Société constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire

de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C N° 404 du 4 juin 1998. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10
décembre 1998, suivant assemblée générale du 13 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C No 835 du 1 

er

 juin 2002. Les statuts ont ensuite été modifiés suivant actes reçus par le même

notaire, en date du 5 octobre 2004, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1 321 du
27 décembre 2004, en date du 11 septembre 2006, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C N° 2 154 du 17 novembre 2006, et en date du 30 septembre 2008, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C N° 2 590 du 23 octobre 2008.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 JUIN 2011.

ASARS CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2011084306/23.
(110094306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

Westley International, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 55.040.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange, en date du

14 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 422 du 29 août 1996. Les statuts ont
été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 14 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C No 760 du 20 octobre 1998 et en date du 22 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C No 9 du 7 janvier 1999. Les statuts ont ensuite été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 690
du 29 août 2001. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre
1998, suivant assemblée générale du 21 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C No 633 du 24 avril 2002. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date
du 17 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 549 du 24 mars 2011.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 JUIN 2011.

WESTLEY INTERNATIONAL
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2011084464/23.
(110094303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2011.

84990

L

U X E M B O U R G

Dexia Life &amp; Pensions Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 39.593.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 12 mai 2011

L'Assemblée  Générale  entérine  le  renouvellement  du  mandat  d'Administrateur  de  Monsieur  Luc  Rasschaert.  Son

mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2014.

L'Assemblée nomme DELOITTE S.A., rue de neudorf, 560, L-2220 Luxembourg, pour la révision légale des comptes

de Dexia Life &amp; Pensions au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour Dexia Life &amp; Pensions
Patrick Schols / Geernard Van den broeck
<i>Chief Executive Officer / Membre du Comité de Direction

Référence de publication: 2011080516/17.
(110089300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2011.

Support Science Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.495.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven.
On the twenty-fourth of May.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

The company CLAN INTERNATIONAL LIMITED, with its registered office at The Valley, Anguilla, British West Indies,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, with professional address at Junglinster (Grand-Duchy of

Luxembourg),

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) Support Science Global S.à r.l., having its regis-

tered office at L-1331 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 97495, has been incorporated by deed of Maître Joseph
ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on December 2, 2003, published in the Mé-
morial C number 25 of January 8, 2004 (the "Company") and that its articles have been amended by the undersigned
notary on August 30, 2007, deed published in the Mémorial C number 2471 of October 31, 2007.

2) That the Company's capital is fixed at eighteen thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 18,750.-), represented

by five hundred (500) ordinary shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each and two hundred and fifty
(250) class A redeemable shares with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company

has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle

any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing

debt of the Company pursuant to point 6).

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the

former registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

84991

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de l'acte:

L'an deux mille onze.
Le vingt-quatre mai.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société CLAN INTERNATIONAL LIMITED, avec siège social à The Valley, Anguilla, Antilles Britanniques,
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de

Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée Support Science Global S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 97495, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 2 décembre
2003, publié au Mémorial C numéro 25 du 8 janvier 2004 (la "Société") et que ses statuts ont été modifiés par le notaire
soussigné en date du 30 août 2007, acte publié au Mémorial C numéro 2471 du 31 octobre 2007.

2) Que le capital de la Société est fixé à dix huit mille sept cent cinquante Euros (EUR 18.750,-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et deux cent cinquante
(250) parts rachetables de classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

3) Que la comparante est l'associée unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter

et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif

impayé, connu et inconnu de la Société dissoute.

7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de

la Société comme indiqué au point 6).

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation de toutes les parts sociales de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante Euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

84992

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2011. Relation GRE/2011/2039. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 6 juin 2011.

Référence de publication: 2011078842/100.
(110087201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2011.

BN D&amp;G, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.514.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2011 que:

Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né le 1 

er

 août 1975 à Tricase (Italie) demeurant professionnellement

40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg en remplacement à été élu administrateur en remplacement de Madame
Annalisa CIAMPOLI, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2011.

Référence de publication: 2011079212/14.
(110088121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

CBRail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 119.933.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CBRail S.à r.l.
4, rue Alphonse Welcker
L-2721 Luxembourg
Herman VAN DER LINDEN

Référence de publication: 2011079242/13.
(110088492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Breakingresearch.com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7780 Bissen, 28, route de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 156.460.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 juin 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011079215/14.
(110088720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

84993

L

U X E M B O U R G

Le Premier 3 JD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 129.439.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 10 juin 2011 que:
(i) Le siège social de la Société a été transféré du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider

L-2522 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

De plus,
(i) la Société prend acte du changement d'adresse de Le Premier Investment III S.C.A., associé unique de la Société,

du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg; et

(ii) la Société prend acte du changement d'adresse des gérants suivants:
(a) P.A.L. Management Services S.à r.l. du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxem-

bourg;

(b) Mlle Céline Pignon du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg;

et

(c) Le Premier Management S.à r.l. du 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg au 6, rue Guillaume Schneider L-2522

Luxembourg

Le 22 juin 2011.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011086747/25.
(110097463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2011.

Abrantes Martins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3446 Dudelange, 1, rue Mathias Cungs.

R.C.S. Luxembourg B 161.266.

STATUTS

L'an deux mil onze.
Le vingt avril.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Fabio Manuel MARQUES DE MATOS, responsable de magasin, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt (France),

2, rue de la Biche.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il

déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de ABRANTES MARTINS SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de taxis, ainsi que toutes opérations industrielles, com-

merciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), représenté par CENT (100)

parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

84994

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par l'associé unique.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à SEPT CENTS EUROS (EUR 700,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3446 Dudelange, 1, rue Mathias Cungs.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1. Véronique SCHNEIDER, gérant de société, demeurant à F-57710 Bure (France), 13, rue Albert Schweitzer, gérant

technique.

2. Fabio Manuel MARQUES DE MATOS, responsable de magasin, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt (France),

2, rue de la Biche, gérant administratif.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et

de l'infraction de blanchiment au code pénal, le comparant déclare être le bénéficiaire réel des fonds faisant l'objet des
présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à
l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: MARQUES DE MATOS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 27 avril 2011. REM 2011 / 568. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signe): SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 7 juin 2011.

Référence de publication: 2011079171/62.
(110088081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Direl LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.927.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 juin 2011

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Marie-Sibylle Wolf et de Robert

Quinn en tant que gérants de catégorie B de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que

gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:

- Mlle Susana Paula Fernandes Gonçalves, avec adresse professionnelle au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg); et

- M. Andras Kulifai, avec adresse professionnelle au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg); et

Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;

84995

L

U X E M B O U R G

- Susana Paula Fernandes Gonçalves, gérant de catégorie B; et
- Andras Kulifai, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Direl Luxco S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011081052/24.
(110089520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2011.

Copper Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.411.059,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.058.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

Référence de publication: 2011079228/11.
(110088567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Copper Blade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 75.000,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 160.627.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

Référence de publication: 2011079230/11.
(110088527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Hacienda S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4756 Pétange, 12-13, place du Marché.

R.C.S. Luxembourg B 161.361.

STATUTS

L'an deux mille onze, le vingt-quatre mai.
Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. Monsieur Admir MEHOVIC, employé privé, né à Berane (MTN), le 14 novembre 1984, demeurant à L-4580 DIF-

FERDANGE, 62-64, rue de Hussigny;

2. Monsieur Mirsad AVDIC, employé privé, né à Sarajevo, le 9 octobre 1982, demeurant à L-4750 PETANGE, 54, rue

de Longwy;

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "HACIENDA S.à r.l"

Art. 2. Le siège social est établi à Pétange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, avec

l’achat et la vente des articles de la branche, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

84996

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Monsieur Admir MEHOVIC, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2. Monsieur Mirsad AVDIC, prédit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille onze.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de NEUF CENTS EUROS (EUR 900.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire:

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Ejup KURBARDOVIC, commerçant, né le 3 avril 1987 à Bac (Monténégro), demeurant à L-4930 Bascharage,

168 bvd J-F Kennedy.

Sont nommés gérants administratifs de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Admir MEHOVIC, prédit.
- Monsieur Mirsad AVDIC, prédit.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et d’un

des deux gérants administratifs.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4756 Pétange, 12-13 Place du Marché.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

84997

L

U X E M B O U R G

Signé: Mehovic; Avdic , Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2011. Relation: EAC/ 2011/7167. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 juin 2011.

Référence de publication: 2011081399/85.
(110090486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.

KGC Networks Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.346.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth day of May.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ms. Lorene RIBIER, Private Employee, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 47, Boulevard Royal, acting in

the name and on behalf of Mrs. Yamaldinova TANZILYA, born on June 11, 1950 in Russia, residing at 2 Daurskaya Str,
107/a, Kazan 420045, Russian Federation, by virtue of a proxy given on April 20, 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:
- Mrs. Yamaldinova TANZILYA is the sole current shareholder (the “Sole Shareholder”) of "KGC Networks Luxem-

bourg S.A.", a société anonyme having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 109.346, incorporated under Luxembourg Laws
pursuant a notarial deed executed before Notary Paul BETTINGEN, a civil law notary established in Niederanven, on July
7, 2005 and published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1284 on November 28, 2005 (the
Company);

- the capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.-EUR) represented by twenty-five thousand

(25,000) shares, of one Euro twenty-four cents (1.24.-EUR) each, fully paid (the Shares);

- the Sole Shareholder has acquired the totality of shares of the Company;
- the Sole Shareholder approves the Company’s interim accounts for the period from the 1 

st

 January 2011 to the 18

th

 May 2011;

- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company;

- the Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the immediate dissolution of

the Company;

- the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to

act its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down
of the liquidation have been duly provisioned.

Furthermore the liquidator declares that with respect to possible liabilities of the Company presently unknown, it

irrevocably assumes to pay all such liabilities.

Therefore, as a consequence of the above, we can consider that:
- all the liabilities of the company are paid;
- the remaining net assets, if any have been paid to the Sole Shareholder;
- the full discharge is granted to the member of the Board of the Managers of the Company for the exercise of their

mandates;

- the dissolution of the Company is done and closed;
- the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years in L-2449 Luxembourg, 47,

Boulevard Royal.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and regis-

tration.

Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.

84998

L

U X E M B O U R G

The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read in the language of the attorney in fact of the person appearing, acting in her hereabove

capacity, known to the Notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed together
with the notary the present deed.

Suit la traduction française

L’an deux mille onze, le vingt-six mai.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Melle Lorene RIBIER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 47 Boulevard Royal,

agissant au nom et pour le compte de Mme. Yamaldinova TANZILYA, née le 11 juin 1950 en Russie, résidant à 2 Daurskaya
Str, 107/a, Kazan 420045, Fédération de Russie, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 20 avril
2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante es qualité qu’elle

agit et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que Mme. Yamaldinova TANZILYA, précitée est l’actionnaire unique actuel (l’" Actionnaire Unique"), de la société

anonyme dénommée KGC Networks Luxembourg S.A., avec siège social au 47, Boulevard Royal, L–2449 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 109.346, qui a été constituée,
en date du 7 juillet 2005, suivant acte reçu par le Notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, et publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1284 du 28 novembre 2005 ( la "Société");

- Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros,(31.000,-EUR), représentés par vingt-cinq mille

(25.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro vingt-quatre cents (1,24.-EUR) chacune.

- Que l'Actionnaire Unique s'est rendue propriétaire de la totalité des parts de la Société;
- Que l’Actionnaire Unique a approuvé les comptes intérimaires de la Société pour la période allant du 1 

er

 janvier

2011 au 18 mai 2011;

- Que l’Actionnaire Unique a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- Que les activités de la Société ayant cessé, l'Actionnaire Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa

mise en liquidation.

- Que l'Actionnaire Unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le Notaire

instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la
dite Société est réglé;

- Que l'actif restant est réparti à l'Actionnaire Unique;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’exercice de leurs

mandats;

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à L – 2449 Luxembourg, 47, boulevard

Royal.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le

présent  acte  de  société  est  rédigé  en  langue  anglaise,  suivi  d’une  version  française;  sur  demande  de  la  même  partie
comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Lecture faite en langue du pays à la mandataire de la partie comparante es qualité qu’elle agit, connue du notaire

instrumentant par nom, prénom, état et demeure, celle-ci signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Ribier et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mai 2011. LAC/2011/24949. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

84999

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 31 mai 2011.

Référence de publication: 2011075758/104.
(110084590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.

Copper Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.043.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2011.

Référence de publication: 2011079233/10.
(110088559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Future Energy Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.467.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 1 

er

 juin 2011 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, résidant professionnellement au 19/21,

Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur.

- De coopter comme nouvel administrateur, Madame Hélène MERCIER, employée privée, résidant professionnelle-

ment  au  19/21  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724  Luxembourg,  son  mandat  ayant  comme  échéance  celui  de  son
prédécesseur.

- De nommer un nouveau président, Monsieur Giorgio BIANCHI, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard

du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31/12/2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011081367/21.
(110091350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.

VALARTIS FUNDS (Lux. I), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 68.826.

<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 20 mai 2011

L’Assemblée décide:
- de réélire Messieurs Gustav STENBOLT, résidant dorénavant professionnellement au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich,

André SCHMIT, résidant professionnellement au 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, Franck BERLAMONT, résidant
dorénavant professionnellement au 33 quai Wilson, CH-1201 Genève, Bernhard BOLLIGER, résidant dorénavant pro-
fessionnellement au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich et Timothy MC CARTHY résidant dorénavant professionnellement
au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich en tant qu’Administrateurs pour un nouveau mandat de 6 ans, se terminant à l’As-
semblée Générale Statutaire de 2017.

- de réélire ERNST &amp; YOUNG en tant que réviseur d’entreprises pour une nouveau mandat de 3 ans, se terminant à

l’Assemblée Générale Statutaire de 2014.

Mr Timothy MC CARTHY, délégué à la gestion journalière, réside dorénavant au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extraits certifiés sincères et conformes
<i>Pour VALARTIS FUNDS (LUX. I)
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2011087480/22.
(110098407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

85000

L

U X E M B O U R G

Resol S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 110.560.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2011 que, Monsieur Michel Schaeffer, directeur

de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire aux comptes,
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011079486/15.
(110088326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Calypsis Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.355.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079237/10.
(110088488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Carbofer Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 103.205.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079239/10.
(110088483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Inverlog S.A., Société Anonyme,

(anc. FIS International SA).

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 89.878.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 juin 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011079384/12.
(110088619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

CMC Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 52.651.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

85001

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 7 juin 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011079255/14.
(110088084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

E.RE.A.S. Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 158.472.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 7 juin 2011.

Référence de publication: 2011079280/10.
(110088225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Euro-Deal International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 74.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011079305/14.
(110088443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Arlene S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 81.517.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration en date du 10 mai 2011

Le 10 Mai 2011, les Administrateurs de ARLENE S.A. ("la Société"), ont pris les résolutions suivantes:
De confirmer le renouvellement du mandat d'Administrateur-délégué, de Luxembourg Corporation Company S.A.

dont le siège social est situé 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale
des Actionnaires devant se tenir en 2016;

Luxembourg, le 11 Mai 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011079823/16.
(110088864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2011.

Mast Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 144.495.

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

85002

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011079432/12.
(110088497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Calypsis Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.355.

L'an deux mille onze, le vingt-cinq mai.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de «CALYPSIS EQUITY S.A.», R.C.S. Luxembourg Numéro B 106 355, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue
de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 25 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 625 du 29 juin 2005.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu du notaire instru-

mentaire en date du 5 mai 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1119 du 28 mai
2010.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au

18, rue de l’Eau, L–1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, domiciliée profession-

nellement au 74, rue Victor Hugo, L–1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, juriste, domicilié professionnellement au 74, rue Victor

Hugo, L–1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de neuf cent quatre-vingt-quinze mille trois cent
dix euros et vingt-cinq cents (EUR 995.310,25,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression des deux catégories d’administrateurs A et B.
2. Modification des règles de prises de décisions du conseil d’administration.
3. Confirmation des mandats des administrateurs en place.
4. Refonte des articles 5 et 6 des statuts
5. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer les deux catégories d’administrateurs A et B.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée  décide  que  l’unanimité  des  membres  du  conseil  d’administration  présents  ou  représentés,  et  le  vote

unanime des administrateurs seront dorénavant requis pour les décisions suivantes:

- L’acquisition, la vente ou la location de toute propriété mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle;
- L’octroi de prêt ou la demande d’emprunt, en argent ou en nature;
- La vente, la location, l’échange ou la disposition de quelque nature que ce soit des actifs de la société, en ce compris

son «goodwill» et son image; de même que l’octroi d’un mandat pour ce faire (à moins que l’assemblée des actionnaires
n’en décide autrement);

- La mise en trust ou fiducie ou l’octroi de tout gage, garantie et ou fidéjussion;
- L’ouverture ou la fermeture de compte bancaire;
- La modification des signataires ou des pouvoirs de signature sur un compte bancaire.

85003

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de confirmer les mandats des administrateurs actuellement en place en les personnes de Mr Peter

STEIMLE, Mr Stefano GIANI, Mr Marc KOEUNE, Mr Jean-Yves NICOLAS, Mr Sébastien GRAVIERE et Mme Nicole
THOMMES.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les articles 5 et 6 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

« Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix à l’exception des décisions qui requièrent

la présence de l’unanimité des membres du conseil d’administration.

L’unanimité des membres du conseil d’administration présents ou représentés, et l’unanimité des voix des adminis-

trateurs sont requises, pour toutes les décisions suivantes:

- L’acquisition, la vente ou la location de toute propriété mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle;
- L’octroi de prêt ou la demande d’emprunt, en argent ou en nature;
- La vente, la location, l’échange ou la disposition de quelque nature que ce soit des actifs de la société, en ce compris

son «goodwill» et son image; de même que l’octroi d’un mandat pour ce faire (à moins que l’assemblée des actionnaires
n’en décide autrement);

- La mise en trust ou fiducie ou l’octroi de tout gage, garantie et ou fidéjussion;
- L’ouverture ou la fermeture de compte bancaire;
- La modification des signataires ou des pouvoirs de signature sur un compte bancaire.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télécon-

férence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut
également prendre ses décisions par voie circulaire.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mai 2011. LAC/2011/24613. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079236/100.
(110088487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

85004

L

U X E M B O U R G

Druster HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.929.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 juin 2011

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Marie-Sibylle Wolf et de Robert

Quinn en tant que gérants de catégorie B de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que

gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:

- Mlle Susana Paula Fernandes Gonçalves, avec adresse professionnelle au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg); et

- M. Andras Kulifai, avec adresse professionnelle au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg); et

Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Susana Paula Fernandes Gonçalves, gérant de catégorie B; et
- Andras Kulifai, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Druster Holdco S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011081053/24.
(110089523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2011.

ROLLINGER Toiture, Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 117.653.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2011 que les administrateurs actuellement en fonction, à savoir:
- Monsieur Marco Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxembourg,
- Monsieur Tommy Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7246 Helmsange, 50, rue des Prés,
- Monsieur Dany Rollinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxembourg,
sont nommés administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Helmsange, le 7 juin 2011.

Référence de publication: 2011079492/15.
(110088353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Freesia S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 111.179.

<i>Extrait des résolutions des associés du 8 juin 2011

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que:
- Kloisters Inc. est réélu au poste d'administrateur A jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en

2017;

- Mr. John G.H. Dercksen est réélu au poste d'administrateur B jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en 2017;

- EMPoint Sàrl est réélu au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en 2017.

Référence de publication: 2011079975/16.
(110089257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2011.

85005

L

U X E M B O U R G

Fidji S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 145.434.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079318/10.
(110088545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Greenman Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R.C.S. Luxembourg B 143.235.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2011.

Référence de publication: 2011079337/10.
(110088558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Holding Akemis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 123.447.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 juin 2011.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2011079351/11.
(110088183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Manwin Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 160.366.

L'an deux mille onze, le vingt et un avril,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

A comparu:

"MANWIN LICENSING EUROPE SARL", ayant son siège social au 49, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg
ici représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao-Conde, employée privée, domicilié professionnellement à Esch-sur-

Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 21 avril 2011.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce que suit:
- La comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée ''MANWIN LUXEMBOURG S. à r.l.", R.C.S.

Luxembourg N° (en cours), ayant son siège social à Luxembourg au 49, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, constituée
par acte de Maître Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 2 février 2011.

- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

- L'objet social est modifié.
En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir et mettre en valeur tous droits de propriété intellectuelle (brevets, noms de domaine, etc.)

et autres droits en dérivant ou les complétant.

85006

L

U X E M B O U R G

La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder des garanties et sûretés pour ces emprunts. Elle peut

accorder toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation
directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe. La société pourra également contracter des emprunts auprès
de tiers.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Suit la traduction en langue anglaise de la modification statutaire:

Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may acquire and manage all intellectual property rights (patents, domain names, etc.) and other rights

deriving therefrom or complementary thereto.

The company may also contract loans and grant guarantees and securities for such loans. It can grant all kinds of

support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group. The company may also contract such loans from third parties.

The company may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all kinds

and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The company may moreover carry out any commercial, industrial or financial operations, in respect of either moveable

or immoveable property, that it may deem of use in the accomplishment of its object."

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 avril 2011. Relation: EAC/2011/5450. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011076280/53.
(110084948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2011.

I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 30.538.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2011.

Référence de publication: 2011079370/11.
(110088427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 59.528.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société du 25 mai 2011, (i) que les mandats d'administrateurs

de Mme Mia Brunell Livfors, Mme Torun Litzen, M. Henning Boysen, M. Charles Burdick, M. Robert Lerwill, M. Roel
Louwhoff et M. William Walker ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société de l'an 2012,
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011, et (ii) que le mandat de Ernst &amp; Young S.A., une société anonyme
constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2,
L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 47.771, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de la Société de l'an 2012, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

85007

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 10 juin 2011.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011080997/19.
(110090198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2011.

Island Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.912.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 160.907.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2011.

Référence de publication: 2011079375/11.
(110088624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

INHALUX.lu, Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 149.080.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 juin 2011.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011079382/14.
(110088719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.

Triton III LuxCo B 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.795.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 juin 2011

L'assemblée générale de la Société a accepté la démission, avec effet immédiat, de Marie-Sibylle Wolf et de Robert

Quinn en tant que gérants de catégorie B de la Société.

L'assemblée générale de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que

gérants de catégorie B de la Société et ce pour une durée illimitée:

- Mlle Susana Paula Fernandes Gonçalves, avec adresse professionnelle au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg); et

- M. Andras Kulifai, avec adresse professionnelle au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg); et

Le conseil de gérance de la Société se compose dès lors comme suit:
- Lars Frankfelt, gérant de catégorie A;
- Susana Paula Fernandes Gonçalves, gérant de catégorie B; et
- Andras Kulifai, gérant de catégorie B; et
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Triton III Luxco B 10 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011088733/24.
(110098344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

85008


Document Outline

Abrantes Martins S.à r.l.

Altoona Investment S.A.

Arlene S.A.

Asars Constructions S.à r.l.

ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise of Luxembourg S.à r.l.

BN D&amp;G

Breakingresearch.com S.A.

Calypsis Equity S.A.

Calypsis Equity S.A.

Carbofer Finance S.A.

Carbofer Finance S.A.

CBRail S.à r.l.

Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie (ECGS)

CMC Finances S.A.

Copper Acquisition S.à r.l.

Copper Blade S.à r.l.

Copper Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Dexia Life &amp; Pensions Luxembourg

Direl LuxCo S.à r.l.

Druster HoldCo S.à r.l.

E.F.IM. S.A.

E.RE.A.S. Finance S.C.A.

Euro-Deal International S.A.

Fidji S.A.

FIS International SA

Freesia S.A.

Future Energy Management Luxembourg S.A.

Greenman Investments S.A.

Hacienda S.à r.l.

H'Air S.à r.l.

Holding Akemis S.à r.l.

I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A., SPF

INHALUX.lu

Inverlog S.A.

Island Group Holdings S.à r.l.

KGC Networks Luxembourg S.A.

Le Premier 3 JD S.à r.l.

Luxredange S.A.

Manwin Luxembourg Sàrl

Mast Finance S.A.

Med Call S.à r.l.

Parkettcenter S.à.r.l.

Parquet Böhm S. à r. l.

Partners Group (Luxembourg) S.à r.l.

Partners Group Secondary 2011 (EUR) S.C.A., SICAR

Pimco Luxembourg III S.A.

Premium Capital Energie Luxembourg S.à r.l.

RBS (Luxembourg) S.A.

Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF

Resol S.A.

ROLLINGER Toiture

Support Science Global S.à r.l.

The Glove Technology

Transcom WorldWide S.A.

Triton III LuxCo B 10 S.à r.l.

VALARTIS FUNDS (Lux. I)

Westley International

Xenos