This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1704
28 juillet 2011
SOMMAIRE
AIM Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81778
AXA Alternative Participations IV, SICAV-
FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81750
Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81792
Even Germany S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81784
Even Germany S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81785
Farenzena Jules Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81771
Fibor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81746
Fidacta Holding Luxembourg S.A. . . . . . . .
81746
Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A. . .
81746
F.I.L. Casa International S.A. . . . . . . . . . . . .
81750
Filip S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81747
Finbra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81747
First Gate Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81748
First Service Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81748
Fiscobelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81749
Four Seasons Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81748
Four Seasons Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
81749
Franzoni Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81749
Freesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81750
Fusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81746
Fusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81749
G.2. Investment Group S.A. . . . . . . . . . . . . .
81747
Galanthus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81772
Gallura Moon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81771
Gliese S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81772
Global Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81773
Gravograph U.S. Finance S.à.r.l. . . . . . . . . .
81773
Grep Eins S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81772
Groupe Compétence S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
81749
Gugler Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81774
Happy Quick S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81785
Happy Quick S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81775
HEDF II UK Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
81787
HEDF II UK Residential S.à r.l. . . . . . . . . . .
81788
HIP Investments S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
81775
Hip Mezzanine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81775
Horst Keller Gebäudereinigung, GmbH,
Niederlassung Luxemburg . . . . . . . . . . . . .
81774
HSBC Global Markets Equities SICAV . . .
81773
Husky Injection Molding Systems . . . . . . . .
81774
Iginio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81788
Immobilière Arenberg S.A. . . . . . . . . . . . . .
81788
Immobilière Livange SA . . . . . . . . . . . . . . . .
81792
Immo Dek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81788
Immofra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81774
Intel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81773
KCTG Foreign Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
81783
KCTG Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
81784
Kekri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81791
Kenmore Astoria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
81791
Koch Chemical Technology European
Treasury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81776
Koch Chemical Technology GP S.à r.l. . . .
81776
Koch Chemical Technology GP S.à r.l. &
Partners SCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81776
Koch Chemical Technology LP2 S.à r.l. . .
81777
Koch Chemical Technology LP3 S.à r.l. . .
81777
Koch Financing Luxembourg S.à r.l. . . . . .
81777
Koch Resources Luxembourg S.à r.l. . . . . .
81783
Laubach Containers Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
81785
Legiex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81784
Lotisseurs in den Strachen S.à r.l. . . . . . . . .
81788
Lux Fund Consult S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
81784
LyondellBasell AFGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81783
Reality S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81775
UnikEvent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81785
81745
L
U X E M B O U R G
Fibor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 88.769.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIBOR S.A.
Angelo DE BERNARDI / Georges DIEDERICH
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011079316/12.
(110088219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Fusion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 62.763.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2011i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 40,
Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, à L-2163
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, Avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exer-
cice 2011.
Luxembourg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079331/18.
(110088610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Fidacta Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 83.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2011079317/12.
(110088690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 90.331.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079320/10.
(110088172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81746
L
U X E M B O U R G
Filip S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 106.554.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2011i>
- que le siège social de la société a été transféré du 22, avenue Marie Thérèse L-2132 Luxembourg au 24, rue Saint
Mathieu L-2138 Luxembourg avec effet au 20 mai 2011;
- que Monsieur Frederik ROB demeurant professionnellement au 24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg a été
nommé gérant avec effet au 20 mai 2011 pour une durée indéterminée à la place de Monsieur Olivier KUCHLY, gérant
démissionnaire.
Pour extrait sincère et conforme
Frederik ROB
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011079321/17.
(110088739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Finbra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 62.242.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2011.i>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.
L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-
sionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:
- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l, avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.
- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié
professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg
Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue
de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.
La société Zimmer & Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société
Anonyme.
La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079322/27.
(110088758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
G.2. Investment Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R.C.S. Luxembourg B 27.423.
<i>Procès-verbal de résolution du 8 juin 2011i>
Est présent:
- Maître Arsène KRONSHAGEN, liquidateur.
Le liquidateur décide de transférer le siège social de la S.A. G.2. INVESTMENT S.A., en liquidation volontaire de
Luxembourg, 18, rue Pierre Krier, à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
81747
L
U X E M B O U R G
A. KRONSHAGEN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011079332/14.
(110088603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
First Service Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 105.192.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2011.
<i>POUR LES LIQUIDATEURS
i>Signature
Référence de publication: 2011079324/12.
(110088408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
First Gate Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 105.619.
Lors de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires tenue le 7 juin 2011, il a été résolu ce qui suit:
- D'approuver la démission de M. Didier Mc Gaw et M. Stéphane Lataste comme administrateurs au conseil d'admi-
nistration de la société;
- D'approuver la démission de l'Alliance Revision Sàrl comme le commissaire aux comptes de la société;
- D'élire M. Gilles Wecker et Melle. Åsa Åhlund, demeurant professionnellement au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg comme administrateurs au conseil d'administration de la société.
- D'élire Modern Treuhand S.A., située au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg comme le commissaire
aux comptes de la société;
- De changer l'adresse du siège social de 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg à 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg.
At the Extraordinary General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on June 7
th
, 2011,
it has been resolved the following:
- To relieve Mr. Didier Mc Gaw and Mr. Stéphane Lataste as directors of the board for the company;
- To relieve l'Alliance Revision Sàrl as the statutory auditor of the company;
- To elect Mr. Gilles Wecker and Ms Åsa Åhlund,, residing professionally at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lux-
embourg as new directors of the board.
- To elect Modern Treuhand S.A. situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 as the statutory auditor of the com-
pany;
- To change the registered address from 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg to 2-4 Avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg.
Référence de publication: 2011079323/27.
(110088055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Four Seasons Capital S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 48.501.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011079327/9.
(110088494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81748
L
U X E M B O U R G
Four Seasons Capital S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 48.501.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011079328/9.
(110088495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Groupe Compétence S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 78.819.
Monsieur Bruno Hue, associé, a changé d’adresse et demeure désormais au 7, rue Neuve, L-5560 Remich
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2011079345/9.
(110088144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Fiscobelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 60.852.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079326/11.
(110088143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Franzoni Group S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 60.346.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011079329/11.
(110088555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Fusion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 62.763.
Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079330/12.
(110088609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81749
L
U X E M B O U R G
F.I.L. Casa International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 34.570.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079310/11.
(110088552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Freesia S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 111.179.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011079312/10.
(110088506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 46, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 161.205.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of May,
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg)
There appeared:
Deutsche Ärzteversicherung AG, a company incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered
office at Börsenplatz 1, 50667 Köln, Germany, duly represented by Régis Galiotto, residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy given in Köln, on 13 May 2011.
The aforementioned proxy will remain attached to this document to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearing party, acting in its above-stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a public
limited company:
1. Denomination, Duration, Corporate object, Registered office
Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter
issued, a corporation in the form of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company
with variable share capital -specialised investment fund ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
specialisé") under the name of AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS (hereinafter referred to as the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these Articles of Incorporation.
Art. 3. Corporate object. The sole object of the Company is to invest directly, or indirectly through intermediary
vehicles, the funds available to it in accordance with the law of 13 February 2007 on specialised investment funds as
amended ("Law of 13 February 2007") in assets eligible there under provided that these assets are shares in companies
including shares in companies which qualify as undertakings for collective investments or as other investment vehicles,
and in interests in partnerships, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results
of its portfolio.
The Company may take any measures permitted under the Law of 13 February 2007 and directly related or incidental
to those referred to above, including the holding on an ancillary basis of cash and other liquid assets such as money market
instruments or money market funds.
81750
L
U X E M B O U R G
The Company must not take on borrowings, except for short-term borrowing up to an overall amount equivalent to
10% of the total binding commitments received by the Company (whether drawn or undrawn), provided that the bor-
rowings must be consistent with market standards.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military deve-
lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
2. Share capital, Variations of the share capital, Characteristics of the shares
Art. 5. Share capital. The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the Company,
as defined in Article 11 hereof. The capital of the Company must reach one million two hundred fifty thousand Euro (€
1,250,000.-) within the first twelve (12) months following its incorporation, and thereafter may not be less than this
amount.
The initial share capital of the Company is set at thirty one thousand Euro (€ 31,000.-) fully paid-up and represented
by thirty-one (31) Class A shares with no par value, as defined in Article 8 hereof.
The reference currency of the Company is Euro ("EUR").
Art. 6. Variations in share capital. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the
Company of new fully paid-up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.
Art. 7. Classes of shares. The board of directors of the Company may, at any time, issue other classes of shares. These
other classes of shares may differ in, inter alia, their fee structure, currency, dividend policy or type of target investors.
Initially, one class of shares, Class A shares, shall be issued. Other classes of shares, once created, shall differ in their
characteristics as more fully described in the prospectus of the Company from time to time.
Art. 8. Form of the shares. The Company shall issue shares in registered form.
Shares are issued in uncertificated or certificated registered form. However the register of shareholders is conclusive
evidence of ownership. If a share certificate is requested at the time of subscription, and in such case, the subscriber will
bear the risk and any additional expense arising from the issue of such certificate. Holders of share certificates must return
their share certificates, duly renounced, to the Company before redemption instructions may be effected.
A register of shareholders shall be kept by a duly appointed agent of the Company. Such share register shall set forth
the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the class of each such
share, the amounts paid for each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The share register is
conclusive evidence of ownership. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and beneficial
owner thereof.
The transfer of a registered share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of
shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other ins-
truments of transfer satisfactory to the Company.
Any owner of registered shares has to indicate to the Company an address to be maintained in the share register. All
notices and announcements of the Company given to owners of registered shares shall be validly made at such address.
Any shareholder may, at any moment, request in writing amendments to his address as maintained in the share register.
In case no address has been indicated by an owner of registered shares, the Company is entitled to deem that the necessary
address of the shareholder is at the registered office of the Company.
The shares are issued, and share certificates if requested are delivered, only upon the acceptance of the subscription
and the receipt of the subscription price under the conditions as set out in the prospectus.
The Company will recognise only one holder in respect of each share in the Company. In the event of joint ownership,
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.
Art. 9. Loss or Destruction of share certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that
his share certificate has been mislaid or destroyed, then at his request, a duplicate share certificate may be issued under
such conditions and guarantees as the Company may determine, including an indemnity or other verification of title or
claim to title countersigned by a bank, stockbroker or other party acceptable to the Company. Upon the issue of the
new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate shall become null
and void.
Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated or
defaced certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company, at its discretion,
81751
L
U X E M B O U R G
may charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate, as well as all costs and reasonable
expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the
annulment of the old share certificate.
Art. 10. Limitation to the ownership of shares. Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable
between well-informed investors in accordance with the Law of 13 February 2007 and excluding at any time individuals
and entities which are not corporate entities for German tax purposes and which have one or more individuals as its
members or owners ("Well-Informed Investors"). The issue or transfer of shares may not result in shares being held by
more than one hundred (100) Well-Informed Investors.
The Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any person, firm,
partnership or corporate body, if in the sole opinion of the Company such holding may be detrimental to the interests
of the existing shareholders or of the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg
or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it
would not have otherwise incurred (an "Excluded Investor"). Such firms, partnerships or corporate bodies shall be de-
termined by the board of directors.
For such purposes, the Company may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears that such registration or
transfer would or may eventually result in the beneficial ownership of said share by a person who is precluded from
holding shares in the Company; or
b) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares in the Company, either
alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such
shareholder all shares held by such shareholder; or
c) where it appears to the Company that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the
Company which would render the Company subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg,
compulsorily repurchase all or a proportion of the shares held by such shareholders.
In such cases enumerated at (a) to (c) (inclusive) hereabove, the following proceedings shall be applicable:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter referred to as the "redemption notice") upon the holders of shares
subject to compulsory repurchase; the redemption notice shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the
redemption price (as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such
notice may be served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his address as indicated
in the share register. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share
certificate, if issued, representing shares specified in the redemption notice. Immediately after the close of business on
the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in the
redemption notice and the share certificate, if issued, representing such shares shall be cancelled in the books of the
Company.
2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be purchased (hereinafter referred to as the
"redemption price") shall be an amount equal to the net asset value per share of the class to which the shares belong,
determined in accordance with Article 11 hereof, as at the date of the redemption notice plus any contingent deferred
sales charge or redemption fees, if applicable.
3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the redemption price will be made to the owner of such
shares in the currency in which the shares are denominated, and will be deposited by the Company with a bank in
Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon surrender of the
share certificate, if issued, representing the shares specified in such redemption notice. Upon deposit of such redemption
price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest
in such shares or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder
appearing as the owner thereof to receive the redemption price so deposited (without interest) from such bank upon
effective surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article 10 shall not be questioned or invalidated in
any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person at the date of any
redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
The Company may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any person who is precluded
from holding shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.
Specifically, the Company may restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Company by any
"US person", meaning a citizen or resident of the United States of America or of any of its territories or possessions or
areas subject to its jurisdiction.
Notwithstanding any provisions in these Articles, a shareholder in the Company being a German Regulated Investor
shall have the right, at any time, to transfer all or part of its shares without the prior consent of the Company or any
other shareholder to a transferee that executes a subscription agreement and qualifies as a Well-Informed Investor and
who is not an Excluded Investor and provided that the transfer does not have the effect that the number of shareholders
exceeds one hundred (100). On the transfer of all or part of the shares by a German Regulated Investor, the transferee
81752
L
U X E M B O U R G
shall accept and become solely liable for all liabilities and obligations relating to such shares, including under these Articles,
and the transferring German Regulated Investor shall be released from (and shall have no further liability of any nature,
not even a secondary or joint and several liability, for) such liabilities and obligations.
Insofar and as long as a German Regulated Investor holds shares as part of its guarantee assets ("Sicherungsvermögen"
as defined in Sec. 66 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act (Versicherungsaufsichtsgesetz)) and such
German Regulated Investor is either in accordance with section 70 of the German Insurance Supervisory Act under the
legal obligation to appoint a trustee (Treuhänder) or is subject to similar legal requirements, such German Regulated
Investor shall dispose of such shares only with the prior written consent of such trustee or its authorized representative
appointed in accordance with section 70 of the German Insurance Supervisory Act, as amended from time to time.
"Disposal" includes, but is not limited to any sale exchange, transfer or assignment of all or part of the shares held by
such German Regulated Investor.
For the purpose of this Article, the term "German Regulated Investor" shall include any German insurance company,
German Pensionskasse or German pension fund (including a German Versorgungswerk) or any other entity subject to
the investment restrictions of the German Insurance Supervisory Act (Versicherungsaufsichtsgesetz) holding shares in
the Company as part of its guarantee assets ("Sicherungsvermögen") or "other restricted assets" ("Sonstiges gebundenes
Vermögen" as defined in Sec. 66 and Sec. 54 para. 1 or Sec. 115 of the German Insurance Supervisory Act (Versiche-
rungsaufsichtsgesetz)).
3. Net asset value, Issue and Repurchase of shares, Suspension of the calculation of the net asset value
Art. 11. Net asset value. The net asset value per share of each class of shares of the Company shall be determined
periodically by the Company, but in any case not less than once per month, as the board of directors may determine
(every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the "valuation day"). If such day falls
on a legal or bank holiday in Luxembourg, then the valuation day shall be the first succeeding full business day in Luxem-
bourg.
The net asset value per share is expressed in the reference currency of the Company, for each class of shares, and is
determined by dividing the value of the total assets of the Company properly allocable to such class of shares less value
of the total liabilities properly allocable to such class of shares by the total number of shares of such class outstanding on
any valuation day.
The valuation of the net asset value per share of the different classes of shares shall be made in the following manner:
a) The assets of the Company will be determined by application of the following principles:
- The valuation of the Company's interests in the investment structures (both by way of equity and debt investments)
will be effected in the following manner:
* An interest in an investment structure will be valued at cost as long as no report is available;
* If a report regarding the investment structure is available, the interest in the investment structure will be valued on
the basis of the latest available report as long as no major evaluation event ("Evaluation Event") occurred. The following
events qualify as Evaluation Events: capital calls, distributions or redemptions effected by the investment structure or one
or more of its underlying investments as well as any material events or developments affecting either the underlying
investments or the investment structures themselves.
* The occurrence of an Evaluation Event will be taken into account.
* The valuation of direct investments, which are made as co-investments, will be effected in the same manner as
described here-above;
- If a net asset value is determined for the units or shares issued by an investment structure, those units or shares will
be valued on the basis of the latest net asset value determined according to the provisions of the particular issuing
documents of the investment structure. In case of the occurrence of an Evaluation Event that is not reflected in the latest
available net asset value of such units or shares issued by such investment structures, the valuation of such units or shares
issued by such investment structures may take into account this Evaluation Event;
- the value of cash held in hand or on deposit, of securities and bills payable at sight, of accounts receivable, of pre-
paid expenses, and of dividends and interest announced or which have become payable and have not yet been received,
will be constituted by the nominal value of these assets, except where it appears improbable that this value can be achieved;
in which case, their value will be determined by deducting a certain amount which is sufficient in the view of the directors
to reflect the true value of these assets;
- any transferable security and any money market instrument negotiated or listed on a stock exchange will be valued
on the basis of the last known price, unless this price is not representative;
If, in the case of securities or money market instruments listed or traded on a stock exchange or another regulated
market, the price determined pursuant to the foregoing is not representative of the real value of these securities, these
will be stated at Director's valuation. This will be at cost unless in the Director's opinion a reduction in value is considered
appropriate having regard to a company's prospects, or a change of valuation is justified by reference to significant trans-
actions in the securities by third parties;
81753
L
U X E M B O U R G
- any transferable security and any money market instrument negotiated on another market will be valued on the basis
of the last available price;
- all other securities and other assets will be valued by the directors based on the reasonable foreseeable sales proceeds
determined prudently and in good faith;
- if, as a result of particular circumstances, valuation based on the above rules becomes impractical or inaccurate, other
valuation criteria which are generally accepted and verifiable in order to obtain a fair valuation will be applied.
The Company may receive all kinds of eligible assets under the Law of 13 February 2007 if the Company gets distribution
in kind from underlying investments.
Any assets which are not expressed in the currency of the class to which they belong will be converted into the
currency of this class at the exchange rate prevailing on the working day concerned, or at the exchange rate provided
for by the terms of the contract.
Any assets held by the Company not expressed in the reference currency will be translated into the reference currency
at the official rate of exchange prevailing on the relevant valuation day.
b) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
- all loans, bills and accounts payable;
- all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory, consultancy or management fees (if
any), Custodian, paying agent and corporate agent fees);
- all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or pro-
perty;
- an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant valuation day, as determined
from time to time by the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the directors; and
- all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the
Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all
costs incurred by the Company, which may inter alia comprise the fees payable to the Custodian, the paying agent, the
corporate agent, investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services,
due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment struc-
tures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining
such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising ex-
penses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the
directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other expenses
payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs
of publications. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an
estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such
period.
All shares in the process of being redeemed by the Company shall be deemed to be issued until the close of business
on the valuation day applicable to the redemption. The redemption price is a liability of the Company from the close of
business on this date until paid.
All shares issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be deemed issued from
the close of business on the valuation day applicable to the subscription. The subscription price is an amount owed to
the Company from the close of business on such day until paid.
As far as possible, all investments and divestments chosen and in relation to which action is taken by the Company up
to the valuation day shall be taken into consideration in the valuation.
Art. 12. Issue, Redemption and Conversion of shares.
12.1. Issue of shares
The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each class at any time and without reserving
the existing shareholders a preferential right to subscription for the shares to be issued and provided however that shares
will not be issued to more than one hundred (100) Well-Informed Investors at a price based on the net asset value per
share for each class of shares determined in accordance with Article 11 hereof, as of such valuation date as is determined
in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased
by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue
and by applicable sales charges, as approved from time to time by the board of directors.
The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly
authorised person, the duty of accepting subscriptions and of receiving payment for such new shares.
All new share subscriptions shall, under pain of nullity, be entirely liberated, and the shares issued carry the same rights
as those shares in existence on the date of the issuance.
The issue price will be paid within the delays detailed in the prospectus of the Company.
81754
L
U X E M B O U R G
The board of directors may at its full discretion agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of
securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation
report from an auditor ("réviseur d'entreprises agréé").
If the directors determine that it would be detrimental to the existing shareholders of the Company to accept a
subscription for shares that represents more than 10% of the net assets, then they may postpone the acceptance of such
subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require him to stagger his proposed subscription
over an agreed period of time.
The Company may reject any subscription in whole or in part, and the directors may, at any time and from time to
time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any
class.
12.2. Redemption of shares
The directors may from time to time as they deem appropriate decide the repurchase of shares or fractions thereof.
The decision to repurchase will be binding for all the shareholders and affect them on a pro rata basis in accordance with
their shareholding. However the shares are not redeemable at the unilateral request of the shareholders.
The Company will announce in due time the redemption through mail addressed to the registered shareholders. The
announcement will mention the duration of the redemption period, the method for calculating the redemption price
which will be determined on the last day of the redemption period and which will be equal to the net asset value calculated
on the last day of the redemption period.
The directors may in their sole and absolute discretion ask the shareholder to accept payment in whole or in part by
an in-kind distribution of securities in lieu of cash.
The redeemed shares will be cancelled. The redemption price will be paid within the delays detailed in the prospectus
of the Company.
12.3.Conversion of shares into shares of a different class of shares
Conversions of shares between different classes of shares, if any, are excluded.
Art. 13. Suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, The redemption and the conversion of
shares. The Company may suspend the calculation of the net asset value per share in the following circumstances:
a) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the directors as a result
of which disposal or valuation of assets owned by the Company would be impracticable;
b) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of the Company or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of
the assets of the Company;
c) if restrictions on foreign exchange or with regard to capital transactions prevent the settlement of transactions on
behalf of the Company;
d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately
be ascertained;
e) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the
Company.
Under exceptional circumstances, which may adversely affect the rights of shareholders, the board of directors re-
serves the right to conduct the necessary sales of investments before setting the share price at which shareholders will
have their shares redeemed. In this case, subscriptions and redemptions in process shall be dealt with on the basis of the
net asset value thus calculated after the necessary sales.
The suspension of the calculation of the net asset value may be published by adequate means if the duration of the
suspension is to exceed a certain period.
Suspended subscription applications may be withdrawn by written notice provided that the Company receives such
notice before the suspension ends.
Suspended subscriptions and redemptions shall be executed on the first valuation day following the resumption of net
asset value calculation by the Company.
4. Investment policies and Restrictions
Art. 14. General provisions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to
determine the corporate and investment policy for the investments and the course of conduct of the management and
business affairs of the Company, all within the investment powers and restrictions as shall be set forth by the board of
directors in the prospectus of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
The risk diversification requirements may not apply during a start-up period as determined in the prospectus of the
Company.
81755
L
U X E M B O U R G
5. General shareholders' meetings
Art. 15. General provisions. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent
the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company.
Art. 16. Annual general shareholders' meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance
with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may
be specified in the notice of the meeting, on 3
rd
Friday in March at 12:30 p.m., and for the first time in 2012. If such day
is a bank holiday in Luxembourg, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional
circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 17. General meetings of shareholders of classes of shares. The shareholders of any class of shares may hold, at
any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class of shares. The general provisions
set out in these Articles of Incorporation, as well as in the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time
to time on commercial companies, shall apply to such meetings.
Art. 18. Functioning of shareholders' meetings. The quorum and time required by law shall govern the notice for and
conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share, regardless of the class to which it belongs, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by
these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as
his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. Fractions of shares are not entitled to a vote.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by simple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
Further, the shareholders of each class separately will deliberate and vote (subject to the conditions of quorum and
majority voting as provided by law) on the following items:
1. affectation of the net profits of their class; and
2. resolutions affecting the rights of the shareholders of one class vis-à-vis of the other classes.
Art. 19. Notice to the general shareholders' meetings. Shareholders shall meet upon call by the board of directors.
To the extent required by law, the notice shall be published in the Mémorial of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper
and in such other newspapers as the board of directors may decide.
6. Management of the company
Art. 20. Management. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three (3)
members who need not to be shareholders of the Company.
Art. 21. Duration of the functions of the directors, Renewal of the board of directors. The directors shall be elected
by the general shareholders' meeting for a period not exceeding six years and until their successors are elected and
qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by reso-
lution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis until the next general
meeting of shareholders.
Art. 22. Committee of the board of directors. The board of directors may choose from among its members a chairman,
and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the share-
holders.
Art. 23. Meetings and deliberations of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the
chairman, or any two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint another director by a majority vote to preside at such meetings. For
general meetings of shareholders and in the case no director is present, any other person may be appointed as chairman.
The board of directors may from time to time appoint officers of the Company, including a general manager, any
assistant managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the
Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors
81756
L
U X E M B O U R G
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and
duties given to them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least three (3) days in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meetings of the board of directors by appointing, in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile transmission, another director as his proxy. One director may replace several other directors.
Any director who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the board
of directors by conference call or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the
meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
Directors may not bind the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of
the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least fifty per cent of the directors are present or
represented at a meeting of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. The chairman shall have the casting vote.
Resolutions signed by all members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmission and similar means. The date of such a
resolution shall be the date of the last signature.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities
which need not be members of the board.
Art. 24. Minutes. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman, or in his
absence, by the chairman pro-tempore who presides at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two (2) directors.
Art. 25. Engagement of the Company vis-à-vis third persons. The Company shall be engaged by the signature of two
(2) members of the board of directors or by the individual signature of any duly authorised director or officer of the
Company or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of
directors.
Art. 26. Powers of the board of directors. The board of directors determines the general orientation of the manage-
ment and of the investment policy, as well as the guidelines to be followed in the management of the Company, always
in application of the principle of risk diversification.
Art. 27. Interest. No contract or other transaction which the Company and any other corporation or firm might enter
into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company are
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
Any director or officer of the Company who serves as a director, officer of employee of any corporation or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any position, relationship with or
interest in any matter, position or transaction involving the AXA group, its subsidiaries and associated companies or such
other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.
Art. 28. Indemnification of the directors. The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
81757
L
U X E M B O U R G
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 29. Allowances to the board of directors. The general meeting of shareholders may allow the members of the
board of directors, as remuneration for services rendered, a fixed annual sum, as directors' remuneration, such amount
being carried as general expenses of the Company and which shall be divided at the discretion of the board of directors
among themselves.
Furthermore, the members of the board of directors may be reimbursed for any expenses engaged in on behalf of the
Company insofar as they are reasonable.
The remuneration of the chairman or the secretary of the board of directors as well as those of the general manager
(s) and officers shall be fixed by the board.
Art. 30. Advisor, Fund managers, Custodian and Other contractual parties. The Company may enter into an investment
advisory agreement in order to be advised and assisted while managing its portfolio, as well as enter into investment
management agreements with one or more fund managers.
In addition, the Company shall enter into service agreements with other contractual parties, for example an adminis-
trative and corporate agent to fulfil the role of "administration central" as defined in the Institut Monétaire Luxembour-
geois Circular 91/75 of 21 January 1991.
The Company shall enter into a custody agreement with a bank (hereinafter referred to as the "Custodian") which
shall satisfy the requirements of the Law of 13 February 2007. All transferable securities and cash of the Company are to
be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsi-
bilities provided by law.
In the event of the Custodian desiring to retire the board of directors shall use their best endeavours to find another
bank to be Custodian in place of the retiring Custodian and the board of directors shall appoint such bank as Custodian.
The board of directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and
until a successor Custodian shall have been appointed in accordance with these provisions to act in the place thereof.
7. Auditor
Art. 31. Auditor. The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be
supervised by an auditor ("réviseur d'entreprise agréé") who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to
respectability and professional experience and who shall perform the duties foreseen by the Law of 13 February 2007.
The auditors shall be elected by the general meeting of shareholders.
8. Annual accounts
Art. 32. Annual accounts, Accounting year. The shareholders shall be provided with the audited annual financial sta-
tements of the Company within one hundred twenty (120) days following the end of the accounting year of the Company.
The accounting year of the Company shall begin on 1 January in each year and shall terminate on 31 December of the
same year, excepted the first accounting year which shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
December 2011.
Art. 33. Profit balance. At the annual general meeting of shareholders, the shareholders of each class shall determine,
at the proposal of the board of directors, whether, and if so the amount thereof, dividends are to be distributed to the
shareholders of the Company, within the limits prescribed by the Law of 13 February 2007.
Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by law and subject to the decision of the board
of directors, be paid out on shares.
Dividends which are not claimed within a period of five (5) years starting from their payment date will become fore-
closed for their beneficiaries and will return to the Company.
In order to repay to the investor the proceeds of sales of any underlying assets and/or other income which will not
be subject to a further investment, the board of directors may, instead of either proposing a dividend payment to the
general meeting of shareholders or making an interim payment on dividends, decide to redeem shares or fractions thereof
in accordance with the terms of Article 12.2 above. The board of directors are authorised to make in-kind distributions/
payments of securities of portfolio companies with the consent of the shareholders.
9. Dissolution and Liquidation
Art. 34. Dissolution and Liquidation of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution taken
by the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements as defined in Article 18 hereof.
Whenever the capital falls below two thirds of the minimum capital as provided by the Law of 13 February 2007, the
board of directors has to submit the question of the dissolution of the Company to the general meeting of shareholders.
The general meeting for which no quorum shall be required shall decide on simple majority of the votes of the shares
presented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the general meeting of shareholders whenever
the capital falls below one quarter of the minimum capital as provided by the Law of 13 February 2007. In such event the
81758
L
U X E M B O U R G
general meeting shall be held without quorum requirements and the dissolution may be decided by the shareholders
holding one quarter of the votes present or represented at that meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net
assets of the Company have fallen below two thirds or one quarter of the legal minimum as the case may be.
The issue of new shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the general shareholders'
meeting, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.
One or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) shall be appointed by the general meeting of
shareholders, which shall as well determine their powers and their compensation, to realise the assets of the Company,
subject to the supervision of the relevant supervisory authority in the best interests of the shareholders.
The proceeds of the liquidation, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators among the holders
of shares in each class in accordance with their respective rights. The amounts not claimed by shareholders at the end
of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse des Consignations in
Luxembourg. If these amounts were not claimed before the end of a period of five (5) years, the amounts shall become
statute-barred and cannot be claimed any more.
Art. 35. Termination of a class of shares. The directors may decide at any moment the termination of any class of
shares. In the case of termination of a class of shares, the shareholders will see their shares compulsory redeemed for
cash at the net asset value per share determined on the day on which such decision shall take effect.
The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class of shares prior to the effective date of the
compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the redemption operations.
Any request for subscription for shares of such class of shares shall be suspended as from the moment of the an-
nouncement of the termination, of the relevant class of shares.
Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Custodian of the Company for a period of six (6) months thereafter; after such period, the assets will be deposited
with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.
All redeemed shares will be cancelled by the Company.
Art. 36. Expenses borne by the Company. Each of the Custodian, the Paying Agent and the Corporate Agent are
entitled to receive fees out of the assets of the Company, pursuant to the relevant agreements between each of them
and the Company and in accordance with customary banking practice. In addition, reasonable disbursements and out-of-
pocket expenses incurred by such parties are charged to the Company as appropriate.
The Company will also bear all other expenses incurred in the operation of the Company which include, without
limitation, fees payable to investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing
services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment
structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings,
maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and ad-
vertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses
of the directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other
expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and
the costs of publications.
The formation expenses of the Company will be borne by the Company and will not be written off.
The Company bears all its running costs as foreseen in Article 11 hereof.
Art. 37. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to
time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority voting requirements provided by the laws of
Luxembourg.
Art. 38. General provisions. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies, the
Law of 13 February 2007 and any other applicable law.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Name of shareholder
Subscribed
capital
Paid-in capital Number
of shares
Deutsche Ärzteversicherung AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- EUR 31,000.-
31
Proof of all such payments has been given as specifically stated to the undersigned notary.
<i>Annual reportsi>
The board of directors has to ensure that shareholders receive an audited annual report comprising information on
all investments made by the Company and details of the financial performance of the Company to each accounting year.
81759
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares that the conditions enumerated in article 26, 26-3 and 26-5 of the Luxembourg law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, are fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, which shall be borne by the Company as a result of its incorporation, are estimated at approximately
EUR 3,000.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named person, representing the entire subscribed capital took the following resolutions:
1. The following are elected as directors for a period of six (6) years ending on the date of the annual general meeting
of shareholders to be held in 2017:
- Mr Julien ALEX, professionally residing at 46, rue François Sébastien Tinant, L-2622 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg;
- Mr Manuel HAUSER, professionally residing at 20, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Grand-Duchy of Lu-
xembourg;
- Mr Olivier DECANNIERE, professionally residing at 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, France; and
- Mr Vincent GOMBAULT, professionally residing at 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, France.
2. The following is elected as independent auditor for a period ending on the annual general meeting of Shareholders
to be held in 2012:
- BDO Audit S.A., having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
3. The registered office of the Company is established at 46, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
person, this deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by its name, surname, status and
residence, the appearing person signed together with the notary the present original deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendelf, am neunzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Deutsche Ärzteversicherung AG, eine Gesellschaft, gegründet und bestehend gemäß den Gesetzen von Deutschland,
mit Geschäftssitz in Börsenplatz 1, 50667 Köln, Deutschland, ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Régis Galiotto,
geschäftsansässig in Luxemburg, kraft Vollmacht ausgestellt in Köln, am 13. Mai 2011.
Die zuvor erwähnte Vollmacht bleibt diesem Dokument beigefügt und wird zusammen mit ihr bei der Registrierungs-
behörde eingereicht werden.
Diese anwesende Partei, mit der oben erwähnten Befugnis handelnd, hat folgende Satzung für eine Aktiengesellschaft
aufgesetzt:
1. Name, Dauer, Gesellschaftszweck, Gesellschaftssitz
Art. 1. Name. Zwischen den Vertragsparteien und allen, welche Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden,
wird eine Gesellschaft gegründet in der Form einer Aktiengesellschaft ("société anonyme"), welche der Gattung der
Kapitalanlagegesellschaften mit veränderlichem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds ("Société d'Investissement à Ca-
pital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé") angehört, mit der Bezeichnung "AXA Alternative Participations IV,
SICAV-FIS" (nachfolgend die "Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Zeit gebildet.
Sie kann durch Beschluss der Aktionäre, welcher in den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Formen gefasst
wird, aufgelöst werden.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht in der direkten oder indirekten Anlage
durch zwischengeschaltete Organismen der zur Verfügung stehenden Mittel in jede Art von geeignetem Vermögen gemäß
dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der jeweils gültigen Fassung ("Gesetz vom 13.
Februar 2007"), vorausgesetzt, dass dieses Vermögen aus Anteilen an Gesellschaften besteht, einschließlich Anteilen an
Gesellschaften, die als Organismen für gemeinsame Anlagen oder andere Anlagevehikel gelten, und Beteiligungen an
81760
L
U X E M B O U R G
Personengesellschaften, mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse ihres Ver-
mögens zugutekommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, wie sie nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 gestattet und die direkt
oder zufällig mit den oben erwähnten verbunden sind, einschließlich des Haltens einer zusätzlichen Grundlage an Bargeld
oder anderen flüssigen Vermögens, wie z.B. Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds.
Die Gesellschaft darf keine Darlehen aufnehmen, außer Darlehen mit kurzer Laufzeit bis zu einem Gesamtbetrag von
10% der gesamten verbindlichen Kapitalzusagen, die von der Gesellschaft erhalten wurden (ob abgerufen oder nicht),
vorausgesetzt, dass das Darlehen mit den Marktstandards übereinstimmt.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch Beschluss des Verwaltungsrats
können Niederlassungen und Repräsentanzen im Großherzogtum oder im Ausland gegründet werden.
Im Falle, wo der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche oder mi-
litärische Entwicklungen stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung der Gesell-
schaft am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland
beeinträchtigen, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum Ende dieser außerordentlichen Gegebenheiten ins
Ausland verlegt werden; eine solche vorübergehende Maßnahme wird keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft
haben, welche unbeschadet einer solchen vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Ge-
sellschaft bleiben wird.
2. Gesellschaftskapital, Veränderungen des gesellschaftskapitals, Charakteristika der Aktien
Art. 5. Aktienkapital. Das Aktienkapital der Gesellschaft soll zu jedem Zeitpunkt gleich dem (gemäß dem nachfolgenden
Artikel 11 berechneten) Gesamt-Nettoinventarwert der Gesellschaft betragen. Das Aktienkapital der Gesellschaft muss
eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) innerhalb der ersten zwölf (12) Monate nach der Gründung
der Gesellschaft erreichen und darf danach diesen Betrag nicht unterschreiten.
Das Anfangskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), voll eingezahlt und eingeteilt
in einunddreißig (31) Aktien ohne Nennwert der Klasse A, wie in Artikel 8 der vorliegenden Statuten beschrieben.
Die Basiswährung der Gesellschaft ist der Euro ("EUR").
Art. 6. Schwankungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von neuen voll
eingezahlten Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs durch die Gesellschaft von bestehenden Aktien ihrer
Aktionäre erhöhen oder vermindern.
Art. 7. Aktienklassen.
Der Verwaltungsrat kann jederzeit neue Aktienklassen ausgeben. Diese neue Aktienklassen können, inter alia, in der
Gebührenstruktur, der Währung, der Dividendenpolitik, und den Zielinvestoren abweichen.
Am Anfang wird eine Klasse Aktien, die Aktienklasse A, ausgegeben. Andere Aktienklassen, wenn einmal geschaffen,
werden entsprechend der genaueren Beschreibung in der jeweils aktuellen Ausgabe des Prospektes der Gesellschaft in
ihren Charakteristika abweichen.
Art. 8. Form der Aktien. Die Gesellschaft wird Aktien als Namensaktien ausgeben.
Die Aktien werden als Namensaktien mit oder ohne Bestätigungsschreiben ausgegeben. Jedoch gilt der Eintrag des
Aktieninhabers im Aktienregister als zweifelfreier Beweis seines Eigentumsrechts. Wird ein Aktienzertifikat bei der
Zeichnung angefragt, trägt der Zeichner das Risiko und etwaige daraus entstehende zusätzliche Kosten. Inhaber solcher
Aktienzertifikate müssen diese zurückbringen und ordnungsgemäß aufgeben, ehe Umtausch-oder Rückzahlungsanwei-
sungen ausgeführt werden können.
Ein Aktienregister wird von einem ordnungsgemäß ernannten Bevollmächtigten der Gesellschaft geführt. In diesem
Register ist der Name, Wohnort oder gewähltes Domizil von jedem Aktieninhaber, die Anzahl der von ihm gehaltenen
Aktien, die Klasse von jeder Aktie, der für jede Aktie bezahlten Betrag, der Transfer der Aktien und die Daten von solchen
Transfers, eingetragen. Dieses Register ist für das Besitzverhältnis der Aktien beweiskräftig. Die Gesellschaft behandelt
den eingetragenen Aktieninhaber als den absoluten Eigentümer und den wirtschaftlichen Berechtigten.
Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche in das Aktienregister
eingetragen wird und welche datiert und durch den Käufer und den Veräußerer oder durch Personen, welche vertre-
tungsberechtigt sind, unterschrieben wird, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere, für sie zulässige Beweise
einer Aktienübertragung annehmen.
Jeder Aktionär von Namensaktien muss der Gesellschaft eine Adresse zwecks Eintragung im Aktienregister mitteilen.
Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Aktionären von Namensaktien können rechtsver-
bindlich an diese Adresse gesandt werden. Ein Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderung seiner
Adresse im Aktienregister beantragen. Falls ein Inhaber von Namensaktien der Gesellschaft keine Adresse mitgeteilt hat,
ist die Gesellschaft berechtigt, anzunehmen, dass die erforderliche Adresse des Aktionärs sich am Sitz der Gesellschaft
befindet.
Aktien werden nur ausgegeben und Aktienzertifikate, insofern sie beantragt sind, werden nur geliefert, nachdem die
Zeichnung angenommen und der Zeichnungspreis unter den Bedingungen des Prospektes eingegangen ist.
81761
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus der oder den Aktien hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, an
dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeug-
ender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat einer ihm gehörender Aktie abhanden gekommen ist oder zerstört
wurde, kann auf seinen Antrag hin die Gesellschaft ein Ersatzzertifikat ausgeben, unter den Bedingungen und Garantien,
welche die Gesellschaft festlegen kann, mit einbegriffen eine Gebühr oder eine Urkundenüberprüfung oder Urkunden-
forderung, welche durch eine Bank, einen Börsenmakler, oder einer anderen Partei, zur Zufriedenheit der Gesellschaft,
unterschrieben ist. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf welchem vermerkt wird, dass es sich um ein
Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.
Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausge-
tauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und
werden von derselben umgehend für ungültig erklärt. Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Akti-
onär Ersatz in angemessener Höhe für die Kosten zu verlangen, welche ihr durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen
Aktienzertifikates oder durch die Annullierung des alten Aktienzertifikates entstanden sind.
Art. 10. Einschränkungen der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien der Gesellschaft dürfen nur besessen werden von
und sind frei übertragbar zwischen sachkundigen Investoren im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 und zu jeder
Zeit sind Individuen und Personen ausgeschlossen, welche nicht als Kapitalgesellschaften für deutsche steuerrechtliche
Zwecke gelten und welche eine oder mehrere Individuen als Mitglieder oder Eigentümer haben ("Sachkundige Investo-
ren"). Weder die Ausgabe noch die Übertragung von Aktien darf dazu führen das Aktien von mehr als einhundert (100)
Sachkundigen Investoren gehalten werden.
Die Gesellschaft kann den direkten oder indirekten Besitz von Aktien der Gesellschaft durch bestimmte natürliche
oder juristische Personen oder Personengesellschaften einschränken oder verbieten, wenn die Gesellschaft nach eigenem
Ermessen der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz zu Lasten der Interessen der bestehenden Aktionäre oder der Gesell-
schaft geht oder wenn ein solcher Besitz eine Verletzung einer gesetzlichen Bestimmung oder Regulierung des Großher-
zogtums Luxemburg oder eines anderen Landes mit sich zieht oder bewirken kann oder wenn durch einen solchen Besitz
die Gesellschaft mit steuerlichen Nachteilen, Geld-oder anderen Strafen, zu rechnen hat, denen sie andernfalls nicht
ausgesetzt worden wäre ("Ausgeschlossener Investor"). Solche natürlichen oder juristische Personen oder Personalge-
sellschaften sind durch den Verwaltungsrat festzustellen.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen und ohne Haftung:
a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktienregister verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese
Ausgabe oder Umschreibung zur Folge haben kann oder wird, dass der Aktienbesitz an eine Person übergeht, die nicht
berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen; oder
b) den Zwangskauf von allen Aktien, welche von einem Aktionär gehalten werden, tätigen, wenn der Gesellschaft
offenkundig wird, dass eine Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder aber
zusammen mit einer anderen Person, wirtschaftlicher Berechtigter dieser Aktien ist; oder
c) wenn der Gesellschaft offenkundig wird, dass eine oder mehrere Personen einen solchen Anteil der Aktien der
Gesellschaft halten, dass die Steuergesetze oder andere Verordnungen von anderen Gerichtsbarkeiten als jene von Lu-
xemburg auf die Gesellschaft anwendbar werden könnten, den Zwangsrückkauf von allen oder einem Teil der von solchen
Aktionären gehaltenen Aktien tätigen.
In diesen in (a) bis (c) (einbegriffen) aufgezählten Fällen wird folgendes Verfahren angewandt:
1) Die Gesellschaft sendet dem Aktionär, der die dem Zwangsrückkauf ausgesetzten Aktien besitzt, eine Benachrich-
tigung (nachstehend "Rückkaufsbenachrichtigung" genannt) zu; die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die, wie erwähnt,
zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Eine
solche Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an seine im Aktienregister eingetragene
Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das Aktienzer-
tifikat, falls ausgegeben, das die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien darstellt, zurückzugeben. Sofort
nach Geschäftsschluss am Tag, der in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben ist, hört der Aktionär auf, Eigentümer
derjenigen Aktien zu sein, die in der Rückkaufsbenachrichtigung erwähnt sind, und das Aktienzertifikat, falls ausgegeben,
welche die entsprechenden Aktien darstellt, wird in den Büchern der Gesellschaft annulliert.
2) Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (der "Rück-
kaufspreis"), ist gleich dem Nettoinventarwert der Aktien der Klasse, zu der die Aktien jeweils gehören, so wie dieser
am Tag der Rückkaufsbenachrichtigung gemäß Artikel 11 der vorliegenden Statuten festgestellt wird, zuzüglich einer
Rückkaufgebühr oder eines Austrittsrechts, falls anwendbar.
3) Vorbehaltlich aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen wird der Rückkaufspreis dem
Eigentümer jener Aktien in der Währung der betreffenden Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder
anderswo ansässigen Bank (welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde) hinterlegt zwecks Zahlung an
den Besitzer gegen Rückgabe des Aktienzertifikates, das, falls ausgegeben, die in der Rückkaufbenachrichtigung angege-
benen Aktien darstellt. Sobald der Preis gemäß diesen Bedingungen hinterlegt wurde, kann keine Person, die in der
81762
L
U X E M B O U R G
Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien erwähnt wurde, Anspruch auf diese Aktien geltend machen; außerdem
kann keine Person rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft oder ihre Guthaben unternehmen, außer das Recht des
Aktionärs, welcher sich als Besitzer der Aktien ausweist, den hinterlegten Preis (ohne Zinsen) bei der Bank gegen Rück-
gabe des Aktienzertifikates ausgezahlt zu bekommen, wie vorgehend erläutert.
4) Die Ausübung durch die Gesellschaft der ihr durch diesen Artikel 10 zugestandenen Befugnisse kann in keinem Fall
mit der Begründung, dass es zum Zeitpunkt der Rückkaufbenachrichtigung keinen ausreichenden Nachweis des Besitzes
der Aktien durch eine Person gab, in Frage gestellt oder für ungültig erklärt werden, unter der Bedingung, dass die
Gesellschaft ihre Befugnisse in gutem Glauben ausführte.
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen und ohne Haftung bei Aktionärsversammlungen denjenigen Personen,
denen es nicht erlaubt ist Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.
Insbesondere kann die Gesellschaft den Besitz von Aktien der Gesellschaft durch jede "US Person" einschränken oder
verbieten. Der Ausdruck "US Person", so wie dieser Ausdruck in der vorliegenden Satzung gebraucht wird, bedeutet
jeder Staatsangehöriger oder Einwohner der Vereinigten Staaten oder eines ihrer Territorien oder Besitztümer oder
Gegenden unter ihrer Gerichtsbarkeit.
Ungeachtet jeder Vorschrift dieser Satzung, hat ein Aktionär der Gesellschaft, der ein Deutsches Versicherungsun-
ternehmen ist, das Recht, zu jeder Zeit, sämtliche oder Teile seiner Aktien ohne die vorherige Zustimmung der
Gesellschaft oder eines anderen Aktionärs auf einen Übertragungsempfänger zu übertragen, der eine Zeichnungsverein-
barung unterschreibt und als Sachkundiger Investor gilt und der kein Ausgeschlossener Investor ist und vorausgesetzt,
dass die Übertragung keine Auswirkung auf die Anzahl der Aktionäre in der Weise hat, dass sie einhundert (100) über-
steigt. Bei der Übertragung sämtlicher oder Teile der Aktien durch ein Deutsches Versicherungsunternehmen, akzeptiert
und wird ausschließlich der Übertragungsempfänger haftbar für alle Haftungen und Verpflichtungen in Bezug auf diese
Aktien, einschließlich der gemäß dieser Satzung, und das übertragende Deutsche Versicherungsunternehmen wird von
diesen Haftungen und Verpflichtungen entbunden (und hat keine weiteren Haftungen irgendeiner Natur, nicht einmal eine
zweitrangige oder gesamtschuldnerische Haftung).
Insoweit und so lange ein Deutscher Versicherungsunternehmer Aktien als Teil seines Sicherungsvermögens (i.S.d. §
66 oder § 115 des Versicherungsaufsichtsgesetzes („VAG“)) und ein solches Deutsche Versicherungsunternehmen ent-
weder in Übereinstimmung mit § 70 VAG rechtlich dazu verpflichtet ist, einen Treuhänder zu ernennen, oder ähnlichen
rechtlichen Voraussetzungen unterliegt, kann ein solches Deutsches Versicherungsunternehmen solche Aktien nur mit
der vorherigen schriftlichen Zustimmung dieses Treuhänders oder seines bevollmächtigten Vertreters, der in Überein-
stimmung mit § 70 VAG in seiner gültigen Fassung ernannt wurde, verkaufen. „Verkauf“ beinhaltet, ist aber nicht
beschränkt auf, jeden Umtausch, Übertragung oder Übereignung sämtlicher oder Teile der Aktien, die von einem solchen
Deutschen Versicherungsunternehmen gehalten werden.
Für die Zwecke dieses Artikels beinhaltet der Begriff „Deutsches Versicherungsunternehmen“ jedes deutsches Ver-
sicherungsunternehmen, Pensionskasse oder Pensionsfonds (einschließlich Versorgungswerken) und jegliche Rechtsträ-
ger, die den Anlagebeschränkungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterliegen, die Aktien der Gesellschaft als Teil
ihres Sicherungsvermögens oder sonstiges gebundenes Vermögen (i.S.d. § 66 und 54 Abs. 1 oder § 115 VAG) halten.
3. Nettoinventarwert, Ausgabe und Rückkauf von Aktien, Aussetzung der Berechnung des nettoinven-
tarwertes
Art. 11. Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert per Aktie jeder Aktienklasse der Gesellschaft wird periodisch
durch die Gesellschaft berechnet, wie der Verwaltungsrat es bestimmen wird, aber in keinem Falle weniger als einmal im
Monat (der Tag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als "Be-
wertungstag" bezeichnet). Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag oder einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt,
ist der Bewertungstag der darauffolgende volle Arbeitstag in Luxemburg.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wird an jedem Bewertungstag in der jeweiligen Referenzwährung der Gesellschaft
ausgedrückt und wird für jede Aktienklasse dadurch bestimmt, dass das der betreffenden Aktienklasse zugewiesene Ver-
mögen der Gesellschaft, minus die der betreffenden Aktienklasse zugewiesene Passiva der Gesellschaft, durch die Zahl
der an einem Bewertungstag im Umlauf befindlichen ausgegebenen Aktien derselben Aktienklasse geteilt wird.
Die Bewertung des Nettoinventarwertes pro Aktie der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt ausgeführt:
a) Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden durch die Anwendung folgender Prinzipien bestimmt:
- Die Beteiligung der Gesellschaft in der Anlagestruktur wird wie folgt bewertet (sowohl im Bezug auf Aktien, als auf
Schuldverschreibungen):
- Jede Beteiligung der Gesellschaft an der Anlagestruktur wird den Kosten zufolge bewertet, solange kein Bericht
vorliegt;
- Liegt ein Bericht, die Anlagestruktur betreffend, vor, so wird die Anlagestruktur aufgrund des letzten verfügbaren
Berichts bewertet, solange kein bedeutendes Bewertungsereignis ("Bewertungsereignis") eintritt. Folgende Ereignisse
gelten als Bewertungsereignis: Kapitalabruf, Ausschüttung von Dividenden oder Rückkäufe durch die Anlagestruktur selbst
oder durch eine oder mehrere ihrer unterliegenden Kapitalanlagen, ebenso wesentliche Ereignisse oder Entwicklungen
welche die Anlagestrukturen selbst oder eine der unterliegenden Kapitalanlagen betreffen/beeinträchtigen.
- Das Auftreten eines Bewertungsereignisses wird berücksichtigt.
81763
L
U X E M B O U R G
- Die Bewertung von Direktinvestitionen, in Form von Ko-Investitionen, entspricht ebenfalls der oben beschriebenen
Methode.
- Wird ein Nettoinventarwert für die von der Anlagestruktur emittierten Anteile und Aktien festgelegt, so werden
diese Anteile und Aktien anhand des letzten vorliegenden Nettoinventarwerts bewertet, welcher gemäß den Bestim-
mungen der Emissionsdokumente der Anlagestruktur festgelegt wird. Sollte ein Bewertungsereignis auftreten, welches
sich nicht im letzten verfügbaren Nettoinventarwert auf diese, von der Anlagestruktur emittierten Anteile oder Aktien
wiederspiegelt, kann dieses Bewertungsereignis bei der Bewertung dieser, von der Anlagestruktur emittierten Anteile
oder Aktien, berücksichtigt werden.
- Der Wert von Kassenguthaben oder Barsicherheiten, von Wertpapieren und Sichtwechseln, von Kontoforderungen,
im Voraus bezahlte Kosten, ebenso wie von Dividenden und angekündigten Zinsen oder angefallene und noch nicht
aufgelaufene Zinsen als Wert wird der ganze Nennwert angenommen, außer wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass
dieser Wert voll bezahlt werden wird oder eingenommen werden kann, wobei in diesem Falle der Wert nach Abzug
eines Betrages, der vom Verwaltungsrat als angemessen angesehen wird, bestimmt wird um den richtigen Wert darzu-
stellen;
- Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden,
werden zum letzten verfügbaren Verkaufskurs bewertet, es sei denn dieser ist nicht repräsentativ;
Falls der letzte verfügbare Verkaufskurs von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten welche an einer Börse oder
einem anderen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, in der Auffassung des Verwaltungsrates nicht
marktgerecht sind, werden diese vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt. Es handelt sich in diesem Fall um
den Anschaffungswert, es sei denn der Verwaltungsrat hält eine Wertreduzierung für angemessen in Betracht des Aus-
sichten der Gesellschaft, oder eine Wertänderung ist aufgrund eines bedeutsamen Geschäftes von diesen Wertpapieren
durch Dritte gerechtfertigt.
- Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, an einem anderen Markt gehandelt werden, werden auf der
Basis des letzten verfügbaren Verkaufspreises bewertet.
- Alle anderen Wertpapiere und sonstige Guthaben werden vom Verwaltungsrat anhand von vernünftigerweise vor-
hersehbaren Verkaufseinnahmen, die der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festgelegt bewertet.
- Falls, aufgrund besonderer Umstände, die Bewertung nach den obigen Regeln nicht mehr möglich ist oder unzuver-
lässig wird, werden andere Bewertungskriterien, welche allgemein anerkannt und nachweisbar sind, angewandt um eine
angemessene Bewertung zu erreichen.
Die Gesellschaft kann alle Arten an geeignetem Vermögen gemäß dem Gesetz von 2007 erhalten, falls die Gesellschaft
eine Sachausschüttung von zugrunde liegenden Investitionen bekommt.
Vermögenswerte die nicht in der Währung der Klasse ausgedrückt sind, der sie angehören, werden in die Währung
dieser Klasse zum gegebenen Wechselkurs des betroffenen Arbeitstages oder zu dem vertraglich festgelegten Wechsel-
kurs umgerechnet.
Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden, welche auf eine andere Devise als die Referenzwährung
lauten, werden in die Referenzwährung zum offiziellen, am entsprechenden Bewertungstag geltenden Wechselkurs, um-
gerechnet.
b) Als Verpflichtungen der Gesellschaft werden betrachtet:
- alle Anleihen, angefallene Wechsel und zu zahlende Abrechnungen;
- sämtliche fällige und zahlbare Verwaltungskosten (darin einschließlich Kosten für Anlageberatung, Unternehmens-
beratung und Verwaltung, falls vorhanden, Kosten für die Depotbank, die Zahlstelle und die Zentraladministration);
- alle bekannten, fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten, darin einbegriffen sämtliche fälligen vertraglichen
Verpflichtungen, welche eine Zahlung in bar oder in Naturalien vorsehen;
- angemessene vom Verwaltungsrat bestimmte Rückstellungen für zukünftig fällige Steuern, die auf das Vermögen und
Einkommen bis zum entsprechenden Bewertungstag basieren, und andere durch den Verwaltungsrat genehmigte oder
gebilligte Reserven, falls vorhanden; und
- alle anderen Verpflichtungen der Gesellschaft, welcher Natur und Art sie auch seien, abgesehen von solchen, die
durch die Aktien der Gesellschaft dargestellt werden. Um den Betrag dieser Verpflichtungen zu bestimmen, berücksichtigt
die Gesellschaft alle von ihr zu tragenden und erwachsenen Ausgaben und darin können unter anderem einbegriffen sein:
die Vergütungen und Kosten für die Depotbank, die Zahlstelle und die Zentraladministration, den/die Anlageberater,
Unternehmensberater oder Verwalter (falls vorhanden); die Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der
Jahresberichte, die Kosten der sorgfältigen Prüfung der Anlagen, die Kosten für Büro und Personal, für Zwischengesell-
schaften, durch Anlagestruktur oder Direktanlagen bedingte Zahlungen (z.B. im Bezug auf Verwaltungskosten und
Kapitalabrufkosten), die Kosten der Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzer-
tifikate, der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs-und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten,
das Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessenen Out-of-Pocket Kosten der Direktoren,
die Kosten der Anreise der Aktieninhaber (zur Generalversammlung der Aktionäre), Registrierungsgebühren und andere
den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlende Kosten, Versicherungskosten, Zinsen,
Brokergebühren und die Kosten von Veröffentlichungen. Die Gesellschaft kann Verwaltungs-und sonstige Kosten regel-
81764
L
U X E M B O U R G
mäßiger oder wiederkehrender Art auf der Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere Perioden im Voraus
rechnen und diese in gleichen Raten über einen solchen periodischen Zeitraum zusammenfassen.
Aktien, die im Begriff sind, von der Gesellschaft zurückgekauft zu werden, gelten als ausgegeben bis zum Geschäfts-
schluss des jeweiligen Bewertungstages, welcher auf den Rückkauf anwendbar ist. Der Rückkaufpreis gilt als Verbindlich-
keit der Gesellschaft ab dem Geschäftsschluss des besagten Tages bis zur Zahlung.
Die im Zusammenhang mit eingegangenen Kaufaufträgen ausgegebene Aktien gelten ab Geschäftsschluss am jeweilig
für die Zeichnung anwendbaren Bewertungstag als ausgegebene Aktien. Der Rückkaufspreis gilt als Forderung der Ge-
sellschaft ab dem Geschäftsschluss des besagten Tages und so lange, bis dieser Preis bezahlt ist.
Soweit wie möglich gehen alle Anlagen und Verkäufe, welche durch die Gesellschaft bis zu einem Bewertungstag
beschlossen und vollzogen werden, in die Bewertung ein.
Art. 12. Ausgabe, Rückkauf und Umtausch von Aktien.
12.1 Ausgabe von Aktien
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu jeder Zeit weitere voll eingezahlte Aktien jeder Aktienklasse auszugeben, ohne
den bestehenden Aktieninhabern ein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu erteilen und vorausgesetzt das Aktien an nicht
mehr als einhundert (100) Sachkundige Investoren ausgegeben werden, und zwar zu einem Preis, der auf dem gemäß
Artikel 11 dieser Satzung berechneten Nettoinventarwert pro Aktie der jeweiligen Aktienklasse, an einem Bewertungs-
datum, das entsprechend der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmten Politik festgelegt wird. Dieser Preis kann
durch eine prozentualen Provision für bei der Investition des Ertrages anfallende Kosten eventuell und anfallende Rück-
kaufgebühren und wie von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Direktor der Gesellschaft oder andere Personen
ermächtigen, Zeichnungen anzunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen.
Um gültig zu sein, muss jede neue Zeichnung von Aktien voll eingezahlt sein; die ausgegebenen Aktien haben dieselben
Rechte wie diejenigen Aktien, welche am Tage der Aktienausgabe in Umlauf waren.
Der Emissionspreis ist innerhalb der im Gesellschaftsprospekt festgelegten Frist zu zahlen.
Der Verwaltungsrat kann nach Belieben eine Aktienausgabe als Gegenleistung für einen Beitrag in Wertpapieren ent-
scheiden, entsprechend den Bedingungen der Luxemburger Gesetzgebung, insbesondere der Verpflichtung einen Wer-
tungsbericht eines Wirtschaftsprüfers ("réviseur d'entreprise agréé") zu liefern.
Falls der Verwaltungsrat bestimmt, dass die Annahme einer Zeichnung von Aktien der Gesellschaft, deren Wert mehr
als 10 % des Nettovermögens der Gesellschaft darstellt, den bestehenden Aktionären schaden kann, kann er die Annahme
der Zeichnung aufschieben und in Absprache mit dem neuen Aktionär, ihn dazu auffordern, die Zeichnung über einen
bestimmten Zeitraum zu staffeln.
Die Gesellschaft kann eine Zeichnung teilweise oder ganz zurückweisen und der Verwaltungsrat kann, nach eigenem
Ermessen und ohne Haftung und ohne Ankündigung, die Ausgabe und den Verkauf von Aktien jeder Aktienklasse abbre-
chen.
12.2 Rückkauf von Aktien
Der Verwaltungsrat kann, von Zeit zu Zeit, wenn er es für angemessen hält, sich für den Rückkauf von Aktien oder
von Bruchteilen dieser entscheiden. Der Entschluss zum Rückkauf ist für alle Aktieninhaber bindend und wirkt sich pro-
portional auf ihrem Aktienbesitz aus. Jedoch sind die Aktien nicht auf einseitige Anfrage der Aktieninhaber rückzahlbar.
Die Gesellschaft wird die eingetragenen Aktieninhaber rechtzeitig, in einem an sie adressierten Schreiben, über den
Rückkauf benachrichtigen. Diese Mitteilung beinhaltet die Dauer des Rückkaufs, das angewandte Berechnungsverfahren
des Rückkaufpreises, welcher am letzten Tag der Rückkaufsfrist bestimmt wird und dem Nettoinventarwert der Aktien
am letzten Tag der Rückkaufsfrist entspricht.
Der Verwaltungsrat kann nach Belieben die Aktieninhaber auffordern die Rückzahlung ganz oder teilweise als Sach-
leistung in Form einer Wertpapierverteilung an Stelle von Bareinlagen anzunehmen.
Die ausgezahlten Aktien werden storniert. Der Rückkaufpreis wird innerhalb der im Prospekt der Gesellschaft fest-
gelegten Frist bezahlt.
12.3 Umtausch von Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse
Der Umtausch von Aktien einer Klasse in Aktien einer anderen Aktienklasse ist ausgeschlossen.
Art. 13. Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, des Rückkaufs und des Umtauschs
von Aktien. Die Gesellschaft ist dazu befugt, die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie in den folgenden Fällen
einzustellen:
a) falls ein Zustand besteht der in der Meinung des Verwaltungsrats als ein Notfall einzustufen ist, in der Hinsicht wo
die Veräußerung oder die Bewertung der Aktiva der Gesellschaft undurchführbar ist;
b) falls die Kommunikationsmittel und Datenverarbeitungssysteme, die normalerweise zur Bestimmung des Wertes
der Anlagen der Gesellschaft oder der aktuellen Preise auf den Märkten oder Börsen gebraucht werden, außer Betrieb
sind, hinsichtlich der Aktiva der Gesellschaft;
81765
L
U X E M B O U R G
c) falls Einschränkungen, Währungswechsel oder Kapitalgeschäfte betreffend, die Abwicklung eines Geschäfts im Auf-
trag der Gesellschaft verhindern;
d) wenn aus irgend einem anderen Grund der Wert einer Anlage nicht rasch und genau festgelegt werden kann;
e) ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Einberufung zu einer Generalversammlung der Aktionäre, in der über
die Auflösung der Gesellschaft Beschluss gefasst werden soll.
Unter außergewöhnlichen Bedingungen, welche die Rechte der Aktionäre nachteilig beeinflussen können, behält sich
der Verwaltungsrat das Recht vor, erst die notwendigen Verkäufe von Kapitalanlagen durchzuführen, bevor der Preis, zu
dem die Aktionäre einen Rückkauf ihrer Aktien erhalten, bestimmt wird. In einem solchen Fall werden schwebende
Zeichnungen und Rückkäufe auf der Basis des derartig nach den notwendigen Verkäufen berechneten Nettoinventar-
wertes gehandhabt.
Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie kann durch angemessene Mittel veröffentlicht
werden, falls die Dauer einer solchen Einstellung eine gewisse Zeitspanne überschreitet.
Schwebende Anträge auf Zeichnung, von Aktien können durch schriftliche Benachrichtigung zurückgezogen werden,
unter der Bedingung, dass die Gesellschaft die entsprechende Benachrichtigung vor dem Ende des Schwebezustandes
erhält.
Derart schwebende Zeichnungen und Rückkäufe von Aktien werden am ersten Bewertungstag nach der Wiederauf-
nahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie durch die Gesellschaft getätigt.
4. Investmentpolitik und Beschränkungen
Art. 14. Allgemeine Bestimmungen. Der Verwaltungsrat hat, aufgrund des Prinzip der Risikostreuung, die Berechtigung
die Geschäfts-und Investmentpolitik bezüglich der Investments und die Handhabungsweise der Verwaltungs-und Ge-
schäftsangelegenheiten der Gesellschaft festzulegen, die sich alle innerhalb der Befugnisse und Beschränkungen befinden,
wie in dem Prospekt der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Gesetzen und Verordnungen von
dem Verwaltungsrat dargestellt.
Die Risikostreuungserfordernisse können nicht, wie im Prospekt der Gesellschaft festgelegt, während des Anlaufzeit-
raums angewendet werden.
5. Generalversammlungen
Art. 15. Allgemeine Bestimmungen. Die ordnungsgemäß gebildete Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft
vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen,
durchzuführen oder zu bestätigen.
Art. 16. Jährliche Generalversammlung. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre wird gemäß der luxembur-
gischen Gesetzgebung in Luxemburg, am Firmensitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der in
der Einberufung festgelegt wird, am dritten Freitag im März um 12:30 Uhr abgehalten, und zum ersten Mal im Jahre 2012.
Falls dieser Tag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden
Bankarbeitstag abgehalten. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwal-
tungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Andere Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in der Einberufung zur je-
weiligen Versammlung angegeben ist.
Art. 17. Generalversammlungen von Aktionären von Aktienklassen. Die Aktionäre einer Aktienklasse können zu jeder
Zeit eine Generalversammlung einberufen, um über Angelegenheiten, welche ausschließlich jene Aktienklasse betreffen,
zu entscheiden. Es gelten die Regeln die in dieser Satzung vorgesehen sind, sowie das luxemburgische Gesetz vom 10.
August 1915, so wie es danach abgeändert worden ist und werden wird.
Art. 18. Funktionsweise der Generalversammlungen. Die Einberufungen, sowie die Quoren und die Fristen, ebenso
der Ablauf der Versammlungen der Aktionäre, müssen, soweit die vorliegende Satzung nichts anderes bestimmt, den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Jede Aktie gibt ungeachtet der Klasse der sie angehört, das Recht auf eine Stimme unter Vorbehalt der Einschränkungen,
die durch die vorliegenden Statuten verfügt werden. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre teilneh-
men, indem er schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax eine andere Person als seinen Bevollmächtigten
angibt. Teile einer einzelnen Aktie geben kein Anrecht auf eine Stimme.
Sofern das Gesetz oder die vorliegende Satzung nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidungen der ord-
nungsgemäß einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch einfache Mehrheit der anwesenden und mitbe-
stimmenden Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an den Ge-
neralversammlungen teilnehmen zu können.
Außerdem werden die Aktionäre jeder Klasse getrennt beraten und unter den gesetzlich vorgesehenen Quorums-und
Mehrheitsbedingungen über folgende Punkte abstimmen:
1. Gewinnverwendung ihrer Aktienklasse; und
81766
L
U X E M B O U R G
2. Entscheidungen, welche die Rechte der Aktionäre einer Aktienklasse gegenüber anderen Aktienklassen betreffen.
Art. 19 Einberufungen zu den Generalversammlungen. Die Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat einberufen.
Soweit gesetzlich erforderlich, wird das Einberufungsschreiben im Mémorial in Luxemburg sowie in einer luxemburgischen
Zeitung und in anderen, vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen veröffentlicht.
6. Verwaltung der gesellschaft
Art. 20. Verwaltung. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht,
verwaltet; die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein.
Art. 21. Dauer des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder, Erneuerung des Verwaltungsrats. Die Verwaltungsrats-
mitglieder werden durch die Generalversammlung für einen Zeitraum, der sechs (6) Jahre nicht überschreiten kann,
gewählt. Sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt wurden und im Amt sind. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mit
oder ohne Begründung jederzeit durch eine Entscheidung der Generalversammlung abberufen und/oder ersetzt werden.
Im Falle einer Vakanz eines Verwaltungsratsmitgliedes, aufgrund von Tod, Pension oder aus einem anderen Grund,
können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung einberufen und durch eine mehrheitliche Abstimmung
ein Verwaltungsratsmitglied bestimmen, um diese Vakanz auf einer provisorischen Basis bis zur nächsten Generalver-
sammlung zu füllen.
Art. 22. Präsidium des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden sowie
einen oder mehrere stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Ferner kann er einen Sekretär ernennen, der nicht Verwal-
tungsratsmitglied sein muss und der für die Redaktion der Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats und der
Versammlungen der Aktionäre verantwortlich ist.
Art. 23. Versammlungen und Beratungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von
zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern an dem Ort, das in dem Einberufungsschreiben angegeben ist, einberufen.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats steht jeder der Versammlungen des Verwaltungsrats und der Aktionäre vor, in
seiner Abwesenheit können jedoch die Aktionäre oder der Verwaltungsrat mit einfacher Mehrheit ein anderes Verwal-
tungsratsmitglied zum Vorsitzenden der Versammlung ernennen. Bei einer Generalversammlung der Aktionäre an der
kein Verwaltungsratsmitglied anwesend ist, kann jede andere Person ernannt werden, um den Vorsitz dieser Versammlung
zu übernehmen.
Der Verwaltungsrat kann Direktoren der Gesellschaft ernennen, inbegriffen einen Generaldirektor, beigeordnete Di-
rektoren, beigeordnete Sekretäre und andere Direktoren, die für die Angelegenheiten der Gesellschaft zu führen als nötig
empfunden werden. Solche Ernennungen können zu jedem Zeitpunkt durch den Verwaltungsrat zurückgezogen werden.
Die Direktoren brauchen keine Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre der Gesellschaft zu sein. Sofern die Satzung
es nicht anderes vorsieht, haben die Direktoren diejenigen Vollmachten und Pflichten, die ihnen vom Verwaltungsrat
erteilt worden sind.
Eine schriftliche Einberufung zu jeder Versammlung des Verwaltungsrats wird an alle Verwaltungsratsmitglieder min-
destens drei (3) Tage vor der Stunde, die für die Versammlung vorgesehen ist, ausgegeben, außer im Falle einer
Dringlichkeit, wobei in diesem Fall die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben
werden. Ein Einberufungsschreiben ist nicht notwendig, falls jedes Verwaltungsratsmitglied dazu seine schriftliche Zu-
stimmung, durch Kabel, Telegramm, Telex, oder Telefax gegeben hat. Für eine Versammlung des Verwaltungsrats, die zu
einer Stunde und an einem Ort abgehalten wird, welche in einer Entscheidung, die vorher durch den Verwaltungsrat
angenommen wurde, festgelegt worden ist, ist eine besondere Einberufung nicht notwendig.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Versammlung des Verwaltungsrats durch ein schriftlich, durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telefax bevollmächtigten anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied, das nicht physisch am Versammlungsort anwesend ist, kann an einer solchen Ver-
sammlung per Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmittel, bei denen alle an der Versammlung teilnehmen-
den Personen sich gegenseitig hören können, teilnehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung durch solche Mittel ist
der persönlichen Anwesenheit an einer solchen Versammlung gleichgestellt.
Die Gesellschaft kann nicht durch die einzelne Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet werden, es sei
denn es besitzt eine ausdrückliche Vollmacht durch einen Beschluss des Verwaltungsrats.
Gültig verhandeln und handeln kann der Verwaltungsrat nur, wenn mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglie-
der bei der Versammlung des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten sind. Entscheidungen werden durch einfache
Mehrheit der Stimmen der anwesenden beziehungsweise vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen. Der Vorsit-
zende des Verwaltungsrates hat die ausschlaggebende Stimme.
Von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterschriebene Entscheidungen sind ebenso gültig und durchführbar wie
jene, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und durchgeführten Versammlung getroffen werden. Diese Un-
terschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehrere Kopien derselben Entscheidung gemacht werden
und können durch Brief, Kabel, Telegramm, Telex, Telefax und ähnlichen Mitteln belegt werden. Als Datum eines solchen
Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.
81767
L
U X E M B O U R G
Was die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie Handlungen im Rahmen der Gesellschaftspolitik und des Gesell-
schaftszweckes angeht, kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse an juristische Personen oder an natürliche Personen,
die nicht Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen, delegieren.
Art. 24. Versammlungsprotokolle. Die Versammlungsprotokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats werden
durch den Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, durch dasjenige Verwaltungsratsmitglied, das den Vorsitz zeitweilig
übernommen hat, unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge von Protokollen, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden sollen, werden durch
den Vorsitzenden, den Sekretär oder durch zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.
Art. 25. Vertretung der Gesellschaft gegenüber Drittpersonen. Rechtlich gebunden wird die Gesellschaft durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die einzelne Unterschrift eines bevoll-
mächtigten Direktors oder anderen Bevollmächtigten der Gesellschaft, der die entsprechende Vollmacht erhalten hat,
oder durch die einzelne Unterschrift jeder anderen Person, der der Verwaltungsrat eine entsprechende Vollmacht ge-
geben hat.
Art. 26. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat bestimmt durch die Anwendung des Prinzips der Risi-
koverteilung die generelle Linie der Vermögensverwaltung und die Investitionspolitik ebenso wie die Richtlinien, die in
der Verwaltung der Gesellschaft zu befolgen sind.
Art. 27. Interessenkonflikte. Kein Vertrag und kein Vergleich, den die Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder
Firma abschließt, kann durch die Tatsache, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Direktoren der
Gesellschaft irgendwelche Interessen in jener anderen Gesellschaft oder Firma als Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber,
Direktor oder Angestellter haben, beeinträchtigt oder ungültig gemacht werden.
Ein Verwaltungsratsmitglied oder Direktor der Gesellschaft, welcher lediglich Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder
Angestellter einer anderen Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesellschaft einen Vertrag schließt oder in einer
anderen Weise in geschäftlichen Beziehungen tritt, verliert dadurch nicht das Recht, zu beraten, abzustimmen und zu
handeln, was die Angelegenheiten die mit einem solchen Vertrag oder solchen Geschäftssachen in Verbindung stehen
anbetrifft.
Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder Direktor ein persönliches Interesse in irgendeiner Transaktion der Gesellschaft
hat, muss dieses Verwaltungsratsmitglied oder Direktor der Gesellschaft den Verwaltungsrat von diesem persönlichen
Interesse informieren, und wird weder mitberaten, noch am Votum über diese Transaktion teilnehmen. Ein Bericht über
diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder Direktors wird bei der nächs-
ten Versammlung der Aktionäre erstattet.
Der im vorstehenden Absatz verwendete Begriff "persönliches Interesse" findet keine Anwendung auf Beziehungen
und Interessen, die die AXA Gesellschaftsgruppe, deren Tochtergesellschaften oder verbundene Gesellschaften oder
jeder anderen von dem Verwaltungsrat nach freiem Ermessen benannten Gesellschaft oder Firma betreffen.
Art. 28. Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft kann jedem Verwaltungsratsmitglied oder Di-
rektor, seinen Erben, Vollstrecker und Administratoren die eingegangenen vernünftigen Ausgaben im Rahmen seiner
Handlungen, die er in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied oder Direktor der Gesellschaft durchgeführt hat
oder auf Bitte der Gesellschaft, falls jene ihn nicht entschädigt, als Verwaltungsratsmitglied oder Direktor einer anderen
Gesellschaft, in welcher die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist, durchgeführt hat, vergüten. Dies beinhaltet nicht
jene Handlungen für deren grobe Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft oder anderen Pflichtverletzungen das Verwaltungs-
ratsmitglied oder Direktor aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses haften muss oder eine solche grobe Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft oder andere Pflichtverletzungen anerkannt worden ist. Im Falle einer Schlichtung betrifft die Vergü-
tung lediglich jene Angelegenheiten, in denen die Gesellschaft sich Rat geholt hat und feststellen kann, dass sie die
Pflichtverletzungen nicht betreffen. Das Recht auf Vergütung schließt keine anderen Ansprüche seitens dieser Personen
aus.
Art. 29. Vergütungen des Verwaltungsrats. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsratsmitgliedern, als Entgelt
für die geleisteten Dienste, eine feste jährliche Summe als Vergütung zuteilen; solche Summen werden als allgemeine
Ausgaben der Gesellschaft verbucht und werden durch den Verwaltungsrat nach freiem Ermessen unter seinen Mitglie-
dern aufgeteilt.
Außerdem können den Verwaltungsratsmitgliedern die von ihnen in Bezug auf die Gesellschaft getätigten Ausgaben
vergütet bekommen, sofern sie angemessen sind.
Die Vergütung des Vorsitzenden und des Sekretärs des Verwaltungsrats sowie diejenigen der Generaldirektoren und
Bevollmächtigten werden durch den Verwaltungsrat festgelegt.
Art. 30. Anlageberater, Portfolio-Verwalter, Depotbank, und Andere Vertragsparteien. Die Gesellschaft kann einen
Anlageberatervertrag abschließen, um bei der Verwaltung ihres Portfolios Beratung und Beistand zu erhalten. Sie kann
ebenfalls mit einem oder mehreren Anlageverwalter Verwaltungsverträge abschließen.
81768
L
U X E M B O U R G
Außerdem kann die Gesellschaft Serviceverträge mit andern Parteien eingehen. Dies beinhaltet unter anderem den
Einsatz eines Zentralverwalters für die Verwaltung der Gesellschaft, der die Rolle der "administration centrale" im Sinne
des Rundschreibens des Institut Monétaire Luxembourgeois n°1991/75 vom 21. Januar 1991 übernimmt.
Die Gesellschaft wird mit einer Bank (im folgenden "Depotbank"), die den Anforderungen des Gesetzes vom 13.
Februar 2007, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen,
gerecht wird, einen Depotbankvertrag abschließen. Alle übertragbaren Wertpapiere und das Bargeld der Gesellschaft
werden von der Depotbank oder für das Konto der Gesellschaft gehalten. Die Depotbank wird gegenüber der Gesellschaft
und ihren Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen.
Falls die Depotbank den Vertrag kündigen möchte, tut der Verwaltungsrat sein Bestes, um eine andere Depotbank zu
ermitteln, welche an die Stelle der kündigenden Depotbank tritt; der Verwaltungsrat wird die betreffende Bank als neue
Depotbank ernennen. Der Verwaltungsrat ist dazu berechtigt, der Depotbank zu kündigen; eine Kündigung wird jedoch
erst wirksam, wenn eine neue Depotbank den vorgehenden Bestimmungen zufolge als Nachfolgerin ernannt wurde.
7. Wirtschaftsprüfer
Art. 31. Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre Finanzlage, insbesondere ihre Buchführung werden
durch Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprise agréé") kontrolliert, welcher die Bedingungen erfüllt, die das Gesetz vom
13. Februar 2007, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen,
in Bezug auf Seriosität und Berufserfahrung vorschreibt. Die Wirtschaftsprüfer werden von der Generalversammlung
ernannt.
8. Jahresabschluss
Art. 32. Jahresanschluss, Geschäftsjahr. Den Anteilseigner wird der überprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft in-
nerhalb von einhundert zwanzig (120) Tage nach dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des gleichen
Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Gründungstag beginnt und am 31. Dezember 2011 endet.
Art. 33. Gewinnverwendung. Die Aktionäre jeder Aktienklasse beschließen auf der jährlichen Generalversammlung,
auf Vorschlag des Verwaltungsrates hin, falls und wenn den Betrag der Ausschüttungen, innerhalb der Grenzen des Ge-
setzes vom 13. Februar 2007, zugunsten der Aktionäre der Gesellschaft vorgenommen werden.
Zwischendividenden können, unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Beschluss des Verwaltungsrates, auf Aktien
ausgezahlt werden.
Ausschüttungen, die nicht innerhalb einer Frist von fünf (5) Jahren beginnend am Datum ihrer Auszahlung gefordert
werden, werden ihren Nutznießern aberkannt und der Gesellschaft zugesprochen.
Um den Investoren den Ertrag eines Verkaufs von unterliegenden Guthaben und/oder anderen Einkommen, welche
nicht weiter angelegt werden, rück zu erstatten, kann der Verwaltungsrat, anstatt entweder der Generalversammlung
der Aktionäre eine Dividendenausschüttung vorzuschlagen oder eine Zwischendividende auszuzahlen, entscheiden den
Rückkauf von Aktien oder Bruchteile dieser zu veranlassen entsprechend den Bedingungen des oben erwähnten Artikel
12.2. Der Verwaltungsrat ist befugt, mit dem Einverständnis der Aktieninhaber, die Ausschüttung/Zahlung von Wertpa-
pieren von Portfolio-Gesellschaften als Sachleistung durchzuführen.
9. Auflösung und Liquidation
Art. 34. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. Zu jeder Zeit kann die Generalversammlung durch einen Beschluss
unter Einhaltung der Quorum-und Mehrheitserfordernisse, wie in Artikel 18 festgelegt, die Gesellschaft auflösen.
Sobald das Kapital der Gesellschaft unter den zwei Dritteln des Mindestkapitals, so wie es vom luxemburgischen Gesetz
vom 13. Februar 2007 vorgesehen wird, fällt, muss der Verwaltungsrat die Frage der etwaigen Auflösung der Gesellschaft
den Aktionären in der Generalversammlung unterbreiten. Die Generalversammlung, für die kein Quorum nötig ist, wird
mit einfacher Mehrheit der an der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien entscheiden.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird auch an die Hauptversammlung der Aktionären weitergeleitet werden,
sobald das Kapital unter ein Viertel des Mindestkapitals fällt, wie durch das Gesetz vom 13. Februar 2007 vorgesehen. In
diesem Fall, wird die Hauptversammlung ohne Beschlussfähigkeitsauflagen abgehalten und die Auflösung kann von den
Aktionären, die ein Viertel der anwesenden oder vertretenen Aktien halten, beschlossen werden.
Die Versammlung muss innerhalb einer Frist von vierzig (40) Tagen vom Tag der Feststellung der Tatsache, dass die
Nettovermögens der Gesellschaft unten zwei Drittel oder ein Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen sind, je nach
dem, einberufen werden.
Die Ausgabe neuer Aktien durch die Gesellschaft wird am Tag der Veröffentlichung der Einberufung zur Generalver-
sammlung der Aktionäre, an der die Auflösung und die Liquidierung der Gesellschaft vorgeschlagen werden wird,
eingestellt.
In diesem Fall werden ein oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können) von der
Generalversammlung der Aktionäre, die ebenfalls ihre allgemeine Befugnisse und Abfindung bestimmt, ernannt, um unter
der Aufsicht der relevanten überwachenden Behörde die Vermögenswerte der Gesellschaft in den besten Interessen der
Aktionäre zu veräußern.
81769
L
U X E M B O U R G
Der Erlös der Liquidation wird von den Liquidatoren netto, abzüglich aller Liquidationsausgaben, unter den Inhabern
von Aktien in jeder Klasse in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Rechten verteilt werden. Die Summen, die am Ende
des Liquidationsprozesses von Aktionären nicht gefordert werden, werden, in Übereinstimmung mit der luxemburgischen
Gesetzesgebung, in der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt. Falls diese Beträge nach Ablauf einer Frist von
fünf (5) Jahren noch nicht verlangt wurden, verjähren sie und ein Anspruch darauf kann nicht mehr erhoben werden.
Art. 35. Schluss einer Aktienklasse. Der Verwaltungsrat kann zu jedem Moment den Schluss irgendeiner Aktienklasse
beschließen. Im Fall vom Schluss einer Aktienklasse, unterliegen die Aktien der Aktionäre einem verbindlichen Rückkauf
gegen Bareinlagen zum Nettoinventarwert pro Aktie bestimmt am Tag des Inkrafttretens einer solchen Entscheidung.
Vor dem Tag des Inkrafttretens des verbindlichen Rückkaufs benachrichtigt die Gesellschaft die betroffenen Aktionäre
der relevanten Aktienklassen und gibt in dieser Benachrichtigung die Gründe des verbindlichen Rückkaufs und das Ver-
fahren der Rückkaufsoperationen an.
Anträge zur Zeichnung von Aktien dieser Aktienklasse werden ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Schlusses der
betroffenen Aktienklasse eingestellt.
Vermögenswerte, die nicht an ihre Eigentümer nach der Durchführung des Rückkaufs ausgeschüttet werden können,
werden für sechs (6) Monate bei der Depotbank hinterlegt; nach diesem Zeitraum werden die Vermögenswerte bei der
Caisse de Consignations im Namen der Besitzer hinterlegt.
Alle zurückbezahlten Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.
Art. 36. Von der Gesellschaft getragene Ausgaben. Die Depotbank, die Zahlstelle und die Zentralverwaltung haben
das Recht Vergütungen aus dem Vermögen der Gesellschaft zu empfangen, wie in den Verträgen zwischen ihnen und der
Gesellschaft festgelegt ist und in Übereinstimmung mit dem Gewohnheitsrechts des Bankenwesens. Außerdem werden
angemessene Auslagen und Ausgaben dieser Dienstleister der Gesellschaft wie angemessen belastet.
Die Gesellschaft wird ebenfalls alle anderen Kosten tragen, die bei der Tätigung der Geschäfte der Gesellschaft ent-
standen sind, inklusive, und zwar ohne Begrenzung, Kosten für Anlageberatung, Unternehmensberatung und Verwaltung,
Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jahresberichte, Prüfungskosten der Anlagen, Kosten für Büro
und Personal, für Zwischengesellschaften, durch Anlagestruktur oder Direktanlagen bedingte Zahlungen (z.B. im Bezug
auf Verwaltungskosten und Kapitalabrufkosten), für Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten
der Aktienzertifikate, der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs-und Werbekosten, die Kosten für
das Vorbereiten, das Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessene Ausgaben der Verwal-
tungsratsmitglieder, die Reisekosten der Aktieninhaber (Kosten der Anreise zur Generalversammlung der Aktionäre),
Registrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlenden
Kosten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokergebühren sowie die Kosten von Veröffentlichungen.
Die Gründungskosten der Gesellschaft werden von dieser getragen und werden nicht abgeschrieben.
Die Gesellschaft trägt alle ihre laufenden Ausgaben, wie in Artikel 11 beschrieben.
Art. 37. Satzungsänderung. Die vorliegende Satzung kann jederzeit geändert werden und zwar durch Beschluss der
Generalversammlung der Aktionäre, die den Bedingungen betreffend Quorum und Mehrheit, wie es das luxemburgische
Gesetz vorsieht, unterworfen ist.
Art. 38. Allgemeine Bestimmungen. Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden von den Bestim-
mungen des Gesetzes vom 10. August 1915 (einschließlich Änderungsgesetzen) über die Handelsgesellschaften, sowie
vom Gesetz vom 13. Februar 2007 und von jedem anderen anwendbaren Gesetz, geregelt.
<i>Zeichnung und Bezahlungi>
Die Zeichner haben folgende Anteilsanzahlen gezeichnet und haben die folgenden Beträge in bar gezahlt:
Name des Anteilseigners
Gezeichnetes
Kapital
Gezahltes
Kapital
Anzahl
der Aktien
Deutsche Ärzteversicherung AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- EUR 31.000,-
31
Beweise dieser Zahlungen wurden wie ausdrücklich dem unterzeichnenden Notar gegenüber angegeben erbracht.
<i>Jahresberichtei>
Der Verwaltungsrat hat sicherzustellen, dass die Anteilseigner einen geprüften Jahresbericht erhalten, der Informati-
onen zu allen Investitionen, die von der Gesellschaft getätigt wurden, und Details zur finanziellen Leistung der Gesellschaft
für jedes Geschäftsjahr enthält.
<i>Erklärungi>
Der unterschreibende Notar erklärt, dass die Bedingungen, die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des abgeänderten Lu-
xemburger Gesetztes von 1915 über Handelsgesellschaften aufgezählt sind, erfüllt sind.
<i>Ausgabeni>
Die Ausgaben, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf EUR 3.000,-geschätzt.
81770
L
U X E M B O U R G
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die oben erwähnte Person, welche das gesamte gezeichnete Kapital repräsentiert fasste folgende Beschlüsse:
1. Die folgenden Personen wurden für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren zum Verwaltungsratsmitglieder bestellt,
welcher mit dem Tag der jährlichen Generalversammlung, die 2017 abgehalten wird, endet.
- Herr Julien ALEX, geschäftsansässig in 46, rue François Sébastien Tinant, L-2622 Luxembourg, Großherzogtum Lu-
xembourg;
- Herr Manuel HAUSER, geschäftsansässig in 20, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Großherzogtum Luxem-
bourg;
- Herr Olivier DECANNIERE, geschäftsansässig in 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, Frankreich; und
- Herr Vincent GOMBAULT, geschäftsansässig in 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, Frankreich.
2. Die folgende Person ist als unabhängiger Wirtschaftsprüfer ausgewählt worden, für einen Zeitraum, der mit der
jährlichen Generalversammlung im Jahr 2012 endet:
- BDO Audit S.A., mit der Geschäftsanschrift 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Großherzogtum
Luxembourg.
3. Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet 46, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten
Personen, diese Urkunde auf Englisch ist und auf die eine deutsche Version folgt; auf Anfrage der selben anwesenden
Personen, geht im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und deutschen Text die englische Version vor.
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Das Dokument wurde den erschienen Personen vorgelesen, die der Notar mit ihrem Vor-und Nachnamen, ihrer
Stellung und Wohnort kennt. Die anwesenden Personen haben zusammen mit dem Notar, der zugegen war, die Origi-
nalurkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mai 2011. Relation: LAC/2011/24586. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 3. Juni 2011.
Référence de publication: 2011077675/1190.
(110086572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2011.
Farenzena Jules Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 73.366.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2011079315/11.
(110088658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Gallura Moon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 140.088.
Il résulte de résolutions écrites de l’actionnaire unique de la Société prises en date du 6 juin 2011 que Monsieur Jean-
François Trapp, né le 15 juillet 1975 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle au 37, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, a démissionné de son poste d’administrateur de la Société avec effet
immédiat.
Le mandat de Monsieur Charles Roemers a été renouvelé pour une nouvelle période de six ans à partir du 6 juin 2011.
Suite à ces résolutions, la Société sera gérée par un administrateur unique: Mr. Charles Roemers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2011.
Référence de publication: 2011079333/15.
(110088136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81771
L
U X E M B O U R G
Galanthus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 135.351.
Il résulte d’une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 6 juin 2011 que:
(i).Monsieur Jean-François Trapp, né le 15 juillet 1975 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle à 37,
rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, a démissionné de son poste d’administrateur B
de la Société avec effet immédiat;
(ii).Mademoiselle Aurélia Roemers, née le 21 juin 1988 à Verviers (Belgique), ayant son adresse au 289, rue de l'Or,
Attert (Nothomb) B-6717, Belgique, a été nommée administrateur de la Société, avec effet immédiat pour une période
de six ans.
L’assemble générale des actionnaires a également décidé de ne plus faire de distinction entre les administrateurs A et
B et, par conséquent, de reclassifier les mandats de Monsieur Charles Roemers et de Madame Françoise Poumay en
mandats d’administrateurs de la Société.
Les mandats de Monsieur Charles Roemers et de Madame Françoise Poumay ont été renouvelés pour une nouvelle
période de six ans à partir du 6 juin 2011.
Suite à ces résolutions, le conseil d’administration sera composé comme suit:
1.M. Charles Roemers, administrateur;
2.Mme. Françoise Poumay, administrateur; et
1.Mlle. Aurélia Roemers, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2011.
Référence de publication: 2011079338/25.
(110088137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Gliese S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 145.235.
Il résulte de résolutions écrites de l’actionnaire unique de la Société prises en date du 6 juin 2011 que Monsieur Jean-
François Trapp, né le 15 juillet 1975 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle au 37, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, a démissionné de son poste d’administrateur de la Société avec effet
immédiat.
Le mandat de Monsieur Charles Roemers a été renouvelé pour une nouvelle période de six ans à partir du 6 juin 2011.
Suite à ces résolutions, la Société sera gérée par un administrateur unique: Mr. Charles Roemers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2011.
Référence de publication: 2011079341/15.
(110088135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Grep Eins S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 122.656.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 4 mai 2011i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Ernst & Young Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach a été réélu réviseur d'entreprise de la société.
Son mandat est reconduit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079344/14.
(110088071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81772
L
U X E M B O U R G
Global Promotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5960 Itzig, 100, rue de l'Horizon.
R.C.S. Luxembourg B 89.881.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011079342/10.
(110088677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Intel Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 35.509.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INTEL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011079383/12.
(110088111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
HSBC Global Markets Equities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 156.143.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszugi>
Es erhellt aus einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 20 Mai 2011,
einregistriert in Luxemburg A.C., am 23. Mai 2011, LAC/2011/23513, dass der Aktionär der Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital «HSBC Global Markets Equities SICAV», in Liquidation, mit Sitz in L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou
Hemmer, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B156143, gegründet
wurde, gemäss notarieller Urkunde vom 12. Oktober 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 2555 vom 24. November 2010, beschlossen hat, die Liquidation der Gesellschaft zu schließen.
Die Gesellschaft wurde in Liquidation gesetzt gemäss Urkunde des Notars Henri HELLINCKX, Notar mit Amts-
wohnsitz in Luxemburg, vom 17. März 2011.
Der Gründer beschließt dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während der Dauer von minimum fünf
Jahren am Sitz der aufgelösten Gesellschaft in L-1748 Findel-Golf, 8, rue Lou Hemmer.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Juni 2011.
Référence de publication: 2011079366/21.
(110088694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Gravograph U.S. Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 76.131.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079343/10.
(110088194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81773
L
U X E M B O U R G
Gugler Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 95.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079349/10.
(110088801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Horst Keller Gebäudereinigung, GmbH, Niederlassung Luxemburg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten.
R.C.S. Luxembourg B 109.088.
<i>Auszug aus der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der Firma Horst Keller Gebäudereinigung, GmbHi>
In der heute unter Verzicht auf Form- und Fristvorschriften stattgefundenen Gesellschafterversammlung wurden von
den unterzeichnenden Gesellschaftern folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz der Betriebsstätte Luxemburg wird ab dem 01.01.2011 von L-5365 Munsbach, 18-20 Parc
d'Avtivite Syrdall nach L-6776 Grevenmacher, 5 an de Laengten verlegt.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Trierweiler, den 15. Dezember 2010.
HORST KELLER Gebäudereinigung GmbH
54311 Trierweiler
Auf der Geig 19
Unterschrift
Référence de publication: 2011079352/18.
(110087828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Immofra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 32.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juin 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011079381/14.
(110088736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Husky Injection Molding Systems, Société Anonyme.
Capital social: EUR 40.000.000,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 21.683.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
b. WONTERS.
Référence de publication: 2011079367/11.
(110088323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81774
L
U X E M B O U R G
HIP Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.285.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079363/10.
(110088452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Happy Quick S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 65.185.
EXTRAIT
Par décision de rassemblée générale annuelle tenue en date du 28 avril 2011, les actionnaires ont décidé d'approuver
le renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises avec effet immédiat au 28 avril 2011 de la société Pricewate-
rhouseCoopers S.à r.l, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra au cours de l'année
2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juin 2011.
<i>Pour Happy Quick S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011079354/16.
(110088459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Reality S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 101.756.
<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenue le 16 mai 2011i>
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée prend note de la démission de l'administrateur Monsieur Thierry FLEMING au 16 mai 2011.
L'Assemblée coopte avec effet immédiat et pour une période de cinq années, Monsieur Pierre LENTZ, né à Luxem-
bourg le 22.04.1959, expert comptable, demeurant professionnellement 2, Avenue Charles De Gaulle L-1653 Luxem-
bourg, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
REALITY SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2011074216/17.
(110082609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2011.
Hip Mezzanine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.044.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079364/10.
(110088770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81775
L
U X E M B O U R G
Koch Chemical Technology European Treasury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 131.215.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079392/18.
(110088414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Koch Chemical Technology GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 131.320.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079393/18.
(110088417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Koch Chemical Technology GP S.à r.l. & Partners SCS, Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 429.395.877,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 131.345.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079394/18.
(110088419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81776
L
U X E M B O U R G
Koch Chemical Technology LP2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 175.038.262,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 131.220.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079396/18.
(110088416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Koch Chemical Technology LP3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.160,00.
Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 146.546.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079397/18.
(110088415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Koch Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.004,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 149.852.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres document et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079398/18.
(110088648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81777
L
U X E M B O U R G
AIM Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 162.254.
STATUTS
L'an deux mille onze, le treize juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Stéphane BOUDON, cadre dirigeant de société, né à Suresnes (France), le 7 mars 1963, demeurant
résident à 60177-080 Fortereza, rue Ubirajara Carneiro (Brésil).
2) Madame Nadezhda POPOVA, administratrice de société, née à Bourgas (Bulgarie), le 30 janvier 1979, demeurant
à F-75007 Paris, 3, Passage de la Vierge.
Les deux sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à
L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration,
après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin
d'être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de
constitution d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme
suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de “AIM LUXEMBOURG S.A.” (ci-après la "Société"),
laquelle sera régie par les dispositions légales y afférentes, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet de rendre des services de conseil et d'assistance à des organismes de placement collectif
de droit luxembourgeois ou tout autre fonds d'investissement, en rapport avec la gestion de leurs avoirs et leur promotion.
La Société peut prendre toute mesure et exécuter toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-
loppement de son objet.
Dans le cadre de son activité, la Société peut accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
En général, la Société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières, lesquelles se rapportent directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou qui peuvent en favoriser
l'accomplissement.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option de valeurs mobilières pour en disposer par voie de vente, transfert, échange
ou autrement et pour les développer.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous tires de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts de
prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés, au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoir ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à sons objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
81778
L
U X E M B O U R G
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-EUR), représenté par TROIS MILLE CENT
(3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,-EUR) chacune.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,-EUR) par la création
et l'émission d'actions supplémentaires d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,-EUR) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en numéraire, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée
d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, de l'acte de constitution du 13 juillet 2011 et peut être renouvelée par une assemblée
générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici-là n'auront pas été émises par le conseil d'admi-
nistration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée par le conseil d'administration et dûment constatée dans les
formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à tenir compte de l'augmentation intervenue.
Il incombe au conseil d'administration ou à toute personne mandatée à ces fins de faire constater cette modification par
un acte notarié.
Le capital social et le capital autorisé peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul admi-
nistrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III. - Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3
ème
mardi du mois de mai à 14.00 heures au siège
social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation.
81779
L
U X E M B O U R G
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents Statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV. - Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
81780
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou
par la seule signature de toute personne à qui des pouvoirs de signatures seront donnés par le conseil d'administration.
Lorsque la Société dispose d'un administrateur unique, ce dernier engagera valablement la Société par sa seule signa-
ture.
Titre V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
Titre VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Titre VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
81781
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013. Exceptionnellement et dans le respect de l'article 70
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la première assemblée générale annuelle se tiendra le 13 janvier
2013.
3) Exceptionnellement le premier président et premier délégué du conseil d'administration pourront être nommés
par une résolution des actionnaires.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Stephane BOUDON, préqualifié, mille cinq cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2) Madame Nadezhda POPOVA, préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total: trois mille cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Les actions ont été libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et une mille euros (31.000,-EUR) se trouve
dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-mentionnés, représentant la totalité du capital social et se considérant comme étant valablement
convoqués, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité:
1. Le siège social est fixé à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont nommés membres du conseil d'administration:
- Monsieur Stéphane BOUDON, cadre dirigeant de société, né à Suresnes (France), le 7 mars 1963, demeurant résident
à 60177-080 Fortereza, rue Ubirajara Carneiro (Brésil);
- Madame Nadezhda POPOVA, administratrice de société, née à Bourgas (Bulgarie), le 30 janvier 1979, demeurant à
F-75007 Paris, 3, Passage de la Vierge; et
- Monsieur Gerry SALUCCI, cadre de société, né à Luxembourg, le 17 décembre 1968, demeurant L-4460 Belvaux,
144, rue de la Gare (Luxembourg).
4. La société anonyme “COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DES AUDITEURS REUNIS (CLAR) S.A.”, en abrégé
“CLAR S.A.”, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150963, est nommée aux fonctions de commissaire aux
comptes de la Société.
5. La société “Paddock Fund Administration S.A.”, en abrégé “PFA”, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxem-
bourg, 3A, rue Guillaume Kroll, est désignée comme Administration Centrale de la Société, principalement en charge de
la tenue de la comptabilité et de la domiciliation de la Société.
6. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme:
- Monsieur Stephane BOUDON, préqualifié, comme président du conseil d'administration et administrateur-délégué,
avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa signature individuelle dans le cadre de la gestion quotidienne de la
Société;
- Madame Nadezhda POPOVA, préqualifiée, comme vice-présidente du conseil d'administration, et administrateur-
délégué, avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa signature individuelle dans le cadre de la gestion quotidienne
de la Société; et
- Monsieur Gerry SALUCCI, préqualifié, comme administrateur, avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa
signature incluant celle du président du conseil d'administration ou du vice-président du conseil d'administration.
7. Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire aux comptes se termineront avec l'as-
semblée générale annuelle de l'année 2017.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
81782
L
U X E M B O U R G
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2011. LAC/2011/32165. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 20 juillet 2011.
Référence de publication: 2011102438/280.
(110116849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2011.
Koch Resources Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 14.550.300,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 128.053.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres document et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079399/18.
(110088649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
KCTG Foreign Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 131.994.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079402/18.
(110088418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
LyondellBasell AFGP, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 111.155.
Le Bilan arrêté au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juin 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011079414/10.
(110088760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81783
L
U X E M B O U R G
KCTG Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 403.087.159,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 131.747.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 juin 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011079403/18.
(110088412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Lux Fund Consult S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 156.768.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juin 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011079413/14.
(110088715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Legiex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 69.246.
Les comptes annuels au 1
er
décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011079417/11.
(110088524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Even Germany S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.940.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079307/10.
(110088066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81784
L
U X E M B O U R G
Laubach Containers Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9283 Diekirch, 5, Promenade de la Sûre.
R.C.S. Luxembourg B 105.948.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 juin 2011.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2011079415/14.
(110088716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Happy Quick S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 65.185.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 juin 2011.
<i>Pour Happy Quick S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2011079355/12.
(110088460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Even Germany S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.940.
Les comptes annuels consolidés au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011079308/11.
(110088067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
UnikEvent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 2, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 162.169.
STATUTS
L'an deux mil onze, le trente juin.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
- Monsieur Christophe KELLER, ingénieur, né à Thionville (France), le 3 juin 1970, demeurant à L-1899 Kockelscheuer,
2, route de Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «UnikEvent S.à r.l.».
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Kockelscheuer.
81785
L
U X E M B O U R G
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet l'exploitation d'une agence d'organisation d'événements. L'agence prend notamment
en charge l'organisation et la gestion de congrès, colloques, séminaires et soirées. Elle gère également le déroulement de
l'événement tel que la restauration, l'animation, la fourniture des matériels et outils de communication ...etc.
D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social ou susceptibles d'en favoriser son déve-
loppement.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Toutes les parts ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par l'associé unique, Monsieur Christophe
KELLER, ingénieur, demeurant à L-1899 Kockelscheuer, 2, route de Luxembourg, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant moyennant certificat bancaire.
La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,
sans qu'il n'y ait lieu à délivrance d'aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. L'associé unique peut céder ses parts à qui il l'entend.
Entre associés les parts sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de refus de cession, le ou les associés non cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en
cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est
toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.
Art. 7. Le décès, l'incapacité, la déconfiture ou la faillite, de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de
l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu au
siège social.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,
proportionnellement au nombre de parts qu'il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Année sociale - Bilan
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, confor-
mément aux dispositions légales en vigueur.
81786
L
U X E M B O U R G
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition du ou des associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.
<i>Déclaration du comparanti>
L'associé unique déclare en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du
capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction
visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médica-
menteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du
Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à 1.000,- EUR.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée, a pris
les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-1899 Kockelscheuer, 2, route de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Christophe KELLER, préqualifié.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Keller, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2011. Relation: LAC/2011/30077. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Sandt.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 juillet 2011.
M. DECKER.
Référence de publication: 2011101710/108.
(110114987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2011.
HEDF II UK Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 126.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Elisa Gottardi.
Référence de publication: 2011079358/10.
(110088638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
81787
L
U X E M B O U R G
HEDF II UK Residential S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 125.823.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Elisa Gottardi.
Référence de publication: 2011079359/10.
(110088639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2011.
Iginio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 149.604.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/05/2011.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2011070539/12.
(110078647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.
Immo Dek S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 23, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 43.948.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011070541/11.
(110077710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.
Immobilière Arenberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 39.970.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2011.
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2011070542/12.
(110078372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.
Lotisseurs in den Strachen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 160.941.
STATUTS
L'an deux mil onze, le treize mai.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
81788
L
U X E M B O U R G
1.- La société à responsabilité limitée «ILCO IMMOBILIERE S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-8057 Bertrange,
17, rue du Chemin de Fer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section et le numéro
B 9.440, i.n. 1971 2400 660,
constituée par acte sous seing privé en date du 9 février 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 82 du 15 juin 1991, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux
termes d'un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 2009, publié
au dit Mémorial C, numéro 1475 du 30 juillet 2009,
représentée par son conseil de gérance:
- Monsieur Learducci RUGO, entrepreneur, demeurant à L-8249 Mamer, 73, rue de Mameranus,
- Monsieur Vincenzo CLEVA, entrepreneur, demeurant à L-8230 Mamer, 20, Gaaschtbierg,
nommés à leurs fonctions avec pouvoir d'engager valablement la société par leur signature conjointe, aux termes d'un
acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg (Bonnevoie), en date du 18
décembre 1997, publié au dit Mémorial C, numéro 200 du 1
er
avril 1998,
2.- a) Madame Valérie Suzanne BESCH, fonctionnaire, née à Luxembourg, le 22 décembre 1949, i.n. 1949 1222 169,
épouse de Monsieur Jean-Marie BEMTGEN, demeurant à L-8278 Holzem, 4, rue du Cimetière,
b) Monsieur Patrick BESCH, employé de bureau, né à Luxembourg, le 22 août 1963, i.n. 1963 0822 117, époux de
Madame Cornélie BOSSELER, demeurant à L-4499 Limpach, 18, rue de Reckange,
Madame Valérie BESCH ici non présente, mais représentée par Monsieur Patrick BESCH, en vertu d'une procuration
sous seing privé lui délivrée à Holzem, le 11 mai 2011,
laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte, pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement,
3.- La société à responsabilité limitée «FMC PROMOTIONS S.à r.l.», ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, route
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section et le numéro B 67.032,
i.n. 1998 2412 628,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 novembre
1998, publié au dit Mémorial C, numéro 36 du 22 janvier 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux
termes d'un acte reçu par le prédit notaire Jean SECKLER, en date du 31 mai 2001, publié au dit Mémorial C, numéro
1278, du 4 septembre 2002,
représentée par son gérant unique Monsieur Maurice ELZ, commerçant, demeurant professionnellement à L-8140
Bridel, 88C, route de Luxembourg,
nommé à ces fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue in fine du prédit acte de constitution du 10
novembre 1998, avec pouvoir d'engager valablement la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “LOTISSEURS IN DEN STRACHEN S.à r.l.”, (ci-
après la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus
particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, le lotissement et la vente de terrains, en particulier à
Holzem, ainsi que l'acquisition, la construction, l'aménagement, la mise en valeur, la gestion et la vente d'immeubles.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement aux dites activités ou à des activités similaires susceptibles de favoriser ou de faciliter l'exécution
ou le développement de son objet social.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Bridel dans la commune de Kopstal (Grand-Duché de Luxembourg).
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €), représenté par dix mille (10.000) parts
sociales de un euro vingt-cinq cents (1,25 €) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
81789
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les dix mille (10.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- La prédite société «ILCO IMMOBILIERE S.à r.l.», deux mille cinq cent trente (2.530) parts sociales;
81790
L
U X E M B O U R G
2.- a) Madame Valérie BESCH, prénommée, quatre cent cinquante-cinq (455) parts sociales et
b) Monsieur Patrick BESCH, prénommé, quatre cent cinquante-cinq (455) parts sociales,
3.- La prédite société «FMC PROMOTIONS S.à r.l.», six mille cinq cent soixante (6.560) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- €) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.
<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.
2. Monsieur Maurice ELZ, commerçant, demeurant professionnellement à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg,
est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Bridel, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. RUGO, V. CLEVA, P. BESCH, M. ELZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 mai 2011. LAC/2011/22077. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 19 mai 2011.
Référence de publication: 2011070601/146.
(110078166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.
Kenmore Astoria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 125.847.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 19 mai 2011.
Référence de publication: 2011070567/10.
(110077914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.
Kekri, Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 129.812.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2011070572/11.
(110077680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.
81791
L
U X E M B O U R G
Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 129.755.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 31 décembre 2010i>
En date du 31 décembre 2010, les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Henricus Cornelis VAN DER MARK, gérant de classe A de la société, avec effet
immédiat;
- de nommer Monsieur Nathan MORIS, né le 4 mars 1971 en Tanzanie, ayant son adresse professionnelle au 26
Woluwedal, Box 8, Woluwe Office Garden, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique, en tant que nouveau gérant de classe
A de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Depuis lors, le conseil de gérance est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Nathan Moris, gérant de classe A
- Monsieur Guy Harles, gérant de classe B
- Monsieur David Hunt, gérant de classe B
- Madame Orna Nofarber, gérant de classe B
- Madame Teresa Bruzzo, gérant de classe B
- Monsieur Klaus Sorensen, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2011.
Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011072039/26.
(110080365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.
Immobilière Livange SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 65.616.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 19 mai 2011i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
La démission de Monsieur George EILERT, retraité, né le 19 mai 1943 à Pétange, demeurant 23, rue Jean Schneider à
L-8272 Mamer de son poste d’administrateur a été acceptée.
La démission de Monsieur Joseph BRAUN, retraité, né le 9 septembre 1931 à Hespérange, demeurant 13, rue des
Sources à L – 5671 ALTWIES de son poste d’administrateur-délégué a été acceptée.
Monsieur Tibor GAJDOS, ingénieur diplômé, né le 3 septembre 1951 à Banska (Slovaquie), demeurant 2 Place des
Villes Jumelées à L-5627 Mondorf-les-Bains, a été nommé administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en
l’année 2017.
Monsieur Tibor GAJDOS junior, étudiant, né le 12 juillet 1992 à Brezno (Slovaquie), demeurant 2 Place des Villes
Jumelées à L-5627 Mondorf-les-Bains, a été nommé administrateur jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en l’année 2017.
Les mandats d’administrateurs de Monsieur Joseph BRAUN, retraité, né le 9 septembre 1931 à Hespérange, demeurant
13, rue des Sources à L – 5671 ALTWIES et de Monsieur Tibor GAJDOS, ingénieur-diplômé, né le 3 septembre 1951 à
Banska (Slovaquie), demeurant 2 Place des Villes Jumelées à L-5627 Mondorf-les-Bains ainsi que le mandat du commissaire
aux comptes BENOY KARTHEISER MANAGEMENT Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d’Arlon à L-1140 Lu-
xembourg Sàrl ont été prolongés jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en l’année 2017.
Luxembourg, le 20 mai 2011.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2011072100/25.
(110079654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
81792
AIM Luxembourg S.A.
AXA Alternative Participations IV, SICAV-FIS
Estée Lauder Cosmetics Luxembourg S.à r.l.
Even Germany S.C.A.
Even Germany S.C.A.
Farenzena Jules Sàrl
Fibor S.A.
Fidacta Holding Luxembourg S.A.
Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A.
F.I.L. Casa International S.A.
Filip S.à r.l.
Finbra S.A.
First Gate Holding S.A.
First Service Holding S.A.
Fiscobelux S.A.
Four Seasons Capital S.A.
Four Seasons Capital S.A.
Franzoni Group S.A.
Freesia S.A.
Fusion S.A.
Fusion S.A.
G.2. Investment Group S.A.
Galanthus S.A.
Gallura Moon S.A.
Gliese S.A.
Global Promotion S.A.
Gravograph U.S. Finance S.à.r.l.
Grep Eins S.A.
Groupe Compétence S.à r.l.
Gugler Europe S.A.
Happy Quick S.A.
Happy Quick S.A.
HEDF II UK Office S.à r.l.
HEDF II UK Residential S.à r.l.
HIP Investments S.à.r.l.
Hip Mezzanine S.à r.l.
Horst Keller Gebäudereinigung, GmbH, Niederlassung Luxemburg
HSBC Global Markets Equities SICAV
Husky Injection Molding Systems
Iginio S.A.
Immobilière Arenberg S.A.
Immobilière Livange SA
Immo Dek S.A.
Immofra S.A.
Intel Holding S.A.
KCTG Foreign Holdings S.à r.l.
KCTG Holdings I S.à r.l.
Kekri
Kenmore Astoria S.à r.l.
Koch Chemical Technology European Treasury S.à r.l.
Koch Chemical Technology GP S.à r.l.
Koch Chemical Technology GP S.à r.l. & Partners SCS
Koch Chemical Technology LP2 S.à r.l.
Koch Chemical Technology LP3 S.à r.l.
Koch Financing Luxembourg S.à r.l.
Koch Resources Luxembourg S.à r.l.
Laubach Containers Sàrl
Legiex S.A.
Lotisseurs in den Strachen S.à r.l.
Lux Fund Consult S.àr.l.
LyondellBasell AFGP
Reality S.A.
UnikEvent S.à r.l.