This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1662
23 juillet 2011
SOMMAIRE
European Fragrances S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
79733
Fiparic S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79776
FS-T S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79776
L14 Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
79757
Lee Cooper International Management S.à
r.l. & Partners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79744
Olympia Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79775
Opportunityflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79732
Opportunityflux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79732
Organ Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79732
Orsen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79773
Oxbow Carbon & Minerals S.à r.l. . . . . . . .
79776
Palmatrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79744
Paser Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
79742
Passaya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79743
Patron Aachen Holdings S. à r. l. . . . . . . . .
79732
Patron Elke S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79743
Patron Ewald Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
79743
Patron Volker Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
79743
Patron Volker S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79743
Pegase Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79754
Peninsula Bay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79755
Pisciculture Kieffer S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
79755
Playcenter International S.A. . . . . . . . . . . . .
79755
Prodac Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
79744
Prudential Capital Luxembourg S.à.r.l. . . .
79744
Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l. . . . . . . .
79744
PVV SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79756
Reichert Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79756
Resitalia Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79757
RESTO WU S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79756
RHIC Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79756
R.M.S. LU S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79756
Sagarmatha II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79772
Sagarmatha S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79772
Santa Rosa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79772
Scatec Norvège Holding II S.A. . . . . . . . . . .
79757
Security Capital European Realty Manage-
ment Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79773
Security Capital European Realty Manage-
ment Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79772
Skype Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79730
SLP III Cayman DS III S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
79773
Société Autonome de Construction S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79773
Société Autonome de Construction S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79773
Sofidex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79773
Sogeco Participations Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
79755
Sophia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
79774
South Riviera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79774
Suburbium S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79774
Sud Latitude Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
79774
Swen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79774
Sylvex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79775
Taurus Euro Retail II Feeder S.à r.l. . . . . . .
79775
Teamlog Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79775
Tele Columbus Management S.à r.l. . . . . .
79730
Transsoder Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
79730
Trentadue Investimenti S.A. . . . . . . . . . . . .
79731
TV Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79731
Unicorn Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
79731
79729
L
U X E M B O U R G
Tele Columbus Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 155.327.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2011.
Référence de publication: 2011073724/10.
(110081570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
Skype Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 94.564,90.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 141.496.
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 23 mai 2011 que les administrateurs
ont décidé de re-nommer pour un terme d’un an, avec effet à partir de l’assemblée générale annuelle de l’actionnaire
unique en tant que Président du conseil d’administration de la Société Monsieur Robert Jan Schol.
- Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’actionnaire unique tenue le 24 mai 2011 que:
* Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’actionnaire unique a décidé de renommer pour le terme
d’un an:
- Monsieur Paul van Baarle,
- Monsieur Robert Jan Schol,
- Mademoiselle Polyxeni Kotoula, et
- Madame Maria van der Sluijs Plantz
* L’actionnaire unique a décidé de réélire en tant que commissaire aux comptes pour le terme d’un an la société
PriceWaterhouseCoopers S.à r.l., RCS Luxembourg B 65.477.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2011.
<i>Pour la société
i>Paul van Baarle / Polyxeni Kotoula
<i>Deux administrateursi>
Référence de publication: 2011073727/26.
(110081764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
Transsoder Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 45.491.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2011i>
- Les mandats d'Administrateur de Monsieur François LANNERS employé privé, demeurant professionnellement au
57A, route d'Arlon, L- 7513 Mersch, de Monsieur Daniel PIERRE, employé privé, demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Kevin DE WILDE, employé privé, demeurant professionnellement au
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A.,
Société Anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, L-1882 Luxembourg sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2017.
79730
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.
Certifié sincère et conforme
TRANSSODER HOLDING S.A.
K. DE WILDE / D. PIERRE
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011073729/20.
(110081944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
Trentadue Investimenti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 146.930.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2011.
Référence de publication: 2011073730/10.
(110081229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
TV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.105.788,06.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.127.
<i>Résolution prise par les associés de la Société en date du 19 mai 2011i>
En date du 19 mai 2011, les associés de la Société ont pris la résolution de nommer les personnes suivantes en tant
que nouveaux gérants de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:
- Monsieur Walter SCOTT, né le 6 avril 1967 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse profes-
sionnelle: San Andrea Street, GFI House, San Gwann, SGN 1612, Malte, gérant de classe A,
- Monsieur Holger FELGNER, né le 25 juin 1971 à Krefeld/Hüls, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 16,
Kuhnbergstraße, 73037 Göppingen Gruß, Allemagne, gérant de classe A.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Mark LESSING, gérant de classe A
- Monsieur Bob GOODMAN, gérant de classe A
- Monsieur Alexander CRISSES, gérant de classe A
- Monsieur Mike TRIPLETT, gérant de classe A
- Monsieur Jeffrey HORING, gérant de classe A
- Monsieur Walter SCOTT, gérant de classe A
- Monsieur Holger FELGNER, gérant de classe A
- Monsieur Bruno BAGNOULS, gérant de classe B
- Madame Laurence GOBLET, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2011.
TV Holding S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011073732/29.
(110081776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
Unicorn Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 28.600,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 116.244.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 18 mai 2011i>
Lors des résolutions des associés, il a été décidé:
1. D’accepter la démission de M. Alain PEIGNEUX en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat.
79731
L
U X E M B O U R G
2. De nommer Mme. Géraldine SCHMIT, née le 12 novembre 1969 à Messancy, Belgique, ayant son adresse profes-
sionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme nouveau gérant de classe B de la Société, avec effet immédiat,
pour une durée indéterminée.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011073733/16.
(110081407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2011.
Opportunityflux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 134.291.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075081/9.
(110083732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Opportunityflux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 134.291.
L’adresse du commissaire aux comptes AUDIEX S.A. est dorénavant la suivante:
- AUDIEX S.A., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2011.
Référence de publication: 2011075082/11.
(110083733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Organ Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 116.119.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011075084/14.
(110083632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Patron Aachen Holdings S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 134.162.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075085/11.
(110082887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79732
L
U X E M B O U R G
European Fragrances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 160.611.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the thirteenth day of April.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
THERE APPEARED:
BRIDGEPOINT EUROPE IV INVESTMENTS S.À R.L., having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the companies register of Luxembourg under the number B
143.146,
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given in
London, on April 12, 2011.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
" 1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of European
Fragrances S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 13.4 -and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers
(as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other
securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the
79733
L
U X E M B O U R G
Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;
3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for
the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance
of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means;
for the purposes of this Article &#1;3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide
funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment
of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of
the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or
not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other
securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn
to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;
3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) divided into twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders"
means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-
curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.5 The Company may repurchase and cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-
holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer;
79734
L
U X E M B O U R G
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to re-
present and/or bind the Company:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers jointly;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons parti-
cipating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this
way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject
to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be
deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of
directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the reso-
lution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
79735
L
U X E M B O U R G
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.
13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting applies mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall
be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders
shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all Shareholders have voted or not.
14. Business year.
14.1 The Company’s financial year starts on 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year provided that,
as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the
following 31
st
December (all dates inclusive).
14.2 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be
held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law.
15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company, determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s).
16. Dissolution and Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a"person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-
cations) thereof.
79736
L
U X E M B O U R G
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a
particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by BRIDGEPOINT EUROPE IV INVESTMENTS S.À R.L., prenamed,
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-)
is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2011.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (1,400.-
EUR).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
capital has passed the following resolutions:
1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
a) HALSEY S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B Number 50.984, a company with its registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg;
b) Miss Kristel SEGERS, company director, born on October 8
th
, 1959, in Turnhout, Belgium, residing at 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg;
c) Mrs Daphne RIBOT, private employee, born on January 30
th
, 1979, in Caen, France, with professional address at
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
d) Mr Charles BARTER, company director, born on 5 April 1962 in Guildford (United Kingdom) residing at Flat 403,
City Pavilion, 33 Britton Street, London EC1M 5UG, United Kingdom;
e) Mr Paul GUNNER, company director, born on March 5
th
, 1973, in Cassington, United Kingdom, residing at Pursers
Farm Cottage, Pursers Lane, Peaslake, Surrey GU5 9RG, United Kingdom.
2) The Company shall have its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, he signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le treize avril.
Par-devant le soussigné Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
BRIDGEPOINT EUROPE IV INVESTMENTS S.À R.L., avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
143.146,
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé donnée à Londres le 12 avril 2011.
Laquelle procuration après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
79737
L
U X E M B O U R G
" 1. Forme sociale et Nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de European Fragrances S.à r.l.
(la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 En tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de
Gérance; ou
2.2.2 En tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une
résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément à ces Statuts – y compris
l'Article 13.4 – et les lois du Grand-Duché de Luxembourg de temps en temps, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxem-
bourgeoise").
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du
Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l’étranger sera prise par le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à
l’étranger.
3. Objets. Les objets de la Société sont:
3.1 D'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles
la Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription
initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, deben-
tures, debenture stocks, obligations, ou tous autres titres émis ou garantis par toute personne et tous autres biens de
toutes sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger ou disposer
des mêmes instruments;
3.2 De poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de
l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou des dettes de toute personnes poursuivant une activité commerciale;
3.3 D'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil
de Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas,
à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;
3.4 D'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de
Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté, y compris l'émission (dans les limites autorisées par la Loi
Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient
taxés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non émis, et de vendre, racheter
convertir et rembourser ces titres;
3.5 D'acquérir une participation dans, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout
arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque
ou autre avec toute personne, y compris tous employés de la Société;
3.6 De s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplis-
sement des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans
lequel la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment
un membre de ou détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute personne morale dans laquelle
l'Entité Holding détient un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associé avec la Société dans toute activité),
avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie
personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens
(présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclus toute obligation, bien
que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemnisation ou rester indemnisé
contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou d'en être responsable, de l'endettement ou obligations financières
de toute autre personne;
3.7 D'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout
droit ou privilège dessus;
3.8 De vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de
tout ou partie des établissements de la Société, pour une contrepartie que le gérant Unique ou le Conseil de Gérance
(selon le cas) considère approprié, y compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entiè-
79738
L
U X E M B O U R G
rement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets (ensemble ou seul) similaires à ceux de la
Société; détenir toutes parts sociales, obligations et autres titres ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre,
échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie
des biens et droits de la Société;
3.9 D'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du
monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, trustee ou autrement; (c) par voie ou à travers des trustees, agents,
sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec d'autres personnes;
3.10 D'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arran-
gements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Gérant Unique ou de Conseil de Gérance
(selon le cas) accessoires ou concluantes pour la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou de l'exercice
de tout ou partie de ses pouvoirs;
A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans toute transaction qui pourrait constituer une activité
réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans
besoin d'autorisation en vertu de la Loi Luxembourgeoise.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euro (€12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts,
"Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être interprété conformément.
5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou
autres titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions à un ou plusieurs comptes. Les décisions
quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant contribué au contributeur.
5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux sous réserve de dispositions contraires des présents
Statuts
5.5 La Société peut racheter et annuler ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions sur le rachat d'actions
propres dans la Loi de 1915.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une
Part Sociale notifient par écrit la Société de celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société
considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins
de vote, dividende et autres droits de paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles sauf pour raison de décès à d'autres personnes que des Associés à moins
que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession;
7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les
Associés détenant trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions
envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;
7.2.3 La cession de Parts Sociales est assujettie aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des
Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise à aux présents Statuts.
8.2 Si la Société est administrée à un moment par Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts par le "Gérant
Unique".
8.3 Si la Société est administrée de temps en temps par plus qu'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le
"Conseil" ou le "Conseil de Gérance").
8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi
Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul gérant, ou en cas de pluralité
de Gérant le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à
79739
L
U X E M B O U R G
l'accomplissement de l’objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise
et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes
suivantes sont autorisées à représenter et/ou à lier la Société:
10.1 Si la Société est administrée par un gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 En cas de pluralité de Gérants, n'importe quels deux Gérants conjointement;
10.3 Toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'Article 11.
11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourront
déléguer n'importe lesquels de leurs pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc
et devront déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et rémunération (si c'est le cas), la durée de
leur période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.
12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance devra nommer un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans
se plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du
Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonction en son nom à la Réunion du
Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant
aux quorums requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne
ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Gérants
sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie
d’utilisation de conférence téléphonique , de vidéo conférence et de conférence téléphonique ou de tous autres équipe-
ments de communication à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de
s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputé être présent
en personne à la réunion et devra être compté dans le quorum et sera autorisé à voter. Sous réserve de la Loi Luxem-
bourgeoise, toutes les activités commerciales qui sont effectuées de cette manière par tous les Gérants seront réputés
pour les besoins des présents statuts, valables et effectivement effectuées à une Réunion du Conseil, peu importe que
moins que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum aient été physiquement
présents au même endroit.
12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou en relation avec tout Gérant, son Représentant) est valide
comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou
plusieurs documents ayant le même contenu et signée par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.
12.7 Les procès-verbaux d'un Conseil de Gérance devront être signés et les extraits de ces procès -verbaux pourront
être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.
13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.
13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides
uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si une telle
figure n'est pas atteinte lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront
convoquer ou être consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la
majorité des votes, sans préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa
participation dans la Société sans un vote unanime des Associés.
13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y
compris le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité des
Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.
13.5 Une résolution pour dissoudre la Société ou déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour
nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
13.6 Une réunion des Associés (une "Réunion des Associés") peut valablement débattre et prendre des décisions sans
se conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion des Associés en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
79740
L
U X E M B O U R G
13.7 Un Associé peut être représenté à une Réunion des Associés en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout
autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.8
13.8.1 S’il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les résolutions des Associés pourront être passées par voie
de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Réunion des Associés à la condition que chaque Associé reçoive
le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote part écrit.
13.8.2 Les conditions de majorité requises pour l'adoption des résolutions lors de Réunion des Associés s'appliquent
mutatis mutandis pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Hormis lorsque cela est requis par la Loi Lu-
xembourgeoise, il n'existe pas de condition de quorum requis pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés.
Les résolutions écrites des Associés seront valablement prises lorsque la Société aura reçu les copies originales (ou copies
envoyées par fax ou pièces jointes à un email) des votes des Associés soumis aux conditions de l'Article 13.8.1 et des
dispositions ci-dessus de cet Article 13.8.2, indépendamment du fait que tous les Associés aient voté ou non.
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu
que, en tant que mesure transitoire, le premier exercice social de la Société débute à la date de sa constitution et se
termine le 31 décembre suivant (toutes dates comprises).
14.2 S’il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, au moins une assemblée générale annuelle doit être tenue
en vertu de l'article 196 de la Loi de 1915.
15. Distribution sur parts sociales.
15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%)
seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve
légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des
Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires au
(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables par
le(s) Associé(s).
16. Dissolution et Liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Réunion des Associés en conformité
avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) Un genre devra inclure chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouverne-
ment, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation
des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition légale ou statuts inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec
ou sans modifications);
17.1.2 les mots "inclus" et "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on
ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots
indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots
généraux;
17.1.3 Les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.
En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembour-
geoise."
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites par BRIDGEPOINT EUROPE IV INVESTMENTS S.À R.L., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
Euro (€ 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
79741
L
U X E M B O U R G
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents Euros (1.400.-EUR).
<i>Résolutionsi>
Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) HALSEY S.à r.l., R.C.S Luxembourg, B Numéro 50.984, une société avec siège social au 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg;
b) Mademoiselle Kristel SEGERS, administrateur de sociétés, née le 8 octobre 1959 à Turnhout, Belgique, demeurant
à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
c) Madame Daphné RIBOT, employée privée, née le 30 janvier 1979, à Caen, France, avec adresse professionnelle au
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
d) Monsieur Charles BARTER, administrateur de sociétés, né le 5 avril 1962 à Guildford (Royaume-Uni), demeurant
à Flat 403, City Pavilion, 33 Britton Street, London EC1M 5UG, Royaume-Uni;
e) Monsieur Paul GUNNER, administrateur de sociétés, né le 5 mars 1973, à Cassington, Royaume-Uni, demeurant à
Pursers Farm Cottage, Pursers Lane, Peaslake, Surrey GU5 9RG, Royaume-Uni.
2) Le siège social de la Société est établi au 2 avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2011. Relation: LAC/2011/18446. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mai 2011.
Référence de publication: 2011059627/532.
(110067137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.
Paser Participations S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 44.287.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2011.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A.
SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire
aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
<i>Pour la société
i>PASER PARTICIPATIONS S.A., société de gestion de patrimoine familiale, “SPF”
Référence de publication: 2011075102/16.
(110083586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79742
L
U X E M B O U R G
Patron Elke S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.590.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075088/11.
(110082886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Patron Ewald Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.591.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075089/11.
(110082890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Passaya S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.349.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075103/10.
(110083589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Patron Volker Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.593.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075090/11.
(110082892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Patron Volker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.594.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075091/11.
(110082891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79743
L
U X E M B O U R G
Prodac Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 149.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.927.
Les comptes annuels pour la période du 29 juillet 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2011.
Référence de publication: 2011075094/12.
(110083425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 200.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 112.103.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 mai 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec immédiat
2. Nomination de Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2011.
Référence de publication: 2011075096/15.
(110083123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Prudential Capital Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.158.640,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 115.098.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2011.
Référence de publication: 2011075097/11.
(110083423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Palmatrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 86.824.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2011, que le siège social a été transféré au 251, route de
Luxembourg à L-3378 LIVANGE.
Pour extrait conforme
Tommy SZEGEDY
Référence de publication: 2011075098/11.
(110083400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Lee Cooper International Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1736 Luxembourg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 159.479.
In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
79744
L
U X E M B O U R G
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Lee Cooper International Management S.à r.l. &
Partners S.C.A.”, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated and existing under
Luxembourg law, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159479 (hereinafter referred to as the
Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy
of Luxembourg, of February 25, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is chaired by Regis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Solange Wolter, notary clerk, with professional address at 101,
rue Cents, L-1319 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act that:
I. The shareholders present or represented by virtue of four (4) proxies given in March 2011 and the number of their
shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.
The said list will be registered with these minutes.
II. It appears from the said attendance list, that all the ordinary shares in circulation and the one (1) management share,
representing together one hundred per-cent (100%) of the share capital of the Company, which shares are fully paid up,
are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all
the items of its agenda.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg;
2. Amendment of the first paragraph of article 4 of the Company’s bylaws;
3. Conversion of the existing thirty-one thousand (31.000) ordinary shares into thirty-one thousand (31.000) class A
ordinary shares.
4. Acknowledgement of the resignation of Ms. Anita Lyse as member of the supervisory board;
5. Appointment with immediate effect and until the annual general meeting to be held in 2012, of Mr. Stephane Bourg,
born on November 20, 1973 in Nantes, France, having his professional address at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as supervisory board member of the Company;
6. Acknowledgement of the new composition of the supervisory board of the Company;
7. Entire restatement of the articles of association of the Company.
IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend the first paragraph of article 4 of the Company’s bylaws so that it shall read as follows:
“ Art. 4. The registered office of the Company is established in Senningerberg.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to convert the existing thirty-one thousand (31.000) ordinary shares into thirty-one thousand
(31.000) class A ordinary shares.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge and accepts the resignation with immediate effect of Ms. Anita Lyse as member
of the supervisory board, born on October 4, 1976 in Alesund, Norway, having her professional address at 5, Rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg from her position as member of the supervisory
board of the Company, and grants her discharge for the execution of her mandate until that date.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to appoint with immediate effect and until the annual general meeting to be held in 2012, Mr.
Stephane Bourg, prenamed, as supervisory board member of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to acknowledge that further to the above resignation and appointment, the supervisory board
of the Company is until the annual general meeting to be held in 2012, composed of:
- Mr. Stephane Bourg, prenamed;
79745
L
U X E M B O U R G
- Mr. Clarence Terry, born on July 11, 1946 in Virginia, United States of America, having his professional address at
5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, United States of America;
- Mr. Lynn Skillen, born on December 29, 1955 in Kansas, United States of America, having his professional address
at 5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, United States of America.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company as follows:
Title I. Denomination, Object, Duration, Registered office
Art. 1. There exists a partnership limited by shares under the name of “Lee Cooper International Management S.à r.l.
& Partners S.C.A.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in
particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the
present articles of association (hereinafter, the Articles) and by any securityholders’ agreement which may be entered
into from time to time between amongst others, all of the shareholders.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin, participate in the creation, development
and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed. The Company may grant assis-
tance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the
Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including sha-
reholders or affiliated entities).
In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-
tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which are liable to promote their development.
The Company may borrow in any form including by way of public offer. It may issue by way of private or public
placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities, subject
always to the provisions of any securityholders’ agreement which may be entered into from time to time between amongst
others, all of the shareholders. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge,
transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the
Manager (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders,
as required by the then applicable provisions of the Law.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. The share capital is set at thirty-one thousand one Euro (EUR 31.001,00) represented by thirty-one thousand
(31.000) class A ordinary shares (hereinafter, the Class A Shares) and one (1) management share (hereinafter, the Ma-
nagement Share), all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
The authorized capital, excluding the subscribed share capital, is set at ten thousand Euro (EUR 10.000,00) represented
by ten thousand (10.000) class B ordinary shares (hereinafter, the Class B Shares and together with the Class A Shares,
the Ordinary Shares), with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, to be vested with the same rights and obligations,
save as for the specific provisions of the Articles or as defined in any securityholders’ agreement that may be entered
into amongst others, all of the shareholders.
The Manager (as defined below) is authorized, during a period of five (5) years from the date of the notarial public
deed enacting the Articles, to increase from time to time the subscribed capital by the amount of the authorized capital.
These increases of capital may be subscribed and class B ordinary shares issued with or without issue premium and paid
up by contribution in kind or cash in accordance with the law and any securityholders’ agreement which may be entered
into amongst others, all of the shareholders. The Manager is specifically authorized to proceed with the issuance of such
authorized shares without reserving for the then existing shareholders, of whichever class of shares, a preferential right
to subscribe for the shares to be issued, except as otherwise set forth in any securityholders’ agreement which may be
entered into from time to time between amongst others, all of the shareholders. In addition to the subscribed share
79746
L
U X E M B O U R G
capital, there shall be set up a premium account per each class of shares into which any premium amount paid on any
share of that class in addition to its nominal value is transferred.
Any share premium paid on the subscription of shares of a given class shall always remain attached to the shares on
which it has been paid and shall be reimbursed exclusively to the owners of such shares.
The amount of the premium account of a given class of shares may be used to provide for the payment of any shares
of that class, which the Company may redeem, from its shareholders.
The Management Share shall be held by Lee Cooper International Management S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 159431, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles and any securityholders’
agreement which may be entered into amongst others, all of the shareholders.
The Ordinary Shares and the Management Share are and shall remain registered shares.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with
Article 13 of the Articles and any securityholders’ agreement which may be entered into from time to time between
amongst others, all of the shareholders.
Art. 7. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 8. Any Management Share held by the Manager is exclusively transferable to a successor or additional manager
with unlimited liability.
The Ordinary Shares are exclusively transferable in accordance with the provisions of any securityholders’ agreement
which may be entered into from time to time between amongst others, all of the shareholders.
Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of one of the shareholders.
Title III. Management
Art. 10. The Company is managed by the Manager.
The Manager may only be removed by the unanimous consent of all the shareholders.
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager
of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board as
provided for in Article 14 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to effect urgent or mere
administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen
(15) days of his appointment. At such general meeting, all of the shareholders may appoint, in accordance with the quorum
and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such appointment, the Company
shall be dissolved and liquidated.
Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.
Art. 11. In dealing with third parties, the Manager shall have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s purpose, provided
that the terms of this article and any securityholders’ agreement which may be entered into from time to time between
amongst others, all of the shareholders, shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the
Supervisory Board shall fall within the competence of the Manager.
Towards third parties, the Company is validly bound by the signature of the Manager represented by duly appointed
representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.
The Manager shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders,
selected among the members of its management body or not, either shareholders of the Company or not.
Art. 12. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.
The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other
than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contri-
butions to the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the fact that the Manager or any one or more of the managers, directors, officers or executives of the Manager is
interested in, or is a director, manager, associate, officer, executive or employee of such other company or firm. Any
director, manager, officer or executive of the Manager who serves as a director, manager, associate, officer, executive
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
79747
L
U X E M B O U R G
by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.
Title IV. General meeting of shareholders
Art. 13. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the
powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise
provided in the Articles, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager. Notwithstanding the
foregoing, any resolution which conflicts with any securityholders’ agreement which may be entered into from time to
time between amongst others, all of the shareholders shall be null and void.
General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. General meetings
of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by registered
letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address recorded in the register
of registered shares, provided, however, that all shares are registered shares.
The annual general meeting of the shareholders shall be held on the second Monday of the month of June at 11.00
a.m. CET at the registered office of the Company or at any other location specified in the notice of meeting.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication
allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another,
(iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting.
Subject to the approval of the Manager and compliance with any securityholders’ agreement which may be entered
into from time to time between amongst others, all of the shareholders, the Articles may be amended from time to time
by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, unless the Articles provide differently.
Title V. Supervisory board
Art. 14. The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be
supervised by the Supervisory Board, comprising at least three (3) members. The Supervisory Board may be consulted
by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions of the Manager that may,
pursuant to law or regulation or under these articles of association, exceed the powers of the Manager.
The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one year. The
members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at
least eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram,
telex, facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board.
Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means
of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.
The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or repre-
sented.
Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two members.
Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as
resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram,
telex, facsimile or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents
shall form the record that proves that such resolution has been taken.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
79748
L
U X E M B O U R G
Title VI. Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established by the Manager who also prepares
an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold
is no longer met.
The balance of the net profit may exclusively be distributed to the shareholders in accordance with the provisions of
any securityholders’ agreement which may be entered into from time to time between amongst others, all of the share-
holders.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by any securityholders’
agreement which may be entered into from time to time between amongst others, all of the shareholders.
Title VII. Dissolution, Liquidation
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the
provisions of Article 17, except those related to the legal reserve.
Title VIII. General provision
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law and to any securityholders’ agreement which may be entered
into amongst others, all of the shareholders for all matters for which no specific provision is made in the Articles.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present changes of the Company’s Supervisory board and registered seat, are estimated at approximately one
thousand five hundred Euro (EUR 1.500,00).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day first written above.
The document having been read to members of the bureau and to the proxyholder of the persons appearing, all of
whom are known to the notary by their full name, civil status and residences, they signed together with Us, the notary,
the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L’an deux mille onze, le trente-et-un mars.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «Lee Cooper
International Management S.à r.l. & Partners S.C.A.», ayant son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 159479, constituée par acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg en date du 25 février 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Regis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents,
L-1319 Luxembourg
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son adresse profession-
nelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de procurations données en mars 2011 et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire
79749
L
U X E M B O U R G
soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement.
II. Il apparait de cette liste de présence que la totalité des actions ordinaires et une (1) action de commandité, repré-
sentant ensemble cent pour-cent (100%) du capital social de la Société, toutes entièrement libérées, sont présentes ou
représentées à la présente assemblée, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à son
ordre du jour.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 4 des statuts de la Société;
3. Conversion des trente et un mille (31.000) actions de commanditaire en trente et un mille (31.000) actions de
commanditaire de catégorie A.
4. Reconnaissance de la démission de Mme. Anita Lyse en tant que membre du conseil de surveillance;
5. Nomination avec effet immédiat et jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle pour l’année 2012, de M.
Stephane Bourg, né le 20 novembre 1973 à Nantes, France, ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que membre du conseil de surveillance de la Société;
6. Reconnaissance de la nouvelle composition du conseil de surveillance;
7. Refonte intégrale des statuts de la Société.
IV. L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 1B,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite au transfert du siège social de la Société l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts
de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir les trente et un mille (31.000) actions de commanditaire en trente et un mille (31.000)
actions de commanditaire de catégorie A
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de reconnaître la démission avec effet immédiat de Mme. Anita Lyse, née le 4 octobre 1976 à
Alesund, Norvège, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que membre
du conseil de surveillance et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à cette date.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer avec effet immédiat et jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle pour l’année
2012, Mr. Stéphane Bourg, prénommé, en tant que membre du conseil de surveillance de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de reconnaitre que suite à la démission et nouvelle nomination et jusqu’à la tenue de l’assemblée
générale annuelle pour l’année 2012, le conseil de surveillance se compose comme ci-après:
- M. Stephane Bourg, prénommé;
- M. Clarence Terry, né le 11 juillet 1946 en Virginie, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au
5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, États-Unis d'Amérique;
- M. Lynn Skillen, né le 29 décembre 1955 au Kansas, États-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au
5200, Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, États-Unis d'Amérique.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de refondre intégralement les statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:
Titre I
er
. Dénomination, Objet, Durée, Siège social
Art. 1
er
. Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination de «Lee Cooper International
Management S.à r.l. & Partners S.C.A.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en
particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par
79750
L
U X E M B O U R G
les présents statuts (ci-après, les Statuts) et par tout pacte de détenteurs de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre
autres, tous les actionnaires.
Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder
tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient
une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses actionnaires ou
entités liées).
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y compris par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
par voie de placement privé ou public, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances sous réserve toujours des dispositions de tout pacte de détenteurs de titres qui
serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires de la Société. Elle peut également consentir des garanties
ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans à Senningerberg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l’intérieur de la même commune ou dans une autre commune par décision
du Gérant (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tel que
requis par les dispositions applicables de la Loi.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social de la Société s’élève à trente et un mille un Euro (EUR 31.001,00) représenté par trente et un
mille (31.000) actions de commanditaire de catégorie A (ci-après, les Actions de Catégorie A) et une (1) action de
commandité (ci-après, l’Action de Commandité), toutes d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.
Le capital autorisé, excluant le capital souscrit, s’élève à dix mille Euro (EUR 10.000,00) représenté par dix mille (10.000)
actions ordinaires de catégorie B (ci-après les Actions de Catégorie B, et ensemble avec les Actions de Catégorie A, les
Actions Ordinaires), ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune, qui auront les mêmes droits et obligations,
prévus de manière spécifique par les statuts ou tel que défini dans tout pacte de détenteurs de titres qui serait entré en
vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires.
Le Gérant (tel que défini ci-après) est autorisé, durant une période de cinq (5) ans depuis la date de l’acte public notarié
enregistrant les Statuts, d’augmenter occasionnellement le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations de capital peuvent être souscrites et des actions ordinaires de catégorie B émises avec ou sans prime
d’émission et payées par apport en nature ou en espèce en accord la Loi et tout pacte de détenteurs de titres qui serait
entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires. Le Gérant est spécifiquement autorisé à procéder à l’émission
de telles actions sans réserver aux actionnaires existants, détenteurs de quelconque catégories d’actions, un droit pré-
férentiel de souscrire aux actions émises, excepté si défini autrement dans tout pacte de détenteurs de titres qui serait
entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires. En plus du capital souscrit, il devrait être mis en place un
compte de prime pour chaque catégorie d’action dans lequel toute prime payée sur n’importe quelle action de cette
catégorie, en plus de sa valeur nominale, sera transférée.
Toute prime payée sur la souscription d’actions d’une catégorie donnée devrait toujours reste attachée aux actions
sur lesquelles elle a été payée et devrait être remboursée exclusivement aux propriétaires desdites actions.
Le montant du compte de prime d’une catégorie donnée d’actions pourra être utilisé afin de permettre le paiement
de toutes actions de cette catégorie que la Société pourra racheter de ses actionnaires.
L’Action de Commandité est détenue par Lee Cooper International Management S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159431, en
tant qu’actionnaire à responsabilité illimité et commandité (ci-après, le Gérant).
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi et les Statuts et tout pacte de détenteurs
de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires.
79751
L
U X E M B O U R G
Les Actions Ordinaires et l’Action de Commandité sont et resteront nominatives.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,
conformément à l’Article 13 des Statuts et tout pacte de détenteurs de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre
autres, tous les actionnaires.
Art. 7. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis. Les co-
propriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 8. Toute Action de Commandité appartenant au Gérant ne peut être cédée qu’à un gérant remplaçant ou addi-
tionnel ayant une responsabilité illimitée.
Toute Action Ordinaire ne peut être cédée que sous réserve toujours des dispositions de tout pacte de détenteurs
de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires.
Art. 9. La Société n’est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’un des actionnaires.
Titre III. Administration
Art. 10. La Société est gérée par le Gérant.
Le Gérant peut seulement être remplacé par l’accord unanime de tous les actionnaires.
En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses
fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil
de Surveillance, suivant l’Article 14, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être actionnaire, afin d’exécuter les
actes de gestion simples ou urgents, jusqu’à ce que se tienne une assemblée générale d’actionnaires, convoquée par cet
administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, tous les actionnaires
pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification
des Statuts. L’absence d’une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.
Une telle nomination d’un gérant remplaçant n’est pas soumise à l’approbation du Gérant.
Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circons-
tances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social de la Société, sous réserve
qu’aient été respectés les termes du présent article et de tout pacte de détenteurs de titres qui serait entré en vigueur
parmi, entre autres, tous les actionnaires.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires ou bien au Conseil de Surveil-
lance par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des représentants
dûment nommés ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le Gérant.
Le Gérant a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi les membres
de son propre organe de gestion ou non, actionnaires de la Société ou non.
Art. 12. Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être couvertes
par les actifs de la Société.
Les détenteurs d’Actions Ordinaires s’abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en
quelque qualité que ce soit autrement qu’en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont
tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.
Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne pourra
être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir du
Gérant auraient un intérêt dans telle autre société ou firme ou par le fait qu’ils seraient administrateurs, associés, direc-
teurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. Tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société
passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires sera, par là même, privé du droit de délibérer,
de voter et d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires.
Titre IV. Assemblée générale des actionnaires
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les
pouvoirs pour ordonner, faire ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve que, sauf si les Statuts
en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est approuvée par le Gérant. Nonobstant
les dispositions précédentes, toutes décision qui entrerait en conflit avec tout pacte de détenteurs de titres qui serait
entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires de la Société, devrait être considérée nulle et non avenue.
L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assemblées
générales d’actionnaires seront convoquées par une convocation donnée par le Gérant indiquant l’ordre du jour et envoyé
par courrier recommandé au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire à l’adresse des
79752
L
U X E M B O U R G
actionnaires telle qu’inscrite au registre des actions nominatives, sous réserve, toutefois, que toutes les actions soient
nominatives.
L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures CET, au siège social ou en
tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable
suivant.
D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les convocations.
Tout actionnaire de la Société peut participer par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen
de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l’assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute
personne participant à l’assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l’assemblée est retransmise
en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne
à l’assemblée.
Les Statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation du Gérant et en accord avec tout pacte de dé-
tenteurs de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires, par une assemblée générale des
actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, à moins que les Statuts n’en disposent autrement.
Titre V. Conseil de surveillance
Art. 14. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront
surveillées par le Conseil de Surveillance composé d’au moins trois (3) membres. Le Conseil de Surveillance peut être
consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du Gérant qui,
selon la Loi, les règlements ou les présents Statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.
Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période d’un an. Les
membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance élit un de ses membres comme
président.
Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.
Une notification écrite de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit
(8) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de
l’urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut être outrepassée par écrit, télégramme, télex ou
télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spéciales
pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus préalablement par une résolution du Conseil de Surveil-
lance.
Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme,
télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque membre
peut représenter plusieurs de ses collègues.
Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres sont
présents ou représentés.
Les résolutions du Conseil de Surveillance sont inscrites dans des procès verbaux signés par le président de la réunion.
Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président de
la réunion ou deux membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet que
les décisions votées lors d’une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télé-
gramme, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue. Une telle approbation doit être confirmée par
écrit et tous les documents constitueront la preuve qu’une telle décision a été adoptée.
Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence
téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires par lesquels toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant, qui prépare
aussi un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout actionnaire peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
79753
L
U X E M B O U R G
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net ne peut être distribué aux actionnaires qu’en accord avec les dispositions de tout pacte de
détenteurs de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales et tout pacte de détenteurs
de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, action-
naires ou non, nommés par les actionnaires qui déterminent leurs pouvoirs et rémunération.
Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux actionnaires se fait en application des stipulations
de l’Article 17 à l’exception de celles relatives à la réserve légale.
Titre VIII. Disposition générale
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi et aux
dispositions de tout pacte de détenteurs de titres qui serait entré en vigueur parmi, entre autres, tous les actionnaires.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présents changements de membre du conseil de surveillance et de siège social, sont évalués sans nul préjudice
à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,00).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du
notaire par leur nom, prénom, statut et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 avril 2011. Relation: LAC/2011/16609. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 mai 2011.
Référence de publication: 2011059717/527.
(110067301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.
Pegase Investment, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.359.
EXTRAIT
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 25 mars 2011 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats de:
- M. Olivier Ferrari, 5 Quai Perdonnet, 1800 Vevey 1, Suisse
- Mme Michéle Berger, 3 boulevard Royal, 2449 Luxembourg
- M. Frédéric Fasel, 1 boulevard Royal, 2449 Luxembourg
pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé Deloitte S.A. pour une période d’une année
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2012.
Pegase Investment
Référence de publication: 2011075104/17.
(110083018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79754
L
U X E M B O U R G
Peninsula Bay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 117.322.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075105/9.
(110082875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Pisciculture Kieffer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8545 Niederpallen, 2, rue de Reichlange.
R.C.S. Luxembourg B 94.417.
En date du 19 janvier 2011, il résulte que les associés ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
Démission de Madame Christiane Bock demeurant L-8545 Niederpallen, 2 rue de Reichlange, au poste de gérante
avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
Décision de nommer Monsieur Pascal Kieffer demeurant L-8545 Niederpallen, 2 rue de Reichlange, au poste de gérant
jusqu’à l’année 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pisciculture Kieffer S.à.r.l.
Référence de publication: 2011075108/16.
(110083026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Playcenter International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 63.239.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011075109/11.
(110083696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Sogeco Participations Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 105.835.
<i>Extrait des délibérations du conseil de gérance en date du 20 avril 2011 à Luxembourg villei>
Le conseil de gérance constate le changement d'adresse du gérant B, Monsieur Alain NOULLET, né le 2 novembre
1960 à Berchem Sainte Agathe (Belgique) du 14, rue du Marché-aux-herbesL-1728 Luxembourg vers le 128, Boulevard
de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011075131/15.
(110083247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79755
L
U X E M B O U R G
PVV SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 82.676.
Les comptes annuels au 31. Dezember 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für PVV SICAV
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2011075114/11.
(110083216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
R.M.S. LU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9044 Ettelbruck, 16, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 91.563.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075116/10.
(110082888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Reichert Technology, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4531 Differdange, 126, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.399.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2011075119/11.
(110083173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
RESTO WU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 76, route Principale.
R.C.S. Luxembourg B 151.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075125/10.
(110083754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
RHIC Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 75.768.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2011.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2011075127/12.
(110083200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79756
L
U X E M B O U R G
Resitalia Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 95.323.
EXTRAIT
Suite à la scission de l'associé unique en date du 15 décembre 2010, il résulte que les 500 parts sociales de la société,
d'une valeur nominale de EUR 25.- chacune, sont désormais attribuées à Hockney Holding S.à r.l, ayant son siège social
au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 30 mai 2011.
Référence de publication: 2011075122/14.
(110083144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Scatec Norvège Holding II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 153.079.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SCATEC NORVÈGE HOLDING II S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011075128/11.
(110083061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
L14 Capital Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 151.687.
In the year two thousand and eleven, on the eighth of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of L14 Capital Partners S.A., a joint-stock company
(société anonyme) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 20, Boulevard Em-
manuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 151687, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 12, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 759, of April 12, 2010, and whose bylaws have been last amended by a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated July 5, 2010, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1848, of September 9, 2010 (the Company).
The meeting is chaired by Ms. Laura Gehlkopf, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr. Regis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Regis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
registered with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all the seventy-five million (75.000.000) shares in circulation representing
the entire share capital of the Company, presently set at seven hundred fifty thousand Euro (EUR 750.000,00), which
shares are fully paid up, are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide
on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of ninety-five thousand three hundred five Euro and two cents (EUR 95.305,02) in
order to raise it from its present amount of seven hundred fifty thousand Euro (EUR 750.000,00) to eight hundred forty-
79757
L
U X E M B O U R G
five thousand three hundred five Euro and two cents (EUR 845.305,02) by creation and issuance of nine million five
hundred thirty thousand five hundred two (9.530.502) new shares, with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each (the
New Shares 1);
2. Waiver of their preferential subscription right by the current shareholders of the Company;
3. Subscription by Mr. Philippe Paillot, born on October 13, 1988, in Lisieux, France, having his personal address at
Clos dessus, 1267 Vich, Switzerland, for nine hundred eighty-two thousand five hundred twenty-six (982.526) New Shares
1, and full payment in the amount of nine thousand eight hundred twenty-five Euro and twenty-six cents (EUR 9.825,26),
together with a share premium in the amount of ninety thousand one hundred seventy-four Euro seventy-four cents (EUR
90.174,74), by payment in cash in the aggregate amount of one hundred thousand Euro (EUR 100.000,00);
4. Subscription by Mr. Yves-Régis Cotrel, born on January 13, 1952, in Berck, France, having his personal address at
Chemin de Praz Buchilly 101, Epalinges 1000 Lausanne 25, Switzerland, for seven hundred thirty-six thousand eight
hundred ninety-four (736.894) New Shares 1, and full payment in the amount of seven thousand three hundred sixty-
eight Euro and ninety-four cents (EUR 7.368,94), together with a share premium in the amount of sixty-seven thousand
six hundred thirty-one Euro and six cents (EUR 67.631,06), by payment in cash in the aggregate amount of seventy-five
thousand Euro (EUR 75.000,00), from a joint bank account;
5. Subscription by Mr. Sebastien Cotrel, born on December 24, 1981, in Abbeville, France, having his personal address
at 124, rue Thiers, Appt 1b4, 92100 Boulogne Billancourt, France, for five hundred eighty-nine thousand five hundred
sixteen (589.516) New Shares 1, and full payment in the amount of five thousand eight hundred ninety-five Euro and
sixteen cents (EUR 5.895,16), together with a share premium in the amount of fifty-four thousand one hundred four Euro
and eighty-four cents (EUR 54.104,84), by payment in cash in the aggregate amount of sixty thousand Euro (EUR
60.000,00);
6. Subscription by PemaQuid Partners L.L.C., a limited liability company established and existing under the laws of
Delaware, United States of America, having its registered office at c/o Corporate Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle, DE 19801, United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of
Delaware under number 4041599 for nine hundred eighty-two thousand five hundred twenty-six (982.526) New Shares
1, and full payment in the amount of nine thousand eight hundred twenty-five Euro and twenty-six cents (EUR 9.825,26),
together with a share premium in the amount of ninety thousand one hundred seventy-four Euro seventy-four cents (EUR
90.174,74), by payment in cash in the aggregate amount of one hundred thousand Euro (EUR 100.000,00);
7. Subscription by Mr. Yves-Alexandre Cotrel, born on February 26, 1978, in Abbeville, France, having his personal
address at 4, Avenue de Montpensier, 60500 Chantilly, France, for five hundred eighty-nine thousand five hundred sixteen
(589.516) New Shares 1, and full payment in the amount of five thousand eight hundred ninety-five Euro and sixteen cents
(EUR 5.895,16), together with a share premium in the amount of fifty-four thousand one hundred four Euro and eighty-
four cents (EUR 54.104,84), by payment in cash in the aggregate amount of sixty thousand Euro (EUR 60.000,00);
8. Subscription by Mr. John Donohue, born on April 22, 1960, à New-York, United States of America, having his
personal address at 3333 43rd Avenue NE, Seattle, WA 98105, United States of America for four hundred ninety-one
thousand two hundred sixty-three (491.263) New Shares 1, and full payment in the amount of four thousand nine hundred
twelve Euro and sixty-three cents (EUR 4.912,63), together with a share premium in the amount of forty-five thousand
eighty-seven Euro and thirty-seven cents (EUR 45.087,37), by payment in cash in the aggregate amount of fifty thousand
Euro (EUR 50.000,00);
9. Subscription by Mr. Christian Barbey, born on April 30, 1951, in Sainte Adresse, France, having his personal address
at Route de la Croix 137, 1095 Lutry, Switzerland, for two million nine hundred forty-seven thousand five hundred
seventy-eight (2.947.578) New Shares 1, and full payment in the amount of twenty-nine thousand four hundred seventy-
five Euro and seventy-eight cents (EUR 29.475,78), together with a share premium in the amount of two hundred seventy
thousand five hundred twenty-four Euro and twenty-two cents (EUR 270.524,22), by payment in cash in the aggregate
amount of three hundred thousand Euro (EUR 300.000,00);
10. Subscription by Ryames Investment Company L.L.C., a limited liability company established and existing under the
laws of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o Corporate Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, United States of America, and registered with the Secretary of State of the
State of Delaware under number 3668206, for one million four hundred seventy-three thousand seven hundred eighty-
nine (1.473.789) New Shares 1, and full payment in the amount of fourteen thousand seven hundred thirty-seven Euro
and eighty-nine cents (EUR 14.737,89), together with a share premium in the amount of one hundred thirty-five thousand
two hundred sixty-two Euro and eleven cents (EUR 135.262,11), by payment in kind consisting in the conversion of a
receivable in the aggregate amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00), held by it towards the Company;
11. Subscription by Ms. Marie-Madeleine Cotrel, born on September 30, 1950, having their personal address at Chemin
de Praz Buchilly 101, Epalinges 1000 Lausanne 25, Switzerland, for seven hundred thirty-six thousand eight hundred ninety-
four (736.894) New Shares 1, and full payment in the amount of seven thousand three hundred sixty-eight Euro and
ninety-four cents (EUR 7.368,94), together with a share premium in the amount of sixty-seven thousand six hundred
thirty-one Euro and six cents (EUR 67.631,06), by payment in cash in the aggregate amount of seventy-five thousand Euro
(EUR 75.000,00);
79758
L
U X E M B O U R G
12. Distribution in cash of the share premium in the aggregate amount of eight hundred seventy-four thousand six
hundred ninety-four Euro and ninety-eight cents (EUR 874.694,98) to the shareholders in proportion to their share-
holding;
13. Capital increase to the extent of eight hundred seventy-four thousand six hundred ninety-four Euro and ninety-
eight cents (EUR 874.694,98) in order to raise it from its amount of eight hundred forty-five thousand three hundred five
Euro and two cents (EUR 845.305,02) to one million seven hundred twenty thousand Euro (EUR 1.720.000,00) by creation
and issue of eighty-seven million four hundred sixty-nine thousand four hundred ninety-eight (87.469.498) new shares,
with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each (the New Shares 2);
14. Subscription by Mr. Philippe Paillot, prenamed, for seven million one hundred thirty-nine thousand five hundred
seventy-eight (7.139.578) New Shares 2, and full payment in the amount of seventy-one thousand three hundred ninety-
five Euro and seventy-eight cents (EUR 71.395,78) by offsetting the amount of share premium owed to him by the
Company by virtue of the above resolutions;
15. Subscription by Mr. Yves-Régis Cotrel, prenamed, for six million eight hundred eighty-five thousand four hundred
five (6.885.405) New Shares 2, and full payment in the amount of sixty-eight thousand eight hundred fifty-four Euro and
five cents (EUR 68.854,05) by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the
above resolutions;
16. Subscription by Mr. Sebastien Cotrel, prenamed, for six hundred ten thousand thirteen (610.013) New Shares 2,
and full payment in the amount of six thousand one hundred Euro and thirteen cents (EUR 6.100,13) by offsetting the
amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions;
17. Subscription by PemaQuid Partners L.L.C., prenamed, for one million sixteen thousand six hundred eighty-six
(1.016.686) New Shares 2, and full payment in the amount of ten thousand one hundred sixty-six Euro and eighty-six
cents (EUR 10.166,86) by offsetting the amount of share premium owed to it by the Company by virtue of the above
resolutions;
18. Subscription by Mr. Yves-Alexandre Cotrel, prenamed, for six hundred ten thousand thirteen (610.013) New
Shares 2, and full payment in the amount of six thousand one hundred Euro and thirteen cents (EUR 6.100,13) by offsetting
the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions;
19. Subscription by Mr. John Donohue, prenamed, for five hundred eight thousand three hundred forty-three (508.343)
New Shares 2, and full payment in the amount of five thousand eighty-three Euro and forty-three cents (EUR 5.083,43)
by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions;
20. Subscription by Mr. Christian Barbey, prenamed, for three million fifty thousand sixty-one (3.050.061) New Shares
2, and full payment in the amount of thirty thousand five hundred Euro sixty-one cents (EUR 30.500,61) by offsetting the
amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions;
21. Subscription by Ryames Investment Company L.L.C., prenamed, for one million five hundred twenty-five thousand
thirty (1.525.030) New Shares 2, and full payment in the amount of fifteen thousand two hundred fifty Euro and thirty
cents (EUR 15.250,30) by offsetting the amount of share premium owed to it by the Company by virtue of the above
resolutions;
22. Subscription by Mr. Emmanuel Cotrel, born on February 3, 1981, in Abbeville, France, having his personal address
at chemin des Bochattets 9, 1296 Coppet, Switzerland, for thirty-two million sixty-eight thousand six hundred thirty-eight
(32.068.638) New Shares 2, and full payment in the amount of three hundred twenty thousand six hundred eighty-six
Euro and thirty-eight cents (EUR 320.686,38) by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company
by virtue of the above resolutions;
23. Subscription by Mr. Maxime Séché, born on March 27, 1984 in Paris, France, having his personal address at 20 rue
des Accacias, 75017 Paris, France, for thirty-two million sixty-eight thousand six hundred thirty-eight (32.068.638) New
Shares 2, and full payment in the amount of three hundred twenty thousand six hundred eighty-six Euro and thirty-eight
cents (EUR 320.686,38) by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above
resolutions;
24. Subscription by Mr. Philippe Gangloff, born on June 22, 1981 in Phalsbourg, France, having his address at c/o Mlle
Lydia-Agathe Knab, Rue de l'Hôtel de Ville 12, 1204 Geneva, Switzerland, for one million two hundred twenty-four
thousand five hundred seventy-eight (1.224.578) New Shares 2, and full payment in the amount of twelve thousand two
hundred forty-five Euro and seventy-eight cents (EUR 12.245,78) by offsetting the amount of share premium owed to
him by the Company by virtue of the above resolutions;
25. Subscription by Ms. Marie-Madeleine Cotrel, prenamed, for seven hundred sixty-two thousand five hundred fifteen
(762.515) New Shares 2, and full payment in the amount of seven thousand six hundred twenty-five Euro and fifteen cents
(EUR 7.625,15) by offsetting the amount of share premium owed to her by the Company by virtue of the above resolutions;
26. Increase of the authorized share capital of up to nine hundred thirty thousand Euro (EUR 930.000,00) represented
by ninety-three million (93.000.000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01) each;
27. Amendment of article 5, first and second paragraphs of the Company's articles of incorporation which shall hen-
ceforth read as follows:
79759
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5. The subscribed share capital is set at one million seven hundred twenty thousand Euro (EUR 1.720.000,00)
represented by one hundred seventy-two million (172.000.000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01)
each.
The authorized share capital of the Company (including the subscribed share capital) amounts to two million six
hundred fifty thousand Euro (EUR 2.650.000,00) represented by two hundred sixty-five million (265.000.000) shares with
a nominal value of one cent (EUR 0,01) each. The board of directors may, at its sole discretion, increase the share capital
within the limits of the authorized share capital up to the total amount of nine hundred thirty thousand Euro (EUR
930.000,00) and is authorized and empowered to:
- realize any increase of the share capital within the limits of the authorized capital in one or several successive tranches,
by the issuing of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the amount of any share premium
to be paid on the shares, if any, the terms and conditions of the subscription for and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in
cash.”
28. Miscellaneous.
IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the Company's share capital to the extent of ninety-five thousand three hundred
five Euro and two cents (EUR 95.305,02) in order to raise it from its present amount of seven hundred fifty thousand
Euro (EUR 750.000,00) to eight hundred forty-five thousand three hundred five Euro and two cents (EUR 845.305,02)
by creation and issuance of nine million five hundred thirty thousand five hundred two (9.530.502) New Shares 1, with a
nominal value of one Euro cent (EUR 0,01) each.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to waive their preferential subscription right in respect of the New Shares 1.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes Mr. Philippe Paillot, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Philippe Paillot, prenamed, resolves to subscribe for nine hundred eighty-two thousand five hundred twenty-six
(982.526) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of nine thousand eight hundred twenty-five Euro and
twenty-six cents (EUR 9.825,26), together with a share premium in the amount of ninety thousand one hundred seventy-
four Euro seventy-four cents (EUR 90.174,74), by payment in cash in the aggregate amount of one hundred thousand
Euro (EUR 100.000,00).
Thereupon intervenes Mr. Yves-Régis Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Yves-Régis Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for seven hundred thirty-six thousand eight hundred ninety-
four (736.894) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of seven thousand three hundred sixty-eight Euro
and ninety-four cents (EUR 7.368,94), together with a share premium in the amount of sixty-seven thousand six hundred
thirty-one Euro and six cents (EUR 67.631,06), by payment in cash in the aggregate amount of seventy-five thousand Euro
(EUR 75.000,00), from a joint bank account.
Thereupon intervenes Mr. Sebastien Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Sebastien Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for five hundred eighty-nine thousand five hundred sixteen
(589.516) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of five thousand eight hundred ninety-five Euro and
sixteen cents (EUR 5.895,16), together with a share premium in the amount of fifty-four thousand one hundred four Euro
and eighty-four cents (EUR 54.104,84), by payment in cash in the aggregate amount of sixty thousand Euro (EUR
60.000,00).
Thereupon intervenes PemaQuid Partners L.L.C., prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by
virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
PemaQuid Partners L.L.C., prenamed, resolves to subscribe for nine hundred eighty-two thousand five hundred twen-
ty-six (982.526) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of nine thousand eight hundred twenty-five Euro
and twenty-six cents (EUR 9.825,26), together with a share premium in the amount of ninety thousand one hundred
seventy-four Euro seventy-four cents (EUR 90.174,74), by payment in cash in the aggregate amount of one hundred
thousand Euro (EUR 100.000,00).
79760
L
U X E M B O U R G
Thereupon intervenes Mr. Yves-Alexandre Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by
virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Yves-Alexandre Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for five hundred eighty-nine thousand five hundred six-
teen (589.516) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of five thousand eight hundred ninety-five Euro and
sixteen cents (EUR 5.895,16), together with a share premium in the amount of fifty-four thousand one hundred four Euro
and eighty-four cents (EUR 54.104,84), by payment in cash in the aggregate amount of sixty thousand Euro (EUR
60.000,00).
Thereupon intervenes Mr. John Donohue, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. John Donohue, prenamed, resolves to subscribe for four hundred ninety-one thousand two hundred sixty-three
(491.263) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of four thousand nine hundred twelve Euro and sixty-
three cents (EUR 4.912,63), together with a share premium in the amount of forty-five thousand eighty-seven Euro and
thirty-seven cents (EUR 45.087,37), by payment in cash in the aggregate amount of fifty thousand Euro (EUR 50.000,00).
Thereupon intervenes Mr. Christian Barbey, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Christian Barbey, prenamed, resolves to subscribe for two million nine hundred forty-seven thousand five hundred
seventy-eight (2.947.578) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of twenty-nine thousand four hundred
seventy-five Euro and seventy-eight cents (EUR 29.475,78), together with a share premium in the amount of two hundred
seventy thousand five hundred twenty-four Euro and twenty-two cents (EUR 270.524,22), by payment in cash in the
aggregate amount of three hundred thousand Euro (EUR 300.000,00).
Thereupon intervenes Ryames Investment Company L.L.C., prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf,
prenamed, by virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the
person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration
authorities.
Ryames Investment Company L.L.C., prenamed, resolves to subscribe for one million four hundred seventy-three
thousand seven hundred eighty-nine (1.473.789) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of fourteen
thousand seven hundred thirty-seven Euro and eighty-nine cents (EUR 14.737,89), together with a share premium in the
amount of one hundred thirty-five thousand two hundred sixty-two Euro and eleven cents (EUR 135.262,11), by payment
in kind consisting in the conversion of a receivable in the aggregate amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR
150.000,00), held by it towards the Company.
Thereupon intervenes Ms. Marie-Madeleine Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed,
by virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person
appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Ms. Marie-Madeleine Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for seven hundred thirty-six thousand eight hundred
ninety-four (736.894) New Shares 1, and to fully pay them up in the amount of seven thousand three hundred sixty-eight
Euro and ninety-four cents (EUR 7.368,94), together with a share premium in the amount of sixty-seven thousand six
hundred thirty-one Euro and six cents (EUR 67.631,06), by payment in cash in the aggregate amount of seventy-five
thousand Euro (EUR 75.000,00).
The amount of eight hundred twenty thousand Euro (EUR 820.000,00) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.
The amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) has been fully paid up by contribution in kind in the
amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150.000,00) consisting in the conversion of a receivable in the same
amount held by Ryames Investment Company LLC towards the Company.
The value of the contribution in kind was subject to an independent auditor's report, in accordance with article 32-1
(5) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, established by Ernst & Young S.A., a joint-stock
company (société anonyme) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg., which
report concludes as follows:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the one million four
hundred seventy-three thousand seven hundred eighty-nine (1.473.789) new shares with a nominal value of one Euro
cent (EUR 0,01) each to be issued with total related share premium of one hundred thirty-five thousand two hundred
sixty-two Euro and eleven cents (EUR 135.262,11), hence total consideration amounting to one hundred fifty thousand
Euro (EUR 150.000).”
The above mentioned report, being initialized ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
79761
L
U X E M B O U R G
<i>Effective implementation of the contributioni>
Ryames Investment Company LLC, prenamed, declares that:
- it is the unlimited owner of the receivable to be contributed, which is freely transferable and is not subject to any
kind of preemption right or purchase option by virtue of which a third party could request that the receivable to be
contributed (or part of it) be transferred to it.
- the receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.
<i>Directors' interventioni>
Thereupon intervened the directors of the Company, duly represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, who require
the notary to act as follows:
The directors acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as
directors of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of
this contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to distribute in cash the share premium in the aggregate amount of eight hundred seventy-four
thousand six hundred ninetyfour Euro and ninety-eight cents (EUR 874.694,98) to the shareholders, in proportion to
their shareholding, as detailed in the following table:
Shareholder
Shareholding
Amount of
premium to
be distributed
(EUR)
Emmanuel Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,66%
320.686,38
Maxime Seche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,66%
320.686,38
Philippe Paillot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,16%
71.395,78
Yves Regis Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,87%
68.854,05
Marie-Madeleine Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,87%
7.625,15
Philippe Gangloff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40%
12.245,78
Sebastien Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70%
6.100,13
PemaQuid Partners L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,16%
10.166,86
Ryames Investment Company L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,74%
15.250,30
Yves-Alexandre Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70%
6.100,13
John Donohue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,58%
5.083,43
Christian Barbey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,49%
30.500,61
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00%
874.694,98
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to increase the Company's share capital to the extent of eight hundred seventy-four thousand
six hundred ninety-four Euro and ninety-eight cents (EUR 874.694,98) in order to raise it from its amount of eight hundred
forty-five thousand three hundred five Euro and two cents (EUR 845.305,02) to one million seven hundred twenty thou-
sand Euro (EUR 1.720.000,00) by creation and issue of eighty-seven million four hundred sixty-nine thousand four hundred
ninety-eight (87.469.498) New Shares 2, with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01) each.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes Mr. Philippe Paillot, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Philippe Paillot, prenamed, resolves to subscribe for seven million one hundred thirty-nine thousand five hundred
seventy-eight (7.139.578) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of seventy-one thousand three hundred
ninety-five Euro and seventy-eight cents (EUR 71.395,78) by offsetting the amount of share premium owed to him by the
Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes Mr. Yves-Régis Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Yves-Régis Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for six million eight hundred eighty-five thousand four hundred
five (6.885.405) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of sixty-eight thousand eight hundred fifty-four
Euro and five cents (EUR 68.854,05) by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue
of the above resolutions.
79762
L
U X E M B O U R G
Thereupon intervenes Mr. Sebastien Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Sebastien Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for six hundred ten thousand thirteen (610.013) New Shares
2, and to fully pay them up in the amount of six thousand one hundred Euro and thirteen cents (EUR 6.100,13) by offsetting
the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes PemaQuid Partners L.L.C., prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by
virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
PemaQuid Partners L.L.C., prenamed, resolves to subscribe for one million sixteen thousand six hundred eighty-six
(1.016.686) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of ten thousand one hundred sixty-six Euro and eighty-
six cents (EUR 10.166,86) by offsetting the amount of share premium owed to it by the Company by virtue of the above
resolutions.
Thereupon intervenes Mr. Yves-Alexandre Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by
virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Yves-Alexandre Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for six hundred ten thousand thirteen (610.013) New
Shares 2, and to fully pay them up in the amount of six thousand one hundred Euro and thirteen cents (EUR 6.100,13)
by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes Mr. John Donohue, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. John Donohue, prenamed, resolves to subscribe for five hundred eight thousand three hundred forty-three
(508.343) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of five thousand eighty-three Euro and forty-three cents
(EUR 5.083,43) by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolu-
tions.
Thereupon intervenes Mr. Christian Barbey, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Christian Barbey, prenamed, resolves to subscribe for three million fifty thousand sixty-one (3.050.061) New
Shares 2, and to fully pay them up in the amount of thirty thousand five hundred Euro sixty-one cents (EUR 30.500,61)
by offsetting the amount of share premium owed to him by the Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes Ryames Investment Company LLC, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, pren-
amed, by virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the
person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration
authorities.
Ryames Investment Company LLC, prenamed, resolves to subscribe for one million five hundred twenty-five thousand
thirty (1.525.030) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of fifteen thousand two hundred fifty Euro and
thirty cents (EUR 15.250,30) by offsetting the amount of share premium owed to it by the Company by virtue of the
above resolutions.
Thereupon intervenes Mr. Emmanuel Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Emanuel Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for thirty-two million sixty-eight thousand six hundred thirty-
eight (32.068.638) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of three hundred twenty thousand six hundred
eighty-six Euro and thirty-eight cents (EUR 320.686,38) by offsetting the amount of share premium owed to him by the
Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes Mr. Maxime Séché, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Maxime Séché, prenamed, resolves to subscribe for thirty-two million sixty-eight thousand six hundred thirty-
eight (32.068.638) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of three hundred twenty thousand six hundred
eighty-six Euro and thirty-eight cents (EUR 320.686,38) by offsetting the amount of share premium owed to him by the
Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes Mr. Philippe Gangloff, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed, by virtue
of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Mr. Philippe Gangloff, prenamed, resolves to subscribe for one million two hundred twenty-four thousand five hundred
seventy-eight (1.224.578) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of twelve thousand two hundred forty-
79763
L
U X E M B O U R G
five Euro and seventy-eight cents (EUR 12.245,78) by offsetting the amount of share premium owed to him by the
Company by virtue of the above resolutions.
Thereupon intervenes Ms. Marie-Madeleine Cotrel, prenamed, here represented by Ms. Laura Gehlkopf, prenamed,
by virtue of a proxy given on February 2, 2011. The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person
appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Ms. Marie-Madeleine Cotrel, prenamed, resolves to subscribe for seven hundred sixty-two thousand five hundred
fifteen (762.515) New Shares 2, and to fully pay them up in the amount of seven thousand six hundred twenty-five Euro
and fifteen cents (EUR 7.625,15) by offsetting the amount of share premium owed to her by the Company by virtue of
the above resolutions.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves pursuant to article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
and pursuant to a report of the Board (the Report) to increase the authorized share capital of up to nine hundred thirty
thousand Euro (EUR 930.000,00) represented by ninety-three million (93.000.000) shares with a nominal value of one
Euro cent (EUR 0,01) each.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to amend article 5, first and second paragraphs of the Company's articles of incorporation which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. The subscribed share capital is set at one million seven hundred twenty thousand Euro (EUR 1.720.000,00)
represented by one hundred seventy-two million (172.000.000) shares with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each.
The authorized share capital of the Company (including the subscribed share capital) amounts to two million six
hundred fifty thousand Euro (EUR 2.650.000,00) represented by two hundred sixty-five million (265.000.000) shares with
a nominal value of one cent (EUR 0,01) each. The board of directors may, at its sole discretion, increase the share capital
within the limits of the authorized share capital up to the total amount of nine hundred thirty thousand Euro (EUR
930.000,00) and is authorized and empowered to:
- realize any increase of the share capital within the limits of the authorized capital in one or several successive tranches,
by the issuing of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the amount of any share premium
to be paid on the shares, if any, the terms and conditions of the subscription for and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in
cash.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at five thousand Euro (EUR 5.000,00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by his full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le huit février.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de L14 Capital Partners S.A., une société anonyme
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151687,
constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 12 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 759 du 12 avril 2010, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand Duché de Luxembourg en date du 5 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1848 du 9 septembre 2010 (ci-après la Société).
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mlle. Laura Gehlkopf, employée, ayant son adresse professionnelle au
1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
79764
L
U X E M B O U R G
Le président désigne comme secrétaire M. Régis Galiotto, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur M. Régis Galiotto, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des soixante-quinze millions (75.000.000) d'actions, repré-
sentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à sept cent cinquante mille Euro (EUR 750.000,00) sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à son ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt-quinze mille trois cent cinq Euro et deux cents (EUR
95.305,02) pour le porter de son montant actuel de sept cent cinquante mille Euro (EUR 750.000,00) à huit cent quarante-
cinq mille trois cent cinq Euro et deux cents (EUR 845.305,02) par la création et l'émission de neuf millions cinq cent
trente mille cinq cent deux (9.530.502) nouvelles actions d'une valeur nominale de un cent (EUR 0.01) chacune (les
Nouvelles Actions 1);
2. Renonciation par les actionnaires actuels de la Société à leur droit préférentiel de souscription;
3. Souscription par M. Philippe Paillot, né le 13 octobre 1988 à Lisieux, France, résidant au Clos dessus, 1267 Vich,
Suisse, à neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-six (982.526) Nouvelles Actions 1 et paiement du montant total
de neuf mille huit cent vingt-cinq Euro et vingt-six cents (EUR 9.825,26), ainsi que d'une prime d'émission d'un montant
de quatre-vingt-dix mille cent soixante-quatorze Euro et soixante-quatorze cents (EUR 90.174,74), par paiement en
numéraire du montant total de cent mille Euro (EUR 100.000,00);
4. Souscription par M. Yves-Régis Cotrel, né le 13 janvier 1952 à Berck, France, résidant au Chemin de Praz Buchilly
101, Epalinges 1000 Lausanne 25, Suisse, à sept cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (736.894) Nouvelles
Actions 1 et paiement du montant total de sept mille trois cent soixante-huit Euro et quatre-vingt-quatorze cents (EUR
7.368,94), ainsi que d'une prime d'émission d'un montant de soixante-sept mille six cent trente et un Euro et six cents
(EUR 67.631,06), par paiement en numéraire du montant total de soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,00), au moyen
d'un compte joint;
5. Souscription par M. Sebastien Cotrel, né le 24 décembre 1981 à Abeville, France, résidant à 124 rue Thiers, Appt
1b4, 92100 Boulogne Billancourt, à cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent seize (589.516) Nouvelles Actions 1 et
paiement du montant total de cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Euro et seize cents (EUR 5.895,16), ainsi que d'une
prime d'émission d'un montant de cinquante-quatre mille cent quatre Euro et quatre-vingt-quatre cents (EUR 54.104,84),
par paiement en numéraire du montant total de soixante mille Euro (EUR 60.000,00);
6. Souscription par PemaQuid Partners L.L.C., une limited liability company établie et existante selon les lois du De-
laware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social c/o Corporate Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro
4041599, à neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-six (982.526) Nouvelles Actions 1 et paiement du montant
total de neuf mille huit cent vingt-cinq Euro et vingt-six cents (EUR 9.825,26), ainsi que d'une prime d'émission d'un
montant de quatre-vingt-dix mille cent soixante-quatorze Euro et soixante-quatorze cents (EUR 90.174,74), par paiement
en numéraire du montant total de cent mille Euro (EUR 100.000,00);
7. Souscription par M. Yves-Alexandre Cotrel, né le 26 février à Abbeville, France, résidant à 4, Avenue de Montpensier,
60500, Chantilly, France à cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent seize (589.516) Nouvelles Actions 1 et paiement du
montant total de cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Euro et seize cents (EUR 5.895,16), ainsi que d'une prime
d'émission d'un montant de cinquante-quatre mille cent quatre Euro et quatre-vingt-quatre cents (EUR 54.104,84), par
paiement en numéraire du montant total de soixante mille Euro (EUR 60.000,00);
8. Souscription par M. John Donohue, né le 22 avril 1960, à New-York, Etats Unis d'Amérique, résidant à 3333 43
rd
Avenue NE, Seattle, WA 98105, Etats-Unis d'Amérique, à quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-trois
(491.263) Nouvelles Actions 1 et paiement du montant total de quatre mille neuf cent douze Euro et soixante-trois cents
(EUR 4.912,63), ainsi que d'une prime d'émission d'un montant de quarante-cinq mille quatre-vingt sept Euro et trente-
sept cents (EUR 45.087,37), par paiement en numéraire du montant total de cinquante mille Euro (EUR 50.000,00);
9. Souscription par M. Christian Barbey, né le 30 avril 1951 à Sainte Adresse, France, résidant à Route de la Croix 137,
1095 Lutry, Suisse, à deux millions neuf cent quarante-sept mille cinq cent soixante-dix-huit (2.947.578) Nouvelles Actions
1 et paiement du montant total de vingt-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro et soixante-dix-huit cents (EUR
29.475,78), ainsi que d'une prime d'émission d'un montant de deux cent soixante-dix mille cinq cent vingt-quatre Euro
et vingt-deux cents (EUR 270.524,22), par paiement en numéraire du montant total de trois cent mille Euro (EUR
300.000,00);
79765
L
U X E M B O U R G
10. Souscription par Ryames Investment Company L.L.C., une limited liability company établie et existante selon les
lois du Delaware, Etats Unis D'Amérique, ayant son siège social c/o Corporate Trust Center 1209 Orange Street, Wil-
mington, New Castle, DE 19801, Etats Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware
sous le numéro 3668206, à un million quatre cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-neuf (1.473.789) Nouvelles
Actions 1 et paiement du montant total de quatorze mille sept cent trente-sept Euro et quatre-vingt-neuf cents (EUR
14.737,89), ainsi que d'une prime d'émission d'un montant de cent trente-cinq mille deux cent soixante-deux Euro et
onze cents (EUR 135.262,11), par paiement en nature d'un montant total de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00),
consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue envers la Société;
11. Souscription par Mme. Marie-Madeleine Cotrel, née le 30 Septembre 1950, résidant au Chemin de Praz Buchilly
101, Epalinges 1000 Lausanne 25, Suisse, à sept cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (736.894) Nouvelles
Actions 1 et paiement du montant total de sept mille trois cent soixante-huit Euro et quatre-vingt-quatorze cents (EUR
7.368,94), ainsi que d'une prime d'émission d'un montant de soixante-sept mille six cent trente et un Euro et six cents
(EUR 67.631,06), par paiement en numéraire du montant total de soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,00);
12. Distribution en numéraire de la prime d'émission d'un montant total de huit cent soixante-quatorze mille six cent
quatre-vingt-quatorze Euro et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 874.694,98) aux actionnaires à proportion de leur ac-
tionnariat;
13. Augmentation du capital social à concurrence de huit cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-quatorze
Euro et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 874.694,98) afin de le porter de son montant de huit cent quarante-cinq mille
trois cent cinq Euro et deux cents (EUR 845.305,02) à un million sept cent vingt mille Euro (EUR 1.720.000,00), par la
création et l'émission de quatre-vingt-sept millions quatre cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit
(87.469.498) nouvelles actions avec une valeur nominale d'un Euro cent (EUR 0.01) chacune (les Nouvelles Actions 2);
14. Souscription par M. Philippe Paillot, précité, à sept millions cent trente-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit
(7.139.578) Nouvelles Actions 2 et paiement du montant total de soixante et onze mille trois cent quatre-vingt-quinze
Euro et soixante-dix-huit cents (EUR 71.395,78) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la
Société, en vertu des résolutions précédentes;
15. Souscription par M. Yves-Régis Cotrel, précité, à six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent cinq
(6.885.405) Nouvelles Actions 2 et paiement du montant total de soixante-huit mille huit cent cinquante-quatre Euro et
cinq cents (EUR 68.854,05) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des
résolutions précédentes;
16. Souscription par M. Sebastien Cotrel, précité, à six cent dix mille treize (610.013) Nouvelles Actions 2 et paiement
du montant total de six mille cent Euro et treize cents (EUR 6.100,13) par compensation du montant de la prime d'émission
lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes;
17. Souscription par PemaQuid Partners L.L.C., précitée, à un million seize mille six cent quatre-vingt-six (1.016.686)
Nouvelles Actions 2 et paiement du montant total de dix mille cent soixante-six Euro et quatre-vingt-six cents (EUR
10.166,86) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions
précédentes;
18. Souscription par M. Yves-Alexandre Cotrel, précité, à six cent dix mille treize (610.013) Nouvelles Actions 2 et
paiement du montant total de six mille cent Euro et treize cents (EUR 6.100,13) par compensation du montant de la
prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes;
19. Souscription par M. John Donohue, précité, à cinq cent huit mille trois cent quarante-trois (508.343) Nouvelles
Actions 2 et paiement du montant total de cinq mille quatre-vingt-trois Euro et quarante-trois cents (EUR 5.083,43) par
compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes;
20. Souscription par M. Christian Barbey, précité, à trois millions cinquante mille soixante et un (3.050.061) Nouvelles
Actions 2 et paiement du montant total de trente mille cinq cents Euro et soixante et un cents (EUR 30.500,61) par
compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes;
21. Souscription par Ryames Investment Company L.L.C., précitée, à un million cinq cent vingt-cinq mille trente
(1.525.030) Nouvelles Actions 2 et paiement du montant total de quinze mille deux cent cinquante Euro et trente cents
(EUR 15.250,30) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions
précédentes;
22. Souscription par M. Emmanuel Cotrel, né le 3 février 1981 à Abbeville, France, résidant au 9, Chemin des Bochattets,
1296 Coppet, Suisse, à trente-deux millions soixante-huit mille six cent trente-huit (32.068.638) Nouvelles Actions 2 et
paiement du montant total de trois cent vingt mille six cent quatre-vingt-six Euro et trente-huit cents (EUR 320.686,38)
par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes;
23. Souscription par M. Maxime Séché, né le 27 Mars 1984 à Paris, France, ayant son adresse personnelle au 20, Rue
des Accacias, 75017 Paris, France, à trente-deux millions soixante-huit mille six cent trente-huit (32.068.638) Nouvelles
Actions 2 et paiement du montant total de trois cent vingt mille six cent quatre-vingt-six Euro et trente-huit cents (EUR
320.686,38) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions
précédentes;
79766
L
U X E M B O U R G
24. Souscription par M. Philippe Gangloff, né le 22 juin 1981 à Phalsbourg, France, résidant à c/o Mlle Lydia-Agathe
Knab, Rue de l'Hôtel de Ville 12, 1204 Genève, Suisse, à un million deux cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-
huit (1.224.578) Nouvelles Actions 2 et paiement du montant total de douze mille deux cent quarante-cinq Euro et
soixante-dix-huit cents (EUR 12.245,78) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société,
en vertu des résolutions précédentes;
25. Souscription par Mme. Marie-Madeleine Cotrel, précitée, à sept cent soixante-deux mille cinq cent quinze (762.515)
Nouvelles Actions 2 et paiement du montant total de sept mille six cent vingt-cinq Euro et quinze cents (EUR 7.625,15)
par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes;
26. Augmentation du capital social autorisé à hauteur de neuf cent trente mille (EUR 930.000,00) représenté par quatre-
vingt-treize millions (93.000.000) d'actions avec une valeur nominale d'un Euro cent (EUR 0,01) chacune;
27. Modification de l'article 5, premier et second alinéas des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million sept cent vingt mille Euro (EUR 1.720.000,00) représenté par
cent soixante-douze millions (172.000.000) d'actions avec une valeur nominale d'un Euro cent (EUR 0.01) chacune.
Le capital social autorisé (incluant le capital social souscrit) est fixé à deux millions six cent cinquante mille Euro (EUR
2.650.000,00) représenté par deux cent soixante-cinq millions (265.000.000) d'actions avec une valeur nominale de un
cent (EUR 0.01) chacune. Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, augmenter le capital social dans les limites
du capital social autorisé jusqu'à un montant total de neuf cent trente mille Euro (EUR 930.000,00) et il est autorisé et
apte à:
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital autorisé dans une ou plusieurs tranches
successives, par l'émission de nouvelles actions, contre paiement en numéraire ou en nature;
- déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, le montant de toute prime
d'émission à payer sur les actions s'il y a lieu, les conditions générales de la souscription et de la libération des nouvelles
actions; et
- retirer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement
en numéraire.»
28. Divers.
IV. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-quinze mille trois cent
cinq Euro et deux cents (EUR 95.305,02) pour le porter de son montant actuel de sept cent cinquante mille Euro (EUR
750.000,00) à huit cent quarante-cinq mille trois cent cinq Euro et deux cents (EUR 845.305,02) par la création et l'émis-
sion de neuf millions cinq cent trente mille cinq cent deux (9.530.502) Nouvelles Actions 1 d'une valeur nominale d'un
Euro cent (EUR 0.01) chacune
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription à l'égard des Nouvelles Actions 1.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Sur ce intervient M. Philippe Paillot, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une procu-
ration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Philippe Paillot, précité, décide de souscrire à neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-six (982.526) Nou-
velles Actions 1 et de les payer à hauteur de neuf mille huit cent vingt-cinq Euro et vingt-six cents (EUR 9.825,26), ainsi
qu'une prime d'émission d'un montant de quatre-vingt-dix mille cent soixante-quatorze Euro et soixante-quatorze cents
(EUR 90.174,74), par paiement en numéraire du montant total de cent mille Euro (EUR 100.000,00);
Sur ce intervient M. Yves-Régis Cotrel, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Yves-Régis Cotrel, précité, décide de souscrire à sept cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze (736.894)
Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de sept mille trois cent soixante-huit Euro et quatre-vingt-quatorze cents
(EUR 7.368,94), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de soixante-sept mille six cent trente et un Euro et six cents
(EUR 67.631,06), par paiement en numéraire du montant total de soixante-quinze mille Euro (EUR 75.000,00), au moyen
d'un compte joint;
Sur ce intervient M. Sebastien Cotrel, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une pro-
curation donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Sebastien Cotrel, précité, décide de souscrire à cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent seize (589.516) Nouvelles
Actions 1 et de les payer à hauteur de cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Euro et seize cents (EUR 5.895,16), ainsi
79767
L
U X E M B O U R G
qu'une prime d'émission d'un montant de cinquante-quatre mille cent quatre Euro et quatre-vingt-quatre cents (EUR
54.104,84), par paiement en numéraire du montant total de soixante mille Euro (EUR 60.000,00);
Sur ce intervient PemaQuid Partners L.L.C., précitée, représentée ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
PemaQuid Partners L.L.C., précitée, représentée par son mandataire, décide de souscrire à neuf cent quatre-vingt-
deux mille cinq cent vingt-six (982.526) Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de neuf mille huit cent vingt-cinq
Euro et vingt-six cents (EUR 9.825,26), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de quatre-vingt-dix mille cent soixante-
quatorze Euro et soixante-quatorze cents (EUR 90.174,74), par paiement en numéraire du montant total de cent mille
Euro (EUR 100.000,00);
Sur ce intervient M. Yves-Alexandre Cotrel, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Yves-Alexandre Cotrel, précité, décide de souscrire à cinq cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent seize (589.516)
Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze Euro et seize cents (EUR
5.895,16), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de cinquante-quatre mille cent quatre Euro et quatre-vingt-quatre
cents (EUR 54.104,84), par paiement en numéraire du montant total de soixante mille Euro (EUR 60.000,00);
Sur ce intervient M. John Donohue, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une procu-
ration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. John Donohue, précité, décide de souscrire à quatre cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-trois (491.263)
Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de quatre mille neuf cent douze Euro et soixante-trois cents (EUR 4.912,63),
ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de quarante-cinq mille quatre-vingt-sept Euro et trente-sept cents (EUR
45.087,37), par paiement en numéraire du montant total de cinquante mille Euro (EUR 50.000,00);
Sur ce intervient M. Christian Barbey, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une pro-
curation donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Christian Barbey, précité, décide de souscrire à deux millions neuf cent quarante-sept mille cinq cent soixante-dix-
huit (2.947.578) Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de vingt-neuf mille quatre cent soixante-quinze Euro et
soixante-dix-huit cents (EUR 29.475,78), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de deux cent soixante-dix mille cinq
cent vingt-quatre Euro et vingt-deux cents (EUR 270.524,22), par paiement en numéraire du montant total de trois cent
mille Euro (EUR 300.000,00);
Sur ce intervient Ryames Investment Company L.L.C., précitée, représentée ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en
vertu d'une procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant
et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Ryames Investment Company L.L.C., précitée, décide de souscrire à un million quatre cent soixante-treize mille sept
cent quatre-vingt-neuf (1.473.789) Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de quatorze mille sept cent trente-sept
Euro et quatre-vingt-neuf cents (EUR 14.737,89), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de cent trente-cinq mille
deux cent soixante-deux Euro et onze cents (EUR 135.262,11), par paiement en nature d'un montant total de cent
cinquante mille Euro (EUR 150.000,00), consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue envers la
Société;
Sur ce intervient Mme Marie-Madeleine Cotrel, précitée, représenté ici par Mlle Laura Gehlkopf, précitée, en vertu
d'une procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le
notaire soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Mme Marie-Madeleine Cotrel, précitée, décide de souscrire à sept cent trente-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze
(736.894) Nouvelles Actions 1 et de les payer à hauteur de sept mille trois cent soixante-huit Euro et quatre-vingt-
quatorze cents (EUR 7.368,94), ainsi qu'une prime d'émission d'un montant de soixante-sept mille six cent trente et un
Euro et six cents (EUR 67.631,06), par paiement en numéraire du montant total de soixante-quinze mille Euro (EUR
75.000,00);
Le montant de huit cent vingt mille Euro (EUR 820.000,00) a été entièrement libéré en numéraire et est désormais à
la libre disposition de la Société, la preuve de quoi a été donnée au notaire soussigné.
Le montant de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00) a été intégralement libéré par apport en nature pour un
montant de cent cinquante mille Euro (EUR 150.000,00), consistant en la conversion d'une créance du même montant
détenue par Ryames Investment Company L.L.C. à l'encontre de la Société.
La valeur de l'apport en nature a été sujette au rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant conformément à l'article
32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, établi par Ernst & Young S.A., une
société anonyme établie et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue
Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et dont le rapport conclut
comme suit:
79768
L
U X E M B O U R G
«Basé sur le travail effectué et décrit au dessus, rien n'a attiré notre attention et nous amène à penser que la valeur
de l'apport en nature ne correspond pas au moins en nombre et à la valeur des un million quatre cent soixante-treize
mille sept cent quatre-vingt-neuf (1.473.789) nouvelles actions ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01)
chacune devant être émises ensemble avec une prime d'émission de cent trente-cinq mille deux cent soixante-deux Euro
et onze cents (EUR 135.262,11), représentant une contre partie d'une valeur totale de cent cinquante mille Euro (EUR
150.000,00).»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Ryames Investment Company L.L.C., précitée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction de la créance apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la créance apportée est libre de tous gages, garanties ou usufruits.
<i>Intervention des administrateursi>
Sont alors intervenus les administrateurs de la Société, ici représentés par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, qui prient
le notaire d'acter que:
Les administrateurs reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement
engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, ils consentent expres-
sément à la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la
libération
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de distribuer en numéraire la prime d'émission d'un montant total de huit cent soixante-quatorze
mille six cent quatre-vingt-quatorze Euros et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 874.694,98) aux actionnaires en proportion
de leur détention de capital, comme détaillée dans le tableau suivant à:
Actionnaire
Détention
du capital
social
Montant de
la prime
d'émission
distribuée
(EUR)
Emmanuel Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,66% 320.686,38
Maxime Seche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,66% 320.686,38
Philippe Paillot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,16%
71.395,78
Yves Regis Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,87%
68.854,05
Marie-Madeleine Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,87%
7.625,15
Philippe Gangloff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40%
12.245,78
Sebastien Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70%
6.100,13
PemaQuid Partners L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,16%
10.166,86
Ryames Investment Company L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,74%
15.250,30
Alexandre Cotrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70%
6.100,13
John Donohue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,58%
5.083,43
Christian Barbey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,49%
30.500,61
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00% 874.694,98
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent soixante-quatorze mille six cent quatre-
vingt-quatorze Euro et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 874.694,98) afin de le porter de son montant de huit cent
quarante-cinq mille trois cent cinq Euro et deux cents (EUR 845.305,02) à un million sept cent vingt mille Euro (EUR
1.720.000,00), par la création et l'émission de quatre-vingt-sept millions quatre cent soixante-neuf mille quatre cent
quatre-vingt-dix-huit (87.469.498) Nouvelles Actions 2 avec une valeur nominale d'un Euro cent (EUR 0.01) chacune.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Sur ce intervient M. Philippe Paillot, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une procu-
ration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Philippe Paillot, précité, décide de souscrire à sept millions cent trente-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit
(7.139.578) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de soixante et onze mille trois cent quatre-vingt-quinze Euro
79769
L
U X E M B O U R G
et soixante-dix-huit cents (EUR 71.395,78) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société,
en vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. Yves-Régis Cotrel, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Yves-Régis Cotrel, précité, décide de souscrire à six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent cinq
(6.885.405) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de soixante-huit mille huit cent cinquante-quatre Euro et cinq
cents (EUR 68.854,05) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des
résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. Sebastien Cotrel, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une pro-
curation donnée le 2 février 2011.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera attachée au
présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Sebastien Cotrel, précité, décide de souscrire à six cent dix mille treize (610.013) Nouvelles Actions 2 et de les
payer à hauteur de six mille cent Euro et treize cents (EUR 6.100,13) par compensation du montant de la prime d'émission
lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient PemaQuid Partners L.L.C., précitée, représenté ici par Mlle Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
PemaQuid Partners, précité, représenté par son mandataire, décide de souscrire à un million seize mille six cent quatre-
vingt-six (1.016.686) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de dix mille cent soixante-six Euro et quatre-vingt-
six cents (EUR 10.166,86) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des
résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. Yves-Alexandre Cotrel, précité, représenté ici par Mlle Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Yves-Alexandre Cotrel, précité, décide de souscrire à six cent dix mille treize (610.013) Nouvelles Actions 2 et de
les payer à hauteur de six mille cent Euro et treize cents (EUR 6.100,13) par compensation du montant de la prime
d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. John Donohue, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une procu-
ration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. John Donohue, précité, décide de souscrire à cinq cent huit mille trois cent quarante-trois (508.343) Nouvelles
Actions 2 et de les payer à hauteur de cinq mille quatre-vingt-trois Euro et quarante-trois cents (EUR 5.083,43) par
compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. Christian Barbey, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une pro-
curation donnée le 2 février 2011.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera attachée au
présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Christian Barbey, précité, décide de souscrire à trois millions cinquante mille soixante et un (3.050.061) Nouvelles
Actions 2 et de les payer à hauteur de trente mille cinq cents Euro et soixante et un cents (EUR 30.500,61) par com-
pensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient Ryames Investment Company L.L.C., précitée, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en
vertu d'une procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant
et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Ryames Investment Company L.L.C., précitée, décide de souscrire à à un million cinq cent vingt-cinq mille trente
(1.525.030) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de quinze mille deux cent cinquante Euro et trente cents (EUR
15.250,30) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions
précédentes.
Sur ce intervient M. Emmanuel Cotrel, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une
procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Emmanuel Cotrel, précité, décide de souscrire à trente-deux millions soixante-huit mille six cent trente-huit
(32.068.638) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de trois cent vingt mille six cent quatre-vingt-six Euro et
trente-huit cents (EUR 320.686,38) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en
vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. Maxime Séché, précité, représenté ici par Mlle Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une procuration
donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné,
restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
79770
L
U X E M B O U R G
M. Maxime Séché, précité, décide de souscrire à trente-deux millions soixante-huit mille six cent trente-huit
(32.068.638) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de trois cent vingt mille six cent quatre-vingt-six Euro et
trente-huit cents (EUR 320.686,38) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en
vertu des résolutions précédentes.
Sur ce intervient M. Philippe Gangloff, précité, représenté ici par Mlle. Laura Gehlkopf, précitée, en vertu d'une pro-
curation donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire
soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
M. Philippe Gangloff, précité, décide de souscrire à un million deux cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-huit
(1.224.578) Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de douze mille deux cent quarante-cinq Euro et soixante-dix-
huit cents (EUR 12.245,78) par compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des
résolutions précédentes.
Sur ce intervient Mme. Marie-Madeleine Cotrel, précitée, représentée ici par Mlle Laura Gehlkopf, précitée, en vertu
d'une procuration donnée le 2 février 2011. Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le
notaire soussigné, restera attachée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Mme Marie-Madeleine Cotrel, précitée, décide de souscrire à sept cent soixante-deux mille cinq cent quinze (762.515)
Nouvelles Actions 2 et de les payer à hauteur de sept mille six cent vingt-cinq Euro et quinze cents (EUR 7.625,15) par
compensation du montant de la prime d'émission lui étant dû par la Société, en vertu des résolutions précédentes.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée, au vu d'un rapport justificatif du Conseil (le Rapport), conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d'augmenter le capital autorisé à hauteur de neuf cent trente mille (EUR
930.000,00) représenté par quatre-vingt-treize millions (93.000.000) d'actions avec une valeur nominale d'un Euro cent
(EUR 0,01) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 5, premier et second alinéas des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million sept cent vingt mille Euro (EUR 1.720.000,00) représenté par
cent soixante-douze millions (172.000.000) d'actions avec une valeur nominale d'un Euro cent (EUR 0.01) chacune.
Le capital social autorisé (incluant le capital social souscrit) est fixé à deux millions six cent cinquante mille (EUR
2.650.000,00) représenté par deux cent soixante-cinq millions (265.000.000) d'actions avec une valeur nominale d'un
Euro cent (EUR 0.01) chacune. Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, augmenter le capital social dans les
limites du capital social autorisé jusqu'à un montant total de neuf cent trente mille Euro (EUR 930.000,00) et il est autorisé
et apte à:
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital autorisé dans une ou plusieurs tranches
successives, par l'émission de nouvelles actions, contre paiement en numéraire ou en nature;
- déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, le montant de toute prime
d'émission à payer sur les actions s'il y a lieu, les conditions générales de la souscription et de la libération des nouvelles
actions; et
- retirer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement
en numéraire.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de cinq mille Euros (EUR 5.000,00).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par son nom et prénom, état et
demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: L. GEHLKOPF, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2011. Relation: LAC/2011/7873. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
79771
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 mai 2011.
Référence de publication: 2011059732/832.
(110067131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.
Sagarmatha II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 115.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075132/9.
(110082852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Sagarmatha S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 115.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075133/9.
(110082874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Santa Rosa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 143.162.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2011.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2011075135/12.
(110083210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Security Capital European Realty Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.229.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 61.388.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société en date du 25 mai 2011i>
En date du 25 mai 2011, l'assemblée générale annuelle des associés de la Société a pris la résolution de renouveler le
mandat des gérants suivants avec effet immédiat et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2011:
- Monsieur Rainer THALER
- Monsieur Kyrill TURCHANINOV
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2011.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT SARL
Signatures
Référence de publication: 2011075137/18.
(110083527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79772
L
U X E M B O U R G
Security Capital European Realty Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.229.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 61.388.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
4 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°701 du 13 décembre 1997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT SARL
Signature
Référence de publication: 2011075138/14.
(110083534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
SLP III Cayman DS III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 156.472.
Merci de prendre note que l’adresse de la gérante Jacqueline Petts a changée elle est la suivante:
- 8 Finance Street central, Batiment: Two IFC 33/F Hong-Kong, Chine
Luxembourg, le 30.05.2011.
Référence de publication: 2011075140/10.
(110083343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Société Autonome de Construction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 31.737.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075141/9.
(110083611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Société Autonome de Construction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 31.737.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075142/9.
(110083618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Sofidex S.A., Société Anonyme,
(anc. Orsen S.A.).
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 66.454.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011075143/11.
(110083202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
79773
L
U X E M B O U R G
Sophia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 90.101.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011075144/11.
(110083542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
South Riviera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 110.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075145/9.
(110082873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Suburbium S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1920 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.501.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour SUBURBIUM SARL
i>Signature
Référence de publication: 2011075147/12.
(110083741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Sud Latitude Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 43.582.
Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011075148/12.
(110083186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Swen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 124.375.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
79774
L
U X E M B O U R G
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011075150/13.
(110083594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Sylvex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 40.302.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011075152/11.
(110083551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Taurus Euro Retail II Feeder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 121.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TAURUS EURO RETAIL II FEEDER S.à r.l.
i>Signatures
Référence de publication: 2011075155/11.
(110083034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Teamlog Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 140.476.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des associés en date du 5 avril 2011i>
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale des Associés accepte la démission d’Alain Peigneux de son poste de gérant de catégorie B de
la Société avec effet immédiat.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale des Associés nomme Sandra Ansay, née le 13 août 1974 à Saint-Mard (Belgique), résidant
professionnellement au 67 rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au poste de gérant de catégorie B de la Société pour une
durée illimitée avec effet immédiat.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011075156/18.
(110083384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Olympia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 109.699.
Comptes annuels rectifiés déposés le 3 Novembre 2010 avec le numéro de dépôt L-100166781
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
79775
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 30 mai 2011.
Référence de publication: 2011075074/11.
(110083673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Oxbow Carbon & Minerals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 97.769.
Suite à l'accord d'apport en nature en date du 17 mai 2011 entre Oxbow Enterprises International, LLC et Oxbow
Netherlands Coöperatieve U.A. les 2.000,- parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- Oxbow Netherlands Coöperatieve U.A. domicilié à Hoofdvestiging Wilhelminakade 93, 3072AP ROTTERDAM, Pays-
Bas, détient 2.000,- parts sociales d'une valeur nominale de USD 50,- chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011075077/13.
(110083397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2011.
Fiparic S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 45.343.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 mars 2010i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Le mandat de Monsieur Norbert SCHMITZ, adresse professionnelle au 3 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et des
sociétés FMS SERVICES S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et S.G.A. SERVICES S.A., 39 allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en tant qu’Administrateurs, et le mandat de Monsieur Eric HERREMANS, adresse professionnelle au 39
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que Commissaire de Comptes sont renouvelés pour une nouvelle période
de six ans.
<i>Pour la société
i>FIPARIC S.A., SPF
Référence de publication: 2011075685/16.
(110083947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
FS-T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 144.799.
<i>Extrait des résolutions circulaires de la Société en date du 15 novembre 2010i>
Le Conseil de Gérance de la Société a décidé d'approuver la modification de l'adresse du siège social de la Société,
actuellement intitulée «10, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach» qui est renommée «10, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach», avec effet au 1
er
janvier 2011, ainsi qu'il résulte d'une décision prise par le Conseil Municipal de
Schuttrange.
De même, l'adresse des associés, actuellement intitulée «10, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach», sera renommée
en «10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 Mai 2011.
<i>Pour FS-T S.à.r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011075693/18.
(110084294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
79776
European Fragrances S.à r.l.
Fiparic S.A., SPF
FS-T S.à r.l.
L14 Capital Partners S.A.
Lee Cooper International Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
Olympia Holdings S.à r.l.
Opportunityflux S.A.
Opportunityflux S.A.
Organ Holding S.A.
Orsen S.A.
Oxbow Carbon & Minerals S.à r.l.
Palmatrans S.A.
Paser Participations S.A.
Passaya S.A.
Patron Aachen Holdings S. à r. l.
Patron Elke S.à r.l.
Patron Ewald Holding S.à r.l.
Patron Volker Holding S.à r.l.
Patron Volker S.à r.l.
Pegase Investment
Peninsula Bay S.A.
Pisciculture Kieffer S.à.r.l.
Playcenter International S.A.
Prodac Acquisition S.à r.l.
Prudential Capital Luxembourg S.à.r.l.
Prudential (Gibraltar Two) S.à r.l.
PVV SICAV
Reichert Technology
Resitalia Equity S.à r.l.
RESTO WU S.à r.l.
RHIC Holding S.A.
R.M.S. LU S.A.
Sagarmatha II S.à r.l.
Sagarmatha S.A.
Santa Rosa S.A.
Scatec Norvège Holding II S.A.
Security Capital European Realty Management Sàrl
Security Capital European Realty Management Sàrl
Skype Global S.à r.l.
SLP III Cayman DS III S.à.r.l.
Société Autonome de Construction S.A.
Société Autonome de Construction S.A.
Sofidex S.A.
Sogeco Participations Sàrl
Sophia Luxembourg S.A.
South Riviera S.A.
Suburbium S. à r.l.
Sud Latitude Invest S.A.
Swen S.A.
Sylvex S.A.
Taurus Euro Retail II Feeder S.à r.l.
Teamlog Lux S.à r.l.
Tele Columbus Management S.à r.l.
Transsoder Holding S.A.
Trentadue Investimenti S.A.
TV Holding S.à r.l.
Unicorn Investors S.à r.l.