This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1588
15 juillet 2011
SOMMAIRE
ARC Asset Management S.A. . . . . . . . . . . .
76212
Capula Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . .
76178
Carglass S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76206
Cerbero Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76206
Chimachi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76206
Dano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76207
Danske SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76207
D.B.N. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76207
DE Investment Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
76208
Delta Concept Investissement S.A. . . . . . .
76208
Elan Investments Limited S.à r.l. . . . . . . . .
76209
EPF Dundee Retail Park S.à r.l. . . . . . . . . . .
76205
Euresa-Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76209
Eurizon Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
76209
Europäische Grundbesitz und Beteili-
gungsgesellschaft S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76210
Faco Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76210
FI Capital Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
76211
FI Financial Markets S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
76218
Flyers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76211
Fortuna Select Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76224
Ganesh Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
76211
Garirom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76212
Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A. . . . .
76218
Hills Japan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76212
Holdis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76215
Hotlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76216
Immobilier JPF S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76224
Immobilier JPF S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76224
Indra Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76216
Industrial Automation Process Internatio-
nal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76217
IVG Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
76209
Kali Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76218
Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76217
Kimberly-Clark Luxembourg S.à r.l. . . . . .
76221
Land and Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
76215
Lang's Lights Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
76222
Laris Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76222
Laris Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76222
Logiconsult SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76205
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . .
76216
Luxroyal Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
76223
LYXOR Selection Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
76221
Mullebutz s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76212
Nouka Investments S.à r..l. . . . . . . . . . . . . . .
76210
Participations 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76222
Primost S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76211
Principe SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76224
Regus plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76205
Rom2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76207
SAF-Holland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76208
Samsonite Sub Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
76195
SGEA Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76217
SHCO 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76223
SIREC International Reinsurance Compa-
ny S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76218
SI.TO. Financière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76216
Triton III LuxCo A 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
76206
Triton III LuxCo B 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
76223
76177
L
U X E M B O U R G
Capula Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 160.145.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of March.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
There appeared:
1) Yan Huo, born on 4 December 1968 in China, bearer of passport number 422092519 issued by United States of
America on 2 March 2009, residing at 9 Wycombe Square, London, W8 7JD,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
2) Masao Asai, born on 20 August 1966 in Aichi, bearer of passport number TZ0711912, issued by Japan on 29 March
2010, residing at 7 Carlton Gardens, London, W5 1AN,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
3) Mark Jason Barnett, born on 12 March 1972 in Pennsylvania, bearer of passport number 452108759, issued by
United States of America on 13 September 2010, residing at Russetts, Green Dene, East Horsley, Surrey, KT24 5RG,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
4) Neil McCallum, born on 2 October 1961 in Darlington, bearer of passport number 465055555, issued by United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 31 December 2009, residing at 8 Birchvale, Cobham, Surrey, KT11
2PX,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
5) Qiang Dai, born on 13 May 1966 in Jiangsu, bearer of passport number G10120619, issued by People’s Republic of
China on 13 April 2007, residing at Flat 15, 45 Queens Gate Terrace, London, SW7 5PN,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
6) Ali Reza Saiedabadi, born on 7 April 1970 in Dehran, bearer of passport number 800382503, issued by United
Kingdom of Great Britain on 15 March 2007, residing at 50D Cornwall Gardens, London, SW7 4BG,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
7) Piyush Bharti, born on 27 September 1976 in Michigan, bearer of passport number 711354371, issued by United
States of America on 1 February 2005, residing at 31 Campden Grove, W8 4JQ,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in Greenwich, Connecticut;
8) Bing-Le Wu, born on 15 July 1962 in China, bearer of passport number 452065865, issued by United States of
America on 14 May 2010, residing at 56 Warwick Gardens, London, W14 8PP,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
9) Sam Xun-Wei Lowe, born on 21 May 1965 in China, bearer of passport number 206641713, issued by United States
of America on 17 June 2002, residing at 48 Melbury Court, London, W8 6NJ,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London;
10) Thorkild Peter Juncker, born on 25 March 1956 in Arhus, bearer of passport number 203337590, issued by
Denmark on 19 June 2008, residing at 67 Victoria Road, London, W8 5RH,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London; and
11) Angel Serrat, born on 21 June 1965 in Ripoll, bearer of passport number XD325901, issued by Spain on 21 May
2008, residing at 90 Cheyne Walk, London, SW35BB,
duly represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 March 2011 in London.
76178
L
U X E M B O U R G
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain
attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Capula Luxembourg
Limited” (the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and -act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg
or foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Share classes - Share series - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is fixed at forty thousand United States dollars (USD 40,000), represented by:
- Two million one hundred eighty-one thousand eight hundred and seventy-five (2,181,875) class A shares, series 1;
- Two hundred sixty-eight thousand two hundred and sixty-four (268,264) class A shares, series 2;
- Ninety-six thousand four hundred and eighteen (96,418) class A shares, series 3;
- Fifty-two thousand nine hundred and seventy-one (52,971) class A shares, series 4;
- Eighty-one thousand five hundred and seventy (81,570) class A shares, series 5;
- Eighty-four thousand six hundred and twenty-five (84,625) class A shares, series 6;
- Two hundred sixty thousand two hundred and eighty-one (260,281) class A shares, series 7;
- Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety-four (790,894) class A shares, series 8;
- Thirty-four thousand three hundred and nineteen (34,319) class A shares, series 9;
- Sixty-nine thousand two hundred and seventy-three (69,273) class A shares, series 10; and
76179
L
U X E M B O U R G
- Seventy-nine thousand five hundred and ten (79,510) class A shares, series 11
each share having a par value of one United States cent (USD 0.01).
5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced on a
class by class basis or across all share classes by a resolution of the general meeting of shareholders, including a resolution
of the shareholders of the relevant share class(es), adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.2 A shareholder’s right in the Company’s assets and profits shall be based on the share class specific profit allocation
and shall further be proportional to the number of shares of the same class held by him/her/it in the Company’s share
capital.
6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company’s dissolution.
6.4 The Company may, at its initiative, or at the initiative of any shareholder, as foreseen in any shareholders agreement,
repurchase or redeem its own shares on a full series by series basis only (i.e. a partial liquidation), under the condition
that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital be reduced accordingly. Share
capital reduction proceeds, if any, will be distributed to the relevant redeeming/liquidating shareholder(s).
6.5 The Company may under certain circumstances, as foreseen from time to time, in any shareholders agreement,
cancel shares on a full series by series basis and reduce the share capital allocable to the shares cancelled accordingly
allocating a corresponding amount and profits allocable to the cancelled shares to the relevant share class specific reserve
account to the benefit of the remaining shareholders of the same class.
6.6 The Company’s shares are in registered form.
6.7 The Company may issue additional classes and series of shares.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.
7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3 The Company’s shares are freely transferable among existing shareholders, each time subject to the prior approval
of the board of managers. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such
transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of
the share capital at least. Transfers by reason of death shall not require the the approval of shareholders representing in
the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders, if the transferees qualify as
heirs compulsorily entitled to a share of the estate (héritiers réservataires), or the surviving spouse as well as all other
legal heirs (héritiers légaux).
8.4 Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5 The Company may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any corres-
pondence or in any other document which establishes the transferor’s and the transferee’s consent.
76180
L
U X E M B O U R G
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company’s corporate bodies.
9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.
9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may resolve by way of written resolutions, subject to the
terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such written resolutions.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company’s share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company’s registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company’s accounts.
10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company’s share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder’s identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company’s registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
76181
L
U X E M B O U R G
11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders of the Company and within every class (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the
share capital of the Company and of every class of shares.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers or by any two
of its members, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by a board of managers composed of at least one (1) class A manager (the Class
A Manager) and at least one (1) class B manager (the Class B Manager), who need not be shareholders. The board of
managers operates as a collective body in charge of the Company’s management. It exercises all representation powers.
Class A managers may not be resident in the United Kingdom.
14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
14.3 The Company’s daily management and the Company’s representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers.
The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose
a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.
Art. 16. Election and Removal of managers and term of the office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
16.3 Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph. Meetings of the board of managers will generally be held
at the registered office of the Company. The board of managers may not meet in the United Kingdom.
17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meetings of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
76182
L
U X E M B O U R G
18.2 Quorum The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or
represented at a meeting of the board of managers.
18.3 Vote Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented
at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager’s identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company’s registered office. No manager participating to a meeting of the
board of managers may do so whilst being physically present in the United Kingdom.
18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. This article 18.7 shall not be
applicable to current operations entered into under normal conditions.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers or by any two of its members as the case may
be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signature of at least one Class A Manager, together with one Class B Manager, or by the joint signatures or by the sole
signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers. The Company
will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company’s
daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company’s books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d’entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.
76183
L
U X E M B O U R G
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company’s financial year shall begin on first April of each year and shall terminate on thirty-
first March of the following year.
Art. 23. Profits.
23.1 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4 Under the terms and conditions provided for by law and upon recommendation of the board of managers, the
general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company’s annual net profits will be used in
accordance with the law, these articles of association as well as any shareholders agreement adopted from time to time.
Art. 24. Interim dividends.
24.1 The board of managers may proceed to the payment of interim dividends, provided that (i) interim accounts have
been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried
forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed
to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company’s auditor, if
any, has stated in his/her/its report to the board of managers that the first two conditions haven been satisfied.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s
dissolution which shall determine the liquidators’/liquidator’s powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended as well as any shareholders agreement adopted
from time to time.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company’s first financial year shall begin on the date of the Company’s incorporation and shall end on 31
st
March 2012.
2) Interim dividends may also be made during the7Company’s first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) Yan Huo, aforementioned,
paid by contribution in cash of thirty thousand seven hundred sixty-one United States dollars and thirty-nine cents
(USD 30,761.39) whereby twenty-one thousand eight hundred eighteen United States dollar and seventy-five cents (USD
21,818.75) will be allocated into the capital account and the remainder eight thousand nine hundred forty-two United
States dollars and sixty-four cents (USD 8,942.64) into the class specific share premium account, in subscription for two
million one hundred eighty-one thousand eight hundred and seventy-five (2,181,875) class A shares, series 1
2) Masao Asai, aforementioned,
paid by contribution in cash three thousand seven hundred eighty-two United States dollars and sixty-one cents (USD
3,782.61) whereby two thousand six hundred eighty-two United States dollars and sixty-four cents (USD 2,682.64) will
be allocated into the capital account and the remainder one thousand ninety-nine United States dollars and ninetyseven
cents (USD 1,099.97) into the class specific share premium account, in subscription for two hundred sixty-eight thousand
two hundred and sixty-four (268,264) class A shares, series 2;
3) Mark Jason Barnett, aforementioned,
paid by contribution in cash one thousand three hundred fifty-nine United States dollars and nine cents (USD 1,359.09)
whereby nine hundred sixty-four United States dollars and eighteen cents (USD 964.18) will be allocated into the capital
account and the remainder three hundred ninety-four United States dollars and ninety-one cents (USD 394.91) into the
class specific share premium account, in subscription for ninety-six thousand four hundred and eighteen (96,418) class A
shares, series 3;
76184
L
U X E M B O U R G
4) Neil McCallum, aforementioned,
paid by contribution in cash seven hundred forty-seven United States dollars and twenty-two cents (USD 747.22)
whereby five hundred twentynine United States dollars and seventy-one cents (USD 529.71) will be allocated into the
capital account and the remainder two hundred seventeen United States dollars and fifty-one cents (USD 217.51) into
the class specific share premium account, in subscription for fifty-two thousand nine hundred and seventy-one (52,971)
class A shares, series 4;
5) Qiang Dai, aforementioned,
paid by contribution in cash one thousand one hundred fifty United States dollars and forty-three cents (USD 1,150.43)
whereby eight hundred fifteen United States dollars and seventy cents (USD 815.70) will be allocated into the capital
account and the remainder three hundred thirty-four United States dollars and seventy-three cents (USD 334.73) into
the class specific share premium account, in subscription for eighty-one thousand five hundred and seventy (81,570) class
A shares, series 5;
6) Ali Reza Saiedabadi, aforementioned,
paid by contribution in cash one thousand one hundred ninety-two United States dollars and seventy-three cents (USD
1,192.73) whereby eight hundred forty-six United States dollars and twenty-five cents (USD 846.25) will be allocated into
the capital account and the remainder three hundred forty-six United States dollars and forty-eight cents (USD 346.48)
into the class specific share premium account, in subscription for eightyfour thousand six hundred and twenty-five (84,625)
class A shares, series 6;
7) Piyush Bharti, aforementioned,
paid by contribution in cash three thousand six hundred sixty-nine United States dollars and eighty-three cents (USD
3,669.83) whereby two thousand six hundred two United States dollars and eighty-one cents (USD 2,602.81) will be
allocated into the capital account and the remainder one thousand sixty-seven United States dollars and two cents (USD
1,067.02) into the class specific share premium account in subscription for two hundred sixty thousand two hundred and
eighty-one (260,281) class A shares, series 7;
8) Bing-Le Wu, aforementioned,
paid by contribution in cash eleven thousand one hundred fifty United States dollars and forty-six cents (USD 11,150.46)
whereby seven thousand nine hundred eight United States dollars and ninety-four cents (USD 7,908.94) will be allocated
into the capital account and the remainder three thousand two hundred forty one United States dollars and fifty-two
cents (USD 3,241.52) into the class specific share premium account in subscription for seven hundred ninety thousand
eight hundred and ninety-four (790,894) class A shares, series 8;
9) Sam Xun-Wei Lowe, aforementioned,
paid by contribution in cash four hundred eighty-three United States dollars and fifty-eight cents (USD 483.58) whereby
three hundred forty-three United States dollar and nineteen cents (USD 343.19) will be allocated into the capital account
and the remainder one hundred forty United States dollars and thirty-nine cents (USD 140.39) into the class specific
share premium account in subscription for thirty-four thousand three hundred and nineteen (34,319) class A shares, serie
9;
10) Thorkild Peter Juncker, aforementioned,
paid by contribution in cash nine hundred seventy-seven United States dollars and two cents (USD 977.02) whereby
six hundred ninety-two United States dollars and seventy-three cents (USD 692.73) will be allocated into the capital
account and the remainder two hundred eighty four United States dollars and twenty-nine cents (USD 284.29) into the
class specific share premium account, in subscription for sixty nine thousand two hundred and seventy-three (69,273)
class A shares, series 10; and
11) Angel Serrat, aforementioned,
paid by contribution in cash one thousand one hundred twenty United States dollars and eighty-three cents (USD
1,120.83) whereby seven hundred ninety-five United States dollars and ten cents (USD 795.10) will be allocated into the
capital account and the remainder three hundred twenty-five United States dollars and seventy-three cents (USD 325.73)
into the class specific share premium account, in subscription for seventy-nine thousand five hundred and ten (79,510)
class A shares, series 11.
Total: forty thousand United States dollars (USD 40,000).
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of forty thousand United States dollars (USD
40,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 2000.
76185
L
U X E M B O U R G
<i>General meeting of shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the Company’s entire share capital and considering themselves as duly
convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of members of the board of managers is fixed at four (4).
2. The following persons are appointed as Class A Managers:
a) Henning Bruder, director, born on 24 March 1957 in Opperhausen, Germany residing at, Am Neuen Garten 42,
14469 Potsdam, Germany.; and
b) Suresh Sundaresan, director, born on 17 June 1949 in India, residing at, 440 Riverside Drive, Apt 61, NY 10027,
USA.
3. The following persons are appointed as Class B Managers:
c) Sinan Sar, private employee, born on 5 June 1980 in Luxembourg, Luxembourg residing at, 5, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg; and
d) Cornelius Bechtel, private employee, born on 11 March 1968 in Emmerich, Luxembourg residing at, 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
4. The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of
shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company’s accounts of the financial year ending
31st March 2010 ot at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.
4. The address of the Company’s registered office is set at be 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing persons, the proxy-holder signed together with
the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundelf, den fünfundzwanzigsten März.
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine Schaeffer, Zivilrechtsnotarin mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum
Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Yan Huo, geboren am 4 Dezember 1968 in China, Inhaber des Reisepasses Nummer 422092519, ausgestellt durch
Vereinigte Staaten von Amerika am 2 März 2009, wohnhaft 9 Wycombe Square, London, W8 7JD,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht;
2) Masao Asai, geboren am 20 August 1966 in Aichi, Inhaber des Reisepasses Nummer TZ0711912, ausgestellt durch
Japan am 29 March 2010, wohnhaft 7 Carlton Gardens, London W5 1AN,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
3) Mark Barnett, geboren am 12 März 1972 in Pennsylvania, Inhaber des Reisepasses Nummer 452108759, ausgestellt
durch Vereinigten Staaten von Amerika am 13 September 2010, wohnhaft Russetts, Green Dene, East Horsley, Surrey,
KT24 5RG,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
4) Neil McCallum, geboren am 2 Oktober 1961 in Darlington, Inhaber des Reisepasses Nummer 465055555, ausgestellt
durch Großbritannien und Nordirland am 31 Dezember 2009, wohnhaft 8 Birchvale, Cobham; Surrey, KT11 2PX,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
5) Qiang Dai, geboren am 13 Mai 1966 in Jiangsu, Inhaber des Reisepasses Nummer G10120619, ausgestellt durch
Volksrepublik China am 13 April 2007, wohnhaft Flat 15, 45 Queens Gate Terace, London SW7 5PN,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
6) Ali Reza Saiedabadi , geboren am 7 April 1970 in Dehran, Inhaber des Reisepasses Nummer 800382503, ausgestellt
durch Großbritannien und Nordirland am 15 März 2007, wohnhaft 50D Cornwall Gardens, London, SW7 4BG, ord-
76186
L
U X E M B O U R G
nungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
7) Piyush Bharti, geboren am 27 September 1976 in Michigan, Inhaber des Reisepasses Nummer 711354371, ausgestellt
durch die Vereinigten Staaten von Amerika am 1 Februar 2005, wohnhaft 31 Campden Grove, London W8 4JQ,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 23 März in Greenwich Connecticut erteilten Vollmacht.
8) Bing-Le Wu, geboren am 15 July 1962 in China, Inhaber des Reisepasses Nummer 452065865, ausgestellt durch
Vereinigten Staaten von Amerika am 14 Mai 2010, wohnhaft 56 Warwick Gardens, London W14 8PP,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
9) Sam Xun-Wei Lowe, geboren am 21 May 1965 in China, Inhaber des Reisepasses Nummer 206641713, ausgestellt
durch Vereinigten Staaten von Amerika am 17 Juni 2002, wohnhaft 48 Melbury Court, London W8 6NJ, ordnungsgemäß
vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
10) Thorkild Juncker, geboren am 25 März 1956 in Arhus, Inhaber des Reisepasses Nummer 203337590, ausgestellt
durch Dänemark am 19 Juni 2008, wohnhaft 67 Victoria Road, London W8 5RH,
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
11) Angel Serrat, geboren am 21 Juni 1965 in Ripoll, Inhaber des Reisepasses Nummer XD325901, ausgestellt durch
Spanien am 21 Mai 2008, wohnhaft 90 Cheyne Walk, London, SW35BB.
ordnungsgemäß vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, kraft einer am 23 März in London erteilten Vollmacht.
Nachdem die Vollmachten durch die Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet
worden sind, sollen diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.
Solch erschienene Parteien haben den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée
aufzunehmen, welche sie gründen möchten und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma “Capula
Luxembourg Limited” (die “Gesellschaft”).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2 Die Gesellschaft kann außerdem:
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3 Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. In-
nerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
76187
L
U X E M B O U R G
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3 Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Anteilsklassen - Anteilsserien - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertra-
gung von Geschäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vierzigtausend US Dollar (USD 40.000) bestehend aus:
- zwei Millionen einhunderteinundachtzigtausendachthundertvierundsechzig (2.181.875) Klasse A Geschäftsanteile Se-
rie 1;
- zweihundertachtundsechzigtausendzweihundertvierundsechzig (268.264) Klasse A Geschäftsanteile Serie 2;
- sechundneunzigtausendvierhundertachtzehn (96.418) Klasse A Geschäftsanteile Serie 3;
- zweiundfünfizigtausendneunhunderteinundsiebzig (52.971) Klasse A Geschäftsanteile Serie 4;
- einundachtzigtausendfünfhundertsiebzig (81.570) Klasse A Geschäftsanteile Serie 5;
- vierundachtzigtausendsechshundertfünfundzwanzig (84.625) Klasse A Geschäftsanteile Serie 6;
- zweihundertsechzigtausendzweihunderteinundachtzig (260.281) Klasse A Geschäftsanteile Serie 7;
- siebenhundertneunzigtausendachthundertvierundneunzig (790.894) Klasse A Geschäftsanteile Serie 8;
- vierunddreizigtausenddreihundertneunzehn (34.319) Klasse A Geschäftsanteile Serie 9;
- neunundsechzigtausendzweihundertdreiundsiebzig (69.273) Klasse A Geschäftsanteile Serie 10; und
Neunundsiebzigtausendfünfhundertundzehn (79.510) Klasse A Geschäftsanteile Serie 11,
jeder Geschäftsanteil hat einen Wert von einem US Dollar cent (USD 0,01)
5.2 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft beschränkt auf die jeweilige Anteils-
klasse oder alle Geschäftsanteile betreffend, durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung inbegriffen eines
Beschlusses der Gesellschafter der betroffenen Anteilsklasse(n), welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Än-
derung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.2 Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft basiert auf der der jeweiligen
Aktienklasse zugeteilten Gewinnzuteilung und darüber hinaus proportional zu der Anzahl der von ihm im Stammkapital
der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile der gleichen Anteilsklasse.
6.3 Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend
den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
6.4 Die Gesellschaft kann auf ihre Initiative oder auf die Initiative der Gesellschafter soweit in jedwedem Gesellschaf-
tervertrag bestimmt, ihre eigenen Geschäftsanteile auf Basis der jeweils gesamten Anteilsserie (partial liquidation)
zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurückgekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile wer-
den sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend herabgesetzt. Erlöse aus Kapitalreduktionen, soweit vorhanden,
werden an die jeweiligen zurückgebenden/liquidierenden Gesellschafter ausgeschüttet.
6.5 Die Gesellschaft kann unter bestimmten Umständen, soweit in der jeweiligen Fassung in jedwedem Gesellschaf-
tervertrag vorgesehen, Geschäftsanteile auf der Basis einer jeweils gesamten Anteilsserie annullieren und das Stammkapital
bezogen auf die annullierten Geschäftsanteile herabsetzen und demzufolge einen entsprechend Betrag und Gewinn be-
zogen auf die annullierten Geschäftsanteile auf das der jeweiligen Anteilsklasse spezifische Rücklagenkonto zum Nutzen
aller verbleibenden Gesellschafter derselben Klasse zuweisen.
6.6 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
6.7 Die Gesellschaft kann weitere Anteilsklassen und Anteilsserien ausgeben.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1 Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
76188
L
U X E M B O U R G
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1 Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-
schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-
sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.
8.3 Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern jeweils unter vorheriger Zustimmung
des Geschäftsführerrats frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfund-
siebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten
Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Gesellschaftsanteilsübertragungen von Todes wegen sollen nicht
die Einwilligung der Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte der über-
lebenden Gesellschafter repräsentieren erfordern, wenn die Geschäftsanteile entweder an pflichteilsberechtigte Erben
(héritiers réservataires), oder an den überlebenden Ehegatten oder an andere gesetzliche Erben übertragen werden
(héritiers légaux)
8.4 Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles
in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft
zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesell-
schafterverzeichnis eintragen kann.
8.5 Die Gesellschaft kann auch einer solchen Übertragung zustimmen und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen,
auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Dokument Bezug genommen wird, aus welchem
die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Gesellschafter” nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
“Gesellschafterversammlung” als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.
9.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4 Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2 Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
76189
L
U X E M B O U R G
10.3 Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4 Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäβ über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversammlung
ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2 In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Stimmabgabe 11.3.1Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme. 11.3.2Sofern sich aus dem Gesetz
oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesellschafterbeschlüsse bei der ersten Ab-
stimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, welche mehr als fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht
worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden die
Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen wirksam
gefasst.
11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5 Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Vi-
deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören
und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend
ist.
11.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
11.7 Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter der Gesellschaft und jeder Anteilklasse, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stamm-
kapitals der Gesellschaft und jeder Anteilsklasse repräsentieren, gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1 Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie
von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse
aufnehmen und unterzeichnen.
13.3 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, oder durch zwei beliebige seiner Mitglieder un-
terzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführerrat verwaltet, welcher aus mindestens einem (1) Klasse A
Geschäftsführer (Klasse A Geschäftsführer) und mindestens einem (1) Klasse B Geschäftsführer (Klasse B Geschäftsfüh-
76190
L
U X E M B O U R G
rer) verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein müssen. Der Geschäftsführerrat, ist das zur Geschäftsführung und
Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan. Klasse A Geschäftsführer dürfen nicht im Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland wohnhaft sein.
14.2 Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3 Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.
14.4 Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten
des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.
Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
16.3 Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer
kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1 Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner
Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben. Sitzungen des
Geschäftsführerrates werden grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Der Geschäftsführerrat darf sich nicht
im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland versammeln.
17.2 Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1 Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Ab-
wesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen
18.2 Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.
18.4 Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5 Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-
okonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
76191
L
U X E M B O U R G
abgehalten wurde. Kein Geschäftsführer darf an Sitzungen des Geschäftsführerrates teilnehmen während er sich physisch
im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland befindet.
18.6 Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
18.7 Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt
oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Dieser Artikel 18.7 ist nicht anwendbar auf laufende Ge-
schäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.
Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung
des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
19.2 Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats oder von zwei beliebigen seiner Mitglieder unterzeichnet werden.
Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame
Unterschrift von je einem Klasse A und einem Klasse B Geschäftsführer oder durch die gemeinsame Unterschrift oder
die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Ge-
schäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und
in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller
Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemein-
schaftlich übertragen wurde.
E. Aufsicht
Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - Unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1 Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
21.2 Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte
der Gesellschaft.
21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
21.6 Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.
21.7 Wenn die Gesellschaft zwei (2) der drei (3) im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen genannten Kriterien
während des in Artikel 36 desselben Gesetzes genannten Zeitraums überschreitet, wird/werden der/die satzungsmäßigen
Buchprüfer durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer ersetzt, welcher/welche unter den Mitgliedern des Institut
des réviseurs d’entreprises gewählt wird/werden und welcher/welche von der Gesellschafterversammlung ernannt wird/
werden, die dessen/deren Amtszeit bestimmt.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten April jedes Jahres und endet am einund-
dreißigsten März des folgenden Jahres.
76192
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
23.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-
versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag sowie jedwedem Gesellschaftervertrag verwendet werden soll.
Art. 24. Zwischendividenden.
24.1 Der Geschäftsführerrat oder kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten
erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der
Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde,
realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rück-
lagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem
Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem
Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
H. Anwendbares Recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden sowie jedwedem Gesellschafter-
vertrag in seiner jeweiligen Fassung..
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März
2012.
2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zeichnenden Gesellschafter haben die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
1) Yan Huo, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, dreißigtausendsiebenhunderteinundsechzig US Dollar und neununddreißig Cent (USD
30.761,39) wovon einundzwanzigtausendachthundertachtzehn US Dollar und fünfundsiebzig Cent (USD 21.818,75) dem
Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden und die verbleibenden achttausendneunhundertzweiundvierzig US
Dollar und vierundsechzig Cent (USD 8.942,64) in das der Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account)
eingezahlt werden, gegen Zeichnung von zwei Millionen einhunderteinundachtzigtausendachthundertfünfundsiebzig
(2.181.875) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 1;
2) Masao Asai, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, dreitausendsiebenhundertzweiundachtzig US Dollar und einundsechzig Cent (USD
3.782,61) wovon zweitausendsechshundertzweiundachtzig US Dollar und vierundsechzig Cent (USD 2.682,64) dem
Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden und die verbleibenden tausendneunundneunzig US Dollar und sieben-
undneunzig Cent (USD 1.099,97) in das der Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt
werden, gegen Zeichnung von zweihundertachtundsechzigtausendzweihundertvierundsechzig (268.264) Klasse A Ge-
schäftsanteilen Serie 2;
3) Mark Jason Barnett, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, tausenddreihundertneunundfünfzig US Dollar und neun Cent (USD 1.359,09) wovon neun-
hundertvierundsechzig US Dollar und achtzehn Cent (USD 964,18) dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen
werden und die verbleibenden dreihundertvierundneunzig US Dollar und einundneunzig Cent (USD 394,91) in das der
Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von sechsundneun-
zigtausendvierhundertachtzehn (96.418) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 3;
4) Neil McCallum, vorbenannt,
76193
L
U X E M B O U R G
zahlte durch Einlage in Bar, siebenhundertsiebenundvierzig US Dollar und zweiundzwanzig Cent (USD 747,22) wovon
fünfhundertneunundzwanzig US Dollar und einundsiebzig Cent (USD 529,71) dem Stammkapital der Gesellschaft zuge-
wiesen werden und die verbleibenden zweihundertsiebzehn US Dollar und einundfünfzig Cent (USD 217,51) in das der
Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von zweiundfünfzig-
tausendneunhunderteinundsiebzig (52.971) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 4;
5) Qiang Dai, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, tausendeinhundertfünfzig US Dollar und dreiundvierzig Cent (USD 1.150,43) wovon acht-
hundertfünfzehn US Dollar und siebzig Cent (USD 815,70) dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden und
die verbleibenden dreihundertvierunddreißig US Dollar und dreiundsiebzig Cent (USD 334,73) in das der Anteilsklasse
spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von einundachtzigtausendfünfhun-
dertsiebzig (81.570) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 5;
6) Ali Reza Saiedabadi, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, tausendeinhundertzweiundneunzig US Dollar und dreiundsiebzig Cent (USD 1.192,73)
wovon achthundertsechsundvierzig US Dollar und fünfundzwanzig Cent (USD 846,25) dem Stammkapital der Gesellschaft
zugewiesen werden und die verbleibenden dreihundertsechsundvierzig US Dollar und achtundvierzig Cent (USD 346,48)
in das der Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von vier-
undachtzigtausendsechshundertfünfundzwanzig (84.625) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 6;
7) Piyush Bharti, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, dreitausendsechshundertneunundsechzig US Dollar und dreiundachtzig Cent (USD
3.669,83) wovon zweitausendsechshundertzwei US Dollar und einundachtzig Cent (USD 2.602,81) dem Stammkapital
der Gesellschaft zugewiesen werden und die verbleibenden tausendsiebenundsechzig US Dollar und zwei Cent (USD
1.067,02) in das der Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung
von zweihundertsechstausendzweihunderteinundachtzig (206.281) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 7;
8) Bing-Le Wu, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, elftausendeinhundertfünfzig US Dollar und sechsundvierzig Cent (USD 11.150,46) wovon
siebentausendneunhundertacht US Dollar und vierundneunzig Cent (USD 7.908,94) dem Stammkapital der Gesellschaft
zugewiesen werden und die verbleibenden dreitausendzweihunderteinundvierzig US Dollar und zweiundfünfzig Cent
(USD 3.241,52) in das der Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen
Zeichnung von siebenhundertneunzigtausendachthundertvierundneunzig (790.894) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 8;
9) Sam Xun-Wei Lowe, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, vierhundertdreiundachtzig US Dollar und achtundfünfzig Cent (USD 483,58) wovon drei-
hundertdreiundvierzig US Dollar und neunzehn Cent (USD 343,19) dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen
werden und die verbleibenden hundertvierzig US Dollar und neununddreißig Cent (USD 140,39) in das der Anteilsklasse
spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von vierunddreißigtausenddrei-
hundertneunzehn (34.319) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 9;
10) Thorkild Peter Juncker, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, neunhundertsiebenundsiebzig US Dollar und zwei Cent (USD 977,02) wovon sechshun-
dertzweiundneunzig US Dollar und dreiundsiebzig Cent (USD 692,73) dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen
werden und die verbleibenden zweihundertvierundachtzig US Dollar und neunundzwanzig Cent (USD 284,29) in das der
Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von neunundsech-
zigtausendzweihundertdreiundsiebzig (69.273) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 10; und
11) Angel Serrat, vorbenannt,
zahlte durch Einlage in Bar, tausendeinhundertzwanzig US Dollar und dreiundachtzig Cent (USD 1.120,83) wovon
siebenhundertfünfundneunzig US Dollar und zehn Cent (USD 795,10) dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen
werden und die verbleibenden dreihundertfünfundzwanzig US Dollar und dreiundsiebzig Cent (USD 325,73) in das der
Anteilsklasse spezifische Agio Konto (share premium account) eingezahlt werden, gegen Zeichnung von neunundsiebzig-
tausendfünfhundertzehn (79.510) Klasse A Geschäftsanteilen Serie 11;
Gesamt: vierzigtausend US Dollar (USD 40.000).
Alle Geschäftsanteile sind ganz in Bar eingezahlt worden, so dass die Summe von vierzigtausend US Dollar (USD 40.000)
von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 2000 geschätzt.
76194
L
U X E M B O U R G
<i>Gesellschafterversammlungi>
Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren und die sich selbst als ord-
nungsgemäß geladen erachten, haben sofort eine Gesellschafterversammlung abgehalten. Nachdem die Gesellschafter-
versammlung zunächst überprüft hat, ordnungsgemäß konstituiert zu sein, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1. Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf vier (4) festgesetzt.
2. Die folgenden Personen werden als Klasse A Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) Henning Bruder, Geschäftsführer, geboren am 24. März 1957 in Opperhausen, Deutschland, wohnhaft in Am Neuen
Garten 42, 14469 Potsdam, Deutschland; und
b) Suresh Sundaresan, Geschäftsführer, geboren am 17. Juni 1949 in Indien, wohnhaft in 440 Riverside Drive, Apt 61,
NY 10027, USA.
3. Die folgenden Personen werden als Klasse B Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) Sinan Sar, Privatbeamter, geboren am 5. Juni 1980 in Luxemburg, Luxemburg, wohnhaft in 5, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxemburg; und
b) Cornelius Bechtel, Privatbeamter, geboren am 11. März 1968 in Emmerich, Luxemburg, wohnhaft in 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg; und
4. Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterver-
sammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr welches am 31. März 2012 endet bestimmt, oder an jedem anderen, von der
Gesellschafterversammlung/vom alleinigen Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem
Datum.
5. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben
erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische
Fassung vorrangig sein.
Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten
Tag aufgenommen.
Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat/haben der
Bevollmächtigte/die Bevollmächtigten diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: C. Diesel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 mars 2011. LAC/2011/14960. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2011.
Référence de publication: 2011050914/978.
(110057218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.
Samsonite Sub Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 160.185.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twenty-fourth March.
Before Us, Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Samsonite International S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered
office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 159.469,
here represented by Mrs Elodie Duchêne, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal on 21 March 2011.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
76195
L
U X E M B O U R G
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by its articles of association
(hereafter, the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member
company.
Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may
be convertible and to the issuance of debentures.
2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any
contracts or obligations of the Company or of group companies.
2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
2.6 The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Samsonite Sub Holdings S.à r.l.".
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director
(gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gerance).
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1. - Subscribed and paid-up share capital
The Company's share capital is fixed at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) represented by
two million five hundred thousand (2,500,000) shares ("parts sociales") (hereafter, the "Shares"), with a nominal value of
United States Dollar one Cent (USD 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid-up.
At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company
("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law; In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the
Law, among others, will apply, thus entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 - Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general
shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.
6.3 - Profit participation
Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of
Shares in existence.
6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to
appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of Shares
In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of article 189 and article 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters
of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
76196
L
U X E M B O U R G
Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6 - Registration of Shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in
accordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have
been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not be
shareholder(s).
The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will de-
termine their number, and mandate period.
A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted
by the shareholders.
The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A director(s) (gérant(s) de classe
A) and one or several class B director(s) (gérant(s) de classe B).
The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be
compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of
directors (gérants).
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors
(conseil de gérance).
7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the sole
director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors
(gérants), by the sole signature of any director (gérant). However if the sole shareholder or the general meeting of
shareholders has appointed one or several class A director(s) (gérant(s) de classe A) and one or several class B director
(s) (gérant(s) de classe B), the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one class A director
(gérant de classe A) and one class B director (gérant de classe B) or by the joint signatures or single signature of any
persons to whom such signatory power has been delegated by the board of directors (conseil de gérance), within the
limits of such power.
The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of his agency.
7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may
also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of directors (conseil de gérance) and of the shareholders.
The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the
directors (gérants) or the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the
Company.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any director (gérant).
The board of directors (conseil de gérance) can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance), and if at least one class
A director (gérant de classe A) and one class B director (gérant de classe B) are present or represented if the sole
shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A director(s) (gérant(s) de classe
A) and one or several class B director(s) (gérant(s) de classe B).
76197
L
U X E M B O U R G
Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing
another director (gérant) as his proxy. Any director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent
him by phone to be confirmed at a later stage.
Any class A director (gérant de classe A) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by
appointing in writing another class A director (gérant de classe A) as his proxy. A class A director (gérant de classe A)
may also appoint another class A director (gérant de classe A) to represent him by phone to be confirmed at a later stage.
Any class B director (gérant de classe B) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by
appointing in writing another class B director (gérant de classe B) as his proxy. A class B director (gérant de classe B)
may also appoint another class B director (gérant de classe B) to represent him by phone to be confirmed at a later stage.
In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a simple majority of directors (gérants) present
or represented, and under the condition that at least one class A director (gérant de classe A) and one class B director
(gérant de classe B) vote in favor of the resolutions if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has
appointed one or several class A director(s) (gérant(s) de classe A) and one or several class B director(s) (gérant(s) de
classe B).
Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) by circular means shall have the same effect as
resolutions passed at the directors' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents
and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the board of directors (conseil de gérance) held by way of
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by tele-
phone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another and effectively communicate with each other. Any participation to a conference
call initiated and chaired by a director (gérant) located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at
such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
7.5 - Liability of directors (gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company which requires a
unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's
share capital, subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Thursday of
the month of June, at 4.00 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be
supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of the same year.
11.2 - Annual accounts
Each year, the director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
shall prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance
sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.
76198
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Distribution of profits.
12.1 - General Principle
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and
expenses represents the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until
and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
12.2 - Interim dividends
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 12.2. and subject
to any rule in addition to these as determined by the director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants) by the
board of directors (conseil de gérance), together with the shareholder(s):
- The director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants) the board of directors (conseil de gérance) shall
have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim
dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate interest.
- In this respect, the director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants) the board of directors (conseil de
gérance) is exclusively competent to decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such
distribution, based on the supporting documentation and principles contained in these Articles and on any agreement
possibly entered into from time to time between the shareholder(s).
- In addition, the decision of the director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants) of the board of directors
(conseil de gérance) shall be supported by interim financial statements of the Company dated less than two (2) months
from such decision of the director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants) of the board of directors (conseil
de gérance) and showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed does not
exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves
decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.
- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on
the above mentioned interim financial statements of the Company. The director (gérant) or in the case of plurality of
directors (gérants) the board of directors (conseil de gérance) may mandate an independent auditor to review such
interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.
- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law,
which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do
not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after
the date of the distribution.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles.
At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders
or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitional provisioni>
By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31
st
of December 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share
capital of the Company as follows:
Subscriber
Number
of shares
Subscribed
amount
(in USD)
% of share
capital
Paid-up
capital
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,000
25,000.-
100%
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500,000
25,000.-
100%
100%
76199
L
U X E M B O U R G
All the Shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,300.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following
resolutions:
1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of directors (gérants) and further resolved to appoint
the following person as directors for an undermined period:
- Mr. Kyle Gendreau, Chief Financial Officer, born on 30 May 1969 in Massachusetts (United States of America), having
his professional address at 615 South DuPont, Highway, City of Dover (Kent), Delaware 19901, United States of America;
- Mr. Nicholas James Clarry, Investment Professional, born on 9 March 1972 in Reading (United Kingdom), having his
professional address at 111 Strand WC2R 0AG London, United Kingdom; and
- Mr. Timothy Charles Parker, Investment Professional, born on 19 June 1955 in Aldershot (United Kingdom) having
his professional address at 111 Strand WC2R 0AG London, United Kingdom.
2. The registered office of the Company shall be established at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
- Samsonite International S.A., une société anonyme, existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au
20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et de Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 159.469,
ici représenté par Madame Elodie Duchêne, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé datée du 21 mars 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant,
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
"Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5 et 9,
les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.
2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être con-
vertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.
2.3 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l'exécution de tous
contrats ou obligations de la Société ou d'une société du groupe.
76200
L
U X E M B O U R G
2.4 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle
et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son
objet.
2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
2.6 La société est assujettie à l'imposition de droit commun.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Samsonite Sub Holdings S.à r.l.».
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille Dollars Américains (USD 25.000,-) représenté par deux millions
cinq cent mille (2.500.000) parts sociales (ci-après les "Parts Sociales") d'une valeur nominale de un cent de Dollar Amé-
ricain (USD 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés conformément à l'article 9 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.
6.3 - Participation aux profits
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des Parts Sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Transfert de Parts Sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les Parts Sociales détenues par chaque associé ne sont transmissibles que
sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les Parts Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en
assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de Parts Sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être
opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6 - Enregistrement de Parts Sociales
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Gérance.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés par l'associé unique ou l'assemblée générale
des associés qui déterminera leur nombre ainsi que la durée de leur mandat.
Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les
associés.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A
et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
76201
L
U X E M B O U R G
Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs
services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3., paragraphe 2 ci-dessous.
En cas de gérant unique, la Société est engagée par sa seule signature, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de n'importe quel gérant. Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un
ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les tiers par la
signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe de toute
personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants et le
cas échéant par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, le secrétaire ou par un gérant.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance, et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents
ou représentés si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Chaque gérant peut se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit par un autre gérant comme son
représentant. Chaque gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera
confirmé par écrit par la suite.
Tout gérant de classe A pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant de
classe A comme son représentant. Un gérant de classe A pourra également désigner un autre gérant de classe A pour le
représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.
Tout gérant de classe B pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant de
classe B comme son représentant. Un gérant de classe B pourra également désigner un autre gérant de classe B pour le
représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants
présents ou représentés à ladite réunion, et à la condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B
aient voté en faveur des dites résolutions si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs
gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Les résolutions écrites signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une
telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
7.5 - Responsabilité des gérants
76202
L
U X E M B O U R G
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur(s) fonction(s), aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
Parts Sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une as-
semblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le premier jeudi du mois de juin à
16h00. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société
sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice social
L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
11.2 - Comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance doit dresser un inventaire (indiquant
toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels appor-
teront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits.
12.1 - Principe général
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
12.2 - Dividendes intérimaires
Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux
règles fixées par le présent article 12.2. ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le gérant ou en cas de
pluralité de gérants par le conseil de gérance avec le / les associé(s):
- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au gérant
ou en cas de pluralité de gérants au conseil de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social de
la Société.
- A cet effet, le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider du
montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes
contenus dans les présents Statuts et de tout accord que le / les associé(s) pourraient conclure entre eux.
- En outre, la décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes
intérimaires de la Société datant de moins de deux (2) mois au moment de cette décision du gérant ou en cas de pluralité
de gérants du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu
76203
L
U X E M B O U R G
que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.
- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limité au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur
les comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants le conseil de
gérance peut donner mandat à un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant
des sommes distribuables.
- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'article 201 de la Loi,
lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre le / les associé(s) des dividendes distribués à lui/eux et ne
correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq ans à partir du
jour de la répartition.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)
s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit:
Souscripteur
Nombre
de Parts
Sociales
Montant
souscrit
(en USD)
% de capital
social
Capital
libéré
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000
25.000,-
100%
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000
25.000,-
100%
100%
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de
vingt-cinq mille Dollars américain (USD 25.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.300,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique agissant à la place de l'assemblée générale des associés a adopté immédiatement les résolutions
suivantes:
1. L'associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer les personnes
suivantes comme gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Kyle Gendreau, Chief Financial Officer, né le 30 mai 1969 au Massachusetts (Etats-Unis), ayant son adresse
professionnelle au 615 South DuPont, Highway, City of Dover (Kent), Delaware 19901, Etats-Unis;
- Monsieur Nicholas James Clarry, Investment Professional, né le 9 mars 1972 à Reading (Royaume-Uni), ayant son
adresse professionnelle au 111 Strand WC2R 0AG Londres, Royaume-Uni; et
- Monsieur Timothy Charles Parker, Investment Professional, né le 19 juin 1955 à Aldershot (Royaume-Uni) ayant son
adresse professionnelle au 111 Strand WC2R 0AG Londres, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. DUCHENE et H. HELLINCKX.
76204
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
avril 2011. Relation: LAC/2011/15227. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 avril 2011.
Référence de publication: 2011052460/515.
(110058558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.
Regus plc, Société Anonyme.
Siège de direction effectif: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.159.
EXTRAIT
Les associés ont décidé lors de l'assemblée générale annuelle en date du 17 mai 2011:
- de renouveler le mandat de KPMG Audit S.à r.l., R.C.S.: B103590, avec siège social au 9, allée Scheffer à L-2520
Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes au 31 décembre 2011;
- de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée ne pouvant excéder
trois ans:
* Douglas Sutherland, avec adresse au 12 rue Joseph Tockert, L-2620 Luxembourg;
* Mark Dixon, avec adresse à L'Estoril, 31 avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco
* Stephen Gleadle, avec adresse à Cokes Lane, Chalfont St., bâtiment Hillview House, HP8 4TA Giles, Buckinghamshire,
Royaume Uni
* Lance Browne, avec adresse au 2888 Hu Nan Road, bâtiment 140 Emerald, 201305 Shanghai, Chine
* Alex Sulkowski, avec adresse au 1B rue Heienhaff, L- 1736 Sennigerberg
* Elmar Heggen, avec adresse au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011077305/25.
(110085691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
EPF Dundee Retail Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.470.
Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mai 2011, le mandat du Réviseur d'Entreprise
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est reconduit pour une période expirant au moment de l'approbation des comptes
annuels de la Société au 31 décembre 2011 par l'associé unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2011.
<i>Pour la Société
i>TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2011069692/16.
(110077020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.
Logiconsult SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3285 Bettembourg, 22, rue Willmar.
R.C.S. Luxembourg B 82.165.
<i>Décision du 16 mai 2011i>
Les mandats des administrateurs et de l’administrateur – délégué sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l’an 2014.
76205
L
U X E M B O U R G
<i>Conseil d'Administrationi>
- Monsieur Charles SCHAUSS, Administrateur-délégué, demeurant à L-3285 Bettembourg, rue Willmar, 22
- Madame Danielle SCHAUSS-STAUDT, Administrateur, demeurant à L-3285 Bettembourg, rue Willmar, 22
- Mademoiselle Bianca SCHAUSS, Administrateur, demeurant à L-3285 Bettembourg, rue Willmar, 22
Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an
2014.
<i>Commissaire aux comptes.i>
- LuxFiduciaire Consulting Sàrl , L-2763 Luxembourg 12, Rue Sainte Zithe
Bettembourg, le 16 mai 2011.
Référence de publication: 2011071296/19.
(110079234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.
Carglass S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 611.500,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 4, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 68.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 16 mai 2011.
Référence de publication: 2011069450/12.
(110076114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Cerbero Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.431.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011069451/9.
(110076329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Chimachi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 3, Op der Bréck.
R.C.S. Luxembourg B 137.903.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069453/10.
(110076459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Triton III LuxCo A 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.678.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 1
er
juin 2011 et avec effet immédiat, la démission de
Charlmaine Vella en tant que gérant de catégorie B de la Société.
Les associés de la Société ont également décidé de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat, en tant que
gérants de catégorie B de la Société, pour une durée illimitée :
- Andras Kulifai, né le 14 juillet 1977 à Budapest (Hongrie) et demeurant professionnellement au 43, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand duché de Luxembourg);
76206
L
U X E M B O U R G
- Susana Paula Fernandes Goncalves, née le 1
er
mai 1981 à Macedo de Cavaleiros (Portugal) et demeurant profes-
sionnellement au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand duché de Luxembourg).
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
- Lars Frankfelt, Gérant de catégorie A
- Andras Kulifai, Gérant de catégorie B
- Susana Paula Fernandes Goncalves, Gérant de catégorie B
<i>Pour Triton III LuxCo A 11 S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2011077354/23.
(110085799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
D.B.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 47.022.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069456/10.
(110076177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Dano S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 72.673.
Les comptes annuels au 30 novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michel SOUTIRAN.
Référence de publication: 2011069457/10.
(110076358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Danske SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 50.991.
Le bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Danske SICAV-SIF
i>SICAV- SIF
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Signatures
Référence de publication: 2011069458/14.
(110076759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Rom2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 109.771.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 02 mai 2011, Mme. Marie BOURLOND,
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été nommée Administrateur, en remplacement de l'Administrateur démis-
sionnaire M. Jean BODONI jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.
Cette même assemblée a ratifié la décision prise par le Conseil d'administration en date du 29 octobre 2010 de coopter
M. Olivier LECLIPTEUR au poste d'administrateur de la société, en remplacement de M. Gabor KACSOH. Le mandat de
l'administrateur définitivement élu, s'achèvera avec ceux de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale annuelle de
2011.
76207
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27 MAI 2011.
<i>Pour: ROM2 S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Nathalie Paquet-Gillard
Référence de publication: 2011076660/20.
(110084174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
DE Investment Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 97.015.
Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2011.
<i>Pour DE Investment Group S.à r.l.
i>Représenté par Monsieur Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011069459/13.
(110076109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Delta Concept Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 71.979.
Les comptes annuels au 31 12 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>L'administrateuri>
Référence de publication: 2011069460/13.
(110076395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
SAF-Holland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 113.090.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société en date du 28 avrili>
<i>2011.i>
Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 28 avril 2011, il a été décidé
de:
1. réélire, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Bernhard SCHNEIDER, résidant professionnellement au
2, Koranska, HRV - 10000 Zagreb, Croatie, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014.
2. réélire, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Richard MUZZY, résidant professionnellement au 6701,
Audubon Road, MI 49422-2099 Holland, Etats-Unis, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012:
3. nommer, en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Samuel Martin, né le 16 novembre 1945 dans le Missouri,
Etats-Unis et résidant professionnellement au 4567 Audubon Road, MI-49423 Holland, Etats-Unis pour une période qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2012.
4. renommer ERNST & YOUNG, société anonyme dont le siège social est situé au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires pour statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
76208
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011078138/28.
(110086108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
Elan Investments Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.997.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2011.
Elan Investments Limited S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011069462/15.
(110076137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Eurizon Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 58.206.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eurizon Investment Sicav
State Street Bank Luxembourg S.A.
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2011069463/13.
(110076593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Euresa-Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 5, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 43.958.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 avril 2008
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Pierre Quairière
<i>Directeur-Générali>
Référence de publication: 2011069464/12.
(110076554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
IVG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.381.
Le bilan de la Société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
76209
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 18 mai 2011.
<i>Pour IVG Luxembourg S.à r.l.
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011069487/14.
(110076715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Europäische Grundbesitz und Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.385.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069465/10.
(110076400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Nouka Investments S.à r..l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 159.393.
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la Société tenue en date du 31 mai 2011:i>
1. la démission du Gérant Victoria Management Services S.A., avec adresse à 58, rue Charles Martel L - 2134 Luxem-
bourg, a été acceptée avec effet au 31 mai 2011
2. la nomination du Gérant de Classe A, Kathryn Bergkoetter, avec adresse à 58 rue Charles Martel L - 2134 Luxem-
bourg , a été acceptée avec effet au 31 mai 2011
3. la nomination du Gérant de Classe A, Kai Hennen, avec adresse à 58 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg , a
été acceptée avec effet au 31 mai 2011
4. la nomination du Gérant de Classe B, Chaumont (Directors) Limited, avec adresse à GTS Chamber, P.O. Box 3471,
Road Town Tortola, Îles Vierges britanniques, a été acceptée avec effet au 31 mai 2011
<i>Gérants Classe Ai>
Mrs. Kathryn Bergkoetter, 58 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg
M. Kai Hennen, 58 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg;
<i>Gérant Classe Bi>
Chaumont (Directors) Limited, GTS Chamber, P.O. Box 3471, Road Town Tortola, Îles Vierges Britanniques
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011077271/24.
(110085671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
Faco Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 118.704.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FACO INVEST S.à r.l.
i>C. BLONDEAU
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011069469/13.
(110076116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
76210
L
U X E M B O U R G
FI Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 75.852.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FI CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
Cristina Levis / Lara Nasato
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011069471/12.
(110076648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Flyers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 77.088.
Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FLYERS S.A
i>Christophe BLONDEAU / Romain THILLENS
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011069472/12.
(110076118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Primost S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 134.456.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 09 mai 2011i>
<i>Première résolutioni>
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
Afin d'assurer le contrôle des comptes de la société, l'Assemblée Générale Extraordinaire nomme à l'unanimité K.F.Fi-
duciaire S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro B143688, «commissaire aux comptes» de la société.
Le mandat du commissaire aux comptes nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
l'exercice social 2011.
M.Patrick KREINS, commissaire aux comptes, est radié de ses fonctions à partir du 09 mai 2011.
Cette résolution a été votée à l'unanimité.
Référence de publication: 2011069877/17.
(110077128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.
Ganesh Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 154.120.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Yves Cacclin / Jean-Patrick Tran-Phat
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011069475/11.
(110076126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
76211
L
U X E M B O U R G
Garirom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 117.884.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2011069476/10.
(110076122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Hills Japan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 141.117.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 May 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069478/10.
(110076149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Mullebutz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.
R.C.S. Luxembourg B 34.938.
<i>Assemblée générale extraordinaire de Mullebutz s.à r.l.i>
L'Assemblée est ouverte à 15 heures.
<i>Ordre du jouri>
- Transfert du siège social.
L'intégralité du capital est représentée par:
Monsieur GOERGEN Nicolas
40, rue de la Libération à L-4210 ESCH/ALZETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales
Madame MATHIAS Marianne
40, rue de la Libération à L-4210 ESCH/ALZETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 parts sociales
Madame LABOUCARIE-CREUTZER Yvette
Impasse Selver à F-57970 YUTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-4210 ESCH/ALZETTE, 40, rue de la Libération, à L-4037 ESCH/
ALZETTE, 13, rue Bolivar.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 15 heures 30.
Fait à Esch/Alzette, le 27 mai 2011.
Madame MATHIAS Marianne.
Référence de publication: 2011077559/23.
(110086018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
ARC Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.199.
In the year two thousand and eleven, on the fifth of May.
Before Maître Martine SCHAEFFER, Notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of ARC Asset Management S.A., a société anonyme (public limited com-
pany) governed by the Luxembourg Law, with registered office in L-1510 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie,
registered in the Trade and Company Register in Luxembourg under Section B and Number 122.199,
incorporated on the 28
th
of November 2006, pursuant to a deed drawn-up before Maître Henri Hellinckx, notary
residing then in Mersch, published in the Official Gazette "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 88
of 31 January 2007.
76212
L
U X E M B O U R G
The Articles of Association were amended on the 12
th
of July 2007, pursuant to a deed drawn-up before Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Official Gazette "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations", number 2247 of 9 October 2007.
The Articles of Association were amended on the 1
st
of October 2007, pursuant to a deed drawn-up before Maître
Christine Doerner, notary residing in Bettembourg, published in the Official Gazette "Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations", number 2464 of 30 October 2007.
The Articles of Association were amended on the 28
th
of November 2007, pursuant to a deed drawn-up before the
undersigned notary, published in the Official Gazette "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number 477 of
25 February 2008.
The Articles of Association were amended on the 21
st
October 2008, pursuant to a deed drawn-up before the same
notary, publié au Mémorial C, published in the Official Gazette "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", number
2743 of 11 November 2008.
The meeting was chaired by Mrs Orietta RIMI, employee, with professional address in L-1510 Luxembourg, 38/40,
avenue de la Faïencerie.
The Chairwoman appointed Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, as Secretary.
The meeting appointed Mr Raymond THILL, maître en droit, with same professional address, as Scrutineer.
The Chairwoman requested the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the Chairwoman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list, as well
as the proxies marked "ne varietur", will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. It is shown from the attendance list that all the shares, representing the whole corporate capital, were represented
at the present extraordinary general meeting, and that the meeting was consequently regularly constituted and could
validly deliberate on all the items of the agenda, the shareholders present or represented considering themselves as being
duly convened and informed of the agenda of the meeting that was sent to them beforehand.
III. The agenda of the meeting was the following:
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,000 (two thousand euro), in order to bring
it from its current amount of EUR 171,000 (one hundred seventy-one thousand euro) to an amount of EUR 169,000 (one
hundred sixty-nine thousand Euro) through the cancelling of the 2 (two) shares of class B of EUR 1,000 (one thousand
euro) each, which have been repurchased by the Company;
2. Subsequent amendment of Article 5 paragraph 1 of the Articles of Association;
3. Miscellaneous.
The general meeting of the shareholders having approved the statements from the Chairman, and considering as duly
constituted and convened, deliberated and passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 2,000
(two thousand euro),
in order to bring it from its present amount of EUR 171,000 (one hundred seventy-one thousand euro), to an amount
of EUR 169,000 (one hundred sixty-nine thousand euro),
through the cancelling of the 2 (two) shares of class B, with a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) each,
which have been repurchased by the Company.
The general meeting of shareholders further resolves to incorporate a non distributable reserve of an amount equal
to the nominal value of the shares, i.e. EUR 2,000 (two thousand euro).
<i>Second resolutioni>
Following the previous resolutions, the general meeting of the shareholders decides to amend Article 5 paragraph 1
of the Articles of Association, which shall henceforth be read in the following way:
' Art. 5. First paragraph. The share capital is set at EUR 169,000 (one hundred sixty-nine thousand euro), represented
by 160 (one hundred and sixty) class A shares and 9 (nine) class B shares with a par value of EUR 1,000 (one thousand
euro) each, fully paid-up.'
<i>Closingi>
With no other outstanding items on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairwoman
brought the meeting to a close.
76213
L
U X E M B O U R G
<i>Feesi>
Then, the meeting noted that the aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any
form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present extraordinary general
meeting, is approximately one thousand two hundred Euro (1,200 EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
parties the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing parties
and in case of any discrepancy between the English and the French text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le cinq mai.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée ARC Asset Ma-
nagement S.A. ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce
à Luxembourg sous la section B et le numéro 122.199,
constituée en date du 28 novembre 2006, par acte devant Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 88 du 31 janvier 2007.
Les statuts ont été modifiés en date du 12 juillet 2007, par acte devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2247 du 9 octobre 2007.
Les statuts ont été modifiés en date du 1
er
octobre 2007, par acte devant Maître Christine Doerner, notaire de
résidence à Bettembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2464 du 30 octobre 2007.
Les statuts ont été modifiés en date du 28 novembre 2007, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 477 du 25 février 2008.
Les statuts ont été modifiés en date du 21 octobre 2008, par acte du même notaire, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2743 du 11 novembre 2008.
L'assemblée est présidée par Madame Orietta RIMI, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1510 Luxem-
bourg, 38/40, avenue de la Faïencerie.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L'assemblée désigne comme scrutatrice Monsieur Raymond THILL, maître en droit, avec même adresse profession-
nelle.
Le président prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations paraphées «ne varietur», resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 2.000.-EUR (deux mille euros), pour le réduire de son
montant actuel de 171.000.-EUR (cent soixante et onze mille euros) à un montant de 169.000.-EUR (cent soixante-neuf
mille euros) par l'annulation des 2 (deux) actions de catégorie B, chacune d'une valeur nominale de 1.000.-EUR (mille
euros), qui ont été rachetées par la Société;
2. Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1 des statuts;
3. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:
<i>Premières résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 2.000.-EUR
(deux mille euros),
76214
L
U X E M B O U R G
pour le ramener de son montant actuel de 171.000.-EUR (cent soixante et onze mille euros) à un montant de 169.000.-
EUR (cent soixante-neuf mille euros),
par l'annulation des 2 (deux) actions de catégorie B, d'une valeur nominale de 1.000.-EUR (mille euros) chacune, qui
ont été rachetées par la Société.
L'assemblée générale décide également de constituer une réserve non distribuable d'un montant égal à la valeur no-
minale des actions, c'est-à-dire 2.000.-EUR (deux mille euros).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le premier alinéa de l'article 5
des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à 169.000.-EUR (cent soixante-neuf mille euros), représenté par 160
(cent soixante) actions de catégorie A et 9 (neuf) actions de catégorie B d'une valeur nominale de 1.000.-EUR (mille
euros) chacune, entièrement libérées.»
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
L'assemblée constate ensuite que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes les espèces qui incombent à
la société à la suite de la présente assemblée générale extraordinaire sont estimés à environ EUR 1.200,-(mille deux cents
euros).
Le notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: O. Rimi, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mai 2011. LAC/2011/21172. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2011.
Référence de publication: 2011068275/151.
(110075615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.
Land and Business S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 114.483.
Le Comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011069495/9.
(110076110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Holdis S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 124.382.
Les comptes annuels au 30 novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Michel SOUTIRAN.
Référence de publication: 2011069480/10.
(110076354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
76215
L
U X E M B O U R G
Hotlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 38.118.
Le bilan au 31 Décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2011.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011069481/13.
(110076112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Indra Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 154.116.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Yves Cacclin / Jean-Patrick Tran-Phat
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011069482/11.
(110076123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
SI.TO. Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 44.390.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 mai 2011, Madame Marie
BOURLOND, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a été nommée administrateur, en remplacement de Monsieur
Jean BODONI démissionnaire.
Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.
Par cette même assemblée, les mandats des administrateurs M. Guy KETTMANN, et M. Guy BAUMANN ainsi que
celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six ans,
prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2017.
Luxembourg, le 24 MAI 2011.
<i>Pour: SI.TO. FINANCIERE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon
Référence de publication: 2011076676/20.
(110084176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 150.947.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3.03.2010
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX-EDJAR Luxembourg Sàrl
i>Signature
Référence de publication: 2011069493/12.
(110076620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
76216
L
U X E M B O U R G
Industrial Automation Process International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, rue de la Platinerie.
R.C.S. Luxembourg B 113.083.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 17.05.2011.
Fiduciaire S.à r.l.
CabexcO
Centre Helfent
1, rue Pletzer - L-8080 Bertrange
Signature
Référence de publication: 2011069483/15.
(110076392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.605.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 Mai 2011.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Robert van't Hoeft
<i>Domiciliation Agenti>
Référence de publication: 2011069489/14.
(110076138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
SGEA Immobilier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 96.233.
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 17 mai 2011, l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
Renouvellement du mandat des administrateurs suivants avec effet immédiat et pour une période venant à échéance
lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2011 et qui se
tiendra en 2012:
Paul van Baarle, avec adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; Jorge Pérez Lozano, avec
adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Xenia Kotoula, avec adresse professionnelle au 1, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg; Ian Baker, avec adresse au 166, Sloane Street, SW1 X9QF Londres, Royaume-Uni
Il a également été décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, L’Alliance Révision SARL, avec siège
social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de
l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2011 et qui se tiendra
en 2012.
Lors du Conseil d’administration tenu en date du 4 mai 2011, il a été décidé de renouveler le mandat de Jorge Pérez
Lozano, avec adresse professionnelle au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que président du conseil d’admi-
nistration
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2011.
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011077335/25.
(110085651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
76217
L
U X E M B O U R G
Kali Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 154.117.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Yves Cacclin / Jean-Patrick Tran-Phat
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011069490/11.
(110076129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
FI Financial Markets S.A., Société Anonyme,
(anc. SIREC, SIREC International Reinsurance Company S.A.).
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 49.656.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 6 maii>
<i>2011i>
Grant Thornton Lux Audit SA, avec siège social à 83, Pafebruch L-8308 Capellen est nommé nouveau commissaire
aux comptes allant du 31 décembre 2010 jusque à 31 décembre 2011.
Monsieur Thierry Hubert et Mademoiselle Cristina Levis sont renommés administrateurs pour un nouveau période
d'un an. Mademoiselle Lara Nasato, employée privée, née le 01.03.1984, à Montebelluna (Italie) avec adresse profession-
nelle au 25A, boulevard Royal, L-2449, est nommé administrateur pour un période d'un an. Leurs mandats viendront à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2012.
Luxembourg, le 10 mai 2011.
Pour extrait sincère et conforme
FI FINANCIAL MARKETS (EX SIREC SA)
Cristina Levis
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2011076987/20.
(110084542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 79.540.
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth of April,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of shareholders of Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., a société en com-
mandite par actions, having its registered office in 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 79.540 (the "Company"), incorporated under the deno-
mination of Compaq Computer Luxembourg S.C.A. pursuant to a notarial deed dated 5 December 2000, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 17 July 2001, under number 538. The articles of incorporation
of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 March 2011,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is opened at 3.00 p.m. with Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg, in
the chair,
who appoints as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the
<i>Agendai>
of the meeting is the following:
1. Acknowledgment of the effectiveness of the merger between Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l. and
Hewlett-Packard Luxembourg Participations S.à r.l. with effect as of 19 April 2011;
76218
L
U X E M B O U R G
2. Amendment of article 7 of the articles of incorporation of the Company as follows:
" Art. 7. Management. The Company shall be jointly managed by the following Managers which must be unlimited
shareholders:
1. Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg
and having its registered office at L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, in its capacity as unlimited shareholder
(«associé commandité») of the Company; and
2. Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg
and having its registered office at L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, in its capacity as unlimited shareholder
(«associé commandité») of the Company.
The two above Managers shall together form the Board of Managers.
The limited shareholders may not act as manager of the Company and shall neither participate in nor interfere with
the management of the Company."
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholder
of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting acknowledges the effectiveness with effect as of 19 April 2011 of the merger between Hewlett-
Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-8308 Capellen,
75, Parc d'Activités Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 88.847,
acting as the absorbing company and Hewlett-Packard Luxembourg Participations S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 79.826, acting as the absorbed company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting resolves to amend article 7 of the Company's
articles of incorporation which shall now read as follows:
" Art. 7. Management. The Company shall be jointly managed by the following Managers which must be unlimited
shareholders:
1. Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg
and having its registered office at L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, in its capacity as unlimited shareholder
(«associé commandité») of the Company; and
2. Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg
and having its registered office at L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, in its capacity as unlimited shareholder
(«associé commandité») of the Company.
The two above Managers shall together form the Board of Managers.
The limited shareholders may not act as manager of the Company and shall neither participate in nor interfere with
the management of the Company."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
76219
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-neuf avril,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hewlett Packard Luxembourg S.C.A., une société
en commandite par actions, ayant son siège social à 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 79.540 (la «Société»), constituée sous la dénomination de Compaq
Computer Luxembourg S.C.A. suivant acte notarié en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 17 juillet 2001, sous le numéro 538. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant un acte du notaire soussigné en date du 23 mars 2011, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
L'assemblée s'est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privé, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a l'
<i>Ordre du jouri>
suivant:
1. Constat de la fusion entre Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l. et Hewlett-Packard Luxembourg Par-
ticipations S.à r.l. avec effet au 19 avril 2011;
2. Modification de l'article 7 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 7. Gestion. La Société sera gérée conjointement par les Gérants suivants qui doivent être des actionnaires
commandités:
1. Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois luxembourgeoises
et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, en sa qualité d'actionnaire commandité de la
Société; et
2. Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois luxembourgeoises
et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, en sa qualité d'actionnaire commandité de la
Société.
Les deux Gérants pré-mentionnés formeront ensemble le Conseil de Gérance.
Les actionnaires commanditaires ne pourront pas agir en tant que gérant de la Société et ne participeront à, ni n'in-
terféreront dans la gestion de la Société.»
3. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
pareillement annexées aux présentes.
III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires
présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable avant cette assemblée, les convocations d'usage n'ont pas été nécessaires.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale constate la fusion avec effet au 19 avril 2011 entre Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à
r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son. siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.847, en tant que société absorbante et Hewlett-
Packard Luxembourg Participations S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8308 Capellen,
76220
L
U X E M B O U R G
75, Parc d'Activités Capellen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 79.826, en
tant que société absorbée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 7. Gestion. La Société sera gérée conjointement par les Gérants suivants qui doivent être des actionnaires
commandités:
1. Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois luxembourgeoises
et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, en sa qualité d'actionnaire commandité de la
Société; et
2. Hewlett-Packard Luxembourg Investment S.à r.l., une société constituée et existant selon les lois luxembourgeoises
et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen, en sa qualité d'actionnaire commandité de la
Société.
Les deux Gérants pré-mentionnés formeront ensemble le Conseil de Gérance.
Les actionnaires commanditaires ne pourront pas agir en tant que gérant de la Société et ne participeront à, ni n'in-
terféreront dans la gestion de la Société.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui naîtront à charge de la Société en
raison de la présente augmentation de capital, sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent
acte.
Signé: M. KREMER, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2011. LAC/2011/18638. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 27 avril 2011.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2011073146/166.
(110074609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.
Kimberly-Clark Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 62.149.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 Mai 2011.
Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.
Robert van't Hoeft
<i>Domiciliation Agenti>
Référence de publication: 2011069491/14.
(110076141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
LYXOR Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.801.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
76221
L
U X E M B O U R G
Société Générale Securities Services Luxembourg
Signature
<i>Corporate and Domiciliary Agenti>
Référence de publication: 2011069494/12.
(110076134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Participations 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 117.742.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 mai 2011 que le conseil d'administration
a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la Société au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg à partir du 3
janvier 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2011.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011069853/16.
(110077166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.
Lang's Lights Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6830 Berbourg, 7A, Neie Wee.
R.C.S. Luxembourg B 53.893.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069496/10.
(110076397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Laris Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 82.481.
Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 18 mai 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069497/10.
(110076472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Laris Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Strassen, 32, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 82.481.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 18 mai 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069498/10.
(110076477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
76222
L
U X E M B O U R G
Triton III LuxCo B 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.796.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé d'accepter, en date du 1
er
juin 2011 et avec effet immédiat, la démission de
Charlmaine Vella en tant que gérant de catégorie B de la Société.
Les associés de la Société ont également décidé de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat, en tant que
gérants de catégorie B de la Société, pour une durée illimitée:
- Andras Kulifai, né le 14 juillet 1977 à Budapest (Hongrie) et demeurant professionnellement au 43, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand duché de Luxembourg);
- Susana Paula Fernandes Goncalves, née le 1
er
mai 1981 à Macedo de Cavaleiros (Portugal) et demeurant profes-
sionnellement au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand duché de Luxembourg).
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
- Lars Frankfelt, Gérant de catégorie A
- Andras Kulifai, Gérant de catégorie B
- Susana Paula Fernandes Goncalves, Gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton III LuxCo B 11 S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2011077355/24.
(110085798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
Luxroyal Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 57.636.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2011.
<i>Pour LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
i>Représenté par M. Matthijs BOGERS
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2011069502/13.
(110076106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
SHCO 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 149.526.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 2011.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011078142/13.
(110085709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
76223
L
U X E M B O U R G
Immobilier JPF S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 131.469.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069503/10.
(110076402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Immobilier JPF S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 131.469.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069504/10.
(110076403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2011.
Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.201.
Par décision prise par voie circulaire en date du 31 Mars 2011, le conseil d'administration a pris note de la démission
de:
- Monsieur Dirk DECLERCQ, PDM Securities S.A. Barones Ludwina de Borrekenslaan, B-2630 Aartselaar,
- Monsieur Luc VAN DEN NESTE, PDM Securities S.A, Barones Ludwina de Borrekenslaan, B-2630 Aartselaar,
et a décidé de coopter:
- Monsieur Henri ROSAER, Van Glabbeek & Co b.v.b.a, Kipdorp 43, B-2000 Antwerpen
- Madame Karin EMBRECHT, Van Glabbeek & Co b.v.b.a, Kipdorp 43, B-2000 Antwerpen
Cette cooptation sera proposée à la ratification par les actionnaires de la SICAV lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
<i>Pour FORTUNA SELECT FUND
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2011076609/21.
(110084158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
Principe SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 88.946.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 2011.
Référence de publication: 2011078134/10.
(110085723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
76224
ARC Asset Management S.A.
Capula Luxembourg Limited
Carglass S.à r.l.
Cerbero Holding S.A.
Chimachi S.à r.l.
Dano S.A.
Danske SICAV-SIF
D.B.N. S.A.
DE Investment Group S.à r.l.
Delta Concept Investissement S.A.
Elan Investments Limited S.à r.l.
EPF Dundee Retail Park S.à r.l.
Euresa-Life S.A.
Eurizon Investment Sicav
Europäische Grundbesitz und Beteiligungsgesellschaft S.A.
Faco Invest S.à r.l.
FI Capital Luxembourg S.A.
FI Financial Markets S.A.
Flyers S.A.
Fortuna Select Fund
Ganesh Investments S.A.
Garirom S.A.
Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.
Hills Japan S.à r.l.
Holdis S.à r.l.
Hotlux S.A.
Immobilier JPF S.àr.l.
Immobilier JPF S.àr.l.
Indra Investments S.A.
Industrial Automation Process International S.à r.l.
IVG Luxembourg S.à r.l.
Kali Investments S.A.
Kimberly-Clark Luxembourg Holdings Sàrl
Kimberly-Clark Luxembourg S.à r.l.
Land and Business S.A.
Lang's Lights Luxembourg S.A.
Laris Immo S.à r.l.
Laris Immo S.à r.l.
Logiconsult SA
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl
Luxroyal Management S.A.
LYXOR Selection Fund
Mullebutz s.à r.l.
Nouka Investments S.à r..l.
Participations 1 S.à r.l.
Primost S.A.
Principe SA
Regus plc
Rom2 S.A.
SAF-Holland S.A.
Samsonite Sub Holdings S.à r.l.
SGEA Immobilier S.A.
SHCO 12 S.à r.l.
SIREC International Reinsurance Company S.A.
SI.TO. Financière S.A.
Triton III LuxCo A 11 S.à r.l.
Triton III LuxCo B 11 S.à r.l.