This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1567
14 juillet 2011
SOMMAIRE
Aesthetic Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
75215
Alpina Real Estate Company II SCA . . . . .
75194
Buffalo Poland Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
75188
ERE HGP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75178
European Capital S.A. SICAR . . . . . . . . . . .
75213
Fenor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75214
Gagfah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75170
ILP III S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75198
JH - Holz S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75204
Leopard Germany Property Papenburg
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75206
Proim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75185
Regulux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75197
Remora Consult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75202
Ressac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75202
Rollasun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75203
RTL Group Central and Eastern Europe
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75203
Russel and Thomson Finance and Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75188
Russel and Thomson Finance and Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75197
Russel and Thomson Finance and Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75197
Sachverständigenbüro Jakoby S.à r.l. . . . . .
75204
Sagical S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75205
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . .
75206
SANZAR Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
75205
Satpo-Peakside JV Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
75203
SCEM Reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75206
Schräinerei Conrardy Succ. Jacques &
Thorn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75211
SciPharm S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75204
S.C.I Village de Mance . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75188
S.C.I. Ville de Cognac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75203
SD SL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75212
Sea-Invest Afrique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75206
Securinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75212
SeeReal Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . .
75204
Select Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75212
Selm Holding International S.A. . . . . . . . . .
75212
SG Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75213
Shane Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
75198
Small S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75212
Smart Holding Group S.A. . . . . . . . . . . . . . .
75213
Smat's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75204
Smat's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75213
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. . . .
75214
Sobepart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75214
Société de Participations Immobilières S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75204
Société Financière Saka S.A., SPF . . . . . . .
75214
Sofilec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75215
SOFT4U S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75215
Solubat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
SPU Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75215
State Street Global Advisors Luxembourg
SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75205
Stofan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
Stofan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
Stoker Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
75205
Symbihome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
Threadneedle (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75216
75169
L
U X E M B O U R G
Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.526.
In the year two thousand and eleven, on the twenty first day of April.
Before us Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg (Luxembourg).
Was held the extraordinary general meeting of shareholders of Gagfah S.A. (the "Company"), a société anonyme -
société de titrisation, having its registered office in Luxembourg, 2-4 rue Beck, L–1222 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 109 526,
incorporated by deed of notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg) of July
12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial”) of 3 December 2005, Number
1323.
The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of Maître
Henri Hellinckx of 21 February 2011, not yet published in the Mémorial.
The meeting is declared open with Mister William Joseph Brennan, director, residing professionally in Luxembourg,
in the chair, who appointed as secretary, Mister Ralph Beyer, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Simone Kassner, kaufmännische Angestellte, residing in Germany, and Mr
Nicolai Kuss, Diplom Kaufmann, residing in Germany.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: (I)
That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the following agenda:
1) Decision to reduce the issued share capital and to cancel any shares acquired (or to be acquired) by the Company
after January 21, 2011, pursuant to the buyback program of the Company announced on December 7, 2010, and reduction
of the relevant reserves constituted in relation thereto; instruction and delegation of power to and authorisation of the
Board of Directors to implement the cancellation of such shares and reductions of share capital and related matters in
one or more instalments as deemed fit by the Board of Directors, to cause the share capital reductions and cancellations
of such shares and the consequential amendment of the Articles of Incorporation to be recorded by way of notarial deeds,
and generally to take any steps, actions or formalities as appropriate or useful to implement this decision of the Extraor-
dinary General Meeting of Shareholders;
2) Decision to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of €70,600,000 by the repurchase
and cancellation of a maximum of 56,480,000 shares from existing shareholders during a period ending nine (9) months
after the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders within the parameters set forth below and to the
extent determined by the Board of Directors, instruction and delegation of power to and authorisation of the Board of
Directors to determine the conditions of the purchase(s) of shares, to implement the share purchases, cancellation of
shares and reduction of share capital, determine the final amount of the share capital reduction and number of shares to
be repurchased and cancelled (if any) within the maximum decided by the general meeting of shareholders, proceed to
the payment of the repurchase price, cause the share capital reduction and cancellation of shares and the consequential
amendment of the Articles of Incorporation to be recorded by way of notarial deed, and generally to take any steps,
actions or formalities as appropriate or useful to implement this decision of the Extraordinary General Meeting of Sha-
reholders;
Parameters of the decision to reduce the issued share capital of the Company by the repurchase and cancellation of
shares (to the extent determined by the Board of Directors):
- maximum amount of capital reduction: €70,600,000;
- repurchase and cancellation of a maximum of 56,480,000 shares;
period: period ending on 21
st
January 2012 at midnight;
- purchase(s) of shares may be made in any manner including without limitation, by tender or other offer(s), buyback
program(s), over the stock exchange or in privately negotiated transactions or in any other manner as determined by the
Board of Directors including derivative transactions or transaction having the same or similar economic effect than an
acquisition, as determined by the Board of Directors;
- purchase price: as determined by the Board of Directors provided that in the case of acquisitions for value:
(i) in the case of acquisitions other than in the circumstances set forth under (ii), for a net purchase price being (x) no
less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each
case being the closing price on Xetra of the Frankfurt Stock Exchange (or successor system) (“Xetra”) over the ten (10)
trading days preceding the date of the purchase (or as the case may be the date of the commitment to the transaction);
(ii) in case of a tender offer (or if deemed appropriate by the Board of Directors, a buyback program),
a. in case of a formal offer being published, for a set net purchase price or a purchase price range, each time within
the following parameters: (x) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent
above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra over the ten (10) trading days preceding the
75170
L
U X E M B O U R G
publication date, provided however that if the stock exchange price during the offer period fluctuates by more than 10%,
the Board of Directors may adjust the offer price or range to such fluctuations;
b. in case of a public request for sell offers is made, a price range may be set (and revised by the Board of Directors
as deemed appropriate) provided that acquisitions may be made at a price which is (x) no less than fifty per cent of the
lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price
on Xetra over a period determined by the Board of Directors provided that such period may not start more than five
(5) trading days before the sell offer start date of the relevant offer and may not end after the last day of the relevant sell
offer period);
3) Renewal and extension of the authorised un-issued share capital within the Company to be set at the amount of €
10,000,000,000, represented by 8,000,000,000 shares with a nominal value of one point twenty-five euro (€ 1.25) each,
acknowledgment of the report pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg company law on the circumstances and prices
of issues of shares against cash without pre-emptive subscription rights, waiver of, suppression and authorisation to the
Board of Directors to waive, suppress or limit, any pre-emptive subscription rights in the case of issues of shares within
the authorised share capital, authorisation to the Board of Directors to proceed to further securitisations and to issue
shares (or any securities or rights giving rights to shares) within the authorised share capital against contributions in cash,
in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions
determined by the Board of Directors or its delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public
offerings of the shares of the Company and in particular without limitation, the Board of Directors may issue shares in
favour of directors, executives, employees, consultants of the Company and the group to which it belongs, directly or
under the terms of option, incentive or like plans approved by the Board of Directors) while preserving, waiving, sup-
pressing or limiting any pre-emptive subscription rights of existing shareholders, determination of the validity period of
the authorised share capital of the Company starting on the day of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
recording the present authorisation and ending on the fifth anniversary of the day of publication of the deed recording
the minutes of the said general meeting on the Mémorial; consequential amendment of the second and third paragraph
of article 5 of the Articles of Association of the Company so as to read as follows:
“The authorised un-issued capital of the Company is set at ten billion Euro (€10,000,000,000) to be represented by
eight billion Shares. The authorised and unissued share capital shall be and the authorisation to issue Shares thereunder
is valid for a period starting on April 21, 2011, and ending five (5) years after the date of the publication of the minutes
of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on April 21, 2011, in the Mémorial (unless
amended or extended by the general meeting of shareholders).
The Board of Directors or delegate(s) duly appointed by the Board, may from time to time issue such Shares within
the authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board or its
delegate(s) may in its or their discretion resolve. In particular without limitation, the Board of Directors may issue shares
in favour of directors, executives, employees, consultants of the Company and the group to which it belongs, directly or
under the terms of option, incentive or like plans approved by the Board of Directors. The Board of Directors is autho-
rised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for
any issues of Shares within the authorised capital.”
4) Change of the date of the annual general meeting of the Shareholders of the Company so that it be held on June
12 at 2:00 p.m. Luxembourg time; consequential amendment of the second paragraph of article 15 of the articles of
association of the Company.
(II) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
(III) That the list of all the proxies of the represented shareholders as well as a shareholders declaration, initialled by
the bureau and the undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
(IV) That the present meeting has been convened by convening notices sent by mail to all holders of record and
published on 1
st
April 2011 and on 12
th
April 2011 in the Mémorial and the Luxemburger Wort as well as on 4
th
April
2011 in the elektronischer Bundesanzeiger.
(V) That out of the two hundred and twenty-five million three hundred and twenty-two thousand six hundred and
eighty-four (225,322,684) shares in issue in the Company, a total number of 125.299.675 shares are represented at the
meeting so that more than fifty percent (50%) of the issued share capital is represented at the meeting and the meeting
is duly quorated and constituted and able to validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved at the majorities (being 99,9856 % of all votes cast) set forth below as follows:
75171
L
U X E M B O U R G
(A) to reduce the issued share capital and to cancel any shares acquired (or to be acquired) by the Company after
January 21, 2011, pursuant to the buyback program of the Company announced on December 7, 2010, and to reduce
the relevant reserves constituted in relation thereto.
(B) to instruct and delegate power to and authorise the Board of Directors to implement the cancellation of such
shares and reductions of share capital and related matters in one or more instalments as deemed fit by the Board of
Directors, to cause the share capital reductions and cancellations of such shares and the consequential amendment of
the Articles of Incorporation to be recorded by way of notarial deeds, and generally to take any steps, actions or formalities
as appropriate or useful to implement this decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
FOR: 125.191.868
AGAINST: 18.089
ABSTENTION: 87.953
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved at the majorities (being 98,1485 % of all votes cast) set forth below as follows:
(A) to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount of seventy million six hundred thousand
Euro (€ 70,600,000) by the repurchase and cancellation of a maximum of fifty-six million four hundred and eighty thousand
(56,480,000) shares from existing shareholders during a period ending nine (9) months after the date of this Extraordinary
General Meeting of Shareholders within the parameters set forth below and to the extent determined by the Board of
Directors.
(B) to instruct and delegate power to and authorise the Board of Directors to determine the conditions of the purchase
(s) of shares, to implement the share purchases, cancellation of shares and reduction of share capital, to determine the
final amount of the share capital reduction and number of shares to be repurchased and cancelled (if any) within the
maximum decided by the present general meeting of shareholders, and to proceed to the payment of the repurchase
price, to cause the share capital reduction and cancellation of shares and the consequential amendment of the Articles
of Incorporation to be recorded by way of notarial deed, and generally to take any steps, actions or formalities as
appropriate or useful to implement the present decision of the general shareholders' meeting.
(C) to approve and authorise the following parameters of the decision to reduce the issued share capital of the
Company by the repurchase and cancellation of shares (to the extent determined by the Board of Directors):
- maximum amount of capital reduction: seventy million six hundred thousand Euro (€ 70,600,000);
- repurchase and cancellation of a maximum of fifty-six thousand four hundred and eighty thousand (56,480,000) shares;
- period: period ending on 21
st
January 2012 at midnight;
- purchase(s) of shares may be made in any manner including without limitation, by tender or other offer(s), buy back
program(s), over the stock exchange or in privately negotiated transactions or in any other manner as determined by the
Board of Directors including derivative transactions or transactions having the same or similar economic effect than an
acquisition, as determined by the Board of Directors;
- purchase price: as determined by the Board of Directors provided that in the case of acquisitions for value:
(i) in the case of acquisitions other than in the circumstances set forth under (ii), for a net purchase price being (x) no
less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each
case being the closing price on Xetra of the Frankfurt Stock Exchange (or successor system) (“Xetra”) over the ten (10)
trading days preceding the date of the purchase (or as the case may be the date of the commitment to the transaction);
(ii) in case of a tender offer (or if deemed appropriate by the Board of Directors, a buy back program),
a. in case of a formal offer being published, for a set net purchase price or a purchase price range, each time within
the following parameters: (x) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (y) no more than fifty per cent
above the highest stock price, in each case being the closing price on Xetra over the ten (10) trading days preceding the
publication date, provided however that if the stock exchange price during the offer period fluctuates by more than 10%,
the Board of Directors may adjust the offer price or range to such fluctuations;
b. in case of a public request for sell offers is made, a price range may be set (and revised by the Board of Directors
as deemed appropriate) provided that acquisitions may be made at a price which is (x) no less than fifty per cent of the
lowest stock price and (y) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case being the closing price
on Xetra over a period determined by the Board of Directors provided that such period may not start more than five
(5) trading days before the sell offer start date of the relevant offer and may not end after the last day of the relevant sell
offer period);
FOR: 122.813.953
AGAINST: 2.316.854
ABSTENTION: 87.953
<i>Third resolutioni>
The Meeting was presented the report by the Board of Directors pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg company
law on the circumstances and prices of issues of shares against cash without pre-emptive subscription rights (the “Re-
75172
L
U X E M B O U R G
port”). (A copy of such report initialled by the bureau and the undersigned notary shall be registered together with the
present deed.)
The Meeting resolved at the majorities (being 95,4869 % of all votes cast) set forth below as follows:
(A) to renew and extend the authorised unissued share capital within the Company and to set it at the amount of €
10,000,000,000, represented by 8,000,000,000 shares with a nominal value of one point twenty-five euro (€ 1.25) each;
(B) to acknowledge the Report and to waive, suppress and to authorise the Board of Directors to waive, suppress or
limit, any pre-emptive subscription rights in the case of issues of shares within the authorised share capital and to authorise
the Board of Directors to proceed to further securitisations and to issue shares (or any securities or rights giving rights
to shares) within the authorised share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available
premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the Board of Directors or its
delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public offerings of the shares of the Company and in
particular without limitation, the Board of Directors may issue shares in favour of directors, executives, employees,
consultants of the Company and the group to which it belongs, directly or under the terms of option, incentive or like
plans approved by the Board of Directors) while preserving, waiving, suppressing or limiting any pre-emptive subscription
rights of existing shareholders.
(C) that the new validity period of the authorised share capital of the Company shall start on the day of this Extraor-
dinary General Meeting of Shareholders recording the present authorisation and shall end on the fifth anniversary of the
day of publication of the deed recording the minutes of this general meeting in the Mémorial.
(D) to consequentially amend the second and third paragraphs of article 5 of the Articles of Association of the Company
so as to read as follows:
“The authorised un-issued capital of the Company is set at ten billion Euro (€10,000,000,000) to be represented by
eight billion Shares. The authorised and un-issued share capital shall be and the authorisation to issue Shares thereunder
is valid for a period starting on April 21, 2011, and ending five (5) years after the date of the publication of the minutes
of the extraordinary general meeting of Shareholders of the Company held on April 21, 2011, in the Mémorial (unless
amended or extended by the general meeting of shareholders).
The Board of Directors or delegate(s) duly appointed by the Board, may from time to time issue such Shares within
the authorised share capital at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board or its
delegate(s) may in its or their discretion resolve. In particular without limitation, the Board of Directors may issue shares
in favour of directors, executives, employees, consultants of the Company and the group to which it belongs, directly or
under the terms of option, incentive or like plans approved by the Board of Directors. The Board of Directors is autho-
rised to suppress, limit or waive any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent it deems advisable for
any issues of Shares within the authorised capital.”
FOR: 119.559.257
AGAINST: 5.650.800
ABSTENTION: 87.853
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved at the majorities (being 99,9655 % of all votes cast) set forth below as follows:
(A) to change the date of the annual general meeting of the Shareholders of the Company so that it be held on June
12 at 2:00 p.m. Luxembourg time and to consequentially amend the second paragraph of article 15 of the articles of
association of the Company so as to read as follows:
“The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or
at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting, on June 12 at 2:00 p.m. If such day is a
legal holiday in Luxembourg the annual general meeting shall be held on the next following business day”.
FOR: 125.162.172
AGAINST: 43.250
ABSTENTION:92.488
There being no further items on the agenda, the Meeting was closed.
<i>Expenses:i>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this deed are estimated at three thousand five hundred euro (3.500.-EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
75173
L
U X E M B O U R G
Follows the German Translation
Im Jahr zweitausendundelf, am einundzwanzigsten April. Vor uns, Maître Léonie Grethen, Notar, wohnhaft in Luxem-
burg (Luxemburg),
Fand eine außerordentliche Generalversammlung der „GAGFAH S.A.“ (die „Gesellschaft“) statt, eine Aktiengesell-
schaft -Verbriefungsgesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 109.526, gegründet am 12. Juli 2005
gemäß Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations („Mémorial“) vom 3. Dezember 2005, Nummer 1323 veröffentlicht wurde.
Die Gesellschaftssatzung wurde mehrere Male geändert, zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître Henri Hellinckx
am 21. Februar 2011, die noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn William Joseph Brennan, Direktor, wohnhaft in Lu-
xemburg Berufsadresse, welcher, Herrn Ralph Beyer, Anwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg zum Schriftführer
bestimmte.
Die Versammlung wählte, Simone Kassner, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in Deutschland, und Nicolai Kuss,
Diplom Kaufmann, wohnhaft in Deutschland, als Wahlprüfer.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den Notar, folgendes
zu beurkunden:
I. Zweck der Versammlung ist die Niederschrift der Beschlüsse, die auf Grundlage der folgenden Tagesordnung zu
fassen sind:
1) Beschluss das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft herabzusetzen und alle, unter dem am 7. Dezember 2010
bekanntgegebenen Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft, und nach dem 21. Januar 2011 zurückgekauften (oder noch
zurückzukaufenden) Aktien zu annullieren, und Herabsetzung der entsprechenden Rücklagen die diesbezüglich angelegt
wurden; Anweisung, Bevollmächtigung und Ermächtigung des Verwaltungsrates, die Annullierung dieser Aktien und die
Kapitalherabsetzung ebenso wie alle zugehörigen Angelegenheiten in einem oder mehreren Malen, wie vom Verwal-
tungsrat als angebracht befunden, durchzuführen, zu veranlassen, dass die Kapitalherabsetzungen und Annullierungen
dieser Aktien und die sich daraus ergebende Änderung der Gesellschaftssatzung durch notarielle Urkunde festgehalten
werden, und im Allgemeinen alle Schritte, Handlungen und Formalitäten vorzunehmen, die angemessen oder notwendig
sind, um diesen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre auszuführen.
2) Beschluss, das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Höchstbetrag von €70.600.000 zu verringern
durch Rückkauf und Annullierung einer Höchstzahl von 56.480.000 Aktien von vorhandenen Aktionären, während eines
Zeitraumes, der neun (9) Monate nach dem Datum der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre endet,
innerhalb der nachfolgenden Parameter und im vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang, Anweisung, Bevollmächtigung
und Ermächtigung des Verwaltungsrates, die Bedingungen des/der Aktienrückkaufs/käufe festzulegen, die Aktienrückkäufe,
die Annullierung der Aktien sowie die Kapitalherabsetzung auszuführen, den Endbetrag der Kapitalherabsetzung und die
Anzahl der zurückzukaufenden und zu annullierenden Aktien (falls vorhanden) innerhalb der von der Generalversammlung
der Aktionäre beschlossenen Höchstzahl festzulegen, den Rückkaufpreis zu bezahlen und zu bewirken, dass die Kapital-
herabsetzung und die Annullierung der Aktien und die sich daraus ergebende Änderung der Gesellschaftssatzung durch
notarielle Urkunde festgehalten werden, und im Allgemeinen alle Schritte, Handlungen und Formalitäten vorzunehmen,
die angemessen und notwendig sind, um diesen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre auszuführen.
Parameter der Entscheidung zur Kapitalherabsetzung der Gesellschaft durch Aktienrückkauf und -annullierung (in dem
vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang):
- Höchstbetrag der Kapitalherabsetzung: €70.600.000;
- Rückkauf und Annullierung bis zu höchstens 56.480.000 Aktien;
- Zeitraum: Frist endend am 21. Januar 2012 um Mitternacht;
- Aktienrückkauf/käufe können auf jegliche Weise erfolgen, einschließlich, ohne Beschränkung, mittels befristeter Ak-
tienkaufangebote oder anderweitiger Offerte(n), Rückkaufprogrammen, über eine Wertpapierbörse oder durch freihän-
digen Verkauf oder auf jede durch den Verwaltungsrat, festgelegte Weise, einschließlich Derivatgeschäfte oder Geschäfte,
die die gleiche oder ähnliche wirtschaftliche Wirkung wie ein Erwerb haben, wie vom Verwaltungsrat festgelegt;
- Kaufpreis: in der vom Verwaltungsrat bestimmten Höhe, vorausgesetzt dass im Falle eines Erwerbes (acquisition for
value):
(i) im Falle eines Erwerbes der nicht unter die unter (ii) dargelegten Sachverhalte fällt, in Höhe eines Nettokaufpreises,
der (x) nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher als fünfzig
Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra der Frankfurter Börse
(oder eines Nachfolgesystems) ("Xetra"), über zehn (10) dem Kaufdatum (oder gegebenenfalls dem Datum der Ver-
pflichtung zum Geschäftsabschluss) vorangehenden Börsentagen, entspricht;
(ii) im Falle eines befristeten Aktienkaufangebotes (oder, wenn vom Verwaltungsrat als angebracht befunden, eines
Rückkaufprogrammes);
75174
L
U X E M B O U R G
a. im Falle der Bekanntgabe eines offiziellen Angebotes, zu einem festgelegten Nettokaufpreis, oder innerhalb einer
Kaufpreisspanne, jedes Mal innerhalb der folgenden Parameter: (x) nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten
Aktienkurses und (y) nicht höher als fünfzig Prozent über dem höchsten Aktienkurs, in jedem Falle dem Schlusskurs des
Xetra über die zehn (10) dem Datum der Bekanntgabe vorangehenden Börsentage entsprechend, vorausgesetzt jedoch
dass, wenn der Börsenkurs innerhalb des Zeitraumes des Angebotes um mehr als zehn Prozent (10%) schwankt, der
Verwaltungsrat den angebotenen Preis oder die angebotene Preisspanne den Schwankungen anpassen kann;
b. im Falle einer öffentlichen Anfrage nach einem Verkaufsangebot, kann eine Preisspanne festgelegt (und vom Ver-
waltungsrat, wenn dieser es für angebracht befindet, überarbeitet) werden, vorausgesetzt dass der Erwerb zu einem Preis
erfolgen kann, (x) der nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher
als fünfzig Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra über eine
vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitspanne entspricht, vorausgesetzt dass jener Zeitraum nicht früher als fünf (5) Bör-
sentage vor dem Datum des Beginns des Verkaufangebotes beginnen und nicht nach dem letzten Tag des relevanten
Verkaufsangebotszeitraums enden darf.
3) Erneuerung und Erweiterung des genehmigten, nicht ausgegebenen Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag
von €10.000.000.000, aufgeteilt in 8.000.000.000 Aktien mit einem Nennwert von jeweils eins Komma fünfundzwanzig
Euro (€1,25), Kenntnisnahme des Berichtes gemäß Artikel 32-3 (5) des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesell-
schaften über die Umstände und Preise der Aktienausgabe gegen Bargeldzahlung ohne Vorzugszeichnungsrechte, Verzicht
auf, Unterdrückung und Ermächtigung des Verwaltungsrates jegliche Vorzugszeichnungsrechte im Falle von Aktienausga-
ben innerhalb des genehmigten Stammkapitals, zu unterdrücken, zu begrenzen oder darauf zu verzichten, Ermächtigung
des Verwaltungsrates weitere Verbriefungen durchzuführen und Aktien auszugeben (oder andere Wertpapiere oder
Rechte die Anrecht auf Aktien geben) innerhalb des genehmigten Stammkapitals gegen Bargeldzahlung, gegen Sacheinlage
oder gegen Einbringung des verfügbaren Agios oder der Rücklage oder anderweitig nach den vom Verwaltungsrat oder
seinem(n) Delegierten festgelegten Bedingungen (einschließlich, ohne Beschränkung, im Zusammenhang mit einem oder
mehreren öffentlichen Zeichnungsangeboten der Aktien der Gesellschaft und insbesondere, ohne Beschränkung, kann
der Verwaltungsrat Aktien ausgeben zu Gunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Angestellten,
Beratern der Gesellschaft und der Gruppe, der sie zugehört, direkt oder unter den Bedingungen eines vom Verwaltungsrat
gebilligten Bezugsrechtsplanes, während jegliche Vorzugszeichnungsrechte der bestehenden Aktionäre gewahrt, darauf
verzichtet, unterdrückt oder begrenzt werden, Festlegung der Gültigkeitsdauer des genehmigten Stammkapitals der Ge-
sellschaft beginnend am Tag der außerordentlichen Aktionärsversammlung welche die gegenwärtige Ermächtigung
beurkundet, und endend am fünften Jahrestag des Tages der Veröffentlichung der Urkunde im Mémorial welche das
Protokoll der besagten Aktionärsversammlung beurkundet; daraus folgende Abänderung des zweiten und dritten Absatzes
von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt:
„Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf zehn Milliarden Euro (€ 10.000.000.000)
festgesetzt, aufgeteilt in acht Milliarden (8.000.000.000) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und
die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 21. April 2011 und endend
fünf (5) Jahre nach dem Datum der Veröffentlichung des Protokolls der außerordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaftsaktionäre vom 21. April 2011 im Mémorial (außer wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der
Aktionäre abgeändert oder verlängert wird).
Der Verwaltungsrat oder der/die ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat ernannte(n) Delegierte(n) können von Zeit zu
Zeit innerhalb des genehmigten Kapitals Aktien zu den Zeiten und zu den Bedingungen ausgeben, wie diese vom Ver-
waltungsrat oder seines/seiner Delegierten in deren Ermessen beschlossen wurde. Insbesondere, ohne Einschränkung,
kann der Verwaltungsrat Aktien zugunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Angestellten, Bera-
tern der Gesellschaft und der Gruppe, zu der sie gehört, direkt oder unter den Bedingungen eines vom Verwaltungsrat
gebilligten Bezugsrechtsplanes ausgeben. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedes Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre zu
unterdrücken, begrenzen oder auszuschlagen bis zu dem Punkt, der als ratsam gilt hinsichtlich der Ausgabe von Aktien
innerhalb des genehmigten Kapitals. Der Verwaltungsrat oder der/die ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat ernannte(n)
Delegierte(n) ist/sind autorisiert, jegliche Vorzugsrechte der Aktionäre zu unterdrücken, zu begrenzen oder darauf zu
verzichten bis zu dem Ausmaß, sofern er es für eine Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals als zweck-
mäßig erachtet.“
4) Änderung des Datums der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, so dass sie am 12. Juni
um 14:00 Uhr luxemburgische Zeit abgehalten wird; daraus folgende Abänderung des zweiten Absatzes von Artikel 15
der Gesellschaftssatzung.
(II) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand
einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleibt vorliegender Urkunde beigefügt, um mit
derselben zur Registrierung eingereicht zu werden.
(III) Die vom Versammlungsbüro und dem Notar paraphierte Liste aller Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie
eine Aktionärserklärung bleiben vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser zur gleichen Zeit zur Registrierung ein-
gereicht zu werden.
75175
L
U X E M B O U R G
(IV) Die vorliegende Versammlung ist durch Einberufungsbenachrichtigung einberufen worden, die mittels Brief an alle
Eingetragenen geschickt worden ist und am 1. April 2011 und am 12. April 2011 im Mémorial und im Luxemburger Wort,
sowie am 4. April 2011 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.
(V) Von den zweihundertfünfundzwanzig Millionen dreihundertzweiundzwanzig Tausend sechshundertvierundachtzig
(225,322,684) ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, ist eine Gesamtzahl von 125.299.675 Aktien bei dieser Versammlung
vertreten so dass mehr als fünfzig Prozent (50%) des ausgegebenen Stammkapitals bei dieser Versammlung vertreten sind
und die Versammlung ordnungsgemäß einberufen und zusammengetreten ist und rechtsgültig über alle Tagesordnungs-
punkte beraten kann.
Daraufhin hat die Generalversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung hat mit den nachstehend dargelegten Mehrheiten (99.9856 % aller abgegebenen Stimmen) wie folgt
beschlossen:
(A) das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft herabzusetzen und alle, unter dem am 7. Dezember 2010 be-
kanntgegebenen Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft, und nach dem 21. Januar 2011 zurückgekauften (oder noch
zurückzukaufenden) Aktien zu annullieren, und die entsprechenden Rücklagen die diesbezüglich angelegt wurden herab-
zusetzen.
(B) den Verwaltungsrat anzuweisen, zu bevollmächtigen und zu ermächtigen, die Annullierung dieser Aktien und die
Kapitalherabsetzung ebenso wie alle zugehörigen Angelegenheiten in einem oder mehreren Malen, wie vom Verwal-
tungsrat als angebracht befunden, durchzuführen, und zu veranlassen, dass die Kapitalherabsetzungen und Annullierungen
dieser Aktien und die sich daraus ergebende Änderung der Gesellschaftssatzung durch notarielle Urkunde festgehalten
werden, und im Allgemeinen alle Schritte, Handlungen und Formalitäten vorzunehmen, die angemessen oder notwendig
sind, um diesen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre auszuführen.
DAFÜR: 125.191.868
DAGEGEN: 18.089
ENTHALTUNG: 87.953
ZWEITER BESCHLUSS
Die Versammlung hat mit den nachstehend dargelegten Mehrheiten (98,1485 % aller abgegebenen Stimmen) wie folgt
beschlossen:
(A) das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Höchstbetrag von siebzig Millionen sechshundert Tausend
Euro (€70.600.000) zu verringern durch Rückkauf und Annullierung einer Höchstzahl von sechsundfünfzig Millionen vier-
hundertachtzig Tausend (56.480.000) Aktien von vorhandenen Aktionären, während eines Zeitraumes, der neun (9)
Monate nach dem Datum der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre endet, innerhalb der nachfolgenden
Parameter und in dem vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang.
(B) den Verwaltungsrat anzuweisen, ihm die Vollmacht zu erteilen und ihn zu ermächtigen, die Bedingungen des/der
Aktienrückkaufs/käufe festzulegen, die Aktienrückkäufe, die Annullierung der Aktien sowie die Kapitalherabsetzung aus-
zuführen, den Endbetrag der Kapitalherabsetzung und die Anzahl der zurückzukaufenden und zu annullierenden Aktien
(falls vorhanden) innerhalb der von der jetzigen Generalversammlung der Aktionäre beschlossenen Höchstzahl festzule-
gen, und den Rückkaufpreis zu bezahlen, zu bewirken, dass die Kapitalherabsetzung und die Annullierung der Aktien und
die sich daraus ergebende Änderung der Gesellschaftssatzung durch notarielle Urkunde festgehalten werden, und ihn im
Allgemeinen alle Schritte, Handlungen und Formalitäten vorzunehmen, die angemessen und notwendig sind, um diesen
Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre auszuführen.
(C) die folgenden Parameter der Entscheidung zur Kapitalherabsetzung der Gesellschaft durch Aktienrückkauf und -
annullierung (in dem vom Verwaltungsrat festgelegten Umfang) zu genehmigen und zu bewilligen:
- Höchstbetrag der Kapitalherabsetzung: siebzig Millionen sechshundert Tausend Euro (€70.600.000);
- Rückkauf und Annullierung bis zu höchstens sechsundfünfzig Millionen vierhundertachtzig Tausend (56.480.000) Ak-
tien;
- Zeitraum: Frist endend am 21. Januar 2012 um Mitternacht;
- Aktienrückkauf/käufe können auf jegliche Weise erfolgen, einschließlich, ohne Beschränkung, mittels befristeter Ak-
tienkaufangebote oder anderweitiger Offerte(n), Rückkaufprogrammen, über eine Wertpapierbörse oder durch freihän-
digen Verkauf oder auf jede durch den Verwaltungsrat, festgelegte Weise, einschließlich Derivatgeschäfte oder Geschäfte,
die die gleiche oder ähnliche wirtschaftliche Wirkung wie ein Erwerb haben, wie vom Verwaltungsrat festgelegt;
- Kaufpreis: in der vom Verwaltungsrat bestimmten Höhe, vorausgesetzt dass im Falle eines Erwerbes (acquisition for
value):
(i) im Falle eines Erwerbes der nicht unter die unter (ii) dargelegten Sachverhalte fällt, in Höhe eines Nettokaufpreises,
der (x) nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher als fünfzig
Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra der Frankfurter Börse
(oder eines Nachfolgesystems) ("Xetra"), über zehn (10) dem Kaufdatum (oder gegebenenfalls dem Datum der Ver-
pflichtung zum Geschäftsabschluss) vorangehenden Börsentage, entspricht;
75176
L
U X E M B O U R G
(ii) im Falle eines befristeten Aktienkaufangebotes (oder, wenn vom Verwaltungsrat als angebracht befunden, eines
Rückkaufprogrammes);
a. im Falle der Bekanntgabe eines offiziellen Angebotes, zu einem festgelegten Nettokaufpreis, oder innerhalb einer
Kaufpreisspanne, jedes Mal innerhalb der folgenden Parameter: (x) nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten
Aktenkurses und (y) nicht höher als fünfzig Prozent über dem höchsten Aktienkurs, in jedem Falle dem Schlusskurs des
Xetra über die zehn (10) dem Datum der Bekanntgabe vorangehenden Börsentage entsprechend, vorausgesetzt jedoch
dass, wenn der Börsenkurs innerhalb des Zeitraumes des Angebotes um mehr als zehn Prozent (10%) schwankt, der
Verwaltungsrat den angebotenen Preis oder die angebotene Preisspanne den Schwankungen anpassen kann;
b. im Falle einer öffentlichen Anfrage nach einem Verkaufsangebot, kann eine Preisspanne festgelegt (und vom Ver-
waltungsrat, wenn dieser es für angebracht befindet, überarbeitet) werden, vorausgesetzt dass der Erwerb zu einem Preis
erfolgen kann, (x) der nicht weniger als fünfzig Prozent (50%) des niedrigsten Aktienkurses entspricht, und (y) nicht höher
als fünfzig Prozent (50%) über dem höchsten Aktienkurs liegt, in jedem Falle aber dem Schlusskurs des Xetra über eine
vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitspanne entspricht, vorausgesetzt dass jener Zeitraum nicht früher als fünf (5) Bör-
sentage vor dem Datum des Beginns des Verkaufangebotes beginnen und nicht nach dem letzten Tag des relevanten
Verkaufsangebotszeitraums enden darf.
DAFÜR: 122.813.953
DAGEGEN: 2.316.854
ENTHALTUNG: 87.953
<i>Dritter Beschlussi>
Der Bericht des Verwaltungsrates gemäß Artikel 32-3 (5) des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften
über die Umstände und Preise der Aktienausgabe gegen Bargeldzahlung ohne Vorzugsrechte (der „Bericht“), wurde der
Versammlung vorgetragen. (Eine Kopie des Berichtes, paraphiert von den Mitgliedern des Versammlungsbüros und vom
unterzeichneten Notar, wird zusammen mit dieser Urkunde einregistriert werden.)
Die Versammlung hat mit den nachstehend dargelegten Mehrheiten (95,4869 % aller abgegebenen Stimmen) wie folgt
beschlossen:
(A) das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von zehn Milliarden Euro
(€10.000.000.000), aufgeteilt in acht Milliarden (8.000.000.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils eins Komma
fünfundzwanzig Euro (€1,25) zu erneuern und erweitern;
(B) den Bericht zu bestätigen und auf jegliche Vorzugszeichnungsrechte zu verzichten und auszuschlagen und den
Verwaltungsrat zu ermächtigen jegliche Vorzugszeichnungsrechte im Falle von Aktienausgaben innerhalb des genehmigten
Stammkapitals, zu unterdrücken, begrenzen oder auszuschlagen, und den Verwaltungsrat zu ermächtigen weitere Ver-
briefungen durchzuführen und Aktien auszugeben (oder andere Wertpapiere oder Rechte die Anrecht auf Aktien geben)
innerhalb des genehmigten Stammkapitals gegen Bargeldzahlung, gegen Sacheinlage oder gegen Einbringung des verfüg-
baren Agios oder der Rücklage oder anderweitig laut den vom Verwaltungsrat oder seinem(n) Delegierten festgelegten
Bedingungen (einschließlich, ohne Beschränkung, im Zusammenhang mit einem oder mehreren öffentlichen Zeichnungs-
angeboten der Aktien der Gesellschaft und insbesondere, ohne Beschränkung, kann der Verwaltungsrat Aktien ausgeben
zu Gunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Angestellten, Beratern der Gesellschaft und der
Gruppe, der sie zugehört, direkt oder unter den Bedingungen eines vom Verwaltungsrat gebilligten Bezugsrechtsplanes),
während jegliche Vorzugszeichnungsrechte der Altgesellschafter gewahrt, unterdrückt, begrenzt oder ausgeschlagen
werden;
(C) dass die neue Gültigkeitsdauer des genehmigten Stammkapitals der Gesellschaft am Tag der außerordentlichen
Aktionärsversammlung welche die gegenwärtige Ermächtigung beurkundet, beginnen wird, und am fünften Jahrestag des
Tages der Veröffentlichung der Urkunde im Mémorial welche das Protokoll der besagten Aktionärsversammlung beur-
kundet, enden wird;
(D) folglich, den zweiten und dritten Absatz von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:
„Das genehmigte, nicht ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft wird auf zehn Milliarden Euro (€ 10.000.000.000)
festgesetzt, aufgeteilt in acht Milliarden (8.000.000.000) Aktien. Das genehmigte und nicht ausgegebene Stammkapital und
die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 21. April 2011 und endend
fünf (5) Jahre nach dem Datum der Veröffentlichung des Protokolls der außerordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaftsaktionäre vom 21. April 2011 im Mémorial (außer wenn dieser Zeitraum von der Generalversammlung der
Aktionäre abgeändert oder verlängert wird).
Der Verwaltungsrat oder der/die ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat ernannte(n) Delegierte(n) können von Zeit zu
Zeit innerhalb des genehmigten Kapitals Aktien zu den Zeiten und zu den Bedingungen ausgeben, wie diese vom Ver-
waltungsrat oder seines/seiner Delegierten in deren Ermessen beschlossen wurde. Insbesondere, ohne Einschränkung,
kann der Verwaltungsrat Aktien zugunsten von Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Angestellten, Bera-
tern der Gesellschaft und der Gruppe, zu der sie gehört, direkt oder unter den Bedingungen eines vom Verwaltungsrat
gebilligten Bezugsrechtsplanes ausgeben. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedes Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre zu
unterdrücken, begrenzen oder auszuschlagen bis zu dem Punkt, der als ratsam gilt hinsichtlich der Ausgabe von Aktien
innerhalb des genehmigten Kapitals. Der Verwaltungsrat oder der/die ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat ernannte(n)
75177
L
U X E M B O U R G
Delegierte(n) ist/sind autorisiert, jegliche Vorzugsrechte der Aktionäre zu unterdrücken, zu begrenzen oder darauf zu
verzichten, sofern er es für die Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals als zweckmäßig erachtet.“
DAFÜR: 119.559.257
DAGEGEN: 5.650.800
ENTHALTUNG: 87.853
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung hat mit den nachstehend dargelegten Mehrheiten (99,9655 % aller abgegebenen Stimmen) wie folgt
beschlossen:
(A) das Datum der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft zu ändern, so dass die jährliche
Generalversammlung am 12. Juni um 14:00 Uhr luxemburgische Zeit abgehalten wird; und
(B) folglich, den zweiten Absatz von Artikel 15 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern: „Die jährliche Haupt-
versammlung der Aktionäre soll am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg stattfinden oder an einem solchen anderen Ort,
der in der Einberufungsbekanntmachung der Versammlung, am 12. Juni um 14 Uhr festgelegt wird. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag in Luxemburg, soll die jährliche Hauptversammlung an dem darauf folgenden Werktag stattfinden.“
DAFÜR: 125.162.172
DAGEGEN: 43.250
ENTHALTUNG: 92.488
Nachdem kein weiterer Punkt auf der Tageordnung stand, wurde die Versammlung geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten jeglicher Form, die von der Gesellschaft getragen werden, werden auf
ungefähr drei tausend fünf hundert Euro (3.500.-EUR) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde,
auf Ersuchen der erschienenen Partei, in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf
Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Daraufhin wurde vorgenannte Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, Ausgefertigt in Luxemburg am vorgenannten Tag.
Die Urkunde wurde den erschienenen Personen vorgelesen und die vorliegende Originalurkunde ist zusammen mit
uns, dem Notar, unterzeichnet worden.
Signé: Brennan, Beyer, Kassner, Kuss,GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2011. Relation: LAC/2011/18772. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 26 avril 2011.
Référence de publication: 2011057124/496.
(110064418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.
ERE HGP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 160.417.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eleventh of April.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain
depositary of the present original deed.
There appeared:
1. “Europa Real Estate II S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and
having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
here represented by Mr Eric BIREN, manager, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, acting in his capacity as manager with individual signing power.
2. “Europa Real Estate II US S.à r.l.”, a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established
and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
here represented by Mr Eric BIREN, previously named, acting in his capacity as manager with individual signing power.
75178
L
U X E M B O U R G
The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is herewith established as follows:
Art. 1. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated August 10, 1915 on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Arti-
cles”), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.
The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of wha-
tever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to grant to other group companies or third parties loans, guarantees,
and to perform any operation which is directly related to its purpose.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial,
financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and deve-
lopment of its objects.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of memberships or similar corporate structures.
The Company may borrow money in any form and secure or discharge any debt or obligation of or binding on the
Company or any of its direct or indirect subsidiaries, or any company being a direct or indirect Partner of the Company,
or any company belonging to the same group as the Company in such manner as may be thought fit and in particular by
mortgages and charges upon all or any part of the undertaking, property, and assets (present or future), or by the creation
and the issue of bonds or other securities of any description.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “ERE HGP S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12'500.-) divided into:
- eleven thousand two hundred and fifty (11,250) class A shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, entirely
paid up (the “A Shares”), and
- one thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, entirely paid
up (the “B Shares”, and together with the A Shares, the “Shares”).
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Partner(s), to offset any net realized losses, to make distributions
to the Partner(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners meeting,
in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share gives its holder the right to one (1) vote and the right to attend any partners' meeting of the Company.
In case of distributions (including, without limitation, any liquidation distribution), the holder(s) of the A Shares shall
be entitled to receive 95.33332167% of the Company's assets, profits and other distributable reserves, while the holder
(s) of the B Shares will be entitled to receive the remaining 4.66667833%.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the sole Partner
or of the partners, as the case may be.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
75179
L
U X E M B O U R G
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vicechairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of managers
or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and allowing the
identification. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex, facsimile or e-mail, or any other similar means of communication. A written decision signed by
all the managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which
was duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partners' meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of shares
which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly
taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning
at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year. 31
st
Art. 16. Each year, with reference to of December, the Company's accounts are established and the manager, or in
case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted
to one or more auditors who need not be partners.
The auditors, if any, will be elected, as the case may be, by the sole partner or by the general partners' meeting, which
will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their
successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole partner or by the general partners' meeting, as the case may be.
75180
L
U X E M B O U R G
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
Art. 19. Subject to and in accordance with article eighteen, the board of managers is authorized to proceed, as often
as it deems appropriate and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends, subject
only to three (3) conditions: a) the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the
basis of interim accounts; b) the date of the interim accounts may not be older than two (2) months at the date of the
relevant board meeting; and c) the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficient distributable
profits exist.
For the purposes of this article nineteen, distributable profits are equal to the net profit realised since the end of the
last financial year, plus any profits carried forward and sums drawn down from reserves available for distributions, less
losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory measurei>
The first financial year begins at the date of the incorporation and shall finish at December 31, 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
All twelve thousand five hundred (12,500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
Partners
Subscribed
capital
Number of
shares
1. Europa Real Estate II S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,250.-EUR 11,250 class A
2. Europa Real Estate II US S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,250.-EUR 1,250 class B
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.-EUR
12,500
The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares having verified that the conditions set forth in Article 183 of the
Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately upon incorporation of the Company, the above named parties, representing the entire subscribed capital,
considering themselves as fully convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have
unanimously passed the following resolutions:
1.- The registered office of the Company is fixed at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2.- The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
a) Mr Vincent GOY, company director, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric BIREN, chartered accountant, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter CLUFF, company director, professionally residing at 132, Sloane Street, London SW1X 9AX.
3.- The Board of Managers is authorised to delegate the daily management of the business of the Company to one or
more of its managers.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
75181
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le onze avril.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A COMPARU:
1. «Europa Real Estate II S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
représentée par Monsieur Eric Biren, gérant, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant avec pouvoir de signature individuelle.
2. “Europa Real Estate II US S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse,
représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé, agissant en sa qualité de gérant avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. L'objet social de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de va-
leurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement, accorder à d'autres sociétés du groupe ou à des tiers des prêts, des garanties et effectuer toute
opération qui est directement liée à son objet social.
Plus généralement, la Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération, incluant, sans limitation, des
transactions commerciales, financières mobilières et immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement
et au développement de son objet social.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.
La Société pourra emprunter des sommes d'argent, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'octroyer des garanties
pour la décharge de toutes dettes ou obligations de la Société ou toute filiale directe ou indirecte, ou toute société étant
un associé direct ou indirect de la Société, ou toute société du même groupe, de toute autre manière appropriée, en
particulier par des hypothèques et sûretés mobilières sur tout ou partie de l'entreprise, de la propriété et des actifs
(présents ou futurs), ou par la création et l'émission d'obligations ou autres valeurs mobilières.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination «ERE HGP S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR), divisé en:
- onze mille deux cent cinquante (11,250) parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR) chacune,
entièrement libérées (les «Parts A»), et
- mille deux cent cinquante (1,250) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (1,-EUR) chacune,
entièrement libérées (les «Parts B», et ensemble avec les Parts A, les «parts sociales»).
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés ou de l'associé unique selon le cas, par la Société, pour
75182
L
U X E M B O U R G
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou à l'associé unique selon le cas,
ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale confère à son propriétaire le droit à un (1) vote et à participer à toute assemblée générale
d'associés de la Société.
En cas de distributions (y compris, sans limitation, toute distribution dans le cadre d'une procédure de liquidation), le
(s) détenteur(s) des Parts A auront droit à 95,33332167% de l'actif, des profits et de toute autre réserve distribuable de
la Société, tandis que le(s) détenteur(s) des Parts B auront droit aux 4,66667833% restants.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle de l'un des gérants.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres permettant leur identification. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courrier électronique ou tout autre
moyen de communication similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si
elle a été adoptée à la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être
75183
L
U X E M B O U R G
rédigée en un seul document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du
conseil de gérance.
Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé
(s) ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, sera (seront) nommé(s), selon le cas, par décision de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et
ils resteront en fonction jusqu'à ce que leur(s) successeur(s) soi(en)t élu(s). Il(s) est (sont) rééligible(s) et il(s) peu(ven)t
être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, selon le cas, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés.
Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Art. 19. En conformité avec l'article dix-huit, le conseil de gérance est autorisé à procéder, aussi souvent qu'il le
considère approprié et à tout moment pendant l'année sociale, au paiement de dividendes intérimaires, en respectant
trois (3) conditions: a) le conseil de gérance pourra seulement prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires
sur la base des comptes intérimaires; b) les comptes intérimaires ne pourront pas être datés de plus de deux (2) mois à
la date de la réunion du conseil; et c) les comptes intérimaires, qui peuvent ne pas être audités, doivent prouver que des
bénéfices distribuables suffisants existent.
Pour les besoins de cet article dix-neuf, les bénéfices distribuables sont égaux au bénéfice net réalisé depuis la fin du
dernier exercice social, plus tous bénéfices reportés et réserves distribuables, moins les pertes reportées et toutes les
sommes à placer en réserve conformément aux dispositions de la Loi ou aux Statuts.
Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
<i>Souscription – Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire
comme suit:
Associés
Capital souscrit
Nombre
d'actions
1. Europa Real Estate II S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,250.-EUR 11,250 class A
2. Europa Real Estate II US S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,250.-EUR 1,250 class B
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-EUR
12,500
La somme de douze mille cinq cents euros (12,500.- EUR) se trouve dés maintenant à la disposition de la Société, la
preuve en ayant été rapporté au notaire soussignée.
<i>Attestationi>
Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183
de la Loi sont remplies et le constate expressément.
75184
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les parties prénommées, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée et se considérant dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et de prendre à l'unanimité les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est établi au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Vincent GOY, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg;
b) Monsieur Eric BIREN, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg;
c) Monsieur Peter CLUFF, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 132, Sloane Street, Londres
SW1X 9AX.
3) Le Conseil de Gérance est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société à un ou plusieurs
gérants.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française, et qu'à la demande des même comparants, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par
son nom, prénom usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. BIREN, C. WERSANDT.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 avril 2011. Relation: EAC/2011/5186. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M.-N. KIRCHEN.
Référence de publication: 2011056758/368.
(110064106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.
Proim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.691.
L'an deux mil onze, le quatre mai.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée PROIM S.A.,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la
Section B et le numéro 112.691,
constituée suite à un acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire alors notaire de résidence à Niederanven, en
date du 12 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 500 du 9 mars 2006, et dont
les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis,
avec un capital social souscrit de cent mille euros (100.000.-EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale
de cent euros (100.-EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Davide MURARI, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. L'Actionnaire unique représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions détenues par ce dernier ont été portés
sur une liste de présence signée par le mandataire de celui-ci, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du
bureau, les membres de l'Assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, ensemble
avec la procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente Assemblée.
Que les mille (1.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente
Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l'ordre du jour.
II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
75185
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1. PRÉSENTATION:
A: du projet de fusion sous seing privé du 29 décembre 2010, prévoyant l'absorption de notre société par la société
anonyme de droit luxembourgeois dénommée LIBELLE S.A., ayant son siège social à L2227 Luxembourg, 18, Avenue de
la Porte Neuve, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 75.201 (ci-après nommée «la société
absorbante»),
la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement
et passivement sans exception ni réserve de notre société à la société absorbante, ledit projet de fusion annexé à la
convocation ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 206 du 2 février 2011, con-
formément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée;
B: des rapports écrits des Conseils d'administration des sociétés fusionnantes, datés du 29 décembre 2010, expliquant
et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange.
2. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
3. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la société
absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion, et plus particulièrement à ce sujet, en échange du transfert de
la totalité des actifs et passifs de la notre société à la société absorbante, sans exception ni réserve.
Il y aura lieu de procéder à une augmentation du capital de la société absorbante d'un montant de un million six cent
quarante mille sept cent soixante euros (1.640.760.-EUR),
pour le porter de son montant actuel de sept cent trente-cinq mille euros (735.000.-EUR) à deux millions trois cent
soixante-quinze mille sept cent soixante euros (2.375.760.-EUR),
par l'émission de cent soixante-quatre mille soixante-seize (164.076) actions nouvelles de dix euros (10.-EUR) chacune,
et l'article 5 des statuts de la société absorbante sera en conséquence mis en concordance avec l'augmentation de
capital.
4. Renonciation d'une façon expresse, de l'accord unanime de tous les Actionnaires, à un examen du projet commun
de fusion par des experts indépendants et au rapport d'expert, le tout en application de l'article 266 (5) de la Loi.
5. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de notre Société pour l'exécution de leurs mandats
respectifs.
6. Détermination du lieu de conservation pendant le délai légal des documents sociaux de notre Société.
Le tout sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la réalisation de cette fusion aux
conditions prévues par le dit projet de fusion, c.à.d. à la date de la dernière Assemblée générale de la société absorbante,
adoptant la fusion, et l'attribution aux Actionnaires de notre Société, d'actions de la société absorbante dans le rapport
d'échange de cent soixante-quatre virgule zéro soixante-seize (164,076) actions nouvelles de la société absorbante pour
une (1) action de la société absorbée, sans aucune soulte.
7. Divers.
L'Assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a
abordé l'ordre du jour. Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée constate que le Conseil d'administration lui a présenté:
A: le projet de fusion sous seing privé du 29 décembre 2010, prévoyant l'absorption de notre société par la société
anonyme de droit luxembourgeois dénommée LIBELLE S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 18, Avenue de
la Porte Neuve, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 75.201 (ci après nommée «la société
absorbante»),
la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement
et passivement sans exception ni réserve de notre société à la société absorbante, ledit projet de fusion annexé à la
convocation ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 206 du 2 février 2011, con-
formément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la Loi),
et dont une copie reste annexée, après signature "ne varietur" par les comparants et le notaire soussigné, au présent
acte.
B: des rapports écrits des Conseils d'administration des sociétés fusionnantes, datés du 29 décembre 2010, expliquant
et justifiant du point de vue juridique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange.
Ces rapports, après signature "ne varietur" par les comparants et le notaire, resteront annexés au présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi,
ont été tenus à la disposition des Actionnaires au siège social de notre Société.
75186
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée approuve le projet de fusion du 29 décembre 2010 et décide de réaliser la fusion par absorption de notre
Société par la société absorbante aux conditions prévues par le projet de fusion,
notamment par l'échange de toutes les actions de notre Société contre des actions nouvelles de la société absorbante
dans le rapport d'échange de une (1) action de notre société pour cent soixante-quatre virgule zéro soixante-seize
(164,076) actions de la société absorbante, sans soulte, par le transfert de tous les actifs et passifs de notre Société à la
société absorbante, et dissolution sans liquidation de notre Société comme suite de la fusion.
Du point de vue comptable, les opérations et tous les bénéfices ou pertes réalisés par la société absorbée sont con-
sidérées comme accomplies pour compte de la société absorbante, à partir du 1
er
juillet 2010.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte que l'actionnaire unique a renoncé à l'examen du projet commun de fusion par des experts
indépendants et au rapport d'expert, le tout en application de l'article 266 (5) de la Loi.
En conformité avec l'article 271 de la Loi, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la
légalité des actes et formalités exécutés par la Société en relation avec la fusion, comme suit:
1) le Projet de Fusion contient toutes les indications prescrites par l'article 261 de la Loi et a été publié au moins un
mois avant la présente date;
2) les rapports du Conseil d'administration des sociétés fusionnantes remplissent les conditions de l'article 265 de la
Loi;
3) la certification de la Société absorbée que tous les documents requis ont été tenus à la disposition des Actionnaires
en conformité avec l'article 267 de la Loi au siège social de la société absorbée au moins un mois avant la date de cette
Assemblée;
4) la renonciation par l'actionnaire unique, en application de l'article 266(5) de la Loi, d'une façon expresse à un examen
du projet commun de fusion par des experts indépendants et au rapport d'expert suivant procuration.
Du point de vue comptable, les opérations et tous les bénéfices ou pertes réalisés par la société absorbée sont con-
sidérées comme accomplies pour compte de la société absorbante, à partir du 1
er
juillet 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée constate que suite à la présente fusion, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
est venu à échéance, et elle remercie tous les administrateurs pour leur dévouement et leur professionnalisme tout au
long de ces années et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de conserver, pendant le délai de 5 ans, les documents sociaux de la Société, au siège de la société
absorbante.
<i>Condition suspensivei>
Les présentes résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la
réalisation de cette fusion aux conditions prévues par le dit projet de fusion par l'Assemblée générale extraordinaire des
Actionnaires de la société absorbante et l'attribution aux Actionnaires de notre Société, d'actions de la société absorbante
dans le rapport d'échange de cent soixante-quatre virgule zéro soixante-seize (164,076) actions nouvelles de la société
absorbante, émises dans le cadre d'une augmentation de capital de cette société absorbante, pour une (1) action de notre
Société.
<i>Clôturei>
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente Assemblée, est estimé à mille sept cents euros (1.700.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte ensemble avec le représentant des actionnaires.
Signé: D. Murari, C. Petit, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 09 mai 2011. LAC/2011/20938. Reçu douze euros EUR 12,
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
75187
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 13 mai 2011.
Référence de publication: 2011069166/137.
(110074254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Russel and Thomson Finance and Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg B 87.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 avril 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069189/10.
(110073893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
S.C.I Village de Mance, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg E 619.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Dépôt complémentaire de l'AGO du 27/08/09 déposée et enregistrée auprès du RCS Luxembourg le 28/08/2009 sous
la référence L090135751.05
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/08/09i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 31/08/09:
- Clôture de la liquidation volontaire de la société à compter du 01/09/09.
- Les documents comptables et administratifs de la société seront conservés durant 5 ans à l'adresse: 24, rue Gaffelt
L-3480 Dudelange
Référence de publication: 2011069202/15.
(110073923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Buffalo Poland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 160.790.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the first day of April.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
THERE APPEARED:
Buffalo Poland Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, and not
yet registered with the Luxembourg trade and companies register,
here represented by Ms. Carole Noblet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal in Luxembourg, on 1 April 2011.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
75188
L
U X E M B O U R G
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will assume the name of "Buffalo Poland Finance S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of ma-
nagers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500. -) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25. -) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members
a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
75189
L
U X E M B O U R G
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.
Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The 500 shares have been subscribed by Buffalo Poland Topco S.à r.l., prenamed.
75190
L
U X E M B O U R G
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2011.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. BRE/Management 5 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under section B number 151600, is appointed manager of the Company for an indefinite period of time.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:
Im Jahre zweitausendelf, den ersten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Buffalo Poland Topco S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Groß-
herzogtums Luxembourg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, noch nicht im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister eingetragen,
hier vertreten durch Frau Carole Noblet, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht,
ausgestellt in Luxemburg, am 1. April 2011.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, dieÜbertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
75191
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Buffalo Poland Finance S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei
Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. DieÜbertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich,wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-
lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei
Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei
Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.
Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-
lungen finden am Gesellschaftssitz statt.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
75192
L
U X E M B O U R G
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch
immer, nicht aufgelöst.
Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine
natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Buffalo Poland Topco S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet.
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
75193
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2011.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausend zweihundert euro (€ 1.200,-) geschätzt.
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. BRE/Management 5 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 151600, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist,gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Signé: Noblet, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 avril 2011. Relation: EAC/2011/4887. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011064695/318.
(110072992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.
Alpina Real Estate Company II SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 150.694.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mrs Rachel Uhl, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
acting in her capacity as proxyholder of ALPINA REAL ESTATE GP II S.A.,a société anonyme, having its registered
office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B.131.703, acting as general partner (the "General Partner") of the Company,
by virtue of the authority granted by resolutions of the board of directors of the General Partner (the "Board of
Directors") dated 15 April 2011,
the appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record her declarations as
follows:
1.- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, on 14 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
352, page 16850 dated 17 February 2010.
2.- Pursuant to article 6.1 of the articles of association of the Company (the "Articles"), the authorised share capital
is set at one hundred and twenty million Euro (EUR 120,000,000.-) to be used in order to issue new management shares,
new class A ordinary shares, new class B ordinary shares, new class I ordinary shares, and new class E ordinary shares.
Pursuant to article 6.5 of the Articles, the General Partner is specially authorized to issue the new shares without
reserving for the existing shareholders of the Company the preferential right to subscribe for new redeemable shares.
Pursuant to articles 6.4. of the Articles the General Partner is authorized to increase, during a period of 5 years after the
date of publication of the Articles, the issued share capital.
3.- By resolutions dated 15 April 2011, the General Partner approved the increase of the share capital of the Company
in relation to the issuance of the new class B ordinary shares and the new class E ordinary shares pursuant to article 32-3
75194
L
U X E M B O U R G
(5) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and articles 6.1, 6.4 and 6.5 of
the Articles.
The share capital of the Company was increased as of 15 April 2011 by an amount of sixty thousand Euro (EUR 60,000.-)
in order to raise it from its current amount of eighty-eight thousand eight hundred and eighty Euro (EUR 88,880.-) to
one hundred and forty-eight thousand eight hundred and eighty Euro (EUR 148,880.-) by (i) issuing four hundred eighty
(480) new class B ordinary shares with a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each (the "New Class B Ordinary Shares")
and with a total share premium of two million three hundred and eighty thousand eight hundred Euro (EUR 2,380,800.-),
i.e. a share premium of four thousand nine hundred and sixty Euro (4,960.-) per New Class B Ordinary Share and (ii)
issuing one thousand and twenty (1,020) new class E ordinary shares with a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each
(the "New Class E Ordinary Shares") and with a total share premium five million fifty-nine thousand two hundred Euro
(EUR 5,059,200.-), i.e. a share premium of four thousand nine hundred and sixty Euro (4,960.-) per New Class E Ordinary
Share.
4.- Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company was subscribed
as follows:
- four hundred and eighty (480) New Class E Ordinary Shares by Segol S.L., with registered office at Galileo, 303-305,
Planta 4
a
, 08028 Barcelona, Spain, for a total amount of nineteen thousand two hundred Euro (EUR 19,200.-) and payment
of a share premium of a total amount of two million three hundred and eighty thousand eight hundred Euro (EUR
2,380,800.-), as of 15 April 2011;
- five hundred and forty (540) New Class E Ordinary Shares by Rosp Corunna Participaciones Empresariales S.L., with
registered office at Alcalde Puga y Parga, 5, oficina 2, 15006 A Coruña, Spain, for a total amount of twenty-one thousand
six hundred Euro (EUR 21,600.-) and payment of a share premium of a total amount of two million six hundred seventy-
eight thousand four hundred Euro (EUR 2,678,400.-) and payment of an actualisation interest of a total amount of forty-
three thousand one hundred and twelve Euro (EUR 43,112.-), as of 15 April 2011; and
- four hundred and eighty (480) New Class B Ordinary Shares by Florentino S.L, with registered office at Polígono
Industrial Lalín 2000, 30-3436500-Lalín (Pontevedra), Spain, for a total amount of nineteen thousand two hundred Euro
(EUR 19.200.-) and payment of a share premium of a total amount of two million three hundred and eighty thousand
eight hundred Euro (EUR 2,380,800.-), as of 15 April 2011.
All the four hundred and eighty (480) New Class B Ordinary Shares and the one thousand and twenty (1,020) New
Class E Ordinary Shares were fully subscribed by the above mentioned subscribers together with the payment of the
share premium and the actualisation interest, the subscription price, the share premium and the actualisation interest
being fully paid up in cash, so that the amount of seven million five hundred and forty-three thousand one hundred and
twelve Euro (EUR 7,543,112.-) was at the disposal of the Company.
5.- As a consequence of the above increase of share capital article 5.1. of the Articles is amended and shall now read
as follows:
" 5.1. The issued share capital of the Company is set at one hundred forty-eight thousand eight hundred eighty Euro
(EUR 148,880.-) divided into:
(i) nine hundred (900) class B redeemable ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares») having a nominal value of
forty Euro (EUR 40.-) each, fully paid in up by one hundred percent (100%) and held by the Limited Shareholders who
are liable only up to their capital contribution;
(ii) two thousand three hundred forty seven (2,347) class E redeemable ordinary shares (the «Class E Ordinary Shares»)
having a nominal value of forty Euro (EUR 40.-) each, fully paid in up by one hundred percent (100%) and held by the
Limited Shareholders who are liable only up to their capital contribution; and
(iii) four hundred and seventy-five (475) redeemable management shares (the «Management Shares») having a nominal
value of forty Euro (EUR 40.-) each, fully paid in up by one hundred percent (100%) and held by the General Partner who,
in its capacity as Unlimited Shareholder, is liable without any limits for any obligations of the Company which cannot be
met out of the Company's assets."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at five thousand Euro.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing person, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-sept avril.
75195
L
U X E M B O U R G
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de ALPINA REAL ESTATE GP II S.A., une société anonyme, ayant son siège social
au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B.131.703, agissant en sa qualité de gérant commandité (le "Gérant Commandité") de la Société,
en vertu d'un pouvoir conféré aux termes des résolutions du conseil d'administration du Gérant Commandité (le
"Conseil d'Administration") en date du 15 avril 2010,
la comparante, qui agit ès qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1.- La Société a été constituée en vertu d'un acte notarié de Joseph Elvinger, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, le 14 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 févier 2010, page
16850, sous le numéro 352.
2.-Conformément à l'article 6.1 des statuts de la Société (les "Statuts"), le capital social autorisé est fixé à cent vingt
million d'Euro (EUR 120.000.000,-) à utiliser afin d'émettre de nouvelles actions de commandité rachetables, de nouvelles
actions ordinaires de catégorie A, de nouvelles actions ordinaires de catégorie B, de nouvelles actions ordinaires de
catégorie I et de nouvelles actions ordinaires de catégorie E.
Conformément à l'article 6.5 des Statuts, le Gérant Commandité est autorisé expressément à émettre les nouvelles
actions rachetables sans réserver aux actionnaires existants de la Société le droit préférentiel de souscription pour des
nouvelles actions rachetables. Conformément à l'article 6.4 des Statuts, le Gérant Commandité est autorisé à augmenter,
pendant une période de 5 ans à compter de la publication des statuts, le capital social émis.
3.- Par résolutions du 15 avril 2010, le Gérant Commandité a approuvé l'augmentation de capital social de la Société
relativement à l'émission de nouvelles actions ordinaires de catégorie E, de nouvelles actions ordinaires de catégorie B
et de Nouvelles Actions de Commandité et la renonciation aux droits préférentiels de souscription des actionnaires
existants conformément à l'article 32-3 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,
telle qu'amendée, et aux articles 6.1, 6.4 et 6.5 des Statuts.
Le capital social de la Société a été augmenté à la date du 15 avril 2010 d'un montant total de soixante mille Euro (EUR
60.000.-) et élevé de son montant actuel de quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 88.800,-) à cent
quarante-huit mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 148,880) par (i) l'émission de quatre cent quatre-vingt (480) nouvelles
actions ordinaires de catégorie B rachetables ayant une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune (les "Nou-
velles Actions Ordinaires de Catégorie B") et avec une prime d'émission totale de deux millions trois cent quatre-vingt
mille huit cents Euro (EUR 2.380.800,-), c'est-à-dire une prime d'émission de quatre mille neuf cent soixante Euro (EUR
4.960,-) par Nouvelle Action Ordinaire de Catégorie B et (ii) l'émission de mille vingt (1.020) nouvelles actions ordinaires
de catégorie E rachetables ayant une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune (les "Nouvelles Actions
Ordinaires de Catégorie E") et avec une prime d'émission totale de cinq millions cinquante-neuf mille deux cents Euro
(EUR 5.059.200,-), c'est-à-dire une prime d'émission de quatre mille neuf cent soixante Euro (EUR 4.960,-) par Nouvelle
Action Ordinaire de Catégorie E.
5.- Sur ce, le Gérant Commandité reconnaît que le capital social de la Société nouvellement émis a été souscrit comme
suit:
- quatre cent quatre-vingt (480) Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie E par Segol S.L., ayant son siège social à
Galileo, 303-305, 4
ème
étage, 08028 Barcelone, Espagne, pour un montant total de dix-neuf mille deux cents Euro (19.200.-
EUR) et avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux millions trois cent quatre-vingt mille huit cents
Euro (EUR 2.380.800-), à la date du 15 avril 2011;
- cinq cent quarante (540) Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie E par Rosp Corunna Participaciones Empresa-
riales S.L., ayant son siège social à Alcade Puga y Parga, 5, oficina 2, 15006 A Coruña, Espagne, pour un montant total de
vingt-et-un mille six cents Euro (EUR 21.600,-) et avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux
millions six cent soixante-dix-huit mille quatre cents Euro (EUR 2.678.400,-) et avec paiement d'un intérêt d'actualisation
d'un montant de quarante-trois mille cent douze Euro (EUR 43.112.-) à la date du 15 avril 2011; et
- quatre cent quatre-vingt (480) Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie B par Florentino S.L, ayant son siège social
à Polígono Industrial Lalín 2000, 30-3436500-Lalín (Pontevedra), Espagne, pour un montant total dix-neuf mille deux cents
Euro (19.200.-EUR) et avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux millions trois cent quatre-vingt
mille huit cents Euro (EUR 2.380.800-), à la date du 15 avril 2011.
Toutes les quatre cent quatre-vingt (480) Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie B et les mille vingt (1.020)
Nouvelles Actions Ordinaires de Catégorie E ont été entièrement souscrites par les souscripteurs ci-dessus ainsi que le
paiement de la prime d'émission et le paiement de l'intérêt d'actualisation, à la fois, le prix de souscription, la prime
d'émission et l'intérêt d'actualisation ont été payés en numéraire de sorte que la somme de sept mille cinq cent quarante-
trois mille cent douze Euro (EUR 7.543.112,-) fut à la disposition de la Société.
5.- En conséquence de l'augmentation de capital social ci-dessus l'article 5.1 des Statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
75196
L
U X E M B O U R G
" 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à cent quarante-huit mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 148,880)
divisé en:
(i) neuf cents (900) actions ordinaires de catégorie B rachetables (les "Actions Ordinaires de Catégorie B") ayant une
valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune, intégralement libérées à cent pour cent (100%) et détenues par
les Commanditaires qui ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport en capital;
(ii) deux mille trois cent quarante-sept (2.347) actions ordinaires de catégorie E rachetables (les "Actions Ordinaires
de Catégorie E") ayant une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune, intégralement libérées à cent pour
cent (100%) et détenues par les Commanditaires qui ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport en capital;
(ii) quatre cent soixante-quinze (475) actions de gérant commandité rachetables (les "Actions de Commandité") ayant
une valeur nominale de quarante Euro (EUR 40,-) chacune, intégralement libérées à cent pour cent (100%) et détenues
par le Gérant Commandité qui, en sa capacité d'associé tenu de manière illimitée, est responsable sans limite pour toutes
les dettes de la Société qui ne peuvent être honorées par les actifs de la Société."
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ cinq mille Euro.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, elle a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 avril 2011. Relation: LAC/2011/19449. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 10 mai 2011.
Référence de publication: 2011068770/171.
(110073825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Russel and Thomson Finance and Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg B 87.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 avril 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069190/10.
(110073899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Russel and Thomson Finance and Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg B 87.201.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 avril 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011069191/10.
(110073901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Regulux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg B 55.725.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
75197
L
U X E M B O U R G
Remich, le 6 mai 2011.
Patrick SERRES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011069194/12.
(110074012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Shane Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.788.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2011.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011069213/13.
(110073958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
ILP III S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 127.503.
In the year two thousand eleven, on the twenty-ninth of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Adrien COULOMBEL, employee, having professional residence in Luxembourg,
acting in his capacity as attomey of the Manager of the company “ILP III S.C.A., SICAR”, a “société en commandite par
actions “, established and having its registered office at L-2128 Luxembourg, 30 rue Marie Adelaide, registered in the
Luxembourg Company Register under section B number 127.503, which was incorporated by a deed of the undersigned
notary, on April 13, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1269 of June 26, 2007,
and whose articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary
on February 23, 2011, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Company»),
by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the Company's Manager on April 22, 2011, a certified
copy of these resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain annexed to the present
deed which they shall be formalised.
The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I.- The subscribed share capital of the Company is presently set at seven million eight hundred sixty-seven thousand
three hundred fifty-four euro eleven cents (EUR 7,867,354.11) divided into:
- one (1) Management Share,
- seven hundred sixty-two thousand one hundred seventeen point one three eight five (762,117.1385) Class A Shares,
- twenty-one thousand five hundred eighteen point two seven two four (21,518.2724) Class B Shares,
- three thousand ninety-nine (3,099) Class C Shares.
II.- Pursuant to Article 8 (e) of the Company's Articles of Incorporation, the Company's authorised capital is set at
one hundred fifty million euro (EUR 150,000,000.-).
III.- Pursuant to the Company's Articles of Incorporation, the Company's Manager has been authorised to increase
the Company's subscribed share capital within the limits of the authorised capital and to amend Article 8 (b) of the Articles
of Incorporation so as to reflect the increase of capital.
IV.- The Company's Manager, in its resolutions adopted on April 21, 2011, and in accordance with the authorities
conferred on it pursuant to the Articles of Incorporation, resolved to increase the subscribed corporate capital by the
amount of one hundred fifty-six thousand six hundred ninety-nine euro seventy-one cents (EUR 156,699.71) in order to
raise it from its present amount of seven million eight hundred sixty-seven thousand three hundred fifty-four euro eleven
cents (EUR 7,867,354.11) to an amount of eight million twenty-four thousand fifty-three euro eighty-two cents (EUR
8,024,053.82) by the creation and the issue of five hundred and six (506) new Class A Shares and fifteen thousand one
75198
L
U X E M B O U R G
hundred sixty-three point nine seven one (15,163.971) new class B Shares with a nominal value of ten euro (EUR 10.-)
per share, having the same rights attached as the existing Shares.
V.- Pursuant to Article 8 (g) of the Company's Articles of Incorporation, the Company's Manager further resolved to
waive to the extent necessary the preferential subscriptions rights reserved to the existing Shareholders and to accept
the subscriptions on April 22, 2011 of five hundred and six (506) new Class A Shares and fifteen thousand one hundred
sixty-three point nine seven one (15,163.971) new class B Shares.
VI.- All these new Shares have been entirely subscribed and entirely paid by the conversion into capital of an unques-
tionable and immediately payable claim for an amount of two million one hundred eleven thousand two hundred eighty-
eight euro eighty-three cents (EUR 2,111,288.83) and in cash for an amount of five million three hundred fifty-seven
thousand one hundred and six euro sixty-two cents (EUR 5,357,106.62) as follows:
Limited Shareholders
Share Capital
Contribution
(EUR)
Number
of shares
subscribed
Share
Premium
Contribution
(EUR)
Bridge
Financing
Conversion
into Capital
Contribution
(EUR)
Cash
Payement
(EUR)
A Shares
Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 200,00
120,0000
1 733 998,99
469 175,30 1 266 023,69
Società Cattolica di Assicuarazione
Coop.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,00
40,0000
577 999,66
156 391,77
422 007,90
Galotti S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360,00
36,0000
520 199,70
140 752,59
379 807,11
A. Rise & Co. S.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
360,00
36,0000
520 199,70
140 752,59
379 807,11
Livaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180,00
18,0000
260 099,85
70 376,29
189 903,55
Finogest Finance S.A. . . . . . . . . . . . .
480,00
48,0000
693 599,60
187 670,12
506 409,48
Halfmoon Assets S.A. . . . . . . . . . . . .
180,00
18,0000
260 099,85
70 376,29
189 903,55
Sibad International S.A. . . . . . . . . . . .
60,00
6,0000
86 699,95
23 458,76
63 301,18
Banca Popolare di Vicenza ScpA . . . .
500,00
50,0000
722 499,58
195 489,71
527 509,87
Compagnie Monegasque
de Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,00
12,0000
173 399,90
46 917,53
126 602,37
FIN PO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,00
6,0000
86 699,95
23 458,76
63 301,18
Union Bancaire Privée . . . . . . . . . . .
60,00
6,0000
86 699,95
23 458,76
63 301,18
Futura Invest S.p.A. . . . . . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999,83
78 195,88
211 003,95
Yleen Investments Ltd . . . . . . . . . . .
100,00
10,0000
144 499,92
39 097,94
105 501,97
Private Equity International S.A. . . . .
200,00
20,0000
288 999,83
78 195,88
211 003,95
Gema 96 SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999,83
78 195,88
211 003,95
Gain Capital Participations S.A.,
SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
10,0000
144 499,92
39 097,94
105 501,97
Kzewl Investment S.A. . . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999,83
78 195,88
211 003,95
Gravilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
10,0000
144 499,92
39 097,94
105 501,97
Total of A Shares . . . . . . . . . . . . . . .
5 060,00
506,0000
7 311 695,74
1 978 355,83 5 338 399,91
B Shares
A. Rise & Co. S.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
14 272,20
1 427,2204
0,00
12 511,54
1 760,66
Investimenti Atlantici S.r.l. . . . . . . . .
14 272,20
1 427,2204
0,00
12 511,54
1 760,66
CO.RE.FI. – Compagnia
Fiduciaria S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 327,71
3 032,7707
0,00
26 586,40
3 741,31
CO.RE.FI. – Compagnia
Fiduciaria S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 327,71
3 032,7707
0,00
26 586,40
3 741,31
G.B.L. Fiduciaria S.p.A. . . . . . . . . . . .
17 839,97
1 783,9967
0,00
15 639,18
2 200,79
Marona Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . .
44 599,92
4 459,9921
0,00
39 097,94
5 501,98
Total of B Shares . . . . . . . . . . . . . . .
151 639,71 15 163,9710
0,00
132 933,00
18 706,71
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 639,71 15 163,9710
7 311 695,74
2 111 288,83 5 357 106,62
In conformity with article 32-1 (5) of the Law of August 10, 1915, as amended, said claim has been dealt with a report
established by Deloitte S.A., with professional address in Luxembourg on April 29, 2011, concluding in English as follows:
"Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the Contribution is not at least equal to the number and value of the 13,546.300 ordinary shares issued with
a par value EUR 10 each amounting to EUR 135,463.00 and a share premium of EUR 1,975,825.83."
75199
L
U X E M B O U R G
Said report, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The total cash sum of five million three hundred fifty-seven thousand one hundred and six euro sixty-two cents (EUR
5,357,106.62) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
The total contribution of seven million four hundred sixty-eight thousand three hundred ninety-five euro forty-five
cents (EUR 7,468,395.45) will be allocated for an amount of one hundred fifty-six thousand six hundred ninetynine euro
seventy-one cents (EUR 156,699.71) to the issued share capital of the Company and for seven million three hundred
eleven thousand six hundred ninety-five euro seventy-four cents (EUR 7,311,695.74) to the share premium account.
VII.- As a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, the article 8 (b) of the Articles
of Incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:
Art. 8. (b). " The issued share capital of the Company is set at eight million twenty-four thousand fifty-three euro
eighty-two cents (EUR 8,024,053.82) divided into:
- one (1) Management Share,
- seven hundred sixty-two thousand six hundred twenty-three point one three eight five (762,623.1385) Class A Shares
- thirty-six thousand six hundred eighty-two point two four three four (36,682.2434) Class B Shares and -three thou-
sand ninety nine (3,099) Class C Shares."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document, are estimated at approximately six thousand euro.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Adrien Coulombel, employé, résidant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de l'Associé Gérant Commandité de la société "ILP III S.C.A., SICAR", société en
commandite par actions, établie et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 30 rue Marie Adelaide et inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 127.503, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1269 du 26 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 23 février 2011, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, (la «Société»)
en vertu des pouvoirs lui conférés par les résolutions de l'Associé Gérant Commandité, prises en date du 22 avril 2011
dont la copie certifiée de ces résolutions, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle personne comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les décla-
rations et constatations suivantes:
I.- Le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à sept millions huit cent soixante sept mille trois cent cinquante-
quatre euros onze cents (EUR 7.867.354,11) divisé en
- une (1) Action de Commandité,
- sept cent soixante-deux mille cent dix-sept virgule un trois huit cinq (762,117.1385) actions de Classe A,
- vingt-et-un mille cinq cent dix-huit virgule deux sept deux quatre (21,518.2724) actions de Classe B,
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions de Classe C.
II.- En vertu de l'Article 8 (e) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, est fixé à cent cinquante millions
d'euros (EUR 150.000.000,-).
III.- En vertu des statuts de la Société, l'Associé Gérant Commandité de la Société a été autorisé à augmenter le capital
souscrit dans les limites du capital autorisé et à modifier l'Article 8 (b) des Statuts de manière à refléter l'augmentation
de capital.
IV.- L'Associé Gérant Commandité de la Société, dans ses résolutions du 21 avril 2011, et en conformité des pouvoirs
lui conférés en vertu des Statuts, a décidé une augmentation du capital souscrit à concurrence de cent cinquante-six mille
75200
L
U X E M B O U R G
six cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante et onze cents (EUR 156.699,71) afin de le porter de son montant actuel de
sept millions huit cent soixante sept mille trois cent cinquante-quatre euros onze cents (EUR 7.867.354,11) à huit millions
vingt-quatre mille cinquante-trois euros quatre-vingt-deux cents (EUR 8.024.053,82) par la création et l'émission de cinq
cent six (506) nouvelles actions de Classe A et quinze mille cent soixante-trois virgule neuf sept un (15.163,971) nouvelles
actions de Classe B, ayant une valeur de dix euros (EUR 10.-) par action et ayant les mêmes droits que les actions
existantes.
V.- En vertu de l'Article 8 (g) des statuts de la Société, l'Associé Gérant Commandité de la Société a également décidé
de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure du nécessaire et a admis les
souscriptions le 22 avril 2011 de cinq cent six (506) nouvelles actions de Classe A et de quinze mille cent soixante-trois
virgule neuf sept un (15.163,971) nouvelles actions de Classe B.
VI.- Toutes ces nouvelles actions ordinaires ont été entièrement souscrites et entièrement libérées par la conversion
en capital d'une créance certaine liquide et exigible pour un montant de deux millions cent onze mille deux cent quatre-
vingt-huit euros quatre-vingt-trois cents (EUR 2.111.288,83) et payées en numéraire pour un montant de cinq millions
trois cent cinquante-sept mille cent six euros soixante-deux cents (EUR 5.357.106,62) comme suit.:
Actionnaires
Apport en
Capital
(EUR)
Nombre
d'action
souscrites
Apport prime
d'émission
(EUR)
Conversion
créance
(EUR)
Apport en
numéraire
(EUR)
Actions de classe A
Efibanca S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 200,00
120,0000 1 733 998,99
469 175,30 1 266 023,69
Società Cattolica di Assicuarazione
Coop.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,00
40,0000
577 999,66
156 391,77
422 007,90
Galotti S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360,00
36,0000
520 199,70
140 752,59
379 807,11
A. Rise & Co. S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360,00
36,0000
520 199,70
140 752,59
379 807,11
Livaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180,00
18,0000
260 099,85
70 376,29
189 903,55
Finogest Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480,00
48,0000
693 599,60
187 670,12
506 409,48
Halfmoon Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
180,00
18,0000
260 099,85
70 376,29
189 903,55
Sibad International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
60,00
6,0000
86 699,95
23 458,76
63 301,18
Banca Popolare di Vicenza ScpA . . . . . . . . .
500,00
50,0000
722 499,58
195 489,71
527 509,87
Compagnie Monegasque de Banque . . . . . . .
120,00
12,0000
173 399,90
46 917,53
126 602,37
FIN PO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,00
6,0000
86 699,95
23 458,76
63 301,18
Union Bancaire Privée . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,00
6,0000
86 699,95
23 458,76
63 301,18
Futura Invest S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999,83
78 195,88
211 003,95
Yleen Investments Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
10,0000
144 499,92
39 097,94
105 501,97
Private Equity International S.A. . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999, 83
78 195,88
211 003,95
Gema 96 SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999, 83
78 195,88
211 003,95
Gain Capital Participations S.A.,
SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
10,0000
144 499,92
39 097,94
105 501,97
Kzewl Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00
20,0000
288 999,83
78 195,88
211 003,95
Gravilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,00
10,0000
144 499,92
39 097,94
105 501,97
Total actions de classe A . . . . . . . . . . . . . . .
5 060,00
506,0000 7 311 695,74 1 978 355,83 5 338 399,91
Actions de classe B
A. Rise & Co. S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 272,20
1 427,2204
0,00
12 511,54
1 760,66
Investimenti Atlantici S.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
14 272,20
1 427,2204
0,00
12 511,54
1 760,66
CO.RE.FI. – Compagnia Fiduciaria S.r.l. . . . .
30 327,71
3 032,7707
0,00
26 586,40
3 741,31
CO.RE.FI. – Compagnia Fiduciaria S.r.l. . . . .
30 327,71
3 032,7707
0,00
26 586,40
3 741,31
G.B.L. Fiduciaria S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 839,97
1 783,9967
0,00
15 639,18
2 200,79
Marona Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 599,92
4 459,9921
0,00
39 097,94
5 501,98
Total actions de classe B . . . . . . . . . . . . . . . 151 639,71 15 163,9710
0,00
132 933,00
18 706,71
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 639,71 15 163,9710 7 311 695,74 2 111 288,83 5 357 106,62
En conformité avec l'article 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, la dite conversion de créance a fait
l'objet d'un rapport, établi par Deloitte S.A., en date du 29 avril 2011, dont la conclusion est rédigée en langue anglaise
est la suivante:
"Based on the procedures applied as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the Contribution is not at least equal to the number and value of the 13,546.300 ordinary shares issued with
a par value EUR 10 each amounting to EUR 135,463.00 and a share premium of EUR 1,975,825.83."
75201
L
U X E M B O U R G
Le susdit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé aux
présentes pour être enregistré avec elles.
Le montant en numéraire de cinq millions trois cent cinquante-sept mille cent six euros soixante-deux cents (EUR
5.357.106,62) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.
L'apport total de sept millions quatre cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-quinze euros quarante-cinq cents
(EUR 7.468.395,45) sera alloué pour cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante et onze cents
(EUR 156.699,71) au capital souscrit de la société et pour sept millions trois cent onze mille six cent quatre-vingt-quinze
euros soixante-quatorze cents (EUR 7.311.695,74) au compte de prime d'émission.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, l'Article 8 (b) des Statuts de la Société est
modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
Art. 8. (b). "Le capital social souscrit de la Société est fixé à huit millions vingt-quatre mille cinquante trois euros quatre-
vingt-deux cents (EUR 8.024.053,82) divisé en:
- une (1) Action de Commandité,
- sept cent soixante-deux mille six cent vingt-trois virgule un trois huit cinq (762.623,1385) actions de Classe A,
- trente-six mille six cent quatre-vingt-deux virgule deux quatre trois quatre (36.682,2434) actions de Classe B et
- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) Actions de Classe C."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ six mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 mai 2011. Relation: EAC/2011/5761. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011068473/234.
(110075196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2011.
Remora Consult, Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.
R.C.S. Luxembourg B 144.847.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069197/10.
(110074285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Ressac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 81.784.
Les comptes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RESSAC S.A.
Robert REGGIORI / Jean-Marc HEITZ
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2011069198/12.
(110074210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
75202
L
U X E M B O U R G
Satpo-Peakside JV Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 142.281.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 11 mai 2011.
Satpo-Peakside JV Co S.à r.l.
Declan McGrath
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2011069205/14.
(110073685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Rollasun S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 133.629.
RECTIFICATIF
Dépôt à rectifier: Comptes sociaux déposés le 06/07/2010 Numéro dépôt L100096709
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069200/12.
(110073662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
RTL Group Central and Eastern Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 97.056.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Mai 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011069201/12.
(110074150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
S.C.I. Ville de Cognac, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3403 Dudelange, 24, rue Gaffelt.
R.C.S. Luxembourg E 3.697.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Dépôt complémentaire de l'AGO du 27/08/09 déposée et enregistrée auprès du RCS Luxembourg le 28/08/2009 sous
la référence L090135749.05
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/08/09i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 31/08/09:
- Clôture de la liquidation volontaire de la société à compter du 01/09/09.
- Les documents comptables et administratifs de la société seront conservés durant 5 ans à l'adresse: 24, rue Gaffelt
L-3480 Dudelange
Référence de publication: 2011069203/15.
(110073944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
75203
L
U X E M B O U R G
Smat's, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 115.192.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l'objet de la rectification:
Référence: L090000982.04
Date: 05/01/2009
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011069245/15.
(110073676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Sachverständigenbüro Jakoby S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. JH - Holz S. à r. l.).
Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 118.231.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 12 mai 2011.
Référence de publication: 2011069204/11.
(110073607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SciPharm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 33, rue Hiehl.
R.C.S. Luxembourg B 150.938.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 12 mai 2011.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2011069206/11.
(110073730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SeeReal Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 112.913.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2011.
Référence de publication: 2011069208/10.
(110073856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Société de Participations Immobilières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.131.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
75204
L
U X E M B O U R G
<i>Pour Société de Participations Immobilières S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011069214/11.
(110074293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SANZAR Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SANZAR Europe S.à r.l.
i>Signatures
Référence de publication: 2011069226/11.
(110074302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Stoker Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 114.492.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069221/10.
(110073956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.816.
Suite au conseil d'administration du 30 mars 2011, monsieur Patrick Armstrong, demeurant au 23-25 rue Delarivière
- Lefoullon, 92064 Paris la Défense - France, a été nommé administrateur en remplacement de monsieur Gregory Ehret
à compter du 30 mars 2011 et jusqu'à la prochaine assemblée générale devant se tenir en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2011.
Signature
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011069219/14.
(110073708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Sagical S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 122.558.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2011 que la société Ser.Com S.a.r.l.,
ayant son siège social au 72, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg, a été nommée nouveau commissaire en rem-
placement d'ADOMEX, démissionnaire. Son mandat prendra fin en 2017.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 10 mai 2011.
Référence de publication: 2011069223/13.
(110073557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
75205
L
U X E M B O U R G
Samsonite International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.469.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2011.
Référence de publication: 2011069225/10.
(110073789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SCEM Reinsurance, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 29.883.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société SCEM REINSURANCE
i>SINSER (Luxembourg) S.A.R.L.
Signature
Référence de publication: 2011069228/12.
(110073709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Sea-Invest Afrique S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 133.563.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011069232/12.
(110073677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Leopard Germany Property Papenburg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 160.759.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twenty-sixth day of April.
Before Me Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Leopard Germany Holding 3 S.àr.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1913 Luxembourg, 12, Rue Léandre Lacroix, incorporated on September 9
th
2010 by
a deed of Maître Joelle BADEN, notary residing in Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in
Luxembourg, section B 155840,
represented by Mrs. Rowena FOWDEN, with professional address at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on April 14
th
2011.
Said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacity, has drawn up the following articles of a private limited
company to be incorporated.
Art. 1. A private limited company (société à responsabilité limitée) is hereby formed, that will be governed by these
articles and by the relevant legislation.
75206
L
U X E M B O U R G
The name of the company is “Leopard Germany Property Papenburg S.àr.l.”.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4.
4.1 The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or
in any other manner, in other companies in Luxembourg or abroad, as well as the management, control and development
of these participations. The Company can also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange
or otherwise.
4.2 The Company can acquire, develop, hold investment properties and the sale of some or part of these properties
as part of the orderly management of the investment, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties
either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including
the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.
4.3 The Company can also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as
well as all other attached rights or rights able to supplement them.
4.4 The Company can, in accordance with the provisions of the law, borrow in any form and in particular by way of
bond issue, convertible or not, of bank loan or shareholder's current account, and grant to other companies in which it
has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company can be interested in all transferable securities, cash deposits, treasury certificates, and any
other form of placement, in particular actions, obligations, options or warrants, to acquire them by purchase, subscription
or any manner, to sell them or exchange them.
4.5 The Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether by personal
covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future) of the
undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and
of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity as the
Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies
or such other entity as it deems fit.
4.6 It may carry out all industrial, commercial, financial personal or real estate transactions which are directly or
indirectly in connection, in whole or part, with its social object.
4.7 It can carry out its object directly or indirectly in proper name or on third's behalf, sole or in association by carrying
out all operations likely to support the aforementioned object or the object of the companies in which the Company
holds interests.
4.8 Generally, it may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem
useful in the accomplishment of its purpose; it will also be able to hold mandates of administration of other Luxembourg
or foreign companies, remunerated or not.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 20,000. - (twenty thousand Euro) divided into 100 (one
hundred) corporate units with a nominal value of EUR 200 - (two hundred Euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial
Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-
bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five
percent of the company's capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members is
subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to
a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed
by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have under their sole signature the most extensive powers to act on behalf of the
company in all circumstances.
75207
L
U X E M B O U R G
If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be managed by the sole member or, if there
are several members, by two members acting under their joint signature.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of each year.
Art. 16. Every year on December 31
st
, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-
bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be
members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,
pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31
st
2011.
<i>Subscription and Paymenti>
The 100 (one hundred) corporate units have been entirely subscribed by the sole member.
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
20,000. - (twenty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1.000.-
<i>Resolutions of the sole memberi>
The sole member, represented as above-mentioned, representing the whole corporate capital, passed the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole shareholder decides to appoint as sole manager of the Company Mr. Robert KIMMELS, director, born on 4
th
March 1969 in Breukelen (the Netherlands), with professional address at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The manager is elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
75208
L
U X E M B O U R G
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by his/her surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us,
Notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person
appearing, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausend elf, den sechsundzwanzigsten April.
Vor Me Paul DECKER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Leopard Germany Master Holding Company S.àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1913
Luxemburg, 12, Rue Léandre Lacroix, gegründet gemäss Urkunde vom 9. September 2010 vor Notar Joelle BADEN, mit
Amtssitz in Luxemburg,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg Sektion B 155839,
vertreten durch Frau Rowena FOWDEN, mit beruflicher Anschrift in L-1913 Luxemburg, 12, Rue Léandre Lacroix,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 14. April 2011. Die oben aufgeführte Vollmacht wird,
nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" paraphiert wurde,
zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die der nachstehenden Satzung, sowie
der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Leopard Germany Property Papenburg S.àr.l.“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4.
4.1 Das Unternehmen befasst sich mit dem Erwerb von Beteiligungen jedweder Art an anderen Unternehmen in
Luxemburg oder im Ausland durch Kauf, durch Tausch oder auf sonstige Weise, sowie mit der Verwaltung, der Kontrolle
und dem Ausbau dieser Beteiligungen. Das Unternehmen kann diese Beteiligungen auch durch Verkauf, durch Tausch
oder auf sonstige Weise abtreten.
4.2 Das Unternehmen kann Finanzimmobilien erwerben, entwickeln und verwalten; zu seinen Aktivitäten zählen des
weiteren der Verkauf von ausgewählten Immobilien oder Teilen dieser Immobilien im Rahmen der regulären Verwaltung
von Investition, Förderung, Verkauf, Verwaltung und/oder Vermietung von Immobilien entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland, sowie sämtliche Tätigkeiten in Bezug auf Immobilien (u. a. das direkte bzw. indirekte Halten
von Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg oder im Ausland), deren wesentliche Ziele der Erwerb, die Entwicklung,
die Förderung, der Verkauf, die Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilien sind.
4.3 Darüber hinaus kann das Unternehmen sämtliche Patente, Marken und sonstigen Rechte am geistigen Eigentum
und immaterielle Rechte sowie alle sonstigen zugehörigen oder ergänzenden Rechte erwerben und verfolgen.
4.4 Das Unternehmen kann – unter Einhaltung des geltenden Rechts – insbesondere über die Ausgabe von Anleihen
(konvertierbar oder nicht konvertierbar), über Bankkredite oder Kontokorrent der Anteilseigner Kredite jeglicher Art
aufnehmen und anderen Unternehmen, an denen es direkte, indirekte oder keine Beteiligungen hält, Darlehen, Anleihen,
Kredite oder Sicherheiten gewähren.
Darüber hinaus kann das Unternehmen in Beteiligungen an allen übertragbaren Wertpapieren, Bardepots, kurzfristigen
Schatzwechseln sowie sonstigen Anlageformen, in spezielle Prozesse, Obligationen, Optionen oder Optionsscheine in-
vestieren, um diese per Kauf, per Zeichnung oder auf sonstige Weise zu erwerben, zu verkaufen oder zu tauschen.
4.5 Das Unternehmen kann zur Erfüllung von Verträgen oder Verpflichtungen des Unternehmens und seiner verbun-
denen Unternehmen oder Tochterunternehmen oder Gesellschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist bzw.
sonstigen, vom Unternehmen für geeignet erachteten Gesellschaften, sowie allen Verwaltungsratsmitgliedern, Managern
oder sonstigen Vertretern des Unternehmens oder denen seiner verbundenen Unternehmen, Tochterunternehmen oder
sonstigen für geeignet erachteten Gesellschaften jegliche Garantie, Bürgschaft oder sonstige Form von Sicherheit oder
Unterstützung gewähren, wobei es gleich ist, ob durch persönliche Zusage oder durch Hypothek oder Belastung aller
oder ausgewählter Immobilien oder sonstiger (aktueller oder künftiger) Anlagegüter des Unternehmens oder durch alle
diesbezüglichen Methoden.
75209
L
U X E M B O U R G
4.6 Es ist berechtigt, sämtliche gewerblichen, kommerziellen, finanziellen, persönlichen oder immobilienbezogenen
Transaktionen durchzuführen, die direkt oder indirekt mit den Unternehmenszielen vollständig oder teilweise in Ver-
bindung stehen.
4.7 Es kann seine Ziele direkt oder indirekt unter eigenem Namen oder im Namen Dritter verfolgen, ausschließlich
oder im Zusammenhang mit der Ausführung sämtlicher Aktivitäten, die der Erreichung der vorgenannten Ziele bzw. der
Ziele von Unternehmen dienen, an denen das Unternehmen beteiligt ist.
4.8 Das Unternehmen kann generell sämtliche Steuerungs- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und alle Aktivi-
täten ausführen, die es im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit für geeignet hält; außerdem kann es vergütete oder nicht
vergütete Verwaltungsmandate für andere Unternehmen in Luxemburg und im Ausland innehaben.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000.- (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 100 (einhundert) Anteile zu
je EUR 200.- (zweihundert Euro).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift von jeweils einem Geschäftsführer.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch einen, oder im Falle
wo mehrere Gesellschafter am Gesellschaftskapital beteiligt sind, von zwei Gesellschaftern gemeinsam geführt werden.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Falls, und so lange ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
75210
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 100 (einhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter gezeichnet.
Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 20,000.- (zwanzigtausend Euro) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
1.000.- EUR.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie eingangs erwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital
darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt als alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Robert KIMMELS, Direktor,
geboren am 4. März 1969 in Breukelen (Niederlande) zu ernennen, beruflich wohnhaft in 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913
Luxemburg.
Der alleinige Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse bestimmen und sie abberufen.
Der alleinige Geschäftsführer ist für eine unbestimmte Dauer gewählt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 12, Rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
Der amtierende Notar, welcher englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Komparenten
vorliegende Urkunde in englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Unter-
schieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, hat dieselbe mit dem Notar vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. FOWDEN, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 avril 2011. Relation: LAC/2011/19058. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Erteilt an das Handels und Gesellschaftsregister in Luxemburg,
Luxemburg, den 10. Mai 2011.
Référence de publication: 2011064240/266.
(110072080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.
Schräinerei Conrardy Succ. Jacques & Thorn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3932 Mondercange, 5A, rue de Limpach.
R.C.S. Luxembourg B 83.797.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011069229/10.
(110074230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
75211
L
U X E M B O U R G
SD SL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.048.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2011.
Référence de publication: 2011069231/10.
(110074242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Securinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.485.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2011.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2011069233/11.
(110073726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Select Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 77, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 158.815.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 04 mai 2011i>
Il résulte dudit procès-verbal que la décision de transférer le siège social vers 77, rue de Clausen L-1342 Luxembourg
avec effet immédiat a été acceptée.
Luxembourg, le 04 mai 2011.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011069234/13.
(110074057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Small S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 29, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>La gérancei>
Référence de publication: 2011069241/10.
(110074185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Selm Holding International S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.611.
Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
75212
L
U X E M B O U R G
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011069238/12.
(110074295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SG Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 78.141.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2011.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2011069239/11.
(110074237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Smart Holding Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 152.230.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mai 2011.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2011069242/11.
(110073727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
European Capital S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.559.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung am 09.05.2011:i>
- Verlängerung des Mandats von Herrn Benoni Dufour, Geschäftsadresse 6, Grand Rue, L-3394, Roeser, Luxembourg,
als Vorstandsmitglied, begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.
- Verlängerung des Mandats von Herrn Malon Wilkus, Geschäftsadresse 2, Bethesda Metro Center, MD 20814, Be-
thesda, USA, als Vorstandsmitglied, begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.
- Verlängerung des Mandats von Herrn John Erickson, Geschäftsadresse 2, Bethesda Metro Center, MD 20814, Be-
thesda, USA, als Vorstandsmitglied, begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.
- Verlängerung des Mandats von Herrn Ira Wagner, Geschäftsadresse 2, Bethesda Metro Center, MD 20814, Bethesda,
USA, als Vorstandsmitglied, begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.
- Verlängerung des Mandats von Herrn Samuel Flax, Geschäftsadresse 2, Bethesda Metro Center, MD 20814, Bethesda,
USA, als Vorstandsmitglied, begrenzt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2017 stattfinden wird.
Luxembourg, 19. Mai 2011.
Unterschriften.
Référence de publication: 2011076601/20.
(110084041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
Smat's, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 115.192.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
75213
L
U X E M B O U R G
EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2011069244/12.
(110073675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 11.809.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Joëlle BADEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011069247/12.
(110073914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Sobepart S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 34.944.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2011.
Référence de publication: 2011069248/10.
(110073562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Fenor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 35.772.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2011:i>
L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Madame Sophia VAN HEESWDK, demeurant NL-2051 GB
OVEREEN, Bloemendaalseweg, 193, de Monsieur Laurentius ERMES, demeurant NL-5101 TC DONGEN, Heuvelstraat,
2 et de Monsieur Pierre SCHILL, avec adresse professionnelle au 18a, boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG,
ainsi que celui du commissaire aux comptes, Fiduciaire GLACIS S.à r.l. ayant son siège social au 18a, boulevard de la Foire,
L-1528 LUXEMBOURG, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice 2016.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 4 mai 2011i>
Madame Sophia VAN HEESWDK est renommée administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'as-
semblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011076603/20.
(110084091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2011.
Société Financière Saka S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.670.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
75214
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2011.
Référence de publication: 2011069251/10.
(110073602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Sofilec, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 7.399.
Le bilan de Sofina S.A. du 31.12.2010 et la déclaration d'accord conformément à l'article 70, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069253/11.
(110074226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
SOFT4U S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 129.173.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069256/10.
(110074282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Aesthetic Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 114.432.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 avril 2011i>
1. M. Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Mme Adela lANCU, administrateur de sociétés, née à Ploiesti (Roumanie), le 8 décembre 1983, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante B
pour une durée indéterminée.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AESTHETIC ACQUISITION S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011069581/16.
(110077479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2011.
SPU Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 244.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 119.265.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2011.
Référence de publication: 2011069259/11.
(110074140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
75215
L
U X E M B O U R G
Stofan, Société Anonyme.
Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.
R.C.S. Luxembourg B 106.087.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069260/10.
(110073617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Stofan, Société Anonyme.
Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.
R.C.S. Luxembourg B 106.087.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069261/10.
(110073618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Symbihome, Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 95.929.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011069263/10.
(110074281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Threadneedle (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 50.216.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Threadneedle (Lux) (la «Société») tenue le 9 mars 2011:i>
Le conseil d'administration de la Société a pris note de la démission de Monsieur William Lowndes de son poste
d'administrateur de la Société avec la date effective le 31 mars 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2011069269/13.
(110074259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.
Solubat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9163 Kehmen, 17, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 113.468.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011077455/10.
(110085483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
75216
Aesthetic Acquisition S.à r.l.
Alpina Real Estate Company II SCA
Buffalo Poland Finance S.à r.l.
ERE HGP S.à r.l.
European Capital S.A. SICAR
Fenor S.A.
Gagfah S.A.
ILP III S.C.A., SICAR
JH - Holz S. à r. l.
Leopard Germany Property Papenburg S.àr.l.
Proim S.A.
Regulux S.à r.l.
Remora Consult
Ressac S.A.
Rollasun S.A.
RTL Group Central and Eastern Europe S.A.
Russel and Thomson Finance and Investments S.A.
Russel and Thomson Finance and Investments S.A.
Russel and Thomson Finance and Investments S.A.
Sachverständigenbüro Jakoby S.à r.l.
Sagical S.A.
Samsonite International S.A.
SANZAR Europe S.à r.l.
Satpo-Peakside JV Co S.à r.l.
SCEM Reinsurance
Schräinerei Conrardy Succ. Jacques & Thorn S.à r.l.
SciPharm S.à r.l.
S.C.I Village de Mance
S.C.I. Ville de Cognac
SD SL S.à r.l.
Sea-Invest Afrique S.A.
Securinvest S.à r.l.
SeeReal Technologies S.A.
Select Invest S.à r.l.
Selm Holding International S.A.
SG Management S.A.
Shane Corporation S.à r.l.
Small S.à r.l.
Smart Holding Group S.A.
Smat's
Smat's
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.
Sobepart S.A.
Société de Participations Immobilières S.à r.l.
Société Financière Saka S.A., SPF
Sofilec
SOFT4U S.A.
Solubat S.à r.l.
SPU Holding S.à r.l.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
Stofan
Stofan
Stoker Luxembourg S.à r.l.
Symbihome
Threadneedle (Lux)