This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1286
15 juin 2011
SOMMAIRE
21social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61687
ABS Finance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61694
Affiliated Computer Services Holdings
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61694
AI Silver S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61688
AI Sub Silver S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61693
Alamo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61685
Alamo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61694
Almalux Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61695
Almalux Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61695
Alt Properties Mediterranean S.à r.l. . . . .
61682
Anglo American Investments 6 . . . . . . . . . .
61696
APTEA Hungary Liquidity Management Li-
mited Liability Company, Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61696
Art Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61693
Asia Eateries Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . .
61693
Asia Eateries Investments Sàrl . . . . . . . . . .
61694
Autospace S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61709
Banque de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
61720
Barwest Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
61724
Bath House S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61720
Belux-Automobile S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
61728
Blue Chip Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61696
Boca Chica S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61710
Business Lab Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
61693
Celius S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61685
Challenger Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
61697
Citi Islamic Portfolios S.A. . . . . . . . . . . . . . .
61706
DH Palos Immobilien- und Projectentwic-
klungs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61717
energie-pass.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61688
Fredifra- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61720
Giordano S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61724
Gottex Real Asset Fund 1 (Waste US) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61697
g + p muller architectes S.àr.l. . . . . . . . . . . .
61724
hcommunications S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61688
Holding Laupraal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61716
Immobilière Maritime Méditérranéenne
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61728
Iris Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61687
JO.C. Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61687
LUXREAL Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61721
luxvision SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61685
Palos International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
61717
Pilot Project Software S.A. . . . . . . . . . . . . . .
61710
Tonal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61695
Treveria Forty-Five S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
61709
Venergie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61688
Vfive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61686
VIATHEN r & d S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61725
Wattwerk Energiekonzepte S.A. . . . . . . . .
61709
Willow Tree S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61684
WPP Luxembourg Germany Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61689
Yalu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61687
61681
L
U X E M B O U R G
Alt Properties Mediterranean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.957.850,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 152.389.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of March .
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Altay Endüstriyel Yatirimlar Ve Ticaret A.S., a Joint stock company established under Turkish commercial law, having
its registered office at Esat Caddesi N°19, Bakanliklar 06640 Ankara (Turkey ), registered with the Ankara Chamber of
Commerce under number 68211, here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address in
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney, given on March 28
th
, 2011.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state that it is the sole
shareholder of the company "ALT PROPERTIES MEDITERRANEAN S.à r.l.” a“société à responsabilité limitée”, having
its registered office in L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, incorporated under Luxembourg law by a deed of April
1
st
, 2010 of notary Maître Joseph ELVINGER, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 18
th
, 2010 under number 1037. The articles of incorporation
were amended for the last time by a deed of the undersigned notary, dated December 30
th
, 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on March 24
th
, 2011 under number 548.
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the Company’s corporate capital to the extent of seven million seven hundred and forty-four thousand
nine hundred Euros (EUR 7.744.900) to raise it from its present amount of six million two hundred and twelve thousand
nine hundred and fifty Euros (EUR 6.212.950.-) to thirteen million nine hundred and fifty-seven thousand eight hundred
and fifty Euros (EUR 13.957.850) by creation and issue of seven million seven hundred and forty-four thousand nine
hundred (7.744.900) new shares (the New Shares), all having a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each.
2. Amendment of article 6, first paragraph of the Company’s articles of association which shall henceforth read as
follows:
“ Art. 6. First paragraph. The company has an issued capital of thirteen million nine hundred and fifty-seven thousand
eight hundred and fifty Euros (EUR 13.957.850) represented by:
- thirteen million nine hundred and fifty-seven thousand eight hundred and fifty (13.957.850) shares with a nominal
value of one euro (EUR 1,-) each.”
II) The sole shareholder then passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the corporate capital to the extent of seven million seven hundred and forty-
four thousand nine hundred Euros (EUR 7.744.900) to raise it from its present amount of six million two hundred and
twelve thousand nine hundred and fifty Euros (EUR 6.212.950) to thirteen million nine hundred and fifty-seven thousand
eight hundred and fifty Euros (EUR 13.957.850) by creation and issue of seven million seven hundred and forty-four
thousand nine hundred (7.744.900) new shares (the New Shares), all having a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each.
The increase in the capital will be carried out through a conversion of a receivable amounting to EUR 7.744.900 (seven
million seven hundred and forty-four thousand nine hundred Euros) held by the sole shareholder towards the company.
<i>Second resolutioni>
Thereupon Altay Endüstriyel Yatirimlar Ve Ticaret A.S., prenamed, represented by Mrs Isabel DIAS, prenamed, by
virtue of the proxy given on March 28
th
, 2011, declared to subscribe to the seven million seven hundred and forty-four
thousand nine hundred (7.744.900) new shares having a par value of EUR 1,-(one Euro) each, and to pay them up by
irrevocable waiver of its receivable against the company, the receivable being waived up to EUR 7.744.900 (seven million
seven hundred and forty-four thousand nine hundred Euros).
The reality and the value of the receivable have been shown to the notary by relevant documents.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution the meeting decides to amend the first paragraph of article 6 of the
articles of incorporation, which shall be worded as follows:
61682
L
U X E M B O U R G
“ Art. 6 (1
st
paragraph). The Company has an issued capital of thirteen million nine hundred and fifty-seven thousand
eight hundred and fifty Euros (EUR 13.957.850) represented by thirteen million nine hundred and fifty-seven thousand
eight hundred and fifty (13.957.850) shares with a par value of one Euro (1.-EUR) each.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at four thousand five hundred Euros (EUR 4.500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mil onze, le trente mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Altay Endüstriyel Yatirimlar Ve Ticaret A.S., une Joint stock company, constituée sous la loi turque, établie et ayant
son siège social à Esat Caddesi N°19, Bakanliklar 06640 Ankara (Turqui e), inscrite au registre de commerce d’Ankara
sous le numéro 68211, ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à
L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d’une procuration établie le 28 mars 2011.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de constater qu’elle est l’associé unique
de la société "ALT PROPERTIES MEDITERRANEAN S.à r.l.” une “société à responsabilité limitée” de droit luxembour-
geois établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, constituée par un acte du notaire Maître
Joseph ELVINGER, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER du 1
er
avril 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 18 mai 2010 sous le numéro 1037. Les statuts de la société ont été modifies pour
la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations le 24 mars 2011 sous le numéro 548.
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social de la société pour un montant de sept millions sept cent quarante-quatre mille neuf
cents Euros (7.744.900.-EUR) pour l’augmenter de son montant actuel de six millions deux cent douze mille neuf cent
cinquante Euros (6.212.950 .-EUR) à un montant de treize millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent cinquante
Euros (13.957.850 .-EUR) par la création et l’émission de sept millions sept cent quarante-quatre mille neuf cent
(7.744.900) nouvelles parts sociales (les Nouvelles Parts Sociales), d’une valeur nominale d’un Euro (1.-EUR) chacune.
2.- Modification de l’article 6, premier paragraphe, des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Premier paragraphe. La société a un capital souscrit de treize millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent
cinquante Euros (13.957.850 .-EUR), représenté par de treize millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent cinquante
(13.957.850) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (1.-EUR) chacune.»
3.- Divers
II) L’associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant d’EUR 7.744.900.-(sept millions sept cent
quarante-quatre mille neuf cents Euros), de sorte à l’augmenter de son montant actuel d’EUR 6.212.950.-(six millions
deux cent douze mille neuf cent cinquante Euros) à la somme d’EUR 13.957.850.-(treize millions neuf cent cinquante-sept
mille huit cent cinquante Euros) par la création et l’émission de 7.744.900 (sept millions sept cent quarante-quatre mille
neuf cent) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale d’EUR 1.-(un Euro) chacune.
L’augmentation de capital sera réalisée par la conversion d’une créance de la somme d’EUR 7.744.900.-(sept millions
sept cent quarante-quatre mille neuf cents Euros) que l’associé unique détient envers la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Sur ce, Altay Endüstriyel Yatirimlar Ve Ticaret A.S., prénommée, ici représentée par Madame Isabel DIAS, prénommée,
en vertu d’une procuration donnée le 28 mars 2011, a déclaré souscrire les 7.744.900 (sept millions sept cent quarante-
quatre mille neuf cents) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale d’EUR 1.-(un Euro) chacune, et de les payer
61683
L
U X E M B O U R G
par la renonciation irrévocable à sa créance envers la société, la créance étant évaluée à la somme de 7.744.900.-Euros
(sept millions sept cent quarante-quatre mille neuf cents Euros).
La preuve de l’existence et la valeur de la créance ont été justifiées au notaire instrumentaire par des documents
pertinents.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article
6 des statuts comme suit:
« Art. 6. (1
er
paragraphe). La société a un capital souscrit de treize millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent
cinquante Euros (13.957.850.-EUR), représenté par treize millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent cinquante
(13.957.850) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (1.-EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ quatre mille cinq cents Euros (EUR 4.500.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instru-
mentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 avril 2011. LAC/2011/16093. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): p.d. Tom Benning.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2011.
Référence de publication: 2011049584/133.
(110055804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
Willow Tree S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.204.
<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique datées du 20 avril 2011i>
1. Monsieur Hector Pedro POLI a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Hector Alfredo POLI a démissionné de son mandat de gérant.
3. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.
4. Monsieur Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né à Bassano del Grappa (Italie), le 3 septembre 1971,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme
gérant pour une durée indéterminée.
5. Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
pour une durée indéterminée.
6. Le nombre des gérants a été augmenté de 2 (deux) à 3 (trois).
Luxembourg, le 28 avril 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Willow Tree S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011058485/24.
(110065699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.
61684
L
U X E M B O U R G
Celius S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 36.520.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011053633/9.
(110060502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Alamo Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.929.
Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2011.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011053599/12.
(110060320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
luxvision SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 157.226.
L'an deux mille onze, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
a comparu:
La société à responsabilité limitée "HABECO SARL", (matricule 2009 2409 709), ayant son siège social à L-9051
Ettelbruck, 62-64, Grand-Rue,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 145.733,
représentée par son gérant unique Monsieur Henri BOULMONT, maître-opticien, né à Luxembourg le 26 décembre
1960 (matricule 1960 12 26 114), demeurant à L-7730 Colmar-Berg, 14, rue de la Poste.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique représentant l'intégralité du
capital social de la société à responsabilité limitée «luxvision SARL», (matr. 2010 2443 412), avec siège social à L-9638
Pommerloch, 19, route de Bastogne, «Shopping Center KNAUF»,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 154 du 26 janvier 2011,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 157.226,
a ensuite requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) pour
le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €) à un montant de quinze mille euros
(15.000,00 €) par l'augmentation de la valeur nominale des 100 parts sociales existantes de sorte que celle-ci passe de
cent vingt-cinq euros (125 €) à cent cinquante euros (150,00 €).
<i>Souscription et Libération du capitali>
La société à responsabilité limitée HABECO SARL, précitée, associée unique, déclare souscrire entièrement à l'aug-
mentation de capital susvisée, par l'apport en nature d'une branche d'activités autonome représentée par son magasin
exploité à Pommerloch.
La branche d'activités apportée en exonération de TVA a été valorisée sur base d'une situation comptable établie pour
le magasin de Pommerloch au 31 décembre 2010 et d'une attestation émanant de la Fiduciaire Cabexco SARL avec siège
à L-8080 Bertrange, Centre Helfent, 1, rue Pletzer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 139.890, chargée de l'établissement des comptes en question.
L'apport de la branche autonome d'activités est évalué à un montant de quinze mille trois cent trente-cinq euros
quatre-vingt-dix cents (15.335,90 €) dont deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) est apporté en capital et le solde, soit
61685
L
U X E M B O U R G
douze mille huit cent trente-cinq euros quatre-vingt-dix cents (12.835,90 €), inscrit en compte courant associé de HA-
BECO SARL.
Ladite attestation et situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instru-
mentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Eu égard à l'apport fait à la valeur nette comptable au 31 décembre 2010, la comparante déclare que toutes les
opérations financières et comptables réalisées à compter du 1
er
janvier 2011 et jusqu'à la date de la présente augmentation
de capital, seront réalisées au profit de luxvision SARL.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (15.000,00 €), divisé en cent (100) parts sociales
de cent cinquante euros (150,00 €) chacune.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et Contre le financement du terrorismei>
L'associée déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent euros (800,00 €).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. BOULMONT, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 25 mars 2011. DIE/2011/3027. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): J. Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME
Ettelbruck, le 5 avril 2011.
Pierre PROBST
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2011050665/68.
(110055668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
Vfive S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 118.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2011.
Nationwide Management S.A.
<i>Administrateur de la société
i>Richard Turner
<i>Administrateur et représente permanentei>
Référence de publication: 2011053577/14.
(110059734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.
61686
L
U X E M B O U R G
Iris Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 153.096.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de notre société, que l'actionnaire a décidé en date du 13 avril 2011:
- De nommer Monsieur Olivier VARIOT, demeurant au chemin du Frêne n°9, CH-1004 Lausanne, SUISSE, aux fonc-
tions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société et cela avec effet immédiat.
Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Olivier VARIOT expireront lors de l'assemblée
générale statutaire de 2015.
Le Conseil d'administration se compose désormais des personnes suivantes:
- Monsieur Gérard GEIER
- Monsieur Olivier VARIOT
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011058585/20.
(110064455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.
Yalu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 14.209.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2011053578/13.
(110059736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.
21social, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 152.306.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2011053580/11.
(110059683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.
JO.C. Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6585 Steinheim, 11, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 97.566.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 07 juin 2010.i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs actuels à savoir:
- Monsieur Claude JOHANN, administrateur-délégué, demeurant à L-6585 Steinheim 11 route d'Echternach
- Madame Ruthild RAUSCHER demeurant à L-6585 Steinheim 11 route d'Echternach.
- Monsieur Robert FRANK demeurant à L-5760 Hassel 1 rue de Luxembourg,
61687
L
U X E M B O U R G
leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes:
Société Luxembourgeoise de Révision Sàrl, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1220 Luxembourg 246,
rue de Beggen son mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
JOHANN Claude / RAUSCHER Ruthild / FRANK Robert.
Référence de publication: 2011058668/20.
(110064984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.
energie-pass.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8550 Noerdange, 15, Dikrecherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 145.263.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le géranti>
Référence de publication: 2011053583/10.
(110060633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
hcommunications S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 154, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 144.239.
EXTRAIT
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement des Actionnaires le 8 avril 2011, l’Assemblée a pris,
entre autres, la résolution suivante:
Le siège social de la société est transféré du 15, rue des Bains L-1212 Luxembourg au 154, Avenue du X Septembre
L-2550 Luxembourg avec effet au 7 avril 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011053584/13.
(110060481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
AI Silver S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.776.
Au conseil d'Administration
Je soussigné, Francesco Moglia suis au regret de vous informer que, je ne serai plus en mesure d'assumer les fonctions
d'administrateur de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Francesco Moglia.
Référence de publication: 2011053586/11.
(110060490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Venergie S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 149.327.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises en date du 31 mars 2011, que:
La société Luxembourg Marine Accounting S.A., ayant son siège social au 63-65, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 111 369, représentée par
Monsieur Koenraad Helon, né le 15 février 1974 à Lokeren, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 8, Kon.
Boudewijnlaan, 9160 Lokeren, Belgique a été élu aux fonctions d'administrateur pour une période d'une année, avec effet
61688
L
U X E M B O U R G
immédiat, en remplacement de Monsieur Mads Nannestad Moeller, administrateur et administrateur délégué démission-
naire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011058753/20.
(110065086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.
WPP Luxembourg Germany Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.550.000,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 148.398.
In the year two thousand and eleven, on the sixth day of January, before Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Luxembourg Germany Holdings
S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having
a share capital of EUR 22,650,000 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under the number B 148398 (the Company). The Company was incorporated on 28 Sep-
tember 2009 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2037 of 17 October 2009.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 17 December 2009 pursuant to a deed
of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, which deed has been published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 407 of 25 February 2010.
THERE APPEARS:
NFO (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, having a share capital of EUR 41,793,775 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 94757 (the Sole Shareholder).
hereby represented by Lynn Elvinger, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on the name and on behalf of the Sole
Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.
The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all of the 22,650,000 (twenty-two million six hundred and fifty-thousand) shares
having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each in the share capital of the Company amounting to EUR 22,650,000
(twenty-two million six hundred and fifty-thousand Euro);
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 21,900,000 (twenty-one million nine hundred
thousand Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to EUR 44,550,000 (forty-
four million five hundred and fifty thousand Euro), by way of the issuance of 21,900,000 (twenty-one million nine hundred
thousand) new shares of the Company having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the New Shares), together with
share premium;
3. Subscription to and payment in kind of the share capital increase specified under item 2. above;
4. Subsequent amendment of article 4, paragraph 1, of the articles of association of the Company in order to reflect
the increase of the share capital specified under item 2. above;
5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power and
authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to proceed
in the name and on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company of the New Shares,
and to see to any formalities in connection therewith; and
6. Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
61689
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR
21,900,000 (twenty-one million nine hundred thousand Euro) in order to bring the share capital of the Company from
its present amount of EUR 22,650,000 (twenty-two million six hundred and fifty-thousand Euro) to an amount of EUR
44,550,000 (forty-four million five hundred and fifty thousand Euro), by way of the issuance of the New Shares.
<i>Third resolutioni>
The Meeting records the following subscription to and payment for the New Shares:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to the 21,900,000 New Shares
and (ii) fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of 184 (one hundred and eighty-four) ordinary shares,
numbered 1 up to and including 184, having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each (the Shares) of WPP
Marketing Communications Germany B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated under
the laws of the Netherlands but German tax resident, with registered office at Karperstraat 10, 1075KZ Amsterdam, the
Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under the
number 34161051.
The Shares are contributed at their fair market value, i.e. an aggregate value of EUR 219,000,000 (two hundred and
nineteen million Euro), which shall be allocated as follows:
(i) EUR 21,900,000 (twenty-one million nine hundred thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company; and
(ii) EUR 197,100,000 (one hundred and ninety-seven million one hundred thousand Euro) is to be allocated to the
share premium reserve of the Company.
The ownership, transferability and valuation of the Shares contributed to the Company are supported by a certificate
issued by the management of the Sole Shareholder and countersigned by the management of the Company (the Certifi-
cate).
A copy of the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting in the name and on behalf of
the Sole Shareholder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.
The Meeting resolves to record that the shareholding of the Company is, further to the above share capital increase,
as follows:
NFO (Luxembourg) S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44,550,000 shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 4, paragraph 1, of the Articles in order to reflect the above increase of the
share capital of the Company so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at EUR 44,550,000 (forty-four million five hundred and
fifty thousand Euro), represented by 44,550,000 (forty-four million five hundred and fifty thousand) shares having a nominal
value of EUR 1 (one Euro) each."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby
empowers and authorizes any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg to,
each acting individually under their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration
in the share register of the Company (including for the avoidance of any doubt the signature of said register) of the changes
mentioned under the second and third resolutions above, and to see to any formalities in connection therewith, if any.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately six thousand seven hundred euro (€ 6.700,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
61690
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le six janvier, par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'Associé Unique de WPP Luxembourg Germany
Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine,
L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 22.650.000 EUR et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148398 (la Société), constituée le 28
septembre 2009 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 2037 du 17 octobre 2009 et dont les statuts (les
Statuts) ont été modifiés le 17 décembre 2009 selon un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N°
407 du 25 février 2010.
A COMPARU:
NFO (Luxembourg) S.à r,l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6,
rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 41.793.775 EUR (l'Associé
Unique) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94757,
ici représentée par Lynn Elvinger, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'Associé
Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les 22.650.000 (vingt-deux millions six cent cinquante mille) parts sociales d'une
valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, dans le capital social de la Société s'élevant à 22.650.000 EUR (vingt-deux
millions six cent cinquante mille euros);
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 21.900.000 (vingt-et-un millions neuf cent mille euros)
afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel à 44.550.000 EUR (quarante-quatre million cinq cent
cinquante mille euros), par voie d'émission de 21.900.000 (vingt-et-un millions neuf cent mille) nouvelles parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune (les Nouvelles Parts Sociales), ensemble avec une
prime d'émission;
3. Souscription et payement par apport en nature de l'augmentation de capital social mentionnée sous le point 2. ci-
dessus;
4. Modification consécutive de l'article 4, paragraphe 1, des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation du
capital social mentionnée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des parts sociales de la Société de manière à y refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg de
procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société des
Nouvelles Parts Sociales, et d'accomplir toutes formalités y relatives.
6. Divers.
III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de
convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par les présentes le capital social de la Société d'un montant de
21.900.000 (vingt-et-un millions neuf cent mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel
de 22.650.000 EUR (vingt-deux millions six cent cinquante mille euros) à 44.550.000 EUR (quarante-quatre million cinq
cent cinquante mille euros), par la voie d'émission des Nouvelles Parts Sociales.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée enregistre la souscription et le payement pour les Nouvelles Parts Sociales comme suit:
61691
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare par les présentes de (i) souscrire aux 21.900.000 Nou-
velles Parts Sociales et de (ii) les libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en 184 (cent quatre-
vingt-quatre) parts sociales ordinaires portant les numéros 1 à 184 inclus, ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent
euros) chacune (les Parts Sociales) de WPP Marketing Communications Germany B.V., une société à responsabilité limitée
(besloten vennootschap) constituée sous les lois des Pays-Bas mais résidente fiscale en Allemagne, ayant son siège social
au Karperstraat 10, 1075 KZ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre de Commerce (Kamer van Koo-
phandel) sous le numéro 34161051.
Les Parts Sociales sont apportées à leur valeur de marché, i.e. un montant total de 219.000.000 EUR (deux cent dix-
neuf millions euros), qui seront attribuées comme suit:
(i) 21.900.000 EUR (vingt-et-un millions neuf cent mille euros) seront attribués au compte de capital social de la Société;
et
(ii) 197.100.000 (cent quatre vingt dix-sept millions cent mille euros) seront attribués au compte de prime d'émission
de la Société.
La propriété, la cessibilité et la valeur des Parts Sociales apportées à la Société sont certifiées par un certificat émis
par l'organe de gestion de l'Associé Unique et contresigné par l'organe de gestion de la Société (le Certificat).
Une copie du Certificat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de
l'Associé Unique et par le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumise aux formalités d'en-
registrement.
L'Assemblée décide d'enregistrer que la participation de la Société est, suite à l'augmentation de capital social ci-dessus,
composée comme suit:
NFO (Luxembourg) S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.550.000 parts sociales
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 4, paragraphe 1, des Statuts afin d'y refléter l'augmentation de capital social
de la Société ci-dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
" Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 44.550.000 EUR (quarante-quatre millions cinq cent cinquante
mille euros), représenté par 44.550.000 (quarante-quatre millions cinq cent cinquante mille) parts sociales ordinaires
d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de manière à refléter les modifications qui
précèdent et donne pouvoir et autorisé tout gérant de la Société ou tout avocat ou employé de Allen & Overy Luxembourg
à procéder individuellement sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société, à l'inscription dans le registre
des parts sociales de la Société (en ce compris pour éviter toute ambiguité la signature dudit registre) des modifications
décidées sous les deuxième et troisième résolutions ci-dessus, et d'accomplir le cas échéant toutes les formalités y
relatives.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et frais qui seront supportés par la Société en conséquence du présent
acte est estimé à environ six mille sept cents euros (€ 6.700,-).
Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, il est
également précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
En foi de quoi, le présent acte notarial a été passé à Luxembourg au jour mentionné au début de l'acte.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Elvinger, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2011. Relation: EAC/2011/687. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011049121/204.
(110054676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.
61692
L
U X E M B O U R G
Business Lab Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 87.017.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2011.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011053628/12.
(110060386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
AI Sub Silver S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.771.
Au conseil d'Administration
Je soussigné, Francesco Moglia suis au regret de vous informer que, je ne serai plus en mesure d'assumer les fonctions
d'administrateur de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Francesco Moglia.
Référence de publication: 2011053587/11.
(110060489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Art Conseil, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 143.535.
<i>Extrait du Procès-verbal l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Steinsel le vendredi 18 mars 2011 à 16 heuresi>
<i>Résolutionsi>
<i>Troisième résolution:i>
Election de Monsieur Eric Coatalem en tant que membre du conseil d’administration pour une période de deux ans,
son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale devant se tenir en 2013.
Monsieur Eric Coatalem demeure professionnellement au 93, Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris.
Cette résolution est mise au vote et recueille l’unanimité.
Référence de publication: 2011053590/14.
(110060077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Asia Eateries Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.824.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société Asia Eateries Holdings S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Jacques Delvaux en date
du 12 août 2010, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 1
er
octobre
2010.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société Theatre Direc-
torship Services Alpha S .à r.l., au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2011.
Référence de publication: 2011053591/16.
(110060505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
61693
L
U X E M B O U R G
Alamo Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.929.
Le bilan modifié au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ce bilan remplace celui déposé le 1
er
juillet 2010 sous la référence L100094021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2011.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011053600/13.
(110060321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Asia Eateries Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.852.675,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.825.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société Asia Eateries Investments S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Jacques Delvaux en
date du 12 août 2010, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 1
er
octobre 2010.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société Theatre Direc-
torship Services Alpha S.à r.l., au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2011.
Référence de publication: 2011053592/16.
(110060504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
ABS Finance Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 68.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ABS Finance Fund
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011053597/14.
(110060496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 114.263.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 13 avril 2011.i>
En date du 13 avril 2011 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de John Andrew London, en tant que gérant de la Société et ce avec effet rétroactif au 21
mars 2011.
61694
L
U X E M B O U R G
- de nommer, Stuart Kirk, né le 6 juillet 1960 à Dublin (Irlande), demeurant professionnellement au Ballycoolin Business
Park, Blanchardstown, Dublin 15 (Irlande), en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet
rétroactif au 21 mars 2011.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants:i>
- Anthony Mark Lewis
- Donna Reeves
- Stuart Kirk
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 2011.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011058551/24.
(110064408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.
Almalux Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 59.892.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2011053602/11.
(110060058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Almalux Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 59.892.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2011053603/11.
(110060061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Tonal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 125.505.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2011,
enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2011, LAC/2011/12986.
Qu’a été prononcée la clôture de la liquidation de la Société à responsabilité limitée «TONAL S.A.», ayant son siège
social à L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 125.505.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 23 décembre 2010, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.
61695
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2011.
Référence de publication: 2011058467/22.
(110066045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.
Anglo American Investments 6, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 122.491.
II résulte du transfert des parts sociales en date du 6 avril 2011 que:
ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège â 20 Carlton House Terrrace, Lon-
dres SW1Y 5AN, Royaume-Uni, a transféré le 6 avril 2011, 1.000 parts sociales de la Société à ANGLO AMERICAN
FERROUS INVESTMENTS Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
A.F. Pace-Bonello
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011053605/15.
(110060028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Blue Chip Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 136.768.
<i>Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschafti>
Anwesend sind:
Herr Guillaume Hubertus POMME, Vorsitzender des Verwaltungsrates
Herr Franz SIGL, Verwaltungsratsmitglied
Die Verwaltungsräte der Blue Chip Europe S.A. halten eine Versammlung ab. und beschließen folgendes:
Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt von
4, Rue Jean Brasseur
L- 1258 Luxembourg
nach
21 Rue de Hollerich
L- 1741 Luxembourg
14.01.2011.
Guillaume POMME / Franz SIGL.
Référence de publication: 2011055026/19.
(110061116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.
APTEA Hungary Liquidity Management Limited Liability Company, Luxembourg Branch, Succursale
d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.181.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
En date du 28 février 2011, A& P Bermuda Limited, la société APTE A Hungary Liquidity Management Limited Liability
Company a décidé de fermer sa succursale avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2011.
Référence de publication: 2011053606/13.
(110060507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
61696
L
U X E M B O U R G
Challenger Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 48.598.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2011i>
- Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
1. Alexis THALER, directeur, demeurant 32, Avenue Hoche, F-75008 Paris;
2. Philippe RENAUD, directeur financier, demeurant 147 ter, boulevard de la Reine, F-78000 Versailles;
3. Eric FORT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
4. Serge KRANCENBLUM, diplômé MBA, demeurant à Luxembourg.
- La personne suivante est nommée réviseur d'entreprises agréé:
Société MAZARS S.A., représentée par Monsieur Philippe SLENDZAK, 10A rue Henri M. Schnadt, L - 2530 Luxem-
bourg.
- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
Fait à Luxembourg, le 8 avril 2011.
Certifié sincère et conforme
CHALLENGER LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2011057071/21.
(110064702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.
Gottex Real Asset Fund 1 (Waste US) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 160.010.
In the year two thousand and eleven, on the twenty third day of March.
Before, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
Gottex Real Asset Fund 1 (Luxembourg) SV S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, qualifying as a securitisation company within the mean-
ing of the Luxembourg law of 22 March 2004 on securitisation, having its registered office at L-2346 Luxembourg, 20,
rue de la Poste, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS), under number B 139777,
with a share capital of USD 20,000.-;
here represented by Me Bertrand MARIAUX, lawyer, residing professionally at 18-20 rue Edward Steichen, L-2520
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, delivered to him.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Gottex Real Asset Fund 1 (Waste US) S.à r.l.” (the Company). The
Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accor-
dance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
61697
L
U X E M B O U R G
measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other parti-
cipation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at USD 20,000.-(twenty thousand United States Dollars) represented by 10,000 (ten
thousand) shares in registered form, having a par value of USD 2 (two United States Dollars) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable between shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their mandate.
The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers.
If several managers are appointed, they constitute the board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
61698
L
U X E M B O U R G
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object
of the Company.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place
indicated in the convening notice.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
61699
L
U X E M B O U R G
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholder(s) towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.2 The operations of the Company are supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entre-
prises agréés), when so required by law.
14.2 The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises agréés, if any, and determine their number, remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises agréés may be re-
appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the issued share
capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by the majority of the
shareholders holding at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
61700
L
U X E M B O U R G
Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original
or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
Gottex Real Asset Fund 1 (Luxembourg) SV S.à r.l., represented as stated above, subscribes to all the 10,000 (ten
thousand) shares in registered form, having a par value of USD 2.- (two) United States Dollars each, and agrees to pay
them in full by a contribution in cash in the amount of USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) which is at
the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Joachim Walter Gottschalk, Chairman and Chief Executive Officer of Gottex Fund Management, born in Munich,
Germany on January 1, 1947, whose professional address is at Avenue de Rhodaine 48, Lausanne 1007, Switzerland;
- Timothy Stephen Roniger, Chartered Accountant and Chief Financial Officer of Gottex Fund Management, born in
Johannesburg, South Africa, on May 30, 1961, whose address is at Avenue de Rhodaine 48, Lausanne 1007, Switzerland;
and
- Benoni Dufour, civil engineer, born in Ostend, Belgium on July 11, 1957, whose professional address if at 15, Op der
Sank, L-5713 Aspelt, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
3. Ernst & Young, the public limited liability company (société anonyme) with registered office at 7 rue Gabriel Lippman,
Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Münsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, is appointed as external approved auditor of
the Company for a period of 6 years.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the
English text and the French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-trois mars,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
61701
L
U X E M B O U R G
A COMPARU:
Gottex Real Asset Fund 1 (Luxembourg) SV S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
qualifiée de société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, et dont le siège social se
situe au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (RCS) sous le numéro B 139777, ayant un capital de USD 20.000,-
représentée par Maître Bertrand MARIAUX, avocat, avec adresse professionnelle à 18-20 rue Edward Steichen, L-2520
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Gottex Real Asset Fund 1 (Waste US) S.à r.l." (la Société). La
Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'affectent pas la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment
acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
61702
L
U X E M B O U R G
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à USD 20.000,-(vingt mille dollars américain), représenté par 10.000 (dix mille) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de USD 2,-(deux dollars américain) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de tout associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société le sollicitera ou sur convocation de tout gérant,
quelqu'il soit, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
61703
L
U X E M B O U R G
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par la seconde Assemblée Générale ou par
Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social
représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
61704
L
U X E M B O U R G
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois
suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité en nombre
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
peuvent ne pas être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
Art. 17.
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2011.
<i>Souscription et Libérationi>
Gottex Real Asset Fund 1 (Luxembourg) SV S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 10.000
(dix mille) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de USD 2,-(deux dollars américains) chacune, et
61705
L
U X E M B O U R G
de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de USD 20.000,-(vingt mille dollars américains),
qui est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à 1.300,EUR.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Joachim Walter Gottschalk, Chairman et Chief Executive Officer de Gottex Fund Management, né à Munich, en
Allemagne le 1
er
janvier 1947, demeurant professionnellement à Avenue de Rhodaine 48, Lausanne 1007, Suisse;
- Timothy Stephen Roniger, Chartered Accountant et Chief Financial Officer de Gottex Fund Management, né à Jo-
hannesburg, en Afrique du Sud, le 30 mai 1961 demeurant professionnellement à Avenue de Rhodaine 48, Lausanne 1007,
Suisse; et
- Benoni Dufour, ingénieur civil, né à Ostend, Belgique le 11 juillet 1957, demeurant professionnellement au 15, Op
der Sank, L-5713 Aspelt, Grand Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Ernst & Young, la société anonyme ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippman, Parc d'Activitè Syrdall 2, L-5365
Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une
durée de 6 ans.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Bertrand MARIAUX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2011. Relation GRE/2011/1264. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 4 avril 2011.
Référence de publication: 2011048060/501.
(110054010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.
Citi Islamic Portfolios S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 60.953.
In the year two thousand and eleven, on the thirty-first day of March.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "CITI ISLAMIC PORTFOLIOS S.A." (the "Company"),
a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 31 Zone d'Activités
Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a notarial deed enacted on 06 October 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial"), number 649 of 20 November 1997,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, number 60 953,
and the articles of incorporation of which have been amended pursuant to several notarial deeds and for the last time
been amended following a notarial deed enacted on 24 July 2006, which deed has been published in the Mémorial number
1794 of 26 September 2006.
The meeting is declared open with Mr Jean-Yves CORNEAU, employee, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Ms Laurence KREICHER, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Olivier LANSAC, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
61706
L
U X E M B O U R G
(i) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1 Deliberation on the dissolution in anticipation and the liquidation of the Company.
2 Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3 Miscellaneous
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital of one hundred seventy thousand United States Dollars (170'000.- USD) being
present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have
had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting RESOLVED to dissolve in anticipation the Company and put it into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The meeting RESOLVED to appoint as sole liquidator of the Company:
the company "PKF ABAX Audit S.A.", a société anonyme established and having its registered office at 6 Place de
Nancy, L-2212 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 142 867).
<i>Third resolutioni>
The meeting RESOLVED that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any
act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation
provided said action is necessary or useful for the liquidation of the Company.
The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third
parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders
such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions provided the delegation of powers
is necessary or useful for the liquidation of the Company.
The Company in liquidation shall be validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature
of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to
speak, the Chairman then closed the meeting.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on the date named at the
beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil
status and residence, said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le trente et un mars.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «CITI ISLAMIC PORTFOLIOS
S.A.» (la «Société»), une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 31
Zone d'Activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant un acte notarié dressé en date du 6 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), numéro 649 du 20 novembre 1997,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 60 953,
61707
L
U X E M B O U R G
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 24 juillet
2006, lequel acte fut publié au Mémorial en date du 26 septembre 2006, sous le numéro 1794.
L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Yves CORNEAU, employé privé, demeurant à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence KREICHER, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier LANSAC, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant d'acter:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Délibération sur la dissolution anticipée de la Société et sur sa mise en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants
resteront pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social d'un montant de cent soixante-dix mille Dollars US (170'000.- USD) étant présente
ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a DÉCIDÉ la dissolution anticipée de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a DÉCIDÉ de nommer en qualité de seul liquidateur de la Société:
la société «PKF ABAX Audit S.A.». une société anonyme établie et ayant son siège social au 6 Place de Nancy, L-2212
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 142 867).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée a DÉCIDÉ que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature
ou l'importance des opérations en question sous condition que ces actes soient nécessaires ou utiles à la liquidation de
la Société.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers sous condition que la délégation
de ces pouvoirs soit nécessaire ou utile à la liquidation de la Société.
La Société en liquidation sera valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,
pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président ensuite clôture l'assemblée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.Y. CORNEAU, L. KREICHER, O. LAUSAC, J.J. WAGNER.
61708
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1
er
avril 2011. Relation: EAC/2011/4416. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011049646/129.
(110055656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
Autospace S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3761 Tétange, 32, rue Thomas Byrne.
R.C.S. Luxembourg B 106.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011053612/10.
(110060483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Treveria Forty-Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 132.545.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant profes-
sionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants:i>
- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar
- Monsieur Jérôme Tibesar
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2011.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011058721/23.
(110064969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.
Wattwerk Energiekonzepte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 146.575.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 07. April 2011i>
<i>Erster Beschluss und Einziger Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den Beitritt von zwei zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedern, neben dem Verwaltungs-
ratsvorsitzenden Herrn Jürgen Gachot, wohnhaft im Rothland 14A in D-66787 Wadgassen, ab dem 27.04.2011.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ab dem heutigen Datum wird ernannt:
- Herr Stefan Weiskircher geboren am 13. Juli 1960 in Illingen (Deutschland), wohnhaft in der Schlanggasse 59, D-66578
Schiffweiler
und
- Herr Stefan Sommerlade geboren am 24. April 1965 in Dudweiler (Deutschland), wohnhaft in der Rilkestraße 5,
D-66399 Ormesheim
61709
L
U X E M B O U R G
Wattwerk Energiekonzepte S.A.
5c, route du Vin
L-5450 Stadtbredimus
Référence de publication: 2011058997/20.
(110065883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.
Boca Chica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2510 Strassen, 29, rue Schafsstrachen.
R.C.S. Luxembourg B 51.924.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 7 avril 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
BOCA CHICA S.à.r.l., en liquidation volontaire, avec siège social à L-2510 Strassen, 29, rue Schafsstrachen
Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Carole KUGENER et liquidateur Maître Carmen RIMONDINI,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 28 avril 2011 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Maître Carmen RIMONDINI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011055027/19.
(110061046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.
Pilot Project Software S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 159.805.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the ninth day of March.
Before us the undersigned Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- Zsolt Holding Aps, a company organized under the laws of Denmark, having its registered office in DK-2970 Hörs-
holm, Rungstedvej 26, registered under the number CVR 30582225 in the Danish register of companies “Erhverv og
Selskabsstyrelsen”,
here represented by Mr Alain Thill, private employee, professionally residing in L-6130 Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
- Tur Holding Aps, a company organized under the laws of Denmark, having its registered office in DK-1100 Copen-
hagen, Östergade 61, 4th floor, registered under the number CVR 28116055 in the Danish register of companies “Erhverv
og Selskabsstyrelsen”,
here represented by Mr Alain Thill, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
- Sune Olsen Holding Aps, a company organized under the laws of Denmark, having its registered office in DK-2100
Copenhagen, Jagtvej 169 B, registered under the number CVR 25372727 in the Danish register of companies “Erhverv
og Selskabsstyrelsen”,
here represented by Mr Alain Thill, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
- Geek Holding Aps, a company organized under the laws of Denmark, having its registered office in DK-2650 Hvidovre,
Ejstrupvej 11, registered under the number CVR 27280498 in the Danish register of companies “Erhverv og Selskabss-
tyrelsen”,
here represented by Mr Alain Thill, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing persons, voting under their given authority, announced the formation by them of a public limited
company, governed by the relevant law and present articles:
61710
L
U X E M B O U R G
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a public limited company (société anonyme) under the name of Pilot Project Software
S.A..
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office ad foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the Company is to carrying out of any commercial, industrial and financial operations, the
investment in and development of real estate and movable property and the investment in participating interests, of either
Luxembourg or foreign companies as well as the management, control and development of such participating interests.
The Company may directly or indirectly invest into the development of software and acquire software products with the
purpose of giving licences to commercial users. The Company may perform everything connected with the foregoing in
the widest sense of the word and the conduct of any business in connection therewith.
Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand eight hundred Euro (EUR 31,800) represented by three
hundred and eighteen (318) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100).
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
The shares can only be pledged with prior approval of all other shareholders.
The shares of an insolvent or bankrupt shareholder shall be offered to the remaining shareholders on a pro rata basis
in relation to their existing shareholding. The acquisition price for such shares of an insolvent or bankrupt shareholder
shall be equal to the net asset value per share as established by the auditor of the company.
In the event that any Shareholder desires to make a Transfer of all or part of its Shares, prior to transferring such
Shares to any Person, each Offering Shareholder shall deliver to the other shareholders a written notice (the “Sale
Notice”) setting forth the number of Shares the offering shareholder intends to Transfer and the per Share amount offered
by the proposed transferee for the Shares.
Following receipt of a Sale Notice, the other shareholders may accept the offered shares on a pro rata basis to their
existing shareholding for a price per Share equal to that offered by the proposed transferee to the offering Shareholder
(s) and on the terms offered by the proposed transferee(s) relating to the payment of the price and the applicable
conditions precedent, as such price and other terms shall be set forth in the Sale Notice by delivering a written notice
to the Offering Shareholder within thirty (30) Business Days of delivery of such Sale Notice (an “Election Notice”).
Provided that the other shareholders delivering the Election Notice (the “Accepting Shareholders”) have agreed to
purchase, in the aggregate, all of the offered shares, the Transfer of the proposed shares to the Accepting Shareholder
(s) shall be consummated no later than fifteen (15) Business Days after the expiration of the thirty (30) Business Day
period following the Sale Notice referred to in the foregoing provisions of this Section (or such longer period as is
necessary to obtain all requisite governmental and regulatory approvals and consents).
The offered shares shall in principle be offered to all other shareholders on a pro rata basis, but the other shareholders
are authorised freely to allocate the offered shares otherwise by unanimous decision among themselves, provided that
they agree to purchase, in the aggregate, all (but not less than all) of the offered shares and.
In the absence of exercise (or in case of waiver) by the other shareholders of their Right of First Refusal under the
conditions provided for herein, the Offering Shareholder(s) shall within 30 days transfer to the Person or Persons iden-
tified in the Sale Notice all (but not less than all) of the offered shares for a consideration not less than the consideration
(and on terms no less favorable to the Offering Shareholder than those) set forth in the Sale Notice.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a Board of directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
61711
L
U X E M B O U R G
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director
may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if all of its members are present or represented, a proxy between
directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote of at least 80%. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed by the joint signatures of the chairman of the board and any of the other
members of the board of directors.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Financial year - General meeting
Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It
has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Any decision to amend these articles require a quorum of at least 50 % of the shares issued by the Company and shall
require a majority vote of at least 51% of the shares represented at such meeting.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is subject to the provisions of the law (especially Art 72-2 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies) authorised to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on June 30 at 11.30 o’clock. If such June 30 is not a business day in Luxembourg the annual
general meeting shall be held at the last business day in June at 11.30.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositioni>
1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31
st
of December
2011.
2) The first annual general meeting will be held in the year 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed the shares as
follows:
- Zsolt Holding Aps, prenamed, one hundred and fifty-nine shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
- Tur Holding Aps, prenamed, fifty-three shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
- Sune Olsen Holding Aps, prenamed, fifty-three shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
- Geek Holding Aps, prenamed, fifty-three shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Total: three hundred and eighteen shares; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand eight hundred
Euro (EUR 31,800) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
61712
L
U X E M B O U R G
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand one hundred and
fifty Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Sebastian Szigethy, company director, born in Glostrup (Denmark) on the 10
th
of June 1968, residing in DK-2970
Hörsholm, Rundstedvej 26 (Denmark);
b) Mr Thomas Ulletved Rasmussen, company director, born in Roskilde (Denmark) on the 18
th
of March 1968, residing
in DK-1850 Frederiksberg, Gammel Kongevej 174, 4 (Denmark);
c) Mr Sune Olsen, company director, born in Korea on the 15
th
of September 1978, residing in DK-2680 Solröd
Strand, Hulvej 6 (Denmark);
d) Mr Casper Parkvist Hvidbjerg, company director, born in Copenhagen (Denmark) on the 30
th
of May 1974, residing
in DK-2650 Hvidovre, Ejstrupvej 11 (Denmark).
3) Has been appointed as chairman of the board:
Mr Sebastian Szigethy, prenamed.
4) Has been appointed as auditor:
The limited liability company PKF WEBER & BONTEMPS, with registered office in L-2212 Luxembourg, 6, Place de
Nancy, R.C.S. Luxembourg number B 135187.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2012.
6) The registered office is fixed in L-1341 Luxembourg, 9, Place Clairefontaine.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing parties and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, he signed together with the notary the
present deed.
Es folgt die deutsche Fassung der Urkunde:
Im Jahre zweitausend und elf, den neunten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
- Zsolt Holding Aps, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Dänemark, mit Sitz in DK-2970 Hörsholm,
Rungstedvej 26, einregistriert unter der Nummer CVR 30582225 im dänischen Gesellschaftsregister “Erhverv og Sels-
kabsstyrelsen”,
hierbei vertreten durch Herrn Alain Thill, Privatangestellter, wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
aufgrund einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;
- Tur Holding Aps, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Dänemark, mit Sitz in DK-1100 Kopenhagen,
Östergade 61, 4. Stock, einregistriert unter der Nummer CVR 28116055 im dänischen Gesellschaftsregister “Erhverv og
Selskabsstyrelsen”,
hierbei vertreten durch Herrn Alain Thill, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;
- Sune Olsen Holding Aps, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Dänemark, mit Sitz in DK-2100 Kopen-
hagen, Jagtvej 169 B, einregistriert unter der Nummer CVR 25372727 im dänischen Gesellschaftsregister “Erhverv og
Selskabsstyrelsen”,
hierbei vertreten durch Herrn Alain Thill, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;
- Geek Holding Aps, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Dänemark, mit Sitz in DK-2650 Hvidovre,
Ejstrupvej 11, einregistriert unter der Nummer CVR 27280498 im dänischen Gesellschaftsregister “Erhverv og Sels-
kabsstyrelsen”,
hierbei vertreten durch Herrn Alain Thill, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht.
Welche Vollmachten, vom Bevollmächtigten und dem Notar “ne varietur” unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigebogen um mit derselben hinterlegt zu werden.
61713
L
U X E M B O U R G
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
wie folgt zu beurkunden.
Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital
Art. 1. Unter der Bezeichnung Pilot Project Software S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktienge-
sellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche
geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung handelsbezogener, industrieller und finanzieller Geschäfte jeder
Art; alle mobiliaren und immobiliaren Geschäfte in Zusammenhang mit beweglichem oder unbeweglichem (Grund-) Ver-
mögen; der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form in anderen Gesellschaften und die Gewährung von Hilfeleistungen;
Darlehen oder Sicherheiten sowie der Erwerb von und der Handel mit Eigentumsrechten, die der Erfüllung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sind. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt in die Entwicklung von Software investieren oder
Softwareprodukte kaufen um Lizenzen an kommerzielle Nutzer zu vergeben. Die Gesellschaft kann jede Handlung in dem
weitesten Sinne des Wortes unternehmen, welche in Verbindung mit den oben erwähnten Aktivitäten stehen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend acht hundert Euro (EUR 31.800), eingeteilt in dreihundert
achtzehn (318) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Aktien können nur mit Zustimmung der anderen Aktionäre Verpfändet werden.
Die Aktien eines insolventen oder in Konkurs befindlichen Aktionärs sind den anderen Aktionären im Verhältnis zu
ihrer bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft anzubieten. Der Kaufpreis solcher Aktien ist auf den Nettoinventarwert
pro Aktie festzulegen und wird von dem Kommissar der Gesellschaft bestimmt.
Bevor ein Aktionär alle oder einen Teil seiner Aktien an einen Dritten veräußern kann, hat er den anderen Aktionären
eine schriftliche Mitteilung über den geplanten Verkauf (“Verkaufsmitteilung”) zukommen zu lassen aus dem hervorgeht
wie viele Aktien verkauft werden sollen und zu welchen Stückpreis der Käufer die Aktien übernehmen möchte.
Nach Erhalt einer Verkaufsmitteilung können die anderen Aktionäre innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Zugang
der Mitteilung die angebotenen Aktien in Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligung an der Gesellschaft zu dem gleichen
Kaufpreis und den gleichen Bedingungen wie in dem Kaufangebot des Interessenten erwerben.
Falls die anderen Aktionäre das Angebot annehmen sämtliche angebotene Aktien zu erwerben, ist die Aktienübertra-
gung innerhalb einer Frist von 15 Tagen zu vollenden.
Die angebotenen Aktien müssen in Prinzip im pro rata Verhältnis zu ihrer Bestehenden Beteiligung and er Gesellschaft
angeboten werden, aber die anderen Aktionäre sind mit einstimmiger Entscheidung befugt die Aktien frei unter sich
aufzuteilen vorausgesetzt sie übernehmen zusammen sämtliche angebotenen Aktien.
Falls das Kaufangebot von den anderen Aktionären nicht fristgerecht angenommen wird oder sie den Verzicht erklären,
hat der verkaufende Aktionär die angebotenen Aktien innerhalb von 30 Tagen zu den in der Verkaufsmitteilung angege-
benen Bedingungen an den angegebenen Interessenten zu verkaufen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem
anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn alle seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung
durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich er-
61714
L
U X E M B O U R G
folgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fern-
schreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einer Mehrheit von mindestens 80% der Stimmen gefaßt; bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Generalversammlung.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates zusammen mit
einem der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates verpflichtet.
Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden
Geschäftsjahr - Generalversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.
Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von den ge-
setzlichen Erfordernissen können abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 14. Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen
Beschlüsse gutzuheißen.
Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat nach Maßgabe des Gesetzes (insb. Des Artikels 72-2 des Ge-
setzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften) ausgeschüttet werden.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 30. Juni um 11.30 Uhr in Luxemburg, am Gesell-
schaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. Ist der 30. Juni kein Geschäftstag in Luxemburg
findet die Generalversammlung am letzten Geschäftstag vor dem 30. Juni statt.
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2011.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2012.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
- Zsolt Holding Aps, vorbezeichnet, einhundert neunundfünfzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
- Tur Holding Aps, vorbezeichnet, dreiundfünfzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
- Sune Olsen Holding Aps, vorbezeichnet, dreiundfünfzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
- Geek Holding Aps, vorbezeichnet, dreiundfünfzig Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Total: dreihundert achtzehn (318) Aktien; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den
Betrag von einunddreißigtausend acht hundert Euro (EUR 31.800) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
61715
L
U X E M B O U R G
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend einhundert fünfzig Euro.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Sebastian Szigethy, Geschäftsführer, geboren in Glostrup (Dänemark) am 10. Juni 1968, wohnhaft in DK-2970
Hörsholm, Rundstedvej 26 (Dänemark);
b) Herr Thomas Ulletved Rasmussen, Geschäftsführer, geboren in Roskilde (Dänemark) am 18. März 1968, wohnhaft
in DK-1850 Frederiksberg, Gammel Kongevej 174, 4 (Dänemark);
c) Herr Sune Olsen, Geschäftsführer, geboren in Korea am 15. September 1978, wohnhaft in DK-2680 Solröd Strand,
Hulvej 6 (Dänemark);
d) Herr Casper Parkvist Hvidbjerg, Geschäftsführer, geboren in Kopenhagen (Dänemark) am 30. Mai 1974, wohnhaft
in DK-2650 Hvidovre, Ejstrupvej 11 (Dänemark).
3) Zum ersten Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde ernannt:
Herr Sebastian Szigethy, vorgenannt.
4) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PKF WEBER & BONTEMPS, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de
Nancy, H.G.R. Luxemburg Nummer B 135187.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2012.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1341 Luxemburg, 9, Place Clairefontaine.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag der Komparentin, dass
diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Kompa-
rentin und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die Englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, hat derselbe gegenwärtige Urkunde
mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Alain Thill, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 2011. Relation GRE/2011/1084. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Junglinster, den 23. März 2011.
Référence de publication: 2011043353/334.
(110049098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2011.
Holding Laupraal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 134.383.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31.12.2009, tenue
en date du 18 avril 2011 que:
Sont réélus, en qualité d'Administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année
2016:
- Madame Mireille GEHLEN, Administrateur B, né le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au
412 F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, Administrateur B né à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412
F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Monsieur Pascal RAFFY, Administrateur A, né le 20 juillet 1963 à Beyrouth (Liban), demeurant demeurant à Gland,
Domaine Impérial, Résidence du Golf, CH-1196 Suisse.
61716
L
U X E M B O U R G
Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412 F, Route d'Esch,
L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 avril 2011.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011058935/25.
(110065853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.
Palos International S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DH Palos Immobilien- und Projectentwicklungs S.à r.l.).
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 90.634.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth of March.
Before Maître Léon Thomas known as Tom METZLER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
There appeared:
1) Mr. Gisbert DREYER, architect, born in Stuttgart (Germany), on March 20, 1943, residing professionally in D-80539
Munich, 10, Maximilianstrasse,
duly represented by Mr. Charles RUPPERT, director, residing in L-5433 Niederdonven, 59, rue des Romains,
by virtue of a proxy under private seal given on March 2
nd
, 2011.
2) Mrs. Jenny GSELL, Dipl.oec. Betriebs- und Volkswirtin und Soziologin, born in Jüterbog (Germany), on April 13,
1953, residing in D-13127 Berlin, 38, Schweizer Tal,
duly represented by Mr. Charles RUPPERT, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on March 3
rd
, 2011.
The said proxies, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The pre-said persons are the sole members of the company DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWIC-
KLUNGS, S.à r.l., having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Trade and
Companies Register of Luxembourg under the number B 90.634, incorporated by a deed received by Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 17, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, number 155 of February 14, 2003. The articles have been amended by virtue of a deed of the pre-said
notary Joseph Elvinger, on ... 2003, published in the Memorial C, on June 11, 2003, number 635, by virtue of a deed
received by the undersigned notary, on June 27, 2008, published in the Memorial C, on July 26, 2008, number 1843 and
by virtue of a deed received by the undersigned notary, on August 5, 2010, published in the Memorial C, on October 6,
2010, number 2094. (hereinafter referred to as the "Company").
Such appearing parties, represented as here above stated, in their capacity of sole members of the Company have
requested the undersigned notary to state their following resolutions:
<i>First resolutioni>
The members resolve to change the name of the Company in "PALOS INTERNATIONAL S.à r.l." and to change in
consequence article 2 of the articles of association of the Company as follows:
"The Company is incorporated under the name of "PALOS INTERNATIONAL S.à r.l.".".
<i>Second resolutioni>
The members resolve to expand the object of the Company an to change in consequence article 3 of the articles of
association of the Company as follows:
"The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial,
personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management
and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which objects are any activities in whatsoever form,
as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having or not
having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
The company also has the object of purchasing, selling, letting and promoting immovable property.
The Company further has as its object:
61717
L
U X E M B O U R G
- advice on business strategy and organisation;
- advice in the field of commercial relations and transactions;
- advice on technology and immovable property,
- advice, acquisition and sale of patents and licences.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, commercial, financial, personal and real
estate transaction which it may deem useful to the accomplishment and development of its object."
<i>Third resolutioni>
The members resolve to change article 11 of the articles of association of the Company as follows:
"The Company is managed by one or more managers, of category A, on the one hand, and category B, on the other,
either partners or not, appointed by the partners with or without limitation of their period of office.
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
The company shall be validly bound in all circumstances either by the signature of the sole manager or when there is
more than one manager by the individual signature of a category A manager or by the joint signatures of a category A
manager and a category B manager.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors or administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company
of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 1.250.- (one thousand two hundred fifty Euros).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day stated at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, acting as here above stated, he signed together with the notary,
the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le seize mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Gisbert DREYER, architecte, né à Stuttgart (Allemagne), le 20 mars 1943, demeurant professionnellement
à D-80539 Munich, 10, Maximilianstrasse,
ici représenté par Monsieur Charles RUPPERT, administrateur de sociétés, demeurant à L-5433 Niederdonven, 59,
rue des Romains,
en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 2 mars 2011.
2) Madame Jenny GSELL, Dipl.oec. Betriebs- und Volkswirtin und Soziologin, née à Jüterbog (Allemagne), le 13 avril
1953, demeurant à D-13127 Berlin, 38, Schweizer Tal,
ici représentée par Monsieur Charles RUPPERT, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du
3 mars 2011.
Les prédites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elle seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
Les prédits comparants sont les seuls associés de la société "DH PALOS IMMOBILIEN- UND PROJECTENTWIC-
KLUNGS, S.à r.l.", avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Société de Luxembourg, sous le numéro B 90.634, constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 155 du 14 février 2003. Les statuts de la société ont été modifiés en vertu d'un acte reçu par le prédit
61718
L
U X E M B O U R G
notaire Joseph Elvinger, en date du 13 mai 2003, publié au Mémorial C, numéro 635 du 11 juin 2003, en vertu d'un acte
reçu par le notaire soussigné en date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C, numéro 1843 du 26 juillet 2008 et en vertu
d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 août 2010, publié au Mémorial C, numéro 2094 du 6 octobre
2010 (ci-après la «Société»).
Lesdits comparants, représentés ainsi qu'il a été dit, en leurs qualités de seuls associés de la Société ont demandé au
notaire instrumentant d'acter leurs résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer la dénomination de la Société en "PALOS INTERNATIONAL S.à r.l." et de modifier
par conséquent l'article 2 des statuts de la société comme suit:
"La Société prend la dénomination de "PALOS INTERNATIONAL S.à r.l."."
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'élargir l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article 3 des statuts de la
société comme suit:
"L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelconque forme que ce soit, toutes
activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l'objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.
La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant ou non
un objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.
La société a par ailleurs pour objet l'achat, la vente, la location et la promotion de biens immobiliers.
La société a encore pour objet:
- le conseil en stratégie et organisation d'entreprises;
- le conseil dans le domaine des relations et des transactions commerciales;
- le conseil en technologies et en immobilier;
- le conseil, l'acquisition et la vente de brevets et licences.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières,
mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités."
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 11 des statuts de la société comme suit:
"La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, d'un côté de catégorie A et de l'autre côté de catégorie B,
associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature du gérant unique soit en cas de
gérants multiples par la signature individuelle d'un gérant de catégorie A ou par les signatures conjointes d'un gérant de
catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs
de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans
des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de part leurs fonctions actuelles
ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite
pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la
Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement
transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser
n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes
susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre."
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 1.250.- (mille deux cent cinquante euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des personnes comparantes ci-dessus,
dûment représentés, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte est dressé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
61719
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite au mandataire, ès-qualité qu'il agit, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Charles RUPPERT, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 mars 2011. Relation: LAC/2011/12461. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 4 avril 2011.
T. METZLER.
Référence de publication: 2011048893/165.
(110053826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.
Bath House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 946.215,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 156.079.
La société BATH HOUSE HOLDING S.à r.l. (anciennement MARSHEG 1 S.à r.l.), une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le n° B157807, ayant son siège social au 21, boulev ard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, est devenue l’associée unique de la Société en acquérant la totalité
des 1,100,250 parts sociales en date du 22 mars 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BATH HOUSE S.à r.l.i>
Référence de publication: 2011053616/14.
(110060030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Banque de Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 5.310.
La liste des signatures autorisées de la BANQUE DE LUXEMBOURG a été déposée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2011.
Benoît Elvinger
<i>Secrétaire du Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2011053619/13.
(110060052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Fredifra- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 59.523.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 26 avril 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Lu-
xembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
L'assemblée générale du 26 avril 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
61720
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 26 avril 2011.
<i>Pour FREDIFRA-SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2011057121/21.
(110064785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.
LUXREAL Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 144.730.
In the year two thousand and eleven, on the twenty third day of March.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company "LUXREAL Invest S.A.", with registered
office in L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse, registered at the Trade and Companies' Register of Luxem-
bourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, under the number 144.730, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on February 10
th
, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Assocations, number 536 of March 12
th
, 2009. The articles of incorporation have not been amended since then.
The meeting is opened by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Michal WITTMANN, director, residing
professionally in Luxembourg.
The shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance
list, signed by the shareholders present or their proxyholders, and to which list, set up by the members of the bureau,
the members of the meeting declare to refer.
The said attendance list, signed "ne varietur" by the members of the bureau and the notary, shall remain annexed to
this document and shall be filed at the same time with the registration authorities, as well as the proxies of the represented
shareholders at the present meeting.
The Chairman declares and asks the notary to enact:
A) That the present extraordinary general meeting has been regularly convened by convening notices.
B) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Creation of two categories of Directors and amendment of article 6 and of article 12 of the articles of association.
2.- Statutory appointments
3.- Miscellaneous.
C) That, as appears from the prenamed attendance list, all the shares are duly represented.
D) That the meeting is regularly constituted, the presence quorum required by law being attained, and that it may
decide validly on all of the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to create two (2) categories of Directors and to amend article 6 and article 12 of the articles of
association and to give it the following wording:
« Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least, who may
be divided into class A directors and class B directors, who need not be shareholders of the Company. However, in case
the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that
the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member
only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,
remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected. The directors are elected by a simple majority vote of the shares present
or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.»
« Art. 12. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors, or the sole signature of any person
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
In case of existence of Class A directors and Class B Directors, the company will be validly bound by the joint signature
of a Class A Director and a Class B Director.
61721
L
U X E M B O U R G
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of
the sole director.»
<i>Second resolutioni>
<i>The meeting confirms as Class B Directors:i>
a) Mrs Martine PITZ, companies' director, born in Dudelange (Grand Duchy of Luxembourg), on the 12
th
of February
1965, professionally residing in L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Petrusse;
b) Mrs Stephanie MARION, companies' director, born in Thionville (France), on the 8
th
of October 1978, professio-
nally residing in L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse;
c) Mrs Aïssatou DIALLO, companies' director, professionally residing in L-1637 Luxembourg, 1 rue Goethe.
Their mandates of the directors will expire at the end of the general annual meeting in the year 2016.
<i>Third resolutioni>
<i>The meeting appoints as Class A Director:i>
Mrs Natalja GOSSEN, director, born in Nadarowka (Kazakhstan) on the 11
th
May 1981, residing in D-54534 Großlitt-
gen, Auf’M Bocksbart 7.
Her mandate will expire at the end of the general annual meeting in the year 2016.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about one thousand Euros.
There being no further business on the Agenda, the meeting is thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend und elf, den dreiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
Haben sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft “LUXREAL Invest S.A.”,
mit Sitz in L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von
Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), Sektion B Nummer 144.730, gegründet gemäss
Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10. Februar 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 536
vom 12. März 2009, versammelt. Die Satzung wurde danach nicht mehr abgeändert.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herr Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Michal WITTMANN,
Direktor, berufsansässig in Luxemburg.
Die Gesellschafter, anwesend oder vertreten, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste vermerkt,
welche von den Gesellschaftern oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet wurde, und auf jene Anwesenheitsliste, fest-
gelegt vom Vorstand der Versammlung, erklären sich die Mitglieder der Versammlung zu berufen.
Diese Anwesenheitsliste, sowie die Vollmachten der in dieser Generalversammlung vertretenen Gesellschafter, welche
von dem Vorstand der Versammlung und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurden, bleiben der ge-
genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
A) Dass diese Versammlung mittels Einberufungsschreiben ordnungsgemäss einberufen wurde.
B) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Schaffung von 2 Kategorien von Verwaltungsratsmitglieders und Abänderung von Artikel 6 und 12 der Satzung.
2.- Statutarische Nominierungen.
3.- Verschiedenes.
61722
L
U X E M B O U R G
C) Dass, wie aus der vorgenannten Anwesenheitsliste hervorgeht, alle Aktien ordnungsgemäss verteten sind.
D) Dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen, das erforderliche Quorum erreicht wurde und dass rechts-
gültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.
Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst zwei (2) Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern zu schaffen und somit Artikel
6 und Artikel 12 der Satzung folgenden Wortlaut zu erteilen:
„ Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, Gesellschafter
oder nicht, welche in Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A und Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B, aufge-
teilt werden können, verwaltet. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich
einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz
von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden bei der jährlichen Aktionärsversammlung, welche ihre Anzahl, Vergütung und
Dauer des Mandats festlegt. Das Mandat eines Verwaltungsratsmitglieds kann die
Dauer von (6) Jahre nicht überschreiten, und die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis Sie von ihren Nachfolger
abgelöst werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionären
gewählt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann mit oder ohne Begündung in der Genereralversammlung abberufen werden.»
« Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern,
oder die Einzelunterschrift der Person welcher solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat erteilt wurden.
In Falle wo der Verwaltungsrat aus Verwaltungsratmitglieder der Kategorie A und Verwaltungsratmitglieder der Ka-
tegorie B besteht, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie
A und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie B, rechtskräftig vertreten.
In Fall wo der Verwaltungsrat aus nur einem (1) Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift
dieses Mitglieds rechtskräftig vertreten.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung bestätigt als Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B:
a) Frau Martine PITZ, Gesellschaftsverwalter, geboren in Düdelingen (Großherzogtum Luxemburg), am 12. Februar
1965, beruflich wohnhaft in L-2330 Luxemburg, 120, boulevard de la Pétrusse
b) Frau Stephanie MARION, Gesellschaftsverwalter, geboren in Thionville (Frankreich), am 8. Oktober 1978, beruflich
wohnhaft in L2330 Luxemburg, 120, boulevard de la Pétrusse
c) Frau Aïssatou DIALLO, Gesellschaftsverwalter, beruflich wohnhaft in L-1637 Luxembourg, 1 rue Goethe.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden nach der jährlichen Gesellschafterverwaltung in 2016.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt als Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A:
Frau Natalja GOSSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Nadarowka (Kazakhstan) am 11. Mai 1981, wohnhaft in
D-54534 Großlittgen, Auf’M Bocksbart 7.
Ihr Mandat endet nach der jährlichen Gesellschafterverwaltung in 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend Euro veranschlagt sind, gehen zu Lasten
der Gesellschaft.
Da die Tagesordnung keine weiteren Punkte beinhaltet, wird die Versammlung aufgehoben.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, auf Ersuchen derselben Komparenten und im Falle
von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
61723
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: Max MAYER, Michal WITTMANN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2011. Relation GRE/2011/1270. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.
Junglinster, den 6. Avril 2011.
Référence de publication: 2011049818/160.
(110055889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
g + p muller architectes S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 1, Montée de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 52.294.
<i>Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2011i>
Les associés de la société à responsabilité limitée «g + p muller architectes S.à r.l.» ayant son siège social à L-1343
Luxembourg 1, Montée de Clausen se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 29 avril 2011. L'assemblée a
pris les résolutions suivantes:
Monsieur Guittou MULLER, architecte diplômé, né à Luxembourg le 18 juin 1975, demeurant à L-8077 Bertrange 3,
impasse Quatre Saisons est nommé gérant technique à partir du 1
er
mai 2011.
Monsieur Paul MULLER , architecte diplômé, né à Luxembourg le 22 janvier 1942 , demeurant à L-1518 Luxembourg
4, rue Comte de Ferraris est nommé gérant administratif à partir du 1
er
mai 2011.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou
du gérant administratif.
L'adresse privée actuelle de l'associé Guittou MULLER est à L-8077 Bertrange 3, impasse Quatre Saisons.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2011.
Guittou MULLER / Paul MULLER.
Référence de publication: 2011059002/20.
(110066578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.
Barwest Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 143.818.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2011053620/13.
(110060072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Giordano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 102.925,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 114.210.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation en date du 30 mars 2011 que la Société ayant son siège social au 64 avenue
de la liberté, 1930 Luxembourg, constituée suivant acte de Me Henri Hellinckx, le 25 janvier 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, le 5 mai 2006, sous le numéro 885, a été clôturée et que par conséquence la
Société est dissoute.
Les livres et documents sociaux de la Société seront déposées et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la
publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'addresse suivante:
61724
L
U X E M B O U R G
64, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 mars 2011.
Martijn Bosch.
Référence de publication: 2011055054/19.
(110060963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.
VIATHEN r & d S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9838 Eisenbach, 13, Wuelesser Wee.
R.C.S. Luxembourg B 160.085.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, den dreißigsten März;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg; (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1. Herr Dieter BREITKREUTZ, Pharmakaufmann, geboren in Halle/Saale (Bundesrepublik Deutschland), am 29. De-
zember 1951, wohnhaft in D-18069 Rostock, Oll-Danie1-Weg 3.
2. Herr Dr. Frank BREITKREUTZ, Rechtsanwalt für Lebens-und Arzneimittelrecht, geboren in Rostock (Bundesre-
publik Deutschland), am 25. Februar 1976, wohnhaft in D-14057 Berlin, Friedbergstrasse 24.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung “VIATHEN r & d S.à r.l.”
gegründet (hiernach die “Gesellschaft“), geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen, insbesondere dem ab-
geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das "Gesetz von 1915") sowie die gegenwärtigen
Statuten (die "Statuten").
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Vertrieb von Nahrungsergänzungen, Lebensmitteln für
medizinische Zwecke, Medizinprodukten und Arzneimitteln, sowie die Anmeldung, der Handel und die Verwertung von
gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Logistik und Buchhaltungs-und Inkassodienstleistungen auf dem Gebiet des
Gesundheitswesens.
Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre
Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise
erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-
ternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unters-
tützen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Hosingen (Großherzogtum Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann, durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde des Sitzes verlegt werden.
Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber
verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche
die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der außergewöhn-
lichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft.
61725
L
U X E M B O U R G
Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt,
welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann die Gesellschaft Filialen, Zweigniederlassungen, Agenturen oder
Verwaltungssitze sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR) festgesetzt, dargestellt durch ein-
hundert (100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,-EUR), voll eingezahlt.
Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und
das Kapital verhältnismäßig herabgesetzt wird.
Art. 6. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer
anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem “nackten” Eigentümer oder zwischen
dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner.
Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten aus-
geübt.
Art. 7. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer
Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.
Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-
neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.
Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden
Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.
Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber
über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.
Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages
nach sich.
Art. 8. Außer seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber,
der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles
Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz
welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als
allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.
Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als
zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.
Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die
Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.
Art. 10. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-
mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber
oder Nichtteilhaber sein können.
Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt.
Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche meh-
rheitlich berät, anvertraut.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen
und um die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.
Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-
nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.
Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel-oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschließlich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.
61726
L
U X E M B O U R G
Art. 12. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäß
im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.
Art. 13. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des
Kapitals vertreten, angenommen werden.
Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der Teilhaber getroffen werden, welche
drei Viertel des Kapitals vertreten.
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern
unterbreiten.
Art. 16. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner
Annahme einsehen.
Art. 17. Der positive Saldo der Gewinn-und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben,
der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des
Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind
nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder
einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus
welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die
Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.
Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im
Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.
Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-
lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.
Art. 19. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 20. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern
selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einhundert (100) Anteile gezeichnet worden wie
folgt:
1) Herr Dieter BREITKREUTZ, vorgenannt, fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Herr Dr. Frank BREITKREUTZ, vorgenannt, fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: hundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sämtliche Anteile sind voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-
EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie es dem amtierenden Notar, welcher dies ausdrücklich
festgestellt.
<i>Beschlussfassung der Gesellschafteri>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, haben die vorgenannten Komparenten, welche das gesamte ge-
zeichnete Gesellschaftskapital vertreten, als Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf 13, Wuelesser Wee in L-9838 Eisenbach, festgesetzt.
2. Herr Dieter BREITKREUTZ, Pharmakaufrnann, geboren in Halle/Saale (Bundesrepublik Deutschland), am 29. De-
zember 1951, wohnhaft in D-18069 Rostock, Oll-Danie1-Weg 3, wird, auf unbestimmte Dauer, zum Geschäftsführer
ernannt.
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig und in allen Umständen und ohne Einschränkungen durch die Einzelunterschrift
des Geschäftsführers verpflichtet.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.
61727
L
U X E M B O U R G
<i>Anmerkungi>
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass vor Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit der
hiermit gegründeten Gesellschaft, diese, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, im Besitz einer vorschriftsmäßigen Han-
delsermächtigung, sein muss, was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.
<i>Notarielle Bescheinigungi>
Die Gesellschaft und ihre Satzung erfüllen nach Form und Inhalt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen hin-
sichtlich der Handelsgesellschaften, insbesondere jene bezüglich der Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Gemäß den derzeit im Großherzogtum Luxemburg gültigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und in Übe-
reinstimmung mit dem vertragsrechtlichen Prinzip, dass Verträge, die vor einem Notar geschlossen werden, unmittelbar
in Kraft treten, existiert die besagte Gesellschaft und erlangt ihre Rechtspersönlichkeit mit dem Datum der Unterzeich-
nung dieses notariellen Gründungsaktes als Körperschaft und juristische Person, in Abgrenzung von ihren Gesellschaftern,
und zwar vor Erfüllung sämtlicher Registrierungs-und Veröffentlichungsformalitäten bei dem Handels-und Gesellschafts-
register Luxemburgs und dem offiziellen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mithin ist die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung als Gesellschaft luxemburgischen Rechtes rechtswirksam gegründet.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,
Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienene Person mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Signé: D. BREITKREUTZ, F. BREITKREUTZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 avril 2011. LAC/2011/15642. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> p.d. (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 7 avril 2011.
Référence de publication: 2011049957/184.
(110055876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
Belux-Automobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4235 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint Martin.
R.C.S. Luxembourg B 74.198.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011053624/10.
(110060675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.
Immobilière Maritime Méditérranéenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 118.240.
Par décision du Conseil d'Administration prise par voie circulaire, le siège social a été transféré du 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010. De plus,
veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle du commissaire aux comptes:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.
Luxembourg, le 28 AVR. 2011.
<i>Pour: IMMOBILIERE MARITIME MEDITERRANEENE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Mireille Wagner
Référence de publication: 2011059379/18.
(110066425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61728
21social
ABS Finance Fund
Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
AI Silver S.A.
AI Sub Silver S.A.
Alamo Investments S.A.
Alamo Investments S.A.
Almalux Capital S.A.
Almalux Capital S.A.
Alt Properties Mediterranean S.à r.l.
Anglo American Investments 6
APTEA Hungary Liquidity Management Limited Liability Company, Luxembourg Branch
Art Conseil
Asia Eateries Holdings Sàrl
Asia Eateries Investments Sàrl
Autospace S.à.r.l.
Banque de Luxembourg
Barwest Investments S.A.
Bath House S.à r.l.
Belux-Automobile S.à r.l.
Blue Chip Europe S.A.
Boca Chica S.à r.l.
Business Lab Holding S.A.
Celius S.A.- SPF
Challenger Luxembourg S.A.
Citi Islamic Portfolios S.A.
DH Palos Immobilien- und Projectentwicklungs S.à r.l.
energie-pass.lu S.à r.l.
Fredifra- SPF
Giordano S.à r.l.
Gottex Real Asset Fund 1 (Waste US) S.à r.l.
g + p muller architectes S.àr.l.
hcommunications S.A.
Holding Laupraal S.A.
Immobilière Maritime Méditérranéenne S.A.
Iris Capital S.A.
JO.C. Finances S.A.
LUXREAL Invest S.A.
luxvision SARL
Palos International S.à r.l.
Pilot Project Software S.A.
Tonal S.A.
Treveria Forty-Five S.à r.l.
Venergie S.A.
Vfive S.A.
VIATHEN r & d S.à r.l.
Wattwerk Energiekonzepte S.A.
Willow Tree S.àr.l.
WPP Luxembourg Germany Holdings S.à r.l.
Yalu S.A.