logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1113

25 mai 2011

SOMMAIRE

4Finance Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53420

Aberdeen Asset Managers Limited, Lu-

xembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53401

Aixone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53378

Alior Lux Sàrl & Co S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

53380

Alis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53382

Alkab S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53378

ArcelorMittal Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . .

53424

Asset Backed Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

53382

Ava Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53401

Ava Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53403

Babcock & Brown (Odense) S.à.r.l.  . . . . . .

53404

Bau Komplett Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

53404

Beemkleeterer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53409

Belair Business Offices S.A.  . . . . . . . . . . . . .

53411

Bertelsmann Capital Investment S.A.  . . . .

53406

Boeing International Corporation  . . . . . . .

53406

Borletti Group TITI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

53406

Brandenburg Properties 18 S.à r.l.  . . . . . . .

53409

Brandenburg Properties 1 S.à r.l.  . . . . . . . .

53408

Bromley S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53411

Business Controls & Services International

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53411

BWA Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53418

BWA Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53412

Café Lenger Stuff s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53382

Carlo Tassara Assets Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53401

Celin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53401

Centurion European German Property 5

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53378

Centurion European German Property 6

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53380

Centurion European German Property 7

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53402

Centurion European German Property 8

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53404

Centurion European German Property 9

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53407

Crédit Agricole Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53424

Hauppauge Digital Europe S.à r.l. . . . . . . . .

53420

Heerendam S.A./N.V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53383

HEP Luxwell S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53423

Heritage Centra Investors S.à r.l.  . . . . . . . .

53419

Holding Company of 090630 S.A.  . . . . . . . .

53409

Icebird Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53412

Icebird S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53412

I.E.D.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53423

Maximus Holding II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53419

Sinabe S.A.- SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53423

53377

L

U X E M B O U R G

Alkab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.287.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alkab S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011051361/12.
(110056947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Aixone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 89.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051362/10.
(110057211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Centurion European German Property 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.710.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of January.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-

gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435.

here represented by Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of a proxy delivered to him. Said proxy after being signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary
shall remain attached to the present deed.

Such appearing party requests, by its proxy, the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the private limited liability company "Centurion European German Property 5 S.à r.l.", with registered office

in L- 1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section
B, under the number 140.710, (hereafter the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the July 24 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2066 of the

26 

th

 of August 2008.

II.- That Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by

five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company, with effect on December 31 

st

 , 2010.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he

will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the manager for the performance of his mandate up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the records and documents of the dissolved Company willbe kept for a period of five years at least at the

L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

53378

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in

any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing person, known to the notary by his first and last

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",

mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda- Inseln unter der Nummer 38435,

hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERICH, Steuerberater, berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur"
unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin ersucht, durch ihren Bevollmächtigten, den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen

zu beurkunden wie folgt:

I.-  Dass  die  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  "Centurion  European  German  Property  5  S.à  r.l.",  mit  Sitz  in

L-1140Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion
B, unter der Nummer140.710, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am
24. Juli 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2066 vom 26. August 2008.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, eingeteilt in fünf

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünf und zwanzig Euro (25,- EUR).

III.- Dass der Komparent alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010, aufzulösen und zu liqui-

dieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und

dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübungseines Mandates bis zum heutigen Tag erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des

Komparenten, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen des-
selben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die deutsche
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jeannot DIDERRICH, Jean SECKLER.

53379

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2011. Relation GRE/2011/421. Reçu soixante-quinze euros 75,00 € .

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035200/90.
(110038616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Alior Lux Sàrl &amp; Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 129.078.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051363/10.
(110056928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Centurion European German Property 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.711.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of January.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with reg-

istered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435.

here represented by Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of a proxy delivered to him. Said proxy after being signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary
shall remain attached to the present deed.

Such appearing party requests, by its proxy, the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the private limited liability company "Centurion European German Property 6 S.à r.l.", with registered office

in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B,
under the number 140.711, (hereafter the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the July 24 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2066 of the

26 

th

 of August 2008.

II.- That Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by

five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.

IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company, with effect on December 31 

st

 , 2010.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he

will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the manager for the performance of his mandate up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the

L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in

any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

53380

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing person, known to the notary by his first and last

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",

mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435,

hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Steuerberater, berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur"
unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin ersucht, durch ihren Bevollmächtigten, den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen

zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Centurion European German Property 6 S.à r.l.", mit Sitz in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter
der Nummer 140.711, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 24. Juli
2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2066 vom 26. August 2008.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-EUR) beträgt, eingeteilt in fünf

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünf und zwanzig Euro (25,-EUR).

III.- Dass der Komparent alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010, aufzulösen und zu liqui-

dieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und

dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübung seines Mandats bis zum heutigen Tag erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des

Komparenten, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen des-
selben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die deutsche
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jeannot DIDERRICH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2011. Relation GRE/2011/422. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

53381

L

U X E M B O U R G

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035201/90.
(110038958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Alis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051364/10.
(110056927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Asset Backed Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 95.590.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Asset Backed Europe SA
Caceis Bank Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2011051367/12.
(110057043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Café Lenger Stuff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4797 Linger, 18, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 150.548.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales et assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité

limitée "CAFE LENGER STUFF s.à r.l.", avec siège social à L-4797 Linger, 18, rue de la Libération, inscrite au RCS à
Luxembourg sous le numéro B 150 548, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 18
mars 2011, numéro 2011/0603 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 22 mars 2011, relation: CAP/2011/1101, ce
qui suit:

a) Monsieur Pierre PELLIZZARO, détenteur de 50 parts sociales de la société "CAFE LENGER STUFF s.à r.l.", prédite,

a cédé 24 parts à Madame Stéphanie SALMON, serveuse, née à Boulay (France) le 21 septembre 1975, demeurant à
F-57480 Evendorff, 2, route de Kirsch.

b) Madame Manon COLLING, détenteuse de 50 parts sociales de la société "CAFE LENGER STUFF s.à r.l.", prédite,

a cédé 25 parts à Madame Stéphanie SALMON, préqualifiée.

Madame Manon COLLING a démissionné de sa fonction de gérante administrative de la société.
Madame Stéphanie SALMON, prénommée a été nommée gérante administrative de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant

technique Monsieur Pierre PELLIZZARO et de la gérante administrative Madame Stéphanie SALMON.

Bascharage, le 11 avril 2011.

Pour extrait conforme
Alex WEBER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2011051373/26.
(110057070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

53382

L

U X E M B O U R G

Heerendam S.A./N.V, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 159.296.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the second day of February.
Before Us, Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Heerendam N.V., a public limited

liability company (naamloze vennootschap) incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its
corporate seat in Geertruidenberg, having its registered office at Bogardstraat 4, 4331 BN Middelburg, the Netherlands,
and registered with the Chamber of Commerce under file number 20157621 (the Company).

The Meeting is chaired by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Mrs. Solange Wolter, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the

Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mrs. Emelie van der Knoop-Marius, lawyer, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer

of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares of the Company held are

indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the repre-
sentative of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxy from the shareholders represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder

and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to enact the following:
I. That the entirety of the share capital of the Company is duly represented at this Meeting which is consequently

regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. That by a resolution of the board of managing directors of the Company validly adopted on December 30, 2009, a

copy of which shall remain annexed to the present deed, the Company resolved to transfer the principal place of business,
the place of effective management and central administration of the Company to the City of Luxembourg without the
Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under
the laws of the Netherlands to give effect to that resolution have been duly performed.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgement of the dismissal by means of the resolutions of the Shareholders taken on December 24, 2009,

of the sole management board member, Mr. W. VAN DER SLUIJS effective as of December 28, 2009, and the full discharge
for the performance of its duties as management board member granted to him.

2. Acknowledgement of the appointment of Mr. Peter VAN OPSTAL, Mr. Gerard VAN HUNEN and Mr. Pieter VAN

NUGTEREN as management board members of the Company, effective as of December 28, 2009, for a period of six (6)
years.

3. Transfer of the registered office, principal place of business, place of effective management and central administration

of the Company from the Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect, without the Company
being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;

4. Adoption by the Company of the legal form of a public limited liability company (société anonyme) with the name

“Heerendam S.A./N.V.” and acceptance of the Luxembourg nationality;

5. Approval of the opening balance sheet of the Company, dated as of October 31, 2010;
6. Amendment and full restatement of the Company’s articles of association so as to conform them to the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality as specified
in item 4. above;

7. Appointment of a statutory auditor for a period of 6 years with effect as of today;
8. Establishment of the registered office and central place of administration of the Company at 40, avenue Monterey

L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

9. Miscellaneous.
Thereupon, the appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record

that:

53383

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholders resolve to acknowledge the dismissal by means of the resolutions of the Shareholders taken on

December 24, 2009, of the sole management board member, Mr. W. VAN DER SLUIJS effective as of December 28,
2009, and the full discharge for the performance of its duties as management board member granted to him.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to acknowledge the appointment of the following persons as management board members

of the Company effective as of December 28, 2009 and for a period of six (6) years:

- Mr. Peter Lourents VAN OPSTAL, company director, born in Zwijndrecht, the Netherlands on February 12, 1969,

with professional address at 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Gerard Alexander VAN HUNEN, company director, born in s’Gravenhage, the Netherlands on September 15,

1967, with professional address at 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Pieter Adriaan Cornelis Simon VAN NUGTEREN, company director, born in Meppel, the Netherlands on April

19, 1966, with professional address at 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to transfer the registered office, principal place of business, place of effective management

and central administration of the Company from the Netherlands to the City of Luxembourg with immediate effect,
without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The Shareholders
further declare that all formalities required under the laws of the Netherlands to give effect to such transfer have been
duly performed.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve that the Company adopts the form of a public limited liability company (société anonyme)

with the name Heerendam S.A./N.V., accepts the Luxembourg nationality and shall, as from the date of the present deed,
be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The Shareholders approve the opening balance sheet of the Company, dated as of October 31, 2010, a copy of which

shall remain attached to the present deed.

The Shareholders state that the total value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to the aggregate

of the issued share capital of the Company.

The Shareholders further acknowledge that in accordance with the Luxembourg law on commercial companies of

August 10, 1915, as amended, the value of the Company has been the subject of a report prepared by Mr. Marco CLAUDE,
Réviseur d’entreprises, dated January 28, 2011, which concludes as follows:

«Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the Company

is not at least corresponding to the amount of the subscribed share capital.»

The said auditor’s report and opening balance sheet, after having been signed by the representative of the sole sha-

reholder, the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be
registered with it.

<i>Sixth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend and fully restate the articles of association

of the Company (the Articles) so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated Articles shall read as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION:

Chapter I.

Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a "Share":
a share in the capital of the Company;
b. a "Shareholder":
a holder of one or more Shares;
c. a "General Meeting of Shareholders":
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
d. the "Management Board":
the board of directors of the Company;

53384

L

U X E M B O U R G

e. "in writing":
by letter, by fax, by e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided that the

identity of the sender can be sufficiently established;

f. the"Distributable Equity":
the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be

maintained pursuant to the Law;

g. a "Company Body":
the Management Board or the General Meeting of Shareholders;
h. the “Law”:
any applicable law or regulation, in the Netherlands and/or the Grand-Duchy of Luxembourg, as the case may be.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is

apparent.

Chapter II. Name, Registered office and Objects.

Art. 2. Name, Corporate Seat, Registered office, Place of central administration and Duration.
2.1 The Company is a public limited liability company (naamloze vennootschap / société anonyme) (the Company) and

its name is: Heerendam S.A./N.V.

2.2 The corporate seat of the Company is in Geertruidenberg, the Netherlands.
2.3 The registered office and the place of central administration of the Company is in the City of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.4 The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Chapter III. Share capital; Register of shareholders; Rights of preemption; Payment on shares.

Art. 4. Share capital.
4.1  The  Company’s authorised  and  issued  share capital  is  set at forty-five thousand and  two  euro  (EUR  45,002),

represented by forty-five thousand and two (45,002) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1)
each, all subscribed and fully paid up.

4.2 The share capital may be increased in one or several times by a resolution of the General Meeting of the Share-

holders, with a majority of the votes cast, representing at least three-quarters of the Company’s issued and subscribed
capital. The resolution to issue Shares shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The issuance of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed
for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands to which such deed those involved shall be parties.

4.3 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions to issue.
4.4. Within eight days after a resolution to issue Shares is made, the Company shall deposit the complete text thereof

at the office of the Commercial Register for Dutch filing purposes.

Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders

are recorded.

53385

L

U X E M B O U R G

5.2 Section 2:85 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders.

Art. 6. Rights of pre-emption.
6.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre emption in proportion to the aggregate nominal

value of his Shares, subject to the relevant limitations prescribed by the Law.

6.2 Prior to each single issuance, the right of pre emption may be limited or excluded by a resolution of the General

Meeting of Shareholders. The right of pre-emption may also be limited or excluded by the Management Board, if, by a
resolution of the General Meeting of Shareholders, it was designated and authorized for a fixed period, not exceeding
five years, to limit or exclude such right of pre emption. The designation may be extended, from time to time, for a period
not exceeding five years. Unless the designation provides otherwise, it may not be withdrawn. If less than one half of the
Company's issued capital is represented at the meeting, a majority of at least two thirds of the votes cast shall be required
for a resolution of the General Meeting of Shareholders to limit or exclude such right of pre emption or to make such
designation.

6.3 The provisions of Articles 6.1 and 6.2 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Shares, but

do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

Art. 7. Payment on shares.
7.1. On issue of a Share, the full nominal value thereof must be paid in, and, in addition, if the Share is issued at a higher

amount, the difference between such amounts.

7.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no contributions in kind has been agreed on. Payment in

foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the provisions of the
Law.

7.3 Contributions in kind on Shares are subject to the provisions of the Law.

Chapter IV. Own shares; Reduction of the issued capital.

Art. 8. Own Shares; Reduction of the Issued Capital.
8.1 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due obser-

vance of the limitations prescribed by law.

8.2 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company’s issued capital. The resolution to

reduce the issued capital shall be taken with a majority of the votes cast, representing at least three-quarters of the
Company’s issued capital. The resolution to reduce the Company’s issued capital shall require a deed, to be executed for
that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg. The resolution whereby the issued share
capital of the Company is reduced shall furthermore require a deed, to be executed for that purpose before a civil law
notary registered in the Netherlands.

8.3 The reduction of the Company’s issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions pre-

scribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.

8.4 The notice of a General Meeting of Shareholders at which a resolution to reduce the Company’s issued capital

shall be proposed shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The
provisions of these Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by
analogy.

Chapter V. Transfer of shares; Blocking clause.

Art. 9. Transfer of Shares.
9.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

9.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it, in accordance with the relevant
provisions of the Law.

Art. 10. Blocking Clause (offer to co-Shareholders).
10.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article

10, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.

10.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (the "Offeror") shall first offer to sell such Shares

to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the Management
Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification, the Mana-
gement Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing one or
more of the Shares on offer ("Interested Parties") must notify the Management Board within one month after said notices
from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received later shall not be taken into
account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested Party with the consent
of the Offeror.

53386

L

U X E M B O U R G

10.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed between

the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement
on the price or the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts to
be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the Chamber of Commerce at
which the Company is registered in the Commercial Register. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect
all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price.

10.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of

the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term
shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given,
an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

10.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on

offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If
they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred
to in Article 10.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in
proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares
on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

10.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested

Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.

10.7 If it is established that none of the co-Shareholders is an Interested Party or that not all Shares put on offer shall

be purchased for payment in cash, the Offeror may freely transfer the total number of the Shares on offer, and not part
thereof, up to three months thereafter.

10.8 All notifications and notices referred to in this Article 10 shall be made by certified mail or against acknowled-

gement of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy
thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise hereina-
bove.

10.9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,

shall be borne by:

a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,

provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;

c. the Company if the offer has not been accepted in full or only in part.
10.10 The preceding provisions of this Article 10 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of

pre-emption.

Chapter VI. Pledging of shares and Usufruct in shares; Depository receipts for shares.

Art. 11. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
11.1 The provisions of Article 9 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a

usufruct in Shares.

11.2 On the creation of a right of pledge and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting rights

attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or usufructuary. The pledgee or usufructuary shall not have
the rights conferred by law upon holders of depositary receipts issued with a company's cooperation for shares in its
capital.

Art. 12. Depositary Receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for

Shares.

Chapter VII. The management board.

Art. 13. Management Board Members.
13.1 The Management Board shall consist of at least three directors. The Management Board members need not be

shareholders of the Company. Both individuals and legal entities can be Management Board members.

13.2 Management Board members are appointed by the General Meeting of Shareholders.
13.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting of Shareholders at any

time.

13.4 The General Meeting of Shareholders shall adopt the remuneration policy in respect of remuneration of the

Management Board.

Art. 14. Sole Management Board member.
14.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a single director

until the ordinary General Meeting of Shareholders following the introduction of an additional shareholder. In this case,

53387

L

U X E M B O U R G

any reference in the Articles of Association to the Management Board or directors should read as a reference to that
sole director, as appropriate.

14.2 Without prejudice to the provisions of Article 16.3, transactions entered into by the Company which conflict

with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under
normal circumstances in the ordinary course of business.

14.3 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of the person to whom the sole director has delegated special signatory powers.

Art. 15. Duties, Decision making Process and Allocation of Duties.
15.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
15.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
15.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast.
15.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided

the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this
manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Ma-
nagement Board members then in office.

15.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management

Board.

15.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.

In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

Art. 16. Representation; Conflicts of Interest.
16.1 The Company shall be represented by the Management Board. Two Management Board members acting jointly

shall also be authorized to bind the Company against third parties.

16.2 The Company is also bound towards third parties by the joint signature or single signature of any person(s) to

whom special signatory powers have been delegated.

16.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the

provisions of this Article 16 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting of Shareholders has appointed
one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict.
A resolution of the Management Board with respect to a matter involving a conflict of interest with one or more Mana-
gement Board members in a private capacity shall be subject to the approval of the General Meeting of Shareholders, but
the absence of such approval shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the
Company.

Art. 17. Approval of Management Board Resolutions.
17.1 Resolutions of the Management Board with respect to a material change of the identity or the character of the

Company or its enterprise as referred to in Section 2:107a of the Dutch Civil Code, are subject to the approval of the
General Meeting of Shareholders.

17.2 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval.

The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

17.3 The absence of approval by the General Meeting of Shareholders of a resolution referred to in this Article 17

shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

Art. 18. Vacancy or Inability to Act. If a seat is vacant on the Management Board ('ontstentenis') or a Management

Board member is unable to perform his duties ('belet'), the remaining Management Board members or member shall be
temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all
Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their
duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to on or more persons designated for that purpose
by the General Meeting of Shareholders.

Chapter VIII. Financial year and Annual accounts; Profits and Distributions.

Art. 19. Financial Year and Annual Accounts.
19.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
19.2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances

this period is extended by the General Meeting of Shareholders by not more than six months, the Management Board
shall prepare annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.

19.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the annual report for inspection by the Sha-

reholders, unless Section 2:396, subsection 7, or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company.

19.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.

53388

L

U X E M B O U R G

19.5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them

is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

19.6 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.

19.7 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts.
19.8 The General Meeting of Shareholders may grant full or limited discharge to the Management Board members for

the management pursued.

Art. 20. Profits and Distributions.
20.1 The allocation of profits accrued in a financial year shall be determined by the General Meeting of Shareholders.

If the General Meeting of Shareholders does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at
latest immediately after the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved.

20.2 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the law given the

contents of the annual accounts.

20.3  The  General  Meeting  of  Shareholders  may  resolve  to  make  interim  distributions  on  Shares  and/or  to  make

distributions on Shares at the expense of any reserve of the Company. In addition, the Management Board may decide
to make interim-distributions on Shares.

20.4 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless

another date of payment has been determined in the resolution.

20.5 Distributions may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable Equity

and, if it concerns an interim distribution, the compliance with this requirement is evidenced by an interim statement of
assets and liabilities as referred to in Section 2:105, subsection 4, of the Dutch Civil Code. The Company shall deposit
the statement of assets and liabilities at the office of the Commercial Register within eight days after the day on which
the resolution to distribute is published.

20.6 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

Art. 21. General Meetings of Shareholders.
21.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held on the third Monday of May of each year at ten ante

meridiem (10.00 a.m.). If such day is not a business day for banks in Geertruidenberg and the City of Luxembourg, the
annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following business day.

21.2 The agenda of this annual General Meeting of Shareholders shall contain, inter alia, the following subjects for

discussion:

a. discussion of the annual report;
b. discussion and adoption of the annual accounts;
c. the granting of discharge to Management Board members;
d. allocation of profits; and
e. other subject presented for discussion by the Management Board or by Shareholders with due observance of Article

22.

The agenda does not need to contain the subjects as referred to a,b,c and d, if it contains a proposal to extend the

period to prepare the annual accounts and (if applicable) to prepare the report, or, if a resolution to that extent has
already been taken.

21.3 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
21.4 Shareholders representing in the aggregate at least one tenth of the Company's issued capital may request the

Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the subjects to be discussed. If the
Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt
of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be
authorized to convene a meeting themselves.

Art. 22. Notice, Agenda and Venue of Meetings.
22.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board. Furthermore, notice of

General  Meetings  of  Shareholders  may  be  given  by  Shareholders  representing  in  the  aggregate  at  least  half  of  the
Company’s issued capital, without prejudice to the provisions of Article 21.

22.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
22.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 22.2.

22.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than sixty days before the

day  of  the  meeting  by  one  or  more  Shareholders  who  individually  or  jointly  represent  at  least  one  percent  of  the
Company’s issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for
discussion, provided that no important interest ('zwaarwichtig belang') of the Company dictates otherwise.

53389

L

U X E M B O U R G

22.5 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.

Instead of through notice letters, any Shareholder that gives his consent, may be sent notice of the meeting by means of
a legible and reproducible message electronically sent to the address stated by him for this purpose to the company.

22.6 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association,

the Company has its corporate seat. General Meetings of Shareholders may also be held elsewhere, but in that case valid
resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be adopted if all of the Company's issued and subscribed
capital is represented.

Art. 23. Admittance and Rights at Meetings.
23.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and

to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.

23.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting

may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

23.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Share-

holders.

23.4 If an accountant has been appointed to audit the annual accounts, the accountant shall have the right to attend

the General Meeting of Shareholders and to express his views.

23.5 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

Art. 24. Chairperson and Secretary of the Meeting.
24.1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders shall be appointed by a majority of the votes cast by the

persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall
act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the
meeting shall act as chairperson.

24.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Art. 25. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.
25.1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The

minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by
them.

25.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If

the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management
Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall
be deposited at the Company's office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be provided
with a copy of or an extract from the records.

Art. 26. Adoption of Resolutions in a Meeting.
26.1 Each Share confers the right to cast one vote.
26.2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of

the General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast.

26.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
26.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by law or these

Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only
be adopted in a meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried
by unanimous vote.

26.5 In the General Meeting of Shareholders, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company

or a subsidiary, nor for any Share for which the Company or a subsidiary holds the depositary receipts.

Art. 27. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
27.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General

Meeting of Shareholders, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The
provisions of Article 23.3 shall apply by analogy.

27.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 25.2.

Chapter IX. Amendment of the articles of association; Change of corporate form; Dissolution and Liqui-

dation

Art. 28. Amendment of the Articles of Association.
28.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopted

with a majority of the votes cast, representing at least three-quarters of the Company’s issued capital. The resolution to

53390

L

U X E M B O U R G

amend the Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the
Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting
of Shareholders, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including in verbatim text thereof,
shall be deposited and kept available at the Company principal office for inspection by the Shareholders until the closing
of the meeting. From the day of the deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application, be provided
with a copy of the proposal free of charge. An amendment of the Articles of Association shall furthermore require a
deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.

28.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form of the

Company shall require a resolution to change the corporate form and a resolution to amend these Articles of Association
adopted by the General Meeting of Shareholders in conformity with the procedure provided for the amendment of the
Articles of Association. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions of the
Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the legal entity.

Art. 29. Dissolution and Liquidation.
29.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders.

The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.

29.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Management

Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting of Shareholders
may decide to appoint other persons as liquidators.

29.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
29.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

29.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to appoint the following legal person as statutory auditor (commissaire aux comptes) with

effect as of today and for a period of six (6) years:

- Grant Thornton Lux Audit S.A., a public company limited by shares, having its registered office at 83, Pafebruch,

L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 43.298.

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolve to establish the registered office, principal place of business, the place of effective manage-

ment and central administration of the Company 40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately one
thousand five hundred Euros (1,500.-EUR).

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the
English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le deux février.
Par-devant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes.

s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de Heerendam N.V., une société

anonyme constituée et organisée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire à Geertruidenberg, son siège social
à  Bogardstraat  4,  4331  BN  Middelburg,  les  Pays-Bas,  et  immatriculée  à  la  Chambre  de  Commerce  sous  le  numéro
20157621 (la Société).

L’Assemblée est présidée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (le

Président).

53391

L

U X E M B O U R G

Le Président nomme Mme. Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en qualité

de secrétaire de l’Assemblée (le Secrétaire).

L’Assemblée choisit Mme Emelie van der Knoop-Marius, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

qualité de scrutateur de l’Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Les actionnaires de la Société représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions de la Société qu’ils détiennent

sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le man-
dataire des actionnaires et les membres du Bureau.

La procuration des actionnaires représentés à l’Assemblée, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire

instrumentant, restera également annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que la totalité du capital social de la Société est dûment représentée à la présente Assemblée qui est par conséquent

régulièrement constituée et peut statuer sur les points portés à l’ordre du jour, reproduits ci-après.

II. Que par une résolution du conseil d’administration de la Société valablement adoptée le 30 décembre 2009, dont

une copie restera annexée au présent acte, la Société a décidé de transférer le siège social, le principal établissement, le
lieu de gestion effective et le siège de l’administration centrale de la Société à Luxembourg Ville, sans dissolution de la
société mais au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale. Toutes les formalités requises
par le droit des Pays-Bas afin d’appliquer cette décision ont été dûment accomplies.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Prise d’acte de la révocation par résolutions des Actionnaires adoptées le 24 décembre 2009, de l’unique membre

du conseil d’administration, M. W. VAN DER SLUIJS en vigueur à compter du 28 décembre 2009, et pleine décharge
accordée lui étant accordée pour l’exécution de son mandat en tant que membre du conseil d’administration.

2. Prise d’acte de la nomination de M. Peter VAN OPSTAL, M. Gerard VAN HUNEN et M. Pieter VAN NUGTEREN

en tant que membres du conseil d’administration de la Société, en vigueur à compter du 28 décembre 2009, pour une
durée de six (6) ans.

3. Transfert du principal établissement, du lieu de gestion effective et du siège de l’administration centrale de la Société

des Pays-Bas à Luxembourg Ville avec effet immédiat sans dissolution de la Société, mais au contraire avec une pleine
continuation de sa personnalité juridique et morale;

4. Adoption par la Société de la forme juridique d’une société anonyme sous la dénomination "Heerendam S.A./N.V."

et acceptation de la nationalité luxembourgeoise;

5. Approbation du bilan d’ouverture de la Société, daté du 31 octobre 2010;
6. Modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois luxem-

bourgeoises, en conséquence de l’acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme mentionné au
point 4 ci-dessus,

7. Nomination d’un commissaire aux comptes pour une période de 6 ans à compter d’aujourd’hui;
8. Etablissement du siège sociale et le siège de l’administration centrale de la Société au 40, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

9. Divers.
Ces faits exposés, les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant

d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de prendre acte de la révocation par résolutions des Actionnaires adoptées le 24 décembre

2009, de l’unique membre du conseil d’administration, M. W. VAN DER SLUIJS en vigueur à compter du 28 décembre
2009, et pleine décharge accordée lui étant accordée pour l’exécution de son mandat en tant que membre du conseil
d’administration.

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de prendre acte de la nomination des personnes suivantes en qualité de membres du conseil

d’administration de la Société en vigueur à compter du 28 décembre 2009 et pour une durée de six (6) ans:

- M. Peter Lourents VAN OPSTAL, administrateur de société, né à Zwijndrecht, les Pays-Bas, le 12 février 1969, avec

adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- M. Gerard Alexander VAN HUNEN, administrateur de société, né à La Haye (s’Gravenhage), les Pays-Bas, le 15

septembre 1967, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg; et

- M. Pieter Adriaan Cornelis Simon VAN NUGTEREN, administrateur de société, né à Meppel, les Pays-Bas, le 19 avril

1966, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

53392

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident de transférer le siège sociale, le principal établissement ainsi que le lieu de gestion effective

et le siège de l’administration centrale de la Société des Pays-Bas à Luxembourg Ville avec effet immédiat, sans dissolution
de la Société, mais au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale. Les Actionnaires déclarent
en outre que toutes les formalités requises selon les lois des Pays-Bas afin de donner effet à ce transfert ont été dûment
accomplies.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident que la Société adopte la forme d’une société anonyme sous la dénomination Heerendam

S.A./N.V., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à compter de la date du présent acte, soumise aux lois du
Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires approuvent le bilan d’ouverture de la Société, daté du 31 octobre 2010, dont une copie restera

annexée au présent acte.

Les Actionnaires déclarent que la valeur totale de l’actif et du passif de la Société est au moins égale au total du capital

social émis de la Société.

Les Actionnaires reconnaissent également que, en vertu de la loi luxembourgeoise sur les société commerciales du 10

août 1915, telle que modifiée, la valeur de la Société a fait l’objet d’un rapport préparé par M. Marco Claude, Réviseur
d’Entreprises, daté du 28 janvier 2011, dont la conclusion est la suivante:

«D'après notre travail, nous n'avons pas connaissance de certains faits qui nous pousseraient à croire que la valeur

globale de la Société ne correspond pas au moins au capital social souscrit.»

Ledit rapport du réviseur d’entreprise ainsi que le bilan d’ouverture, après signature par le mandataire de l’actionnaire

unique, par les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte aux fins de l’enregistre-
ment.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Actionnaires décident de modifier et de reformuler intégralement

les statuts de la Société (les Statuts) afin de les mettre en conformité avec les lois luxembourgeoises.

Les Statuts coordonnés de la Société auront la teneur suivante:

STATUTS

Chapitre I 

er

 .

Art. 1. Définitions.
1.1 Dans les présents Statuts les mots suivants auront les significations suivantes:
(a) une "Action":
une Action dans le capital de la Société;
(b) un "Actionnaire":
le détenteur d’une ou de plusieurs Actions;
(c) "Assemblée Générale des Actionnaires":
une réunion des Actionnaires et autres personnes autorisées à assister aux assemblées des Actionnaires;
(d) le "Conseil d’Administration":
le conseil d’administration de la Société;
(e) "par écrit":
par courrier, fax, e-mail, ou un message légal et reproductible envoyé par voie électronique, à condition que l’identité

de l’expéditeur puisse être établie avec certitude;

(f) les "Fonds Propres Distribuables":
la partie des fonds propres de la Société qui excède le total du capital émis et les réserves qui doivent être maintenues

conformément à la Loi;

(g) un "Organe de la Société"
le Conseil d’Administration ou l’Assemblée Générale des Actionnaires;
(h) la "Loi":
Toute loi ou règlement applicable aux Pays-Bas et/ou au Grand-Duché de Luxembourg, selon le cas.
1.2 Les références aux Statuts seront censées faire référence aux articles qui font partie des présents Statuts, sauf

indication spécifique contraire.

53393

L

U X E M B O U R G

Chapitre II. Dénomination, Siège social et Objets.

Art. 2. Dénomination, Siège Statutaire, Siège Social, Siège de l’administration centrale et Durée.
2.1 La Société est une société anonyme (la Société) dont la dénomination est: Heerendam S.A./N.V.
2.2 Le siège statutaire de la Société est établi à Geertruidenberg, les Pays-Bas.
2.3 Le siège social et le siège de l’administration centrale de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand Duché de

Luxembourg.

2.4 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Objets. La Société a pour objet de:
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de dette
de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Chapitre III. Capital social; Registre des actionnaires; Droits de préemption; Libération des actions.

Art. 4. Capital social.
4.1 Le capital social autorisé et émis de la Société est fixé à quarante-cinq mille deux euros (EUR 45.002), représenté

par quarante-cinq mille deux (45.002) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

4.1 Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par une résolution de l’Assemblée Générale des

Actionnaires, avec une majorité des voix exprimées, représentant au moins les trois-quarts du capital souscrit et émis de
la Société. La décision d’émettre des Actions requiert l’exécution d’un acte notarié, qui devra être passé à cet effet par-
devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg. L’émission d’une Action requiert également un acte notarié,
qui devra être passé à cet effet par-devant un notaire résidant au Pays-Bas acte auquel les personnes concernées seront
parties.

4.3 Lors de la décision d’émission des Actions, le prix et les autres conditions d’émission devront être déterminés.
4.4 Endéans un délai de huit jours après une résolution d’émettre les Actions, la Société déposera le texte complet de

celle-ci au bureau du Registre de Commerce pour les formalités d’enregistrement selon le droit néerlandais.

Art. 5. Registre des Actionnaires.
5.1 Le Conseil d’Administration tiendra un registre des Actionnaires dans lequel sont inscrits les noms et adresses de

tous les Actionnaires.

5.2 La section 2:85 du Code Civil Néerlandais s’applique au registre des Actionnaires.

Art. 6. Droits de préemption.
6.1 Lors de l’émission des Actions, chaque Actionnaire aura un droit de préemption au prorata de la valeur nominale

totale de ses Actions, sous réserve des restrictions concernées prévues par la Loi.

6.2 Le droit de préemption peut être limité ou exclu par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires avant

chaque émission d’Actions. Le droit de préemption peut également être limité ou exclu par le Conseil d’Administration
si, par une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, il a été désigné et autorisé, pour une période fixe ne
dépassant pas cinq ans, de limiter ou exclure ce droit de préemption. Cette désignation peut être prolongée, au fil du
temps, pour une période ne dépassant pas cinq ans. A moins que cette désignation n’en dispose autrement, elle ne pourra
être retirée. Si moins de la moitié du capital émis de la Société est représentée à l’assemblée, une majorité d’au moins

53394

L

U X E M B O U R G

deux-tiers des voix exprimées sera requise pour une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires pour limiter ou
exclure ce droit de préemption ou pour effectuer cette désignation.

6.3 Les dispositions des Articles 6.1 et 6.2 s’appliqueront par analogie à l’octroi des droits de souscription des Actions,

mais ne s’appliquent pas à l’émission des Actions à une personne qui exerce un droit de souscription sur les Actions
préalablement accordé.

Art. 7. Libération des actions.
7.1 Lors de l’émission d’une Action, la valeur nominale totale de cette action doit être entièrement libérée, et, de plus,

si l’Action est émise à un montant plus élevé, la différence entre ces montants.

7.2 La libération d’une Action doit être faite en numéraire dans la mesure où aucun apport en nature n’a été convenu.

La libération dans une devise étrangère ne sera permise qu’avec l’approbation de la Société et en conformité avec les
dispositions de la Loi.

7.3 Les apports en nature des Actions sont soumis au respect des dispositions de la Loi.

Chapitre IV. Actions propres; Réduction du capital émis.

Art. 8. Actions propres; Réduction du Capital Emis.
8.1 La Société et ses filiales peuvent acquérir des Actions entièrement libérées ou à défaut, des certificats de dépôt,

en conformité avec les dispositions de la Loi.

8.2 L’Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de réduire le capital émis de la Société. La décision de réduire

le capital émis de la Société sera prise à la majorité des voix exprimées représentant au moins les trois quarts du capital
émis de la Société. La décision de réduire le capital émis de la Société requiert l’exécution d’un acte notarié passé à cet
effet par devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg. La résolution par laquelle le capital social émis est
réduit requiert également un acte notarié devant être passé à cet effet par-devant un notaire résidant aux Pays-Bas.

8.3 La réduction du capital émis de la Société s’effectuera conformément et dans les limites des dispositions de la Loi

y afférantes.

8.4 La convocation de l’Assemblée Générale des Actionnaires, appelée à statuer sur une proposition de réduction du

capital émis de la Société, devra mentionner l’objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réali-
sation. Les dispositions des présents Statuts portant sur une proposition de modification statutaire seront applicables par
analogie.

Chapitre V. Cession d’actions; Clause de blocage.

Art. 9. Cession d’Actions.
9.1 La cession d’une Action requiert un acte notarié passé à cet effet par devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte

auquel les personnes concernées par la cession seront parties.

9.2 A moins que la Société ne soit elle-même partie à l’acte notarié, les droits attachés à toute Action ne pourront

être exercés qu’après la reconnaissance de la cession concernée par la Société ou la notification de l’acte à la Société
conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 10. Clause de Blocage (offre aux co-Actionnaires).
10.1 La cession d’une ou de plusieurs Actions ne peut s’effectuer que conformément aux dispositions prévues ci-après

à l’Article 10, à  moins  que (i)  tous  les autres  Actionnaires n’aient donné  leur approbation par  écrit pour la cession
concernée, laquelle approbation sera alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l’Actionnaire concerné est tenu
en vertu de la Loi de céder ses Actions à un ancien Actionnaire.

10.2 Un Actionnaire qui désire céder une ou plusieurs de ses Actions ("l’Offrant") devra en premier lieu proposer de

vendre ces Actions à ses co-Actionnaires. Cette offre sera effectuée par l’Offrant par notification écrite adressée au
Conseil d’Administration, indiquant le nombre d’Actions qu’il désire céder. Dans un délai de deux semaines à compter
de la réception de cette notification, le Conseil d’Administration notifiera l’offre aux co-Actionnaires. Les co-Actionnaires
intéressés par l’achat d’une ou plusieurs des Actions offertes (les "Parties Intéressées") doivent le notifier au Conseil
d’Administration dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le Conseil d’Administration des notifications susmen-
tionnées; passé ce délai, toute notification reçue des co-Actionnaires ne pourra être prise en considération. Si la Société
elle-même, est co-Actionnaire, elle ne pourra agir en tant que Partie Intéressée qu’avec le consentement de l’Offrant.

10.3 Le prix auquel les Actions offertes peuvent être acquises par les Parties Intéressées sera fixé d’un commun accord

entre l’Offrant et les Parties Intéressées ou par un ou plusieurs experts désigné(s) par eux. S’ils ne trouvent pas d’accord
sur le prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), désigné
(s) à la requête d’une ou de plusieurs des parties concernées, par le président de la Chambre de Commerce auprès de
laquelle la Société est immatriculée au Registre de Commerce. Si un expert est désigné, il sera autorisé à contrôler tous
les livres et registres de la Société et devra obtenir toute information utile pour la détermination du prix.

10.4 Dans un délai d’un mois à compter de la détermination du prix, les Parties Intéressées devront notifier au Conseil

d’Administration le nombre d’Actions offertes qu’ils désirent acquérir. Une Partie Intéressée qui n’aurait pas procédé à
la notification dans le délai précité, ne sera plus considérée comme telle. Une fois que la notification mentionnée précé-

53395

L

U X E M B O U R G

demment  aura  été  effectuée,  une  Partie  Intéressée  ne  pourra  se  retirer  qu’avec  l’approbation  des  autres  Parties
Intéressées.

10.5 Si les Parties Intéressées souhaitent acquérir davantage d’Actions que le nombre total d’Actions offertes, les

Actions offertes seront réparties entre eux. Les Parties Intéressées détermineront la répartition d’un commun accord.
S’ils ne trouvent pas d’accord sur la répartition dans un délai de deux semaines à compter de la notification au Conseil
d’Administration, tel que mentionné à l’Article 10.4, les Actions offertes seront réparties entre eux par le Conseil d’Ad-
ministration,  dans  la  mesure  du  possible  au  pro  rata  de  l’actionnariat  de  chaque  Partie  Intéressée  au  jour  de  cette
répartition. Toutefois, le nombre d’Actions offertes attribuées à une Partie Intéressée ne peut pas dépasser le nombre
d’Actions qu’il souhaite acquérir.

10.6 L’Offrant est autorisé à se retirer pendant un mois à compter du jour où il a été informé de/des Partie(s) Intéressée

(s) au(x)quelle(s) il peut vendre la totalité des Actions offertes ainsi que du prix de ladite vente.

10.7 S’il est établi qu’aucun des co-Actionnaires n’est une Partie Intéressée ou que les Actions offertes ne seront pas

toutes achetées contre une libération en numéraire, l’Offrant peut librement céder le nombre total des Actions offertes,
et non pas une partie, endéans les trois mois qui suivent.

10.8 Toutes les notifications et documents mentionnés au présent Article 10 devront être communiqués par lettre

recommandée ou contre accusé de réception. Une copie de toute notification ou document reçu par le Conseil d’Ad-
ministration  devra  immédiatement  être  transmise  à  l’Offrant  et  à  toutes  les  Parties  Intéressées  (à  l'exception  de
l’expéditeur), sauf stipulation contraire ci-dessus.

10.9 Tous les frais liés à la nomination de l’expert ou des experts, selon le cas, et à la détermination du prix par ceux-

ci incomberont à:

(a) l’Offrant, si celui-ci retire son offre;
(b) l’Offrant et les acquéreurs à parité, si les Actions ont été acquises par une ou plusieurs Parties Intéressées, étant

entendu que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre des Actions acquises par lui;

(c) la Société, si l’offre n’a pas été acceptée en totalité ou uniquement en partie.
10.10 Les dispositions précédentes du présent article 10 s’appliqueront par analogie à tout droit de souscription des

Actions et droits de préemption.

Chapitre VI. Nantissement et Usufruit sur actions; Certificats de dépôt des actions.

Art. 11. Nantissement et Usufruit sur Actions.
11.1 Les dispositions de l’article 9 s’appliqueront également par analogie au nantissement des Actions et à la création

ou au transfert d’un usufruit sur Actions.

11.2 Lors de la création d’un droit de nantissement sur une Action, de la constitution ou du transfert d’un usufruit sur

une Action, les droits de vote attribuables à cette Action ne peuvent pas être attribués au créancier gagiste ou à l’usu-
fruitier. Le créancier gagiste ou usufruitier n’auront pas les droits conférés par la loi aux titulaires des certificats de dépôt
émis avec une coopération de la société pour les actions dans son capital.

Art. 12. Certificats de dépôt des Actions. La Société ne participera pas à l’émission de certificats de dépôt de ses

Actions.

Chapitre VII. Le conseil d’administration.

Art. 13. Membres du Conseil d’Administration.
13.1 Le Conseil d’Administration sera constitué d’au moins trois administrateurs. Les membres du Conseil d’Admi-

nistration ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la Société. Les membres du Conseil d’Administration
peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

13.2 Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires.
13.3 Un membre du Conseil d’Administration peut être suspendu ou révoqué à tout moment par l’Assemblée Générale

des Actionnaires.

13.4 L’Assemblée Générale des Actionnaires devra fixer la politique de rémunération du Conseil d’Administration.

Art. 14. Membre unique du Conseil d’Administration.
14.1 Lorsque le nombre d’actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur unique

jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires suivant l’introduction d’un actionnaire supplémentaire. Dans ce
cas, toute référence dans les Statuts au Conseil d’Administration ou aux administrateurs le cas échéant devra être inter-
prétée comme une référence à cet administrateur unique.

14.2 Sans préjudice des dispositions de l’article 16., les transactions conclues par la Société qui ont un intérêt contraire

à celui de son administrateur unique doivent être consignées dans des procès-verbaux. Ceci n’est pas valable pour les
transactions réalisées dans des circonstances normales dans la pratique courante des affaires.

14.3 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l’administrateur unique ou par la signature conjointe

ou individuelle de la personne à laquelle l’administrateur unique a délégué des pouvoirs de signature spéciaux.

53396

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Fonctions, Processus Décisionnel et Répartition des Fonctions.
15.1 Le Conseil d’Administration sera chargé de la gestion de la Société.
15.2 Chacun des membres du Conseil d’Administration dispose d’un vote à l’occasion des décisions prises par le

Conseil d’Administration.

15.3 Toutes les décisions du Conseil d’Administration seront adoptées par plus de la moitié des voix exprimées.
15.4 Les décisions du Conseil d’Administration peuvent également être adoptées en dehors des réunions, par écrit ou

d’une  autre  façon,  à  condition  que  la  proposition  de  vote  en  question  soit  soumise  à  tous  les  membres  du  Conseil
d’Administration alors en fonction et qu’aucun d’eux ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L’adoption de
décisions par écrit s’effectuera par déclarations écrites émanant de tous les membres du Conseil d’Administration alors
en fonction.

15.5 Les décisions du Conseil d’Administration seront consignées dans un registre qui sera tenu par le Conseil d’Ad-

ministration.

15.6 Le Conseil d’Administration peut fixer des règles supplémentaires au sujet de son processus décisionnel et de

ses méthodes de travail. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration peut également déterminer les missions assignées
particulièrement à chacun des membres du Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale des Actionnaires peut dé-
cider que ces règles et répartitions des fonctions devront être fixées par écrit et soumises à son approbation.

Art. 16. Représentation; Conflits d’Intérêt.
16.1 La Société sera représentée par le Conseil d’Administration. Deux membres du Conseil d’Administration agissant

conjointement peuvent également engager la Société envers les tiers.

16.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou individuelle de toute personne

à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

16.3 En cas de conflit d’intérêts entre la Société et un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, les dispo-

sitions du présent article 16 s’appliquent intégralement à moins que l’Assemblée Générale des Actionnaires n’ait nommé
une ou plusieurs autres personnes afin de représenter la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit
d’intérêts. Une décision du Conseil d’Administration approuvant une opération impliquant un conflit d’intérêts avec un
ou plusieurs membres du Conseil d’Administration agissant en leur nom propre, sera soumise à l’approbation de l’As-
semblée Générale des Actionnaires, mais le défaut de cette approbation n’affectera pas la capacité de représentation du
Conseil d’Administration ou de ses membres.

Art. 17. Approbation des Décisions du Conseil d’Administration.
17.1 Les résolutions du Conseil d’Administration concernant un changement matériel de l’identité ou du caractère de

la Société ou de ses entreprises comme mentionné à la Section 2:107a du Code Civil Néerlandais, sont soumis à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

17.2 L’Assemblée Générale des Actionnaires a le pouvoir de soumettre les décisions du Conseil d’Administration à

son approbation. Ces décisions devront être clairement précisées et notifiées par écrit au Conseil d’Administration.

17.3 L’absence d’approbation d’une décision par l’Assemblée Générale des Actionnaires mentionnée au présent article

17 ne portera pas atteinte au pouvoir de représentation du Conseil d’Administration ou de ses membres.

Art. 18. Vacance ou Empêchement. En cas de vacance de poste au Conseil d’Administration (‘ontstentenis’) ou d’em-

pêchement d’un membre du Conseil d’Administration (‘belet’), les autres membres du Conseil d’Administration seront
temporairement chargés de la gestion de la Société. Si tous les postes au sein du Conseil d’Administration sont vacants
ou si tous les membres du Conseil d’Administration ou le membre unique du Conseil d’Administration selon le cas, sont
dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, la gestion de la Société sera provisoirement confiée à une ou plusieurs per-
sonnes désignées à cet effet par l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Chapitre VIII. Exercice social et Comptes annuels; Bénéfices et Distributions.

Art. 19. Exercice Social et Comptes Annuels.
19.1 L’exercice social de la Société correspondra à l’année civile.
19.2 Le Conseil d’Administration prépare tous les ans, cinq mois au plus tard après la fin de l’exercice social, sauf si

en raison de circonstances extraordinaires ce délai est prolongé par l’Assemblée Générale des Actionnaires mais pour
une durée de six mois maximum, les comptes annuels et déposera ces comptes annuels au principal établissement de la
Société où ils peuvent être consultés par les Actionnaires.

19.3 Endéans le même délai, le Conseil d’Administration déposera également le rapport annuel qui pourra être consulté

par les Actionnaires, à moins que la Section 2:396, sous-section 7, ou la Section 2:403 du Code Civil Néerlandais ne
s’applique à la Société.

19.4 Les comptes annuels seront composés d’un bilan, d’un compte de profits et pertes et de notes explicatives.
19.5 Les comptes annuels seront signés par les membres du Conseil d’Administration. S’il manque la signature d’un

ou de plusieurs d’entre eux, il en sera fait mention avec explications à l’appui.

53397

L

U X E M B O U R G

19.6 La Société peut, et si la loi l’exige, devra nommer un comptable afin d’auditer les comptes annuels. Cette nomi-

nation sera effectuée par l’Assemblée Générale des Actionnaires.

19.7 L’Assemblée Générale des Actionnaires adoptera les comptes annuels.
19.8 L’Assemblée Générale des Actionnaires peut accorder décharge pleine ou limitée aux membres du Conseil d’Ad-

ministration pour la gestion exercée.

Art. 20. Bénéfices et Distributions.
20.1 L’Assemblée Générale des Actionnaires décidera de l’affectation des bénéfices acquis au cours de l’exercice social.

Si l’Assemblée Générale des Actionnaires n’adopte pas de résolution concernant l’affectation des bénéfices avant ou au
plus tard immédiatement après l’adoption des comptes annuels, les bénéfices réservés.

20.2 La distribution des bénéfices s’effectuera après l’approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le

permet étant donné le contenu des comptes annuels.

20.3 L’Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Actions

et/ou de procéder à des distributions sur des Actions imputées sur toute réserve de la Société. En outre, le Conseil
d’Administration peut décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Actions.

20.4 Les distributions sur des Actions seront rendues exigibles immédiatement après la décision de procéder à une

distribution, sauf si une autre date de paiement a été fixée dans la décision.

20.5 Les distributions ne pourront être effectuées que dans les limites du montant des Fonds Propres Distribuables

et si cette distribution concerne une distribution intérimaire, que la preuve de la conformité avec ces montants soit
attestée par un bilan intérimaire comme indiqué à la Section 2:105, sous-section 4, du Code Civil Néerlandais. La Société
déposera le bilan au Registre du Commerce Néerlandais endéans les huit jours de la publication de la décision de cette
distribution.

20.6 Lors du calcul du montant d’une distribution sur des Actions, les Actions détenues par la Société ne seront pas

prises en considération.

Art. 21. Assemblées Générales des Actionnaires.
21.1 L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires sera tenue le troisième lundi du mois de mai de chaque année

à 10 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Geertruidenberg et à Luxembourg Ville,
I’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

21.2 L’ordre du jour de cette Assemblée Générale annuelle des Actionnaires comportera, entre autres, les points

suivants:

a. débat sur le rapport annuel;
b. débat et adoption des comptes annuels;
c. décharge accordée aux membres du Conseil d’Administration;
d. affectation des bénéfices; et
e. toute autre proposition émanant du Conseil d’Administration ou des Actionnaires, conformément aux dispositions

de l’article 22.

Les sujets visés aux points a, b, c et d ne seront pas être inscrits à l’ordre du jour si celui-ci contient une proposition

de prolonger la période de préparation des comptes annuels et (le cas échéant) de préparation du rapport annuel, ou si
une décision a, à cet effet, déjà été prise.

21.3 Les autres Assemblées Générales des Actionnaires seront tenues aussi souvent que le Conseil d’Administration

le juge nécessaire.

21.4 Les Actionnaires représentant ensemble au moins un dixième du capital émis de la Société ont le droit de de-

mander au Conseil d’Administration de convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires, en indiquant précisément
les sujets à débattre. Si dans un délai de quatre semaines le Conseil d’Administration n’a pas procédé à la convocation de
l’Assemblée Générale des Actionnaires de telle sorte qu’elle puisse se tenir dans un délai de six semaines à compter de
la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités à procéder eux-mêmes à cette convocation.

Art. 22. Convocation, Ordre du jour et Lieu des Assemblées.
22.1 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration. De plus, les

Assemblées Générales des Actionnaires peuvent être convoquées par les Actionnaires représentant au total au moins la
moitié du capital émis de la Société, sans préjudice des dispositions de l’Article 21.

22.2 La convocation sera faite au plus tard le quinzième jour précédent la date de réunion de l’assemblée.
22.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non indiqués dans la convocation peuvent être

envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois du délai mentionné à l’article 22.2.

22.4 Un sujet à débattre dont le débat a été demandé par écrit soixante jours au plus tard avant le jour de l’assemblée

par un ou plusieurs Actionnaires qui représentent individuellement ou conjointement au moins un pour cent du capital
émis de la Société, figurera sur la convocation ou sera notifié de la même façon que les autres sujets à débattre, sauf
intérêt important contraire (‘zwaarwichtig belang’) de la Société.

53398

L

U X E M B O U R G

22.5 La convocation se fait par des lettres de convocation envoyées aux adresses des Actionnaires, telles qu’indiquées

dans le registre des Actionnaires. Au lieu d’effectuer la convocation par lettre, tout Actionnaire qui donne son consen-
tement, peut recevoir une convocation par message légal et reproductible envoyé électroniquement à l’adresse qu’il a
indiquée à cet effet à la société.

22.6 Les Assemblées Générales des Actionnaires sont tenues dans la commune où, selon les présents Statuts, la Société

à son siège statutaire. Les Assemblées Générales des Actionnaires peuvent aussi être tenues ailleurs, mais dans ce cas les
décisions valables de l’Assemblée Générale des Actionnaires ne pourront être prises que si le capital souscrit et émis de
la Société est intégralement représenté.

Art. 23. Conditions d’admission et Droits de Réunion.
23.1 Chaque Actionnaire sera habilité à assister aux Assemblées Générales des Actionnaires, à y prendre la parole et

à y exercer son droit de vote. Les Actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée par un mandataire habilité, à
cet effet, par écrit.

23.2 A l’assemblée, chaque personne ayant un droit de vote est tenue de signer la feuille de présence. Le président de

l’assemblée peut déterminer si la feuille de présence doit également être signée par d’autres personnes présentes à
l’assemblée.

23.3 Les membres du Conseil d’Administration auront, en tant que tels, voix consultative aux Assemblées Générales

des Actionnaires.

23.4 Si un comptable a été nommé afin de contrôler les comptes annuels, le comptable sera autorisé à participer à

l’Assemblée Générale des Actionnaires et à donner son point de vue.

23.5 Le président de l’assemblée décidera de l’admission à l’Assemblée Générale d’autres personnes.

Art. 24. Président et Secrétaire de l’Assemblée.
24.1 Le président de l’Assemblée Générale des Actionnaires sera nommé à la majorité des voix exprimées par les

titulaires ayant droits de vote présents à l’assemblée. Jusqu’à ce que cette désignation soit faite, un membre du Conseil
d’Administration aura la qualité de président, ou, si aucun membre du Conseil d’Administration n’est présent à l’assemblée,
la personne la plus âgée présente à l’assemblée agira en qualité de président de l’assemblée.

24.2 Le président de l’assemblée désignera un secrétaire pour l’assemblée.

Art. 25. Procès-verbaux; Registre des Décisions des Actionnaires.
25.1 Le secrétaire de l’Assemblée Générale des Actionnaires conservera les procès verbaux des procédures à l’as-

semblée. Les procès-verbaux seront adoptés par le président et le secrétaire de l’assemblée et signés par eux pour preuve
de leur acceptation.

25.2 Le Conseil d’Administration conservera les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l’Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires. Si le Conseil d’Administration n’est pas représenté à l’assemblée, le président de l’assemblée
devra s’assurer que le Conseil d’Administration a reçu une copie des décisions adoptées dès que possible après l’assem-
blée. Les registres seront tenus à disposition au siège de l’administration centrale de la Société où ils pourront être
consultés par les Actionnaires. Sur demande, chaque Actionnaire pourra obtenir une copie ou extrait des registres.

Art. 26. Adoption de Décisions en Assemblée.
26.1 Chaque Action donne droit à une voix.
26.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents Statuts ne prévoient une majorité qualifiée, toutes les décisions de

l’Assemblée Générale des Actionnaires seront toutes adoptées par plus de la moitié des voix exprimées.

26.3 Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.
26.4 Si les formalités requises par la Loi ou les présents Statuts concernant la convocation et la tenue des Assemblées

Générales des Actionnaires ne sont pas observées, les décisions valables de l’Assemblée Générale des Actionnaires ne
seront adoptées à l’assemblée que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté à cette assemblée et
si cette décision est prise à l’unanimité.

26.5 Au sein de l’Assemblée Générale des Actionnaires, aucun droit de vote ne pourra être exercé pour des Actions

détenues par la Société ou une Filiale ainsi que celui afférent aux Actions pour lesquelles la Société ou une Filiale détient
les certificats de dépôt.

Art. 27. Adoption de Décisions sans la tenue d’Assemblées.
27.1 Les décisions de l’Assemblée Générale des Actionnaires peuvent également être adoptées par écrit, sans qu’une

Assemblée Générale des Actionnaires ne soit tenue, à condition qu’elles soient adoptées à l’unanimité de tous les Ac-
tionnaires disposant d’un droit de vote. Les dispositions de l’article 23.3 s’appliqueront par analogie.

27.2 Chaque Actionnaire est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées au Conseil

d’Administration dans les plus brefs délais par écrit. Le Conseil d’Administration prendra note des décisions prises et
ajoutera ces procès-verbaux à ceux mentionnés à l’article 25.2.

53399

L

U X E M B O U R G

Chapitre IX. Modification des statuts; Modification de la forme juridique; Dissolution et Liquidation.

Art. 28. Modification des Statuts.
28.1 L’Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de modifier les présents Statuts par le biais d’une décision

adoptée à la majorité des voix exprimées, représentant au moins les trois quarts du capital émis de la Société. La décision
de modifier les Statuts requiert l’exécution d’un acte notarié passé à cet effet devant un notaire résidant au Grand-Duché
de Luxembourg. Si lors d’une Assemblée Générale des Actionnaires, une proposition de modification des présents Statuts
est présentée, il doit en être fait mention dans la convocation à l’assemblée et un exemplaire de la proposition reproduisant
mot pour mot la modification proposée, devra en même temps être déposé au siège de l’administration centrale de la
Société où il pourra être consulté par les Actionnaires, ceci jusqu’à ce que l’assemblée soit levée. A compter du jour du
dépôt jusqu'au jour de la tenue de l’assemblée, tout Actionnaire pourra, sur demande, obtenir une copie de la proposition,
à titre gratuit. Un acte notarié sera, par ailleurs, rédigé à cet effet par devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter
modification de ces Statuts.

28.2 La Société peut changer sa forme juridique en une autre forme de société. La transformation requiert une décision

de transformation, ainsi qu’une décision de modification des présents Statuts adoptée par l’Assemblée Générale des
Actionnaires en conformité avec la procédure décrite pour la modification des Statuts. En outre, une transformation de
la Société sera soumise aux dispositions de la Loi. Une transformation de la forme juridique n’affectera pas la personnalité
juridique de la Société.

Art. 29. Dissolution et Liquidation.
29.1 La Société peut être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l’Assemblée Générale des Actionnaires. La

décision de dissoudre la Société requiert un acte, lequel doit, à cet effet, s’effectuer par devant notaire résidant au Grand-
Duché de Luxembourg Il doit être fait mention de la proposition de dissolution de la Société dans la convocation à
l’Assemblée.

29.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, les membres

du Conseil d’Administration seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L’Assemblée Générale des
Actionnaires peut décider de nommer d‘autres personnes en qualité de liquidateurs.

29.3 Pendant la liquidation, les dispositions des présents Statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.
29.4 Le solde restant après le remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Actionnaires au

prorata de la valeur nominale totale des Actions que chacun d’entre eux détient.

29.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.

<i>Septième résolution

Les Actionnaires décident de nommer la personne morale suivante en tant que commissaire aux comptes de la Société

avec effet à compter d’aujourd’hui pour une période de six (6) ans:

- Grant Thornton Lux Audit S.A., une société anonyme (public company limited by shares), dont le siège social se situe

au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298.

<i>Huitième résolution

Les Actionnaires décident d’établir le siège sociale, le principal établissement, le lieu de gestion effective et le siège de

l’administration centrale de la Société au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire, s’élève environ à mille cinq
cents Euros (1.500,- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, certifie par la présente qu’à la requête des parties

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre les
versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes;
Lecture du document ayant été faite aux parties comparantes, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, E. VAN DER KNOOP-MARIUS et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 février 2011. Relation: LAC/2011/6869. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

53400

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011035275/987.
(110038759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

C.T.A.M. S.A., Carlo Tassara Assets Management S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.494.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011051374/10.
(110056935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Celin Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 68.289.

EXTRAIT

En tant que domiciliataire de la société CELIN HOLDING S.A., immatriculé B 68 289, nous dénonçons le siège social

à L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011051375/14.
(110057057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Aberdeen Asset Managers Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 121.297.

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

<i>Extrait

En date du 17 mars 2011, le conseil d'administration de ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED, société à respon-

sabilité  limitée,  constituée  en  Grande-Bretagne,  immatriculée  au  registre  de  commerce  en  Grande-Bretagne  sous  le
numéro S.C. 108 419, (la «Société») a décidé de fermer avec effet au 17 mars 2011 la succursale luxembourgeoise de la
Société située au 2b, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg (la «Succursale»).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 avril 2011.

Référence de publication: 2011051357/15.
(110056988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2011.

Ava Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 20, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 54.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2011051525/11.
(110058414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

53401

L

U X E M B O U R G

Centurion European German Property 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.712.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of January.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-

gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435.

here represented by Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of a proxy delivered to him. Said proxy after being signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary
shall remain attached to the present deed.

Such appearing party requests, by its proxy, the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the private limited liability company "Centurion European German Property 7 S.à r.l.", with registered office

in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B,
under the number 140.712, (hereafter the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the July 24 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2070 of the

26 

th

 of August 2008.

II.- That Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.-EUR), represented by

five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.-EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company, with effect on December 31 

st

 , 2010.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he

will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the manager for the performance of his mandate up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the

L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in

any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing person, known to the notary by his first and last

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",

mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435,

hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERICH, Steuerberater, berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur"
unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

53402

L

U X E M B O U R G

Die Komparentin ersucht, durch ihren Bevollmächtigten, den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen

zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Centurion European German Property 7 S.à r.l.", mit Sitz in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter
der Nummer 140.712, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 24. Juli
2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2070 vom 26. August 2008.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-EUR) beträgt, eingeteilt in fünf

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünf und zwanzig Euro (25,EUR).

III.- Dass der Komparent alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010, aufzulösen und zu liqui-

dieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und

dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des

Komparenten, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen des-
selben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die deutsche
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jeannot DIDERRICH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2011. Relation GRE/2011/423. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035202/90.
(110038959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Ava Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 54.778.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 1 

<i>er

<i> avril 2011

<i>Résolution:

Les actionnaires décident de changer de commissaire et ainsi de remplacer la fiduciaire PKF Weber &amp; Bontemps, 6

place de Nancy L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B135187 par la société Callens, Pirenne, Theunissen &amp; Co,
société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 59, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B38178.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2011051526/17.
(110058415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

53403

L

U X E M B O U R G

Babcock &amp; Brown (Odense) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 112.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.430.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales conclue et signée en date du 4 avril 2011 que:
B&amp;B MH 6 Co. Limited, une société à responsabilité limitée de droit maltais ayant son siège social à 171 Old Bakery

Street, Valletta VLT 1455 (Malte), immatriculée auprès du Registry of Companies of Malta (Malte) sous le numéro C38198,
a cédé l'intégralité des 1.485 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la société à B&amp;B MH 3 Co. Limited,
une société à responsabilité limitée de droit maltais ayant son siège social à 171 Old Bakery Street, Valletta VLT 1455
(Malte), immatriculée auprès du Registry of Companies of Malta (Malte) sous le numéro C36861.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011051529/19.
(110057660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Bau Komplett Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.602.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051530/10.
(110057945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Centurion European German Property 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.707.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of January.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-

gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435.

here represented by Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of a proxy delivered to him. Said proxy after being signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary
shall remain attached to the present deed.

Such appearing party requests, by its proxy, the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the private limited liability company "Centurion European German Property 8 S.à r.l.", with registered office

in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B,
under the number 140.707, (hereafter the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the July 24 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2070 of the

26 

th

 of August 2008.

II.- That Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.-EUR), represented by

five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.-EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company, with effect on December 31 

st

 , 2010.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.

53404

L

U X E M B O U R G

VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he

will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the manager for the performance of his mandate up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the

L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in

any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing person, known to the notary by his first and last

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",

mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Bermuda-Inseln unter der Nummer 38435,

hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Steuerberater, berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur"
unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin ersucht, durch ihren Bevollmächtigten, den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen

zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Centurion European German Property 8 S.à r.l.", mit Sitz in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter
der Nummer 140.707, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 24. Juli
2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2070 vom 26. August 2008.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-EUR) beträgt, eingeteilt in fünf

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünf und zwanzig Euro (25,-EUR).

III.- Dass der Komparent alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010, aufzulösen und zu liqui-

dieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und

dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des

Komparenten, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen des-

53405

L

U X E M B O U R G

selben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die deutsche
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jeannot DIDERRICH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2011. Relation GRE/2011/424. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035203/90.
(110038960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Bertelsmann Capital Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 128.114.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 6 août 2010

Le 6 août 2010, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat des

personnes ci-après en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée de trois (3) ans à
compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société:

- Monsieur Elmar HEGGEN, administrateur de catégorie B
- Monsieur Andrew BUCKHURST, class B Direktor
- Monsieur Thomas RABE, class A Direktor
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

Bertelsmann Capital Investment (S.A.) Sicar
Signature

Référence de publication: 2011051532/18.
(110057699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Boeing International Corporation, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 131.398.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051533/10.
(110057988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Borletti Group TITI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 154.683.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 7 Avril 2011.

<i>Résolution:

L’assemblée générale nomme Madame Virginie Derains, employée privée, avec adresse professionnelle 31, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, gérant B, en remplacement de Monsieur Jean Martin Stoffel, démission-
naire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 7 Avril 2011.

Référence de publication: 2011051534/15.
(110058381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

53406

L

U X E M B O U R G

Centurion European German Property 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 140.706.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of January.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

The company established under the laws of Bermuda "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED", with re-

gistered office in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermuda), inscribed in the
Trade and Companies Register of Bermuda under number 38435.

here represented by Mr Jeannot DIDERRICH, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of a proxy delivered to him. Said proxy after being signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary
shall remain attached to the present deed.

Such appearing party requests, by its proxy, the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the private limited liability company "Centurion European German Property 9 S.à r.l.", with registered office

in L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B,
under the number 140.706, (hereafter the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on the July 24 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2077 of the

27 

th

 of August 2008.

II.- That Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.-EUR), represented by

five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.-EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company, with effect on December 31 

st

 , 2010.

V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he

will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the manager for the performance of his mandate up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the

L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in

any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxy-holders of the appearing person, known to the notary by his first and last

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Bermuda-Inseln "CENTURION EUROPEAN HOLDINGS LIMITED",

mit Sitz in Hamilton HM JX, Par-La-Ville Place, Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2257, (Bermudas), eingetragen im Gesell-
schaftsregister der BermudaInseln unter der Nummer 38435,

hier vertreten durch Herrn Jeannot DIDERRICH, Steuerberater, berufsansässig in Luxemburg, auf Grund einer ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur"
unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

53407

L

U X E M B O U R G

Die Komparentin ersucht, durch ihren Bevollmächtigten, den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen

zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Centurion European German Property 9 S.à r.l.", mit Sitz in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter
der Nummer 140.706, gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 24. Juli
2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2077 vom 27. August 2008.

II.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,-EUR) beträgt, eingeteilt in fünf

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünf und zwanzig Euro (25,-EUR).

III.- Dass der Komparent alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2010, aufzulösen und zu liqui-

dieren.

V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und

dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.

VII.- Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1140

Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des

Komparenten, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen des-
selben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die deutsche
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Jeannot DIDERRICH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2011. Relation GRE/2011/425. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035204/90.
(110038961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Brandenburg Properties 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 115.887.

<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la Société en date du 17 décembre 2010:

- Le siège social de l’Associé, Brandenburg Properties S.à r.l., est transféré avec effet au 17 décembre 2010 du 5, rue

Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 avril 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011051535/14.
(110058146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

53408

L

U X E M B O U R G

Brandenburg Properties 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 153.307.

<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la Société en date du 2 mars 2011:

- La nomination du gérant de classe B de la société, Claire Burke (née Ryan), avec adresse à 56 rue Charles Martel,

2134 Luxembourg, a été acceptée avec effet au 2 mars 2011 et ce, pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011051536/13.
(110058012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Beemkleeterer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9560 Wiltz, 8, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 156.889.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011051538/10.
(110058397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Holding Company of 090630 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place Clairfontaine.

R.C.S. Luxembourg B 147.013.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eleven, on the thirty-first of January.
Before the undersigned notary Maître Jean SECKLER, residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-

gned.

There appeared:

The public limited company Holding Company of 090629 S.A., having its registered office in L-1341 Luxembourg, 9,

Place Clairefontaine, R.C.S. Luxembourg number B 147021,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de

Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal,
The said proxy signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party requests the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the public limited company Holding Company of 090630 S.A., with registered office in L-1341 Luxembourg, 9,

Place Clairefontaine, R.C.S. Luxembourg number B 147013 (hereinafter "the Company"), has been incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary on the 30 

th

 of June 2009, published in the Mémorial C number 1457 of the 28 

th

 of

July 2009.

II.- That the subscribed capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.-EUR), divided into thirty-one (31) shares

with a par value of one thousand Euro (1,000.-EUR) each.

III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company.
V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he

will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.

VII.- That fully discharge is given to the board of directors and the statutory auditor for the performance of their

mandates up to this date.

VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the shares have been cancelled.

53409

L

U X E M B O U R G

X.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least at the

former registered office of the company.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in

any form whatsoever, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing person, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this

document.

The deed having been read to the proxy-holder, known to the notary by his first and last name, civil status and residence,

he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zwei tausend elf, den ein und dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft Holding Company of 090629 S.A., mit Sitz in L-1341 Luxemburg, 9, Place Clairefontaine, H.G.R

Luxemburg Nummer B 147021,

hier vertreten durch Herrn Alain THILL, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg,

aufgrund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht,
Vorerwähnte  Vollmacht,  "ne  varietur"  paraphiert  durch  den  Bevollmächtigten  und  den  amtierenden  Notar,  bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin ersucht den amtierenden Notar ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:
I.- Dass die Aktiengesellschaft Holding Company of 090630 S.A., mit Sitz in L-1341 Luxemburg, 9, Place Clairefontaine,

H.G.R Luxemburg Nummer B 147013 (hiernach "die Gesellschaft"), gegründet worden ist gemäß Urkunde aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar am 30. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1457 vom 28. Juli 2009.

II.- Dass das Gesellschaftskapital auf ein und dreissig tausend Euro (31.000,-EUR) festgelegt ist, eingeteilt in ein und

dreissig (31) Aktien von jeweils ein tausend Euro (1.000,-EUR).

III.- Dass die Komparentin alleinige Aktieninhaberin der Gesellschaft ist.
IV.- Dass die Komparentin beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
V.- Dass die Komparentin die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass die Komparentin, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben

und dass sie persönlich die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche die zur Zeit nicht
bekannt sind, gewährleistet.

VII.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer

Mandate erteilt wird.

VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Aktien annulliert worden sind.
X.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am frü-

heren Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,

unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

Komparentin, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen der-
selben Komparentin, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische
Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.

53410

L

U X E M B O U R G

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem instrumentierenden Notar nach Vor-und Zu-

namen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 février 2011. Relation GRE/2011/661. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 8. März 2011.

Référence de publication: 2011035279/93.
(110039027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

Belair Business Offices S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 1, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 149.137.

Le bilan au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Administrateur

Référence de publication: 2011051539/10.
(110058100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Bromley S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 21.630.

AUSZUG

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 11. April 2011 wurde beschlossen den Rücktritt folgender

Personen als administrateur délégué à la gestion journalière (delegiertes Verwaltungsratsmitglied) der Gesellschaft mit
Wirkung zum 24. März 2011 anzunehmen:

- Jean-Marie POOS; und
- Luc BRAUN
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. April 2011.

<i>Für Bromley S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2011051541/17.
(110058322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Business Controls &amp; Services International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 11.398.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle réunie en date du 8 mars 2011

L’an deux mille onze, le huit mars, les actionnaires de la société BUSINESS CONTROLS &amp; SERVICES INTERNATIO-

NAL S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social et ont pris les résolutions suivantes:

1) Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué étant arrivés à échéance, les actionnaires décident

de renouveler dans leurs fonctions:

- Madame Colette WOHL, demeurant 6, rue des Primevères à L-8090 Bertrange,
- Monsieur Gérard CHOFFEE, demeurant 44, Avenue Hamoir à B-1180 Bruxelles (Belgique), et
- Madame Béatrice NIEDERCORN-MICHAUX, demeurant 51, rue de Verdun à F-57100 Thionville (France).
Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2017 et statuant sur les comptes de l’exercice clos en 2016.

Le mandat de l’administrateur-délégué, Madame Béatrice NIEDERCORN-MICHAUX, est également renouvelé pour

la période décrite ci-dessus.

2) Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir:

53411

L

U X E M B O U R G

Fiduciaire CABEXCO SARL, ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent (RCS Luxem-

bourg B 139.890), étant également arrivé à échéance, les actionnaires décident de renouveler son mandat jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017 et statuant sur les comptes de l’exercice clos en 2016.

Luxembourg, le 8 mars 2011.

<i>Les actionnaires

Référence de publication: 2011051543/25.
(110057645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

BWA Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 141.597.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BWA Lux S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011051544/12.
(110057822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Icebird S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-

moine Familial,

(anc. Icebird Holding S.A.).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 92.742.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "ICEBIRD HOLDING S.A.", a société anonyme

holding, having its registered office in Luxembourg, 42, rue de la Vallée, (R.C.S. Luxembourg: B 92742), incorporated by
a notarial deed on March 21, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 465 of
April 29, 2003.

The  extraordinary  general  meeting  is  opened  by  Mrs  Sylviane  SCHROEDER,  private  employee,  with  professional

address in Luxembourg in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christine COULON-RACOT, private employee, with pro-

fessional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Christelle HERMANT-DOMANGE, private employee, with professional address

in Luxembourg. The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary
to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a holding

company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of a Family Private Assets Management Company (“SPF”)
as defined by the Law of May, 11, 2007.

2. Change of the company's name from “ICEBIRD HOLDING S.A.” into “ICEBIRD S.A., société de gestion de patri-

moine familial” and subsequent amendment of the first paragraph of Article 1 to be read as follows: “There exists a
corporation (société anonyme) under the name of “ICEBIRD S.A., société de gestion de patrimoine familial”.

3. Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation relating to the purpose of the company which

henceforth will be read as follows:

“ Art. 2. The company has for exclusive object the acquisition, the holding, the management and the realization of

financial assets, such as the financial instruments in the sense of the law of August 5 

th

 , 2005 concerning the contracts

of financial guarantee, and the cash and the assets of whatsoever form, held in an account, with the exception of any
commercial activity.

The company may hold a participating interest in a company at the sole condition that it will not interfere in its

management.

53412

L

U X E M B O U R G

The company will take any measures to protect its rights and will carry out any operation which it may deem useful

to the accomplishment and development of its purposes, remaining however within the limits established by the Law of
May 11 

th

 , 2007 concerning the creation of a “société de gestion de patrimoine familial” ("SPF").

4. Cancellation, in the Article 3 of the Articles of Incorporation, of paragraphs concerning the fallen due and not

renewed authorized capital

5. Addition of a new paragraph to Article 3 as follows:
“The company will reserve its shares to the following investors:
a) a physical person acting within the framework of the management of its private holdings or
b) a patrimonial entity acting exclusively in interest of the holdings deprived of one or several physical persons or
c) an intermediary acting for aimed investors sub a) or b) of the present paragraph.”
6. Amendment of Article 4 of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

“ Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting”.

7. Amendment of Article 5 of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

“ Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors. In case the Company has only one director, such director exercises all
the powers granted to the board of directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman;
in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting. The board can validly deliberate and act
only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter,
telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company. Resolutions shall
require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote. According to article 60 of the Law, the daily
management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their
nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member
of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general
meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by
authentic proxy or power of attorney by private instrument. The Company will be bound by the joint signature of two
(2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of
directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature
of the sole director”.

8. Amendment of Article 11 of the Articles of incorporation so as to reflect the following terms:

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, and the law of May 11, 2007 on Private

Assets Management Company (“SPF”) shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the
contrary.

9. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an

attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or

represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the
agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:

53413

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend the status of the company so that, henceforth, the company

will no more have the status of a holding company as defined by the law of July 31, 1929 but the status of a Family Private
Assets Management Company (“SPF”) as defined by the Law of May, 11, 2007.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolved to change the Company's name and subsequent to amend the first sen-

tence of the Article 1 of the Articles of incorporation as follows:

“There exists a corporation (société anonyme) under the name of “Icebird S.A., société de gestion de patrimoine

familial”.”

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend Article 2 of the company relating to the purpose of the company

which henceforth will be read as follows:

“ Art. 2. The company has for exclusive object the acquisition, the holding, the management and the realization of

financial assets, such as the financial instruments in the sense of the law of August 5 

th

 , 2005 concerning the contracts

of financial guarantee, and the cash and the assets of whatsoever form, held in an account, with the exception of any
commercial activity.

The company may hold a participating interest in a company at the sole condition that it will not interfere in its

management.

The company will take any measures to protect its rights and will carry out any operation which it may deem useful

to the accomplishment and development of its purposes, remaining however within the limits established by the Law of
May 11 

th

 , 2007 concerning the creation of a “société de gestion de patrimoine familial” ("SPF").

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolved to cancel, in Article 3 of the Articles of incorporation, the text concerning

the fallen due and not renewed authorized capital.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolved to add a new paragraph to Article 3 of the Articles of incorporation as

follows:

“The company will reserve its shares to the following investors:
a) a physical person acting within the framework of the management of its private holdings or
b) a patrimonial entity acting exclusively in interest of the holdings deprived of one or several physical persons or
c) an intermediary acting for aimed investors sub a) or b) of the present paragraph.”

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend Article 4 of the Articles of Incorporation which will be read as

follows:

“ Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.”

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

“ Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

53414

L

U X E M B O U R G

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting of the

board of directors duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical document stating the terms of the resolution accurately, and may be evidenced by letter, telefax or telex.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.”

<i>Eighth resolution

The extraordinary general meeting resolved to amend Article 11 of the Articles of incorporation to be read as follows:

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, and the Law of May 11, 2007 on

Family Private Assets Management Company (“SPF”) shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide
for the contrary".

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-huit décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "Icebird Holding S.A.",

ayant son siège social à Luxembourg, 42, rue de la Vallée, (R.C.S. Luxembourg: B 92742) constituée suivant acte notarié
en date du 21 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 465 du 29 avril 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylviane SCHROEDER, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine COULONRACOT, employée privée, demeurant profes-

sionnellement  à  Luxembourg.  L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Christelle  HERMANT-DOMANGE,
employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification de la dénomination de la société de «ICEBIRD HOLDING S.A.» en «ICEBIRD S.A., société de gestion

de patrimoine familial» et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 1 des statuts qui se lira comme
suit: "Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination
de “Icebird S.A., société de gestion de patrimoine familial”.

3. Modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social de la société comme suit:

53415

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir
une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

4. Annulation. dans l'article 3 des statuts, des paragraphes concernant le capital autorisé venu à échéance et non

renouvelé.

5. Ajout d'un nouvel alinéa à l'article 3 des statuts comme suit: «La société réservera ses actions aux investisseurs

suivants:

a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
6. Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.»

7. Modification de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration. Le Conseil
d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres
est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant
admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des
voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. La gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être
déléguées  à  un  ou  plusieurs  administrateurs,  directeurs,  gérants  et  autres  agents,  associés  ou  non,  agissant  seuls  ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement
compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La
Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. La société se
trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s)
à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil
d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.».

8. Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.".

9. Divers.

53416

L

U X E M B O U R G

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une

société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini
par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination de la société et de modifier en conséquence

le premier alinéa de l'article 1 des statuts qui se lira comme suit:

«Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de

«Icebird S.A., société de gestion de patrimoine familial».»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social de la société comme

suit:

« Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir
une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'annuler, dans l'article 3 de statuts, le texte concernant le capital autorisé

venu à échéance et non renouvelé.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 3 des statuts comme suit:
«La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En
cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés
ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

53417

L

U X E M B O U R G

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.».

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.».

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. SCHROEDER, C. COULON-RACOT, C. HERMANT-DOMANGE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2011. Relation: EAC/2011/87. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011035302/352.
(110038600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2011.

BWA Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 141.597.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BWA Lux S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011051545/12.
(110057823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

53418

L

U X E M B O U R G

Maximus Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 157.631.

II résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 28 février 2011, que la société Platinum Equity

Capital Partners International II (Cayman), L.P., une société en commandite, constituée selon le droit des lles Cayman,
ayant son siège social à c/o Walkers SPV limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands ("'Platinum Equity Capital Partners International II (Cayman), L.P,''), a cédé:

- mille deux cent soixante-cinq (1.265) parts sociales de la Société à la société Platinum Equity Capital Partners-PF

International II (Cayman), L.P., une société en commandite, constituée selon le droit des lles Cayman, ayant son siège
social à c/o Walkers SPV limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman
Islands (''Platinum Equity Capital Partners-PF International II (Cayman), L.P.");

- mille deux cent trente-sept (1.237) parts sociales de la Société à la société Platinum Equity Capital Partners-A Inter-

national II, (Cayman), L.P., une société en commandite, constituée selon le droit des lles Cayman, ayant son siège social
aà c/o Walkers SPV limited. Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands
(''Platinum Equity Capital Partners-A International II (Cayman), L.P,");

- six cent quatre-vingt-sept (687) parts sociales de la Société à la société Platinum Maximus Principals International

(Cayman), L.P., une société en commandite, constituée selon le droit des lles Cayman, ayant son siège social à c/o Walkers
SPV limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands (''Platinum Maximus
Principals International (Cayman), L.P.);

- 20,8358150% des droits de propriété indivis sur deux (2) parts sociales de la Société à la société Platinum Equity

Capital Partners-PF International II (Cayman), L.P.;

- 25% des des droits de propriété indivis sur deux (2) parts sociales de la Société à la société Platinum Equity Capital

Partners-A International II (Cayman), L.P.;

- 25% des droits de propriété indivis sur deux (2) parts sociales de la Société a la société Platinum Maximus Principals

International (Cayman), L.P.

Suite à la cession, les parts sociales de la Social (i.e. 11.000) sont détenues comme suit:
- Platinum Equity Capital Partners International II (Cayman), L.P.:
* 7.809 parts sociales de la Société;
* et 29,1641850% des droits de propriété indivis sur deux parts sociales de la Société.
- Platinum Equity Capital Partners-PF International II (Cayman), L.P.:
* 1.265 parts sociales de la Société;
* et 20,8358150% des droits de propriété indivis sur deux parts sociales de la Société.
- Platinum Equity Capital Partners-A International II (Cayman), L.P.:
*1.237 parts sociales de la Société;
* et 25 % des droits de propriété indivis sur deux parts sociales de la Société.
- Platinum Maximus Principals International (Cayman), L.P.:
* 687 parts sociales de la Société;
* et 25% des droits de propriété indivis sur deux parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2011.

Référence de publication: 2011036250/45.
(110040454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

Heritage Centra Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.671.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 11 avril 2011 que la société FIDIS S.à r.l.

démissionne de son mandat de gérant B de la Société avec effet au 14 avril 2011 et que la société

- EFFIGI S.à r.l, a société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le N°

B 107.313 ayant son siège social 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

53419

L

U X E M B O U R G

est nommée en qualité de gérant B de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 14 avril 2011.
A compter du 14 avril 2011, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:
- Mark J. JROLF, Gérant A;
- DMC Sàrl, gérant B;
- EFFIGI Sàrl, gérant B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

<i>Pour Heritage Centra Investors S.à.r.l.
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011051632/24.
(110058169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Hauppauge Digital Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 370.320,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 71.905.

EXTRAIT

En date du 8 avril 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Frank Walenta, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Wim Rits, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant avec

effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Le siège social de la société est transféré au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1 

er

 août

2010.

Suite à ces résolutions le conseil de gérance se compose comme suit:
- Kenneth Plotkin, gérant
- Wim Rits, gérant
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 avril 2011.

Référence de publication: 2011051633/20.
(110057664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

4Finance Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5252 Sandweiler, 25A, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 159.360.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am ersten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Wolfgang SAUER, Kaufmann, wohnhaft in D-67480 Edenkoben, Bahnhofstraße, 149,
hier vertreten durch Herrn Christian KÖNIG, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstr. 23,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht vom 10.01.2011.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienene Partei und den un-

terzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselbigen bei den für die Registrierung
zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

In ihrer oben beschriebenen Eigenschaft ersuchte die erschienene Partei den unterzeichneten Notar, die Satzung einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Rechtsform - Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen

„4Finance Lux S.à r.l." gegründet.

53420

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Zweck dieser Gesellschaft ist es, für eigene oder für fremde Rechnung beratende oder betreuende Tätigkeiten

im  Finanzwesen  auszuführen,  insbesondere  die  Begleitung  der  Auflegung  von  Investmentvehikeln  aller  Art  sowie  die
Vermittlung von Finanzprodukten anzubahnen und zu begleiten. Die Gesellschaft kann vorbehaltlich eventuell erforder-
licher behördlicher Genehmigungen sämtliche Aufgaben erledigen, die im vorstehend dargelegten Rahmen erforderlich
sind.  Sie  kann  im  Namen  und  für  Rechnung  der  von  ihr  vertretenen  Gesellschaften  und  Privatpersonen  Verträge
abschließen, Verbindlichkeiten begründen oder eingehen und rechtsverbindliche Erklärungen aller Art abgeben.

Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen in jeder Form an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften halten.

Sie kann auch jede andere Anlageform erwerben, verwalten, weiterentwickeln und übertragen.

Die Gesellschaft kann anderen Gesellschaften oder Privatpersonen Darlehen gewähren oder auf andere Weise Beis-

tand leisten.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Gewerbe- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten

ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Sandweiler. Er kann durch Beschluss der Geschäftsführer, die

gemeinsam die Geschäftsleitung der Gesellschaft bilden, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5.  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölftausendvierhundert  Euro  (12.400,-  EUR)  aufgeteilt  in  einhundertvie-

rundzwanzig (124) Anteile mit einem Wert von je einhundert Euro (100,- EUR), die allesamt vom Gründungsgesellschafter
gehalten werden.

Art. 6. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.
Die Anteile der Gesellschaft können nur mit vorheriger Zustimmung aller übrigen Gesellschafter übertragen werden.

Den Mitgesellschaftern wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt.

Durch das Ausscheiden eines Gesellschafters durch dessen Tod oder einen sonstigen Grund werden dessen Anteile

falls  sie  nicht  einem  anderen  Gesellschafter  zufallen,  stimmrechtslos.  Die  Ausübung  des  Stimmrechtes  durch  einen
Rechtsnachfolger ist vorbehaltlich einer ausdrücklichen Zustimmung der anderen Gesellschafter ausgeschlossen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung aller Gesellschafter abgeändert werden.

Art. 8. Durch den Tod, die zeitweilige Aufhebung von Bürgerrechten, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines

Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 9. Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht aus mehreren Geschäftsführern, die gemeinsam die Geschäfts-

leitung bilden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer sind mit den weitestgehenden, d.h. mit sämtlichen nicht den Gesellschaftern bzw. der General-

versammlung  gesetzlich  ausdrücklich  obliegenden  Befugnissen  ausgestattet,  unter  allen  Umständen  im  Namen  der
Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszu-
führen und zu erlauben. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung ernannt, welche deren Amtsdauer
festsetzt. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe eines rechtfertigenden Grundes ("cause légitime") durch
die Generalversammlung abberufen werden.

Die Gesellschaft wird im Falle eines alleinigen Geschäftsführers durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers

oder im Falle mehrerer Geschäftsführer durch die gemeinsame Zeichnung zweier Geschäftsführer oder aber durch die
Unterschrift einer Person verpflichtet, der die Befugnis zur Unterzeichnung durch den alleinigen Geschäftsführer bzw.
die Geschäftsleitung erteilt worden ist. Der alleinige Geschäftsführer / die Geschäftsleitung kann besondere Vollmachten
auf Grund notariell beglaubigter oder privatschriftlicher Urkunde erteilen.

Art. 10. Es besteht keine persönliche Haftung des oder der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die er/sie im Namen

der Gesellschaft vorschriftsmäßig eingehen bzw. eingegangen sind.

Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen der Generalversammlung - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters

Art. 11. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 12. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die

mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Eine Satzungsänderung erfordert die Zustimmung aller Gesellschafter.

53421

L

U X E M B O U R G

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 13. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 14. Mindestens fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften kann die

Geschäftsleitung Dividenden sowie Zwischendividenden ausschütten. Die Auszahlung von Zwischendividenden unterliegt
nachfolgenden Voraussetzungen:

a) es ist eine Zwischenbilanz zu erstellen, aus welcher hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel für eine Zwische-

nausschüttung zur Verfügung stehen;

b) als Ausschüttungsbetrag darf höchstens der folgende Betrag ausgezahlt werden: der seit dem Ende des letzten

Geschäftsjahres - dessen Jahresabschluss genehmigt worden ist - realisierte Gewinn, zuzüglich der Gewinnvorträge und
der auf zu diesem Zweck freigewordenen Rücklagen geleisteten Zahlungen, sowie abzüglich der Verlustvorträge und der
zur Bildung von Rücklagen geleisteten Zahlungen, die im Gesetz oder der Satzung der Gesellschaft vorgesehen sind;

c) ferner muss vorbenannte Entscheidung innerhalb von 2 Monaten nach Erstellung der unter Punkt a) genannten

Zwischenbilanz getroffen werden.

F. Auflösung - Liquidation

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche

Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der
Gesellschafter ernannt, ausgeführt. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung
der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem,

unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile aufgeteilt.

Art. 16. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handels-

gesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung, geregelt.

G. Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet durch Herrn Wolfgang SAUER, vorgenannt, und vollständig in bar eingezahlt, so dass

ab heute der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendvierhundert Euros (12.400,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies
dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

H. Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.

I. Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

950,- EUR geschätzt.

J. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der einzige Gesellschafter, vertreten wie eingangs erwähnt, welcher das

Gesamtkapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 25A, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler.
2. Es wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Wolfgang SAUER, Kaufmann, geboren am 8. April 1968 in Annweiler (Deutschland), wohnhaft in D-67480 Eden-

koben, Bahnhofstraße, 149, welcher die Gesellschaft gegenüber Dritten durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig
vertreten kann, Selbstkontrahierung einbegriffen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, sowie

Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. KÖNIG, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2011. Relation: LAC/2011/9898. Reçu 75,- € (soixante-quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt an das Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

53422

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 7. März 2011.

Référence de publication: 2011036390/128.
(110040002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

HEP Luxwell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 100.052.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 25 mars 2011

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Alain HEINZ et Monsieur Fabio MAZZONI de leurs mandats d’adminis-

trateurs de la Société avec effet immédiat.

L’assemblée décide de nommer Monsieur José CORREIA, né le 04 octobre 1971 à Palmeira (Portugal) et Monsieur

Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin (France), résidant professionnellement au 67, rue
Ermesinde L-1469 Luxembourg, aux postes d’administrateurs de la Société avec effet immédiat.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2016.
L’assemblée décide de révoquer A&amp;C Management Services S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société

avec effet immédiat.

L’assemblée décide de nommer READ S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois enregistré

au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B45083, ayant son siège social au 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat.

Son mandat commencera avec la revue des comptes au 31 décembre 2007 et prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011051635/23.
(110058366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

I.E.D.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 74.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011051640/9.
(110057706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Sinabe S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 44.063.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 7 avril 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.
L'assemblée générale du 7 avril 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

53423

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 7 avril 2011.

<i>Pour SINABE S.A. –SPF
Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011049916/21.
(110055428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

Crédit Agricole Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 91.986.

Le Conseil d'administration de la société, en sa réunion du 16 décembre 2010, a pris les résolutions suivantes:
- acter la démission de Monsieur Philippe Doré, Administrateur, à compter du 10 décembre 2010
- coopter comme administrateur Monsieur Olivier Livenais, né le 15 juillet 1975 à Angers (France), ayant son adresse

professionnelle au 13-15, rue de la Baume à F-75008 Paris, en remplacement de M. Doré, démissionnaire, dont il achèvera
le mandat. Le mandat de Monsieur Livenais prendra effet le lendemain ouvrable de la date de réception de son agrément
par la Commission de surveillance du secteur financier, (soit le 10 mars 2011) et prendra fin lors de l'assemblée générale
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/03/2011.

<i>Pour le Conseil d'administration
Hervé ROUX
<i>Secrétaire général

L'assemblée générale des actionnaires de la société, en sa réunion du 14 février 2011, a pris les résolutions suivantes:

- L'Assemblée nomme Monsieur Christophe Gancel, né le 11 novembre 1952 à Paris (14 

ème

 ), ayant son adresse

professionnelle au 64, rue du Stand à CH-1211 Genève (Suisse), comme administrateur de la société à dater de ce jour
(14 février 2011).

- Le mandat de Monsieur Christophe Gancel prendra fin au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à

statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/02/2011.

<i>Pour le Conseil d'administration
Hervé ROUX
<i>Secrétaire général

Référence de publication: 2011036814/30.
(110040571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

ArcelorMittal Dudelange, Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R.C.S. Luxembourg B 17.870.

<i>- Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 4 février 2011 -

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Henri BLAFFART, Président et membre du

Conseil d'Administration d'ArcelorMittal Dudelange, avec effet au 4 février 2011,

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de coopter comme Administrateur, Monsieur Thierry RENAUDIN,

CEO d'ArcelorMittal Lorraine avec l'adresse professionnelle: F-57190 Florange, 17 Avenue des Tilleuls. Le Conseil d'Ad-
ministration le nomme également Président.

Dudelange, le 7 février 2011.

Pour extrait conforme
Marc MAMER / Armand ROBINET
<i>Fondé de pouvoirs / Fondé de pouvoirs

Référence de publication: 2011052163/17.
(110058812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53424


Document Outline

4Finance Lux S.à r.l.

Aberdeen Asset Managers Limited, Luxembourg Branch

Aixone S.à r.l.

Alior Lux Sàrl &amp; Co S.C.A.

Alis S.A.

Alkab S.à r.l.

ArcelorMittal Dudelange

Asset Backed Europe S.A.

Ava Luxembourg

Ava Luxembourg

Babcock &amp; Brown (Odense) S.à.r.l.

Bau Komplett Service S.à r.l.

Beemkleeterer S.à r.l.

Belair Business Offices S.A.

Bertelsmann Capital Investment S.A.

Boeing International Corporation

Borletti Group TITI S.à r.l.

Brandenburg Properties 18 S.à r.l.

Brandenburg Properties 1 S.à r.l.

Bromley S.A.

Business Controls &amp; Services International S.A.

BWA Lux S.à r.l.

BWA Lux S.à r.l.

Café Lenger Stuff s.à r.l.

Carlo Tassara Assets Management S.A.

Celin Holding S.A.

Centurion European German Property 5 S.à r.l.

Centurion European German Property 6 S.à r.l.

Centurion European German Property 7 S.à r.l.

Centurion European German Property 8 S.à r.l.

Centurion European German Property 9 S.à r.l.

Crédit Agricole Luxembourg

Hauppauge Digital Europe S.à r.l.

Heerendam S.A./N.V

HEP Luxwell S.A.

Heritage Centra Investors S.à r.l.

Holding Company of 090630 S.A.

Icebird Holding S.A.

Icebird S.A., société de gestion de patrimoine familial

I.E.D.I. S.A.

Maximus Holding II S.à r.l.

Sinabe S.A.- SPF