logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 860

30 avril 2011

SOMMAIRE

Amber Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41265

Ardea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41268

Ardennes Invest Lux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

41270

Azimuth International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

41269

Azimuth International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

41270

Baddon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41279

Bellune Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41273

Bio-Tech International S.A.  . . . . . . . . . . . . .

41274

Biron S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41274

Braveza Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41278

Britanica Asset Management SA  . . . . . . . .

41280

Casuarina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41280

Cergrafhold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41274

C.I.D., Céramique Internationale Dévelop-

pement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41279

Dialna S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41266

Dialna S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41266

FIAL International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41234

FM Racing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41262

G & P Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41263

Grus Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41279

International Allied Services S.A.  . . . . . . . .

41280

Internaxx Bank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41234

JALUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41272

Lieber Racing Team S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

41270

M-F LUX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41268

Mouton S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41264

NEIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41263

Norpa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41257

Ophrys Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41275

Rémy Cointreau Luxembourg S.A.  . . . . . .

41275

Safcon Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41274

Saran S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41263

Service VIP Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41259

SHRM Financial Services (HK) Limited, Lu-

xembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41244

SHRM Financial Services (HK) Limited, Lu-

xembourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41244

Société d'Etude et de Recherche Appli-

quée en Cancérologie (SERAC) S.A.  . . . .

41270

Sparinvest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41268

Triangle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41265

Ultimo Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41234

West Investment Holding S.A.  . . . . . . . . . .

41277

Wireless M2M Subco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

41261

Xenia Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41266

41233

L

U X E M B O U R G

Ultimo Holding, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 118.760.

Comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011037294/12.
(110040679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Internaxx Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 78.729.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 9 mars 2011, il a été décidé de confirmer

pour autant que de besoin ce qui suit:

- la démission de Monsieur Angus Rigby, né le 13/01/1971 à Donald, Australie, avec effet au 20 janvier 2011 en tant

qu'administrateur de la Société («executive Director»);

- la nomination de Monsieur Paul Whitehead, né le 28/07/1968 à Northampton, USA, résidant 22 Albert Square,

Bowdon, Altricham, Cheshire WA14 3EW au Royaume-Uni, avec effet au 9 mars 2011 jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en 2014, en tant qu'administrateur de la Société («executive Director»).

- la nomination de Madame Annemarie Jung, née le 13/08/1971 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au

46A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2011 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en 2014 en tant qu'administrateur de la Société («executive Director»);

- la nomination de Madame Annemarie Jung, née le 13/08/1971 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au

46A Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2011 pour une durée indéterminée en tant que

déléguée à la gestion journalière de la Société;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg, le 17 mars 2011.

Internaxx Bank S.A.
Signature

Référence de publication: 2011040017/25.
(110043764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

FIAL International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 31.393.

<i>Projet de Scission

Dans un but de regroupement des différentes activités stratégiques du groupe,
le Conseil d'Administration de FIAL INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,
au capital social de EUR 2.200.000 (deux millions deux cent mille), représenté par 25.696 (vingt-cinq mille six cent

quatre-vingt-seize) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées,

ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, Rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés

à Luxembourg sous le numéro B 31.393 (ci-après définie "l'ancienne FIAL", la "Société" ou la "Société à scinder")

constituée par acte du notaire Maître Frank BADEN le 11 août 1989, publié au Mémorial C de 1990 numéro 4 page

174, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 975
du 25 mai 2007

propose de procéder à la scission partielle de la Société par la constitution d'une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, dénommée ci-après la "nouvelle société", ayant le statut fiscal "soparfi".

La nouvelle société portera la dénomination sociale de:

41234

L

U X E M B O U R G

- FIAL INDUSTRIAL S.à r.L, (dénommée ci-après: "FIAL INDUSTRIAL") ayant son siège social à L-l 724 Luxembourg,

19-21, Boulevard du Prince Henri.

Le capital social de FIAL INDUSTRIAL sera de EUR 200.000 (deux cent mille euros), représenté par 100 (cent) partes

sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées,

La scission partielle de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tels que modifiés (ci-après "la loi sur les sociétés").

Les comptes retenus pour déterminer les conditions de l'opération sont ceux arrêtés par le Conseil d'administration

en date du 31 décembre 2010.

Les actionnaires de la Société sont appelés, à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la

Société (date de la scission) qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet, à approuver la scission
partielle par laquelle la Société transfère, sans toutefois disparaître, à la nouvelle société FIAL INDUSTRIAL, l'intégralité
de son portefeuille de participation avec les droits et obligations qui s'y rattachent, activement et passivement, la Société
continuant son activité commerciale avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

La Société réduira ainsi son capital social d'un montant de 200.000 euro par annulation de 2.336 actions sans désignation

de valeur nominale, les parts sociales de la société FIAL INDUSTRIAL représentatives du capital sociale de 200.000 euro
de FIAL INDUSTRIAL, crées par l'apport du portefeuille de participations avec les droits et obligations qui s'y rattachent
résultant de la scission partielle, étant attribués aux actionnaires de la Société au prorata des actions annulées de la Société
à raison de 2.336 parts sociales de FIAL INDUSTRIAL contre 2.336 actions de la Société annulées.

La partie du patrimoine de la Société scindée, faisant l'objet de scission partielle, sera intégralement dévolu à la nouvelle

société dans l'état où il se trouvera à la date de ladite scission partielle.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société en relation avec l'apport du portefeuille de participations

avec les droits et obligations qui s'y rattachent seront considérées, à compter de la date de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire de la Société approuvant la scission comme accomplies pour compte de la nouvelle société issue de la scission
à laquelle a été attribuée actif et passif.

En application de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales, tous les actionnaires de la Société renonceront

au rapport du Conseil d'Administration et aux rapports d'experts prévus par l'article 293 et 294.

Les parts sociales de la nouvelle société seront inscrites au nom des actionnaires de la Société sur le registre des parts

nominatives des associés de la nouvelle société dès que la scission sera approuvée. Les actions de la Société, correspondant
aux actifs nets transférées à FIAL INDUSTRIAL, seront annulées le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la
Société approuvant la scission.

Un certificat d'inscription nominative sera remis à chaque associé de la nouvelle société au cas où ces associés le

demandent.

Les  parts  sociales  de  la  nouvelle  société  donneront  le  droit  de  participer  aux  votes  sur  les  bénéfices  et  boni  de

liquidation éventuels de la nouvelle société dès l'approbation de la scission par l'assemblée générale des actionnaires de
la Société FIAL INDUSTRIAL, sans modalités particulières relatives à ce droit.

La Société n'a émis aucune part bénéficiaire ni aucune action privilégiée. En conséquence, aucun actionnaire ne dispose

de droits spéciaux et aucun titre autre que des parts n'est émis par la nouvelle société.

Aucun avantage particulier n'est attribué au Commissaire aux comptes, ni aux membres de l'organe de gestion eu

égard à l'opération de scission.

Les éléments du patrimoine total, actif et passif de la Société, avant scission, tels qu'arrêtés au 31 décembre 2010, sont

les suivants:

ACTIF

31/12/2010

B./1. - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT / FRAIS D'ÉTABLISSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 005.68

2040-01

Frais changement de statuts (08.03.07)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 005.68

B./2. 

FRAIS 

D'ÉTABLISSEMENT 

AMORTISSEMENTS 

FRAIS

D'ÉTABLISSEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 005.68

2049-01

Amort. frais Changement de statuts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 005.68

C./3. - ACTIF IMMOBILISÉ / IMMOBILISATIONS CORPORELLES . . . . . . . . . . . . . . .

2 091.00

2220-01

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 091.00

C./4.  -  ACTIF  IMMOBILISÉ  /  AMORTISSEMENT  IMMOBILISATIONS
CORPORELLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 533.40

2229-01

Amort.du Mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 533.40

C./5. - ACTIF IMMOBILISÉ / IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . 6 507 372.63

2800-01

Galperti Investments Inc 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

768 442.60

2800-02

L.F.F. Holding 33.33%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 136 421.00

2800-04

S.F.F. Holding 33.33%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

949 964.00

2800-05

P.F.F. Holding 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

878 902.00

41235

L

U X E M B O U R G

2800-08

Galperti India 33.33%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 345.82

2800-09

Galperti Middle East 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247 919.76

2800-10

L.F.F. Properties Partnership 23.10%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256 849.00

2800-11

Tre Invest 50%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234 578.00

2800-12

Ardita Latina Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 100.00

2800-13

Galperti Far East Holdings Limited 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

2800-16

Galperti Do Brasil Comercial LTDA 99.99%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 000.00

2800-18

Galperti (Hong Kong) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.00

2800-19

Galperti South East Asia PTE LTD 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 124.59

2800-20

Australasian Fittings and Flanges PTY LTD 26%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.24

2800-21

Gaperti Korea (Trading) Inc 50%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 093.60

2800-22

PT. Mitra Galperti 70%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789 265.98

2800-24

Galperti Manufacturing (Malaysia) SDN.BHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

697 420.99

2803-03

Acompte sur achat de particip. Galperti Energy RU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 991.24

2900-01

Financement Galperti Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 663.81

C./7.  -  ACTIF  IMMOBILISÉ  /  CORRECTION  DE  VALEUR  IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-70 284.76

2851-02

Corr. de val. sur Part. L.F.F. Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-58 558.50

2851-04

Corr. de val. sur Part. Ardita Latina Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9 100.00

2853-01

Corr. de val. des financ. Galperti Inv.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2 626.26

D./1. - ACTIF CIRCULANT/CRÉANCES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 379 665.27

2900-07

Financement à Fial s.p.a. (Eur 1an + 0.5%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 000.00

4101-02

Créance sur particip. - Galperti Far East USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4109-03

A recevoir sur cession Galperti France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4113-03

TVA à récupérer 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4113-04

TVA à récupérer 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 270.32

4113-05

TVA à récupérer 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 082.23

4113-06

TVA à récupérer 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 003.00

4120-02

Acompte sur TVA 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4120-04

Avances pour impôts (IF 2007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 730.00

4120-08

Avances pour impôts (IF 2006)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 730.00

4120-09

Avances pour impôts (IF 2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.00

4120-10

Avances pour impôts (IF 2009)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.00

4120-11

Avances pour impôts (IF 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 730.00

4128-05

Créance P.F.F. Holding (anc. Marc Justet)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4128-06

Créance à recevoir Galperti Korea (Trading) Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353 000.00

4128-07

Créance à recevoir Tan Poh Beng (SGD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 135.91

4147-04

Dividendes à recevoir / part. SFF Holding (NOK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 902 363.81

D./2./1. - ACTIF CIRCULANT / DIVERS À RECEVOIR / PRODUITS À RECEVOIR
ANNÉE EN COURS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 493.74

4140-01

Intérêts à recevoir sur dépôts EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.74

4141-01

Intérêts à recevoir sur financ. Mediocreval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 121.34

4141-04

Intérêts sur financement actionnaire à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 600.00

4141-05

Intérêts à recevoir sur placement Europarco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4144-01

Intérêts à recevoir / Obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 730.66

4146-01

Intérêts bancaires à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

D./III. - ACTIF CIRCULANT / VALEURS MOBILIÈRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 607 976.87

2833-01

Placement obligataire Mediocreval éch. 05.08.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 000.00

2833-03

Placement obligataire Mediocreval éch. 15.09.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 000.00

2835-01

Placement fiduciaire Europarco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5200

Actions / Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 638 169.71

5299-01

Correction de valeur Mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-30 192.84

D./ IV./1. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / CAISSE  . . . .

9 856.44

5790-01

Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 856.44

D./ IV./ 2. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES 11 034 201.55

41236

L

U X E M B O U R G

COURANTS SEB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5500-02-GBP Compte Courant SEB GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 805 057.36

5500-1-EUR Compte Courant SEB EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 538 103.06

5500-1-NOK Compte Courant SEB NOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401 240.73

5500-1-SGD Compte Courant SEB SGD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262 543.76

5500-1-USD Compte Courant SEB USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 256.64

D./  IV./  3.  -  ACTIF  CIRCULANT  /  AVOIRS  EN  BANQUES  ET  CAISSE  /  DÉPÔTS
SEB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5300-01-GBP Dépôts Terme SEB GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5300-1-EUR Dépôts Terme SEB EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

D./  IV./  4.  -  ACTIF  CIRCULANT  /  AVOIRS  EN  BANQUES  ET  CAISSE  /  DÉPÔTS
DE GARANTIE SEB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 715.36

5450-1-EUR Certificats de dépôts EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5451-01

Garanties bancaires EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 715.36

D./ IV./ 9. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES
COURANTS (DIVERS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 364 814.30

5502-01

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 055 216.06

5502-02

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 249.67

5502-03

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) NOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5502-04

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 727.66

5503-01

Compte Courant Credito Valt. EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 996 430.96

5503-02

Compte Courant Credito Valt. USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 407.62

5503-03

Compte Courant Credito Valt. GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 450.40

5506-01

Compte Courant Sarasin EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162 331.93

D./  IV./10.  -  ACTIF  CIRCULANT/AVOIRS  EN  BANQUES  ET  CAISSE  /  DÉPÔTS
(DIVERS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5304-2

Dépôt à terme Unicredit EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

F. - COMPTES DE RÉGULARISATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152.97

4906-01

Prime d'assurance payée d'avance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152.97

TOTAL ACTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 971 521.97

PASSIF

31/12/2010

A./1. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 200 000.00

1010-01

Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 200 000.00

A./II. - CAPITAUX PROPRES / PRIMES LIÉES AU CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 000.00

1100-01

Prime d'émission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 000.00

A./III. - CAPITAUX PROPRES / ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 593 744.00

1200-01

Réserve de réévaluation participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 593 744.00

A./IV. - CAPITAUX PROPRES / RÉSERVE LÉGALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 000.00

1300-01

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 000.00

A./VII. - CAPITAUX PROPRES / RÉSULTATS REPORTÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 111 088.12

1400-01

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 111 088.12
A./IX. - CAPITAUX PROPRES / RÉSULTAT DE L'EXERCICE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 338 203.57

1420-01

Résultat de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 338 203.57

B. - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

682 910.00

1610-02

Provision pour risque de change  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 188.00

1610-06

Provision impôt sur la fortune 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 962.50

1610-07

Provision impôt sur la fortune 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 692.50

1610-08

Provision impôt sur la fortune 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 582.50

1610-09

Provision impôt sur la fortune 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 077.50

1610-10

Provision impôt sur la fortune 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 075.00

1699-02

Provision pour risques/participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319 332.00

C./2.  -  DETTES  SUPÉRIEURES  A  UN  AN  /  EMPRUNTS  OBLIGATAIRES
NON SUBORDONNÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 300 000.00

1710-01

Emprunts Oblig. Conv. 2.8 éch. 30.11.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

1712-01

Emprunts Oblig. 4.5 éch. 31.12.2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

41237

L

U X E M B O U R G

1713-02

Emprunt Oblig. Non Conv. Privé éch. 31.12.2019 2%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 300 000.00

C./3. - DETTES SUPÉRIEURES A UN AN / EMPRUNTS A LONG TERME . . . . . . . . . 7 000 000.00

1740-01

Emprunt à Galperti Middle East 0%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 000 000.00

E./1. - AUTRES DETTES / DETTES PLUS CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS  . . . .

3 500.00

4499-01

Frais déclaration fiscale à payer (2006)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4499-02

Frais déclaration fiscale à payer (2007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4499-03

Frais déclaration fiscale à payer (2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4499-04

Frais déclaration fiscale à payer (2009)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 500.00

4825-01

Intérêts échus à payer (EO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

E./2. - AUTRES DETTES / CHARGES À PAYER SUR L'EXERCICE EN COURS  . . . . .

85 165.00

4562-01

Intérêts à payer sur emprunts obligataires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 622.22

4562-02

Intérêts Emprunt Oblig. 2.8 + 4.5 M à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 675.00

4564-01

Intérêts retard à payer sur emprunts obligataires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4582-01

Frais d'audit à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000.00

4583-01

Frais déclaration fiscale à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 500.00

4583-02

Frais déclaration TVA à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4588-03

Factures à payer (téléphone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.00

4588-07

Factures à payer (BDO Cie Fiduciaire)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.83

4588-11

Factures à payer (SEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4588-12

Factures à payer (Reka Imprimerie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4588-13

Factures à payer (Companies Network Int.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000.00

4588-15

Assurance Le Foyer à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.95

E./3. - AUTRES DETTES / AUTRES DETTES MOINS D'UN AN . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 911.28

4400-02

A payer s/acquisition particip. Far EAst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4400-03

A payer s/augm K particip. Far EAst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4400-12

Part. Galperti Manufacturing (Malaysia) à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 911.28

5502-01

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

TOTAL PASSIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 971 521.97

En contrepartie de l'apport de la partie du patrimoine, activement et passivement, faisant l'objet de la scission partielle

de la Société scindée, la nouvelle société recevra les éléments de patrimoine actif et passif suivants et aura par conséquent
la situation d'ouverture suivante:

<i>Répartition

FIAL INDUSTRIAL S.à r.l.

ACTIF

31/12/2010

C./5. - ACTIF IMMOBILISÉ / IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2800-09

Galperti Middle East 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247 919.76

D./ IV./ 2. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES
COURANTS SEB

5500-1-EUR Compte Courant SEB EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 300 000.00

TOTAL ACTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 547 919.76

PASSIF

31/12/2010

A./1. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT

1010-01

Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 000.00

Prime de Scission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 587.76

B. - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1699-02

Provision pour risque s/participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319 332.00

C./3. - DETTES SUPÉRIEURES A UN AN / EMPRUNTS À LONG TERME

1740-01

Emprunt à Galperti Middle East 0%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 000.00
TOTAL PASSIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 547 919.76

La Société continuant à détenir les actifs et passifs suivants:
FIAL INTERNATIONAL S.A.

ACTIF

31/12/2010

B./1. - FRAIS D'ÉTABLISSEMENT / FRAIS D'ÉTABLISSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 005.68

2040-01

Frais changement de statuts (08.03.07)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 005.68

41238

L

U X E M B O U R G

B./2. 

FRAIS 

D'ÉTABLISSEMENT 

AMORTISSEMENTS 

FRAIS

D'ÉTABLISSEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 005.68

2049-01

Amort. frais Changement de statuts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 005.68

C./3. - ACTIF IMMOBILISÉ / IMMOBILISATIONS CORPORELLES . . . . . . . . . . . . . . .

2 091.00

2220-01

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 091.00

C./4.  -  ACTIF  IMMOBILISÉ  /  AMORTISSEMENT  IMMOBILISATIONS
CORPORELLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 533.40

2229-01

Amort.du Mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 533.40

C./5. - ACTIF IMMOBILISÉ/IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 259 452.87

2800-01

Galperti Investments Inc 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

768 442.60

2800-02

L.F.F. Holding 33.33%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 136 421.00

2800-04

S.F.F. Holding 33.33%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

949 964.00

2800-05

P.F.F. Holding 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

878 902.00

2800-08

Galperti India 33.33%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 345.82

2800-09

Galperti Middle East 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

2800-10

L.F.F. Properties Partnership 23.10%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256 849.00

2800-11

Tre Invest 50%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234 578.00

2800-12

Ardita Latina Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 100.00

2800-13

Galperti Far East Holdings Limited 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

2800-16

Galperti Do Brasil Comercial LTDA 99.99%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 000.00

2800-18

Galperti (Hong Kong) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.00

2800-19

Galperti South East Asia PTE LTD 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 124.59

2800-20

Australasian Fittings and Flanges PTY LTD 26%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250.24

2800-21

Gaperti Korea (Trading) Inc. 50%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 093.60

2800-22

PT. Mitra Galperti 70%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

789 265.98

2800-24

Galperti Manufacturing (Malaysia) SDN.BHD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

697 420.99

2803-03

Acompte sur achat de particip. Galperti Energy RU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 991.24

2900-01

Financement Galperti Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 663.81

C./7.  -  ACTIF  IMMOBILISÉ  /  CORRECTION  DE  VALEUR  IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-70 284.76

2851-02

Corr. de val. sur Part. L.F.F. Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-58 558.50

2851-04

Corr. de val. sur Part. Ardita Latina Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-9 100.00

2853-01

Corr. de val. des financ. Galperti Inv.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2 626.26

D./1. - ACTIF CIRCULANT / CRÉANCES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 379 665.27

2900-07

Financement à Fial s.p.a. (Eur 1an + 0.5%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 000.00

4101-02

Créance sur particip. - Galperti Far East USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4109-03

A recevoir sur cession Galperti France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4113-03

TVA à récupérer 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4113-04

TVA à récupérer 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 270.32

4113-05

TVA à récupérer 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 082.23

4113-06

TVA à récupérer 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 003.00

4120-02

Acompte sur TVA 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4120-04

Avances pour impôts (IF 2007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 730.00

4120-08

Avances pour impôts (IF 2006)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 730.00

4120-09

Avances pour impôts (IF 2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.00

4120-10

Avances pour impôts (IF 2009)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.00

4120-11

Avances pour impôts (IF 2010)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 730.00

4128-05

Créance P.F.F. Holding (anc. Marc Justet)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4128-06

Créance à recevoir Galperti Korea (Trading) Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353 000.00

4128-07

Créance à recevoir Tan Poh Beng (SGD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 135.91

4147-04

Dividendes à recevoir / part. SFF Holding (NOK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 902 363.81

D./2./1.  -  ACTIF  CIRCULANT/DIVERS  À  RECEVOIR/  PRODUITS  À  RECEVOIR
ANNÉE EN COURS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 493.74

4140-01

Intérêts à recevoir sur dépôts EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.74

4141-01

Intérêts à recevoir sur financ. Mediocreval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 121.34

41239

L

U X E M B O U R G

4141-04

Intérêts sur financement actionnaire à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 600.00

4141-05

Intérêts à recevoir sur placement Europarco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4144-01

Intérêts à recevoir / Obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 730.66

4146-01

Intérêts bancaires à recevoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

D./III. - ACTIF CIRCULANT / VALEURS MOBILIÈRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 607 976.87

2833-01

Placement obligataire Mediocreval éch. 05.08.2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000 000.00

2833-03

Placement obligataire Mediocreval éch. 15.09.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 000 000.00

2835-01

Placement fiduciaire Europarco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5200

Actions / Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 638 169.71

5299-01

Correction de valeur Mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-30 192.84

D./ IV./1. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / CAISSE  . . . .

9 856.44

5790-01

Caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 856.44

D./ IV./ 2. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES
COURANTS SEB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 734 201.55

5500-02 GBP Compte Courant SEB GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 805 057.36

5500-1-EUR Compte Courant SEB EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 238 103.06

5500-1-NOK Compte Courant SEB NOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401 240.73

5500-1-SGD Compte Courant SEB SGD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262 543.76

5500-1-USD Compte Courant SEB USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 256.64

D./  IV./  3.  -  ACTIF  CIRCULANT  /  AVOIRS  EN  BANQUES  ET  CAISSE  /
DÉPÔTS SEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5300-01-GBP Dépôts Terme SEB GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5300-1-EUR Dépôts Terme SEB EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

D./ IV./ 4. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / DÉPÔTS DE
GARANTIE SEB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 715.36

5450-1-EUR Certificats de dépôts EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5451-01

Garanties bancaires EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 715.36

D./ IV./ 9. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES
COURANTS (DIVERS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 364 814.30

5502-01

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 055 216.06

5502-02

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 249.67

5502-03

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) NOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5502-04

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 727.66

5503-01

Compte Courant Credito Valt. EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 996 430.96

5503-02

Compte Courant Credito Valt. USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 407.62

5503-03

Compte Courant Credito Valt. GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 450.40

5506-01

Compte Courant Sarasin EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162 331.93

D./  IV./10.  -  ACTIF  CIRCULANT  /  AVOIRS  EN  BANQUES  ET  CAISSE  /  DÉPÔTS
(DIVERS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

5304-2

Dépôt à terme Unicredit EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

F. - COMPTES DE RÉGULARISATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152.97

4906-01

Prime d'assurance payée d'avance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152.97

TOTAL ACTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 423 602.21

PASSIF

31/12/2010

A./I. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 970 000.00

1010-01

Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 970 000.00

Prime de Scission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 412.24

A./II. - CAPITAUX PROPRES / PRIMES LIÉES AU CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 000.00

1100-01

Prime d'émission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 000.00

A./III. - CAPITAUX PROPRES / ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 593 744.00

1200-01

Réserve de réévaluation participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 593 744.00

A./IV. - CAPITAUX PROPRES / RÉSERVE LÉGALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 000.00

1300-01

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 000.00

A./VII. - CAPITAUX PROPRES / RÉSULTATS REPORTÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 111 088.12

1400-01

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 111 088.12

41240

L

U X E M B O U R G

A./IX. - CAPITAUX PROPRES / RÉSULTAT DE L'EXERCICE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 338 203.57

1420-01

Résultat de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 338 203.57

B. - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363 578.00

1610-02

Provision pour risque de change  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 188.00

1610-06

Provision impôt sur la fortune 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 962.50

1610-07

Provision impôt sur la fortune 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 692.50

1610-08

Provision impôt sur la fortune 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 582.50

1610-09

Provision impôt sur la fortune 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 077.50

1610-10

Provision impôt sur la fortune 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 075.00

1699-02

Provision pour risque s/participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

C./2.  -  DETTES  SUPÉRIEURES  À  UN  AN  /  EMPRUNTS  OBLIGATAIRES
NON SUBORDONNÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 300 000.00

1710-01

Emprunts Oblig. Conv. 2.8 éch. 30.11.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

1712-01

Emprunts Oblig. 4.5 éch. 31.12.2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

1713-02

Emprunt Oblig. Non Conv. Privé éch. 31.12.2019 2%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 300 000.00

C./3. - DETTES SUPÉRIEURES À UN AN / EMPRUNTS À LONG TERME . . . . . . . . .

0.00

1740-01

Emprunt à Galperti Middle East 0%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

E./1. - AUTRES DETTES / DETTES PLUS CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS  . . . .

3 500.00

4499-01

Frais déclaration fiscale à payer (2006)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4499-02

Frais déclaration fiscale à payer (2007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4499-03

Frais déclaration fiscale à payer (2008)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4499-04

Frais déclaration fiscale à payer (2009)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 500.00

4825-01

Intérêts échus à payer (EO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

E./2. - AUTRES DETTES / CHARGES À PAYER SUR L'EXERCICE EN COURS  . . . . .

85 165.00

4562-01

Intérêts à payer sur emprunts obligataires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 622.22

4562-02

Intérêts Emprunt Oblig. 2.8 + 4.5 M à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 675.00

4564-01

Intérêts retard à payer sur emprunts obligataires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4582-01

Frais d'audit à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000.00

4583-01

Frais déclaration fiscale à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 500.00

4583-02

Frais déclaration TVA à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4588-03

Factures à payer (téléphone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.00

4588-07

Factures à payer (BDO Cie Fiduciaire)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.83

4588-11

Factures à payer (SEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4588-12

Factures à payer (Reka Imprimerie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4588-13

Factures à payer (Companies Network Int.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000.00

4588-15

Assurance Le Foyer à payer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.95

E./3. - AUTRES DETTES / AUTRES DETTES MOINS D'UN AN . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 911.28

4400-02

A payer s/acquisition particip. Far EAst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4400-03

A payer s/augm K particip. Far EAst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

4400-12

Part. Galperti Manufacturing (Malaysia) à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 911.28

5502-01

Compte Courant BP Sondrio (Zurigo) EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

TOTAL PASSIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 423 602.21

Suit le projet d'acte constitutif de la nouvelle société: FIAL INDUSTRIAL S.à r.l.
Siège social: L-1724 Luxembourg
19-21, Boulevard du Prince Henri

STATUTS

Titre I 

er

 . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

41241

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La Société prend la dénomination de "FIAL INDUSTRIAL S.à r.l.".

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 200.000 (deux cent mille euros), représenté par 100 (cent) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,

par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

41242

L

U X E M B O U R G

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 2011. Les premiers Gérant(s) sont élus

par l'assemblée générale extraordinaire des associés suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Libération

Le capital social de FIAL INDUSTRIAL S.à r.l. est de EUR 200.000 (deux cent mille euros), tel que figurant à l'article

6 du projet des statuts ci-avant, sera détenu par les associés comme suit.

- F.I.A.L. Finanziaria Industrie Alto Lario S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
- Roberto Galperti Immobiliare e Finanziaria S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales

Il sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société,

suivant la répartition proposée dans le projet de scission partielle, savoir:

FIAL INDUSTRIAL S.à r.l.

ACTIF

31/12/2010

C/5. - ACTIF IMMOBILISÉ / IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2800-09

Galperti Middle East 100%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247 919.76

D. / IV. / 2. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES ET CAISSE / COMPTES
COURANTS SEB

5500-1-EUR Compte Courant SEB EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 300 000.00

TOTAL ACTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 547 919.76

PASSIF

31/12/2010

A./1. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT

1010-01

Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 000.00

Prime de Scission  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 587.76

B. - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

1699-02

Provision pour risque s/participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319 332.00

C. / 3. - DETTES SUPÉRIEURES À UN AN / EMPRUNTS À LONG TERME

1740-01

Emprunt à Galperti Middle East 0%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 000.00
TOTAL PASSIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 547 919.76

<i>Attribution

Les 100 (cent) parts sociales représentatives du capital social de EUR 200.000 (deux cent mille euros) de la société

présentement constituée, sont attribuées aux associés de la Société proportionnellement à leurs droits dans le capital de
la Société.

Luxembourg, le 21.04.2011.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Christian Unsen / Pascal Verdin-Pol

Référence de publication: 2011057503/504.
(110063636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

41243

L

U X E M B O U R G

SHRM Financial Services (HK) Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.416.

OUVERTURE DE SUCCURSALE

<i>Extrait des résolutions des administrateurs adoptées le 03 janvier 2011

L'administrateur unique de SHRM Financial Services (HK) Limited, une société organisée et existant selon les lois des

Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques, immatriculée auprès de Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 542015 (la
Société) a décidé d'établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg (la Succursale).

L'administrateur unique de la Société est Robert Reid Thurlow, né le 26 février 1970, à Whangarei (Nouvelle Zélande),

ayant son adresse professionnelle au Queensway 89, Tower II, Lippo Centre, Room 2207-9, 22F, Admiralty, Central,
Hong Kong et il a le pouvoir d'engager la Société.

L'administration unique de la Société a décidé d'adopter les résolutions suivantes concernant la Succursale:
1. La Succursale prendra la dénomination suivante: SHRM Financial Services (HK) Limited, Luxembourg Branch.
2. Le siège social de la Succursale sera établi au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Mme Liliya Semenyuk, née le 21 novembre 1976 à Kamensk-Ouralskiy (Russie), avec adresse professionnelle au 64,

rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, est nommée en tant que représentant permanent pour
la Succursale (le Représentant Permanent) pour une durée indéterminée.

4. Le Représentant Permanent est investi de tous les pouvoirs pour la gestion de la Succursale au nom de la Société

et  a  le  pouvoir  d'engager  la  Succursale  au  nom  de  la  Société  par  sa  seule  signature  pour  tous  les  actes  et  pour  les
procédures devant les tribunaux.

5. Les activités de la Succursale doivent consister mais ne sont pas limitées à:
La Succursale aura comme objet d'agir comme bureau de représentation de la Société et de SHRM Trustees (BVI)

Limited tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et de promouvoir tant au Luxembourg qu'à l'étranger des services de con-
stitution, domiciliation et administration de sociétés de droit étranger au sein de la juridiction de la Société et de celle
de SHRM Trustees (BVI) Limited, étant entendu que ces activités ne seront pas exercées par la Succursale au Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SHR Financial Service (HK) Limited
Alex van Zeeland
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011016036/34.
(110017613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

SHRM Financial Services (HK) Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 158.416.

<i>Notarial certificate

I, Lewis S. Hunte, Notary Public for the Territory of the British Virgin Islands appointed for life and practising in Road

Town, Tortola, British Virgin Islands DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST that the attached documents of SHRM Fi-
nancial Services (HK) Limited, a BVI Business Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands on the
15th day of April, 2003, Company Number 542015 are:

- Certified true copy of the Certificate of Change of Name;
- Certified true copy of the Register of Directors;
- Certified true copy of the Register of Members;
- Certificate of Incumbency;
- Certificate of Good Standing issued by the Registry of Corporate Affairs; and
- Certified true copy of the Memorandum and Articles of Association.
I further CERTIFY AND ATTEST that the signatures appearing on the attached certified documents and Certificate

of Incumbency are the authentic signatures of Aliza Tyson and Ronan Kuczaj who has the legal capacity to sign for and
on behalf of SHRM Trustees (BVI) Limited and the Certificate of Good Standing has been signed by Mrs. Myrna Herbert,
the Registrar of Corporate Affairs.

41244

L

U X E M B O U R G

Dated this 13th day of January, 2011.

BRITISH VIRGIN ISLANDS
LEWIS S. HUNTE
<i>NOTARY PUBLIC
Signature

We hereby certify that this copy is a true and complete copy of the original (or a properly certified copy of the original).
Dated: 13 January 2011
Authorised Signatory
SHRM Trustees (BVI) Limited
TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

<i>Certificate of change of name (section 21)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the

BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of a change of name having been complied
with

S-HR&amp;M Financial Services (HK) Limited
BVI COMPANY NUMBER 542015
which was re-registered in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004, on the 1 

st

 day of

January, 2007 has changed its name to

SHRM Financial Services (HK) Limited
this 22 

nd

 day of December, 2010.

22 

nd

 day of December, 2010.

<i>for REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
Signature

<i>Register of Directors

Company:

SHRM Financial Services (HK) Limited

NAME OF
OFFICER

ADDRESS

OCCUPATION OFFICE

HELD

DATE OF
ELECTION

Date
When Cea-
sed
to be an
Officer

REMARKS

Reid Thurlow Lot 940, DD 369. House No. 22

Tsak Yue Wu Village, Pak Tam
Road Sai Kung Country Park, N.T.,
Hong Kong

Director

Director 15-Apr-2003

We hereby certify that this copy is a true and complete copy of the original (or a properly certified copy of the original).
Dated: 13 January 2011
Authorised Signatory
SHRM Trustees (BVI) Limited

<i>Register of Members and Share Ledger

Company:

SHRM Financial Services (HK) Limited

Name

Reid Thurlow

Profession:

Director

Address

Lot 940, DD 369, House No. 22
Tsak Yue Wu Village, Pak Tam
Road Sai Kung Country Park, N.T.,
Hong Kong

IC/Passport number

AB604641, New Zealand

Nationality

New Zealander
Citizen

Company number

N/A

Place of incorporation N/A

Class of share:

Denomination:

Current holding: Date entered as a

member:

Date ceased to be
a member:

Ordinary

USD1.00

100

5-May-2003

Shares acquired

41245

L

U X E M B O U R G

Date of acquisition

or transfer

Number of sha-
res acquired

Certificate
number

Distinctive
numbers of shares

Amount payable
(partly paid shares)

Shares disposed
(see shares
transferred)

Notes

5-May-2003

100

1

1-100

Nil

Nil

Allotment

Shares transferred

Date of transfer

Number of shares
transferred

Certificate
number

Distinctive numbers
of shares

Total Nominal
Value

Transferee

We hereby certify that this copy is a true and complete copy of the original (or a properly certified copy of the original).
Dated: 13 January 2011
Authorised Signatory
SHRM Trustees (BVI) Limited

Company:

SHRM Financial Services (HK) Limited

Name

Reid Thurlow

Profession:

Director

Address

Lot 940, DD 369, House No. 22
Tsak Yue Wu Village, Pak Tam
Road Sai Kung Country Park, N.T.,
Hong Kong

IC/Passport number

AB604641, New Zealand

Nationality

New Zealander
Citizen

Company number

N/A

Place of incorporation N/A

Class of share:

Denomination:

Current holding: Date entered as a

member:

Date ceased to be
a member:

Ordinary

USD1.00

100

5-May-2003

Shares acquired

Date of acquisition

or transfer

Number of sha-
res acquired

Certificate
number

Distinctive
numbers of shares

Amount payable
(partly paid shares)

Shares disposed
(see shares
transferred)

Notes

5-May-2003

100

1

1-100

Nil

Nil

Allotment

Shares transferred

Date of transfer

Number of shares
transferred

Certificate
number

Distinctive numbers
of shares

Total Nominal
Value

Transferee

<i>Certificate of incumbency

Name of Company: SHRM Financial Services (HK) Limited
We, SHRM Trustees (BVI) Limited of Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

being the duly appointed Registered Agent of SHRM Financial Services (HK) Limited (the Company") a BVI Business
Company incorporated in the Territory of the British Virgin Islands on the 15 

th

 day of April, 2003, Registration Number

542015, hereby confirm the followings:-

(1) that the Company is on the Register of Companies in the British Virgin Islands and has paid all fees due and payable

to the British Virgin Islands Financial Services Commission;

(2) that as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company at Trinity

Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands:

a) the Company is authorised to issue US$50,000 comprising 50,000 shares with a par value of US$1.00 each
b) the Company does not maintain a register of mortgages and charges
c) no proceedings are pending or threatened against the Company
d) no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver over its assets
b) the current director is:

NAME

DATE OF APPOINTMENT

Reid Thurlow

15-Apr-2003

c) the current Secretary is:

NAME

DATE OF APPOINTMENT

CHAN, Shuk Yee Veronica

29-Apr-2003

e) the current principal shareholder (i.e. companies/individuals with 10% or more of the shares/voting rights of the

Company, of which none are held in the form of bearer shares) is:

41246

L

U X E M B O U R G

Name of Shareholder

Cert. No. No. of Shares

Reid Thurlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

Dated this 12 

th

 day of January, 2011.

<i>For and on behalf of SHRM Trustees (BVI) Limited
Signatures
<i>Authorised Signatories

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

<i>Certificate of good standing (section 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES Z that, pursuant to the

BVI Business Companies Act, 2004,

SHRM Financial Services (HK) Limited
BVI COMPANY NUMBER: 542015
1. Is on the Register of Companies;
2: Has paid all fees, annual fees and penalties that are due and payable;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation; and
6. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.

12 

th

 day of January, 2011.

Signature
<i>REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

We hereby certify that this copy is a true and complete copy of the original (or a properly certified copy of the original).
Dated: 13 January 2011
Authorised Signatory
SHRM Trustees (BVI) Limited
Company Number 542015
TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT (CAP291)
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION
SHRM Financial Services (HK) Limited
Incorporated the 15th day of April, 2003
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT (CAP.291)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

SHRM FINANCIAL SERVICES (HK) LIMITED

1. Name. The Name of the Company is SHRM Financial Services (HK) Limited.

2. Registered office. The Registered Office of the Company will be situated at Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands or such other place within the British Virgin Islands as the directors may from time
to time determine.

3. Registered agent. The Registered Agent of the Company will be SHRM Trustees (BVI) Limited, Trinity Chambers,

P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands or such person or company being a person or company entitled
to act as a Registered Agent as the directors may from time to time determine.

4. General objects and Powers. The objects for which the Company is established are:
(a) To carry on the business of an investment company and for that purpose to acquire (by original subscription,

contract, tender, purchase or exchange underwriting) and to hold, in the name of the company or of any nominee, share
stocks, debentures, debenture stocks, bonds, notes, obligations or securities, and to subscribe for the same subject to
such terms and conditions (if any) as may be thought fit.

(b) To exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any such share stock

obligations or other securities including without prejudice to the generality of the foregoing all such powers of veto or
control as may be conferred by virtue of the holding by the Company of some special proportion of the issued or nominal

41247

L

U X E M B O U R G

amount thereof and to provide managerial and other executive supervisory and consultancy services for or in relation
to any company in which the Company is interested upon such terms as may be thought fit.

(c) To buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, improve, decorate,

furnish, operate, maintain, reclaim or otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real
estate in all its branches, to make advances upon the security of land or houses or other property or any interest therein,
and whether erected or in course of erection and whether on first mortgage or charge or subject to a prior mortgage
or mortgages or charge or charges, and to develop land and buildings as may seem expedient but without prejudice to
the generality of the foregoing.

(d) To carry on the business of traders and merchants of any kind, nature or description, and the sale or rendering of

related products and services, and the employment of the necessary personnel therefor.

(e) Without prejudice to the generality of the foregoing paragraphs: to purchase, sell, exchange, lease, manage, hold,

trade, invest in all kinds of movable or immovable property, merchandise, commodities, effects, products, services of any
kind, nature or description, to carry out any type of commercial or financial operation, to receive and/or pay royalties,
commissions and other income or outgoings of any kind, to purchase, construct, charter, own, operate, manage, admi-
nister transport vessels of any kind and their appurtenances and related services and agencies; to sell or render related
services and employ the necessary personnel therefor.

(f) To buy, sell, underwrite, invest in, exchange or otherwise acquire, and to hold, manage, develop, deal with and turn

to account any  bonds,  debentures,  shares  (whether  fully  paid  or not),  stock options, commodities,  futures,  forward
contracts, notes or securities of governments, states, municipalities, public authorities or public or private limited or
unlimited companies in any part of the world, precious metals, gems, works of art and other articles of value and whether
on a cash or margin basis and including short sales, and to lend money against the security of any of the aforementioned
property.

(g) To borrow or raise money by the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages,

or any other securities founded or based upon all or any of the assets or property of the Company or without any such
security and upon such terms as to priority or otherwise as the Company shall think fit.

(h) To engage in any other business or businesses whatsoever, or in any act or activity, which are not prohibited under

any law for the time being in force in the British Virgin Islands.

(i) To do all such other things as are incidental to. or the Company may think conducive to, the attainment of all or

any of the above objects.

And it is hereby declared that the intention is that each of the object specified in each paragraph of this clause shall,

except where otherwise expressed in such paragraph, be an independent main object and be in no ways limited or
restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the company.

5. Exclusions. The Company shall not be treated as carrying on business with persons resident in the British Virgin

Islands by reason only that:

(a) it makes or maintains deposits with person carrying on banking business within the British Virgin Islands;
(b) it makes or maintains professional contact with solicitors, barristers, accountants, bookkeepers, trust companies,

administration companies, investment advisers or other similar persons carrying on business within the British Virgin
Islands;

(c) it prepares or maintains books and records within the British Virgin Islands;
(d) it holds, within the British Virgin Islands, meetings of its directors or members;
(e) it holds a lease of property for use as an office from which to communicate with members or where books and

records of the Company are prepared or maintained;

(f) it holds shares, debt obligations or other securities in a company incorporated under the International Business

Companies Act (CAP.291) or under the Companies Act;

(g) its shares, debt obligations or other securities in the Company are owned by any person resident in the British

Virgin Islands or by any company incorporated under the International Business Companies Act (CAP.291) or under the
Companies Act.

6. The Company has no power to:
(a) carry on business with persons resident in the British Virgin Islands;
(b) own an interest in real property situate in the British Virgin Islands, other than a lease of property for use as an

office from which to communicate with members or where books and records of the Company are prepared or main-
tained;

(c) carry on banking or trust business, unless it is licensed under the Banks and Trust Companies Act, 1990;
(d) carry on business as an insurance or reinsurance company, insurance agent or insurance broker, unless it is licensed

under an enactment authorising it to carry on that business;

(e) carry on the business of company management unless it is licensed under the Company Management Act, 1990,

(which Act governs company management activities carried out in or from within the Virgin Islands only);

41248

L

U X E M B O U R G

(f) carry on the business of providing the Registered Office or the Registered Agent for companies incorporated in

the British Virgin Islands.

7. Share capital. The shares in the Company shall be issued in the currency of United States of America.

8. Authorised capital. The authorised capital of the Company is US$50,000.00 comprising 50,000 shares with par value

of US$1.00 each. Shares may be issued by the Director at their discretion and may only be issued as registered shares.

9. Classes of shares. The shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by

resolution from time to time determine and until so divided shall comprise on class and series.

10. Rights, Qualifications of shares. The directors shall by resolution have the power to issue any class or series of

shares that the Company is authorised to issue in its capital, original or increased with or subject to any designations,
powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions.

11. Registered shares. Shares in the Company may only be issued as registered shares and may not be exchanged for

shares issued to bearer.

12. Amendments. The Company may by resolution of its members or of its directors, amend or modify any of the

conditions contained in the Memorandum of Association and increase or reduce the authorised capital of the Company
in any way which may be permitted by law.

We, S-HR&amp;M Financial Services Limited of Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands for the purpose of incorporating an International Business Company under the laws of the British Virgin Islands
hereby subscribe our name to this Memorandum of Association.

NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER
Carl Seymour (Sgd)
S-HR&amp;M Financial Services Limited
Kingston Chambers
P.O. Box 173
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

DATED this 15 

th

 day of April, 2003.

WITNESS to the above signature:
Deanna Trott-Rubaine (Sgd)
Kingston Chambers

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

SHRM FINANCIAL SERVICES (HK) LIMITED

Interpretation.
1. References in these regulations to the Act shall mean The International Business Companies Act (CAP.291). The

following Regulations shall constitute the regulations of the Company. In these Articles, words and expressions defined
in the Act shall have the same meaning and, unless otherwise required by the context, the singular shall include the plural
and vice versa, the masculine shall include the feminine and the neuter and references to persons shall include corporations
and all legal entities capable of having a legal existence.

Shares.
2. The authorised capital of the Company US$50,000.00 comprising 50,000 shares with par value of US$1.00 each.

Shares may be issued by the Directors at their discretion and may only be issued as registered shares.

3. Every person whose name is entered as a member the share register, being the holder of registered shares, shall

without payment, be entitled to a certificate signed by two directors or two officers or by one director or one officer of
the Company or under the common Seal of the Company with or without the signature of any director or officer of the
Company specifying the share or shares held and the par value thereof, provided that in respect of a registered share, or
shares, held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery
of certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all.

4. If a certificate is worn out or lost it may be renewed on production of the worn out certificate, or on satisfactory

proof of its loss together with such indemnity as the directors may reasonably require. Any member receiving a share
certificate shall indemnify and hold the Company and its officers harmless from any loss or liability which it or they may
incur by reason of wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession of such
a certificate.

41249

L

U X E M B O U R G

Share capital and Variation of rights.
5. Subject to the provisions of these Articles, the unissued shares of the Company (whether forming part of the original

or any increased capital) shall be at the disposal of the Directors who shall offer, allot, grant options over or otherwise
dispose of them to such persons at such times and for such consideration, being not less than the par value of the shares
being disposed of, and upon such terms and conditions as the directors may determine.

6. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares,

any share in the Company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether
in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the directors may from time to time determine.

7. Subject to the provisions of the Act in this regard, shares may be issued on the terms that they are redeemable, or

at the option of the Company be liable to be redeemed on such terms and in such manner as the directors before or at
any time after the issue of the shares may determine.

8. The directors may redeem any such share at a premium.
9. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless

otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is being wound
up, be varied with the consent in writing to the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class
and the holders of not less than three-fourths of the issued shares of any other class of shares which may be affected by
such variation.

10. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not,

unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the
creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.

11. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust, and

the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any
equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except as
by these Regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except any absolute right to
the entirety thereof by the registered holder.

Transfer of shares.
12. Registered shares in the Company may be transferred by a written instrument signed by the transferor and con-

taining the name and address of the transferee or such other manner or form and subject to such evidence as the directors
shall consider appropriate.

13. Upon receipt of notification of any change of name and adress of any agent or attorney given to the Company for

the  purpose  of  service  of  any  notice  information  or  written  statement  required  to  given  to  members,  identified  by
reference to the number of the certificate the directors shall forthwith amend the register maintained for this purpose.

Transmission of shares.
14. The Executor or administrator of a deceased member or the trustee of a bankrupt member shall be the only person

recognised by the Company as having any title to his share but they shall not be entitled to excercise any rights as a
member of the Company until they have proceeded as set forth in the next following three Articles, save that and only
in the event of death, incompetence or bankruptcy of any member or members of the Company as a consequence of
which the Company no longer has any directors or members, then upon the production of any documentation which is
reasonable evidence of the applicant being entitled to:

(a) a grant of probate of the will, or grant of letters of administration of the estate, or confirmation of the appointment

as executor, of a deceased member; or

(b) the appointment of a guardian of an incompetent member; or
(c) the trustee of a bankrupt member; or
(d) any other documentation providing reasonable evidence of the applicant's beneficial ownership of shares
to the company's Registered Agent in the British Virgin Islands together with (if so requested by the Registered Agent)

a notarised copy of the share certificate(s) of the deceased incompetent or bankrupt member, an indemnity in favour of
the Registered Agent and appropriate legal advice in respect of any document issued by a foreign court, then the admi-
nistrator, executor, guardian or trustee in bankruptcy (as the case may be) notwithstanding that their name has not been
entered in the share register of the Company, may be written resolution of the applicant, endorsed with written approval
by the Registered Agent, be appointed a director of the Company or recognised as beneficial owner of the shares.

15. The production of the Company of any document which is evidence of:
(a) a grant of probate of the will, or grant of letters of administration of the estate, or confirmation of the appointment

as executor, of a deceased member; or

(b) the appointment of a guardian of an incompetent member; or
(c) the trustee of a bankrupt member; or
(d) any other documentation providing reasonable evidence of the applicant's beneficial ownership of the shares-

41250

L

U X E M B O U R G

shall be accepted by the Company even if the deceased, incompetent member or bankrupt member is domiciled outside

the British Virgin Islands if the document is issued by a foreign court which had competent jurisdiction in the matter. For
the purposes of establishing whether or not a foreign court had competent jurisdiction in such a matter the directors
may obtain appropriate legal advice. The directors may also require an indemnity to be given by the executor, adminis-
trator, guardian or trustee in bankruptcy.

16. Any person becoming entitled by operation of law or otherwise to a share or shares in consequence of the death,

incompetence or bankruptcy of any member may be registered as a member upon such evidence being produced as may
reasonably be required by the directors. An application by any such person to be registered as a member shall for all
purposes be deemed to be a transfer of shares of the deceased, incompetent or bankrupt member and the directors shall
treat it as such.

17. Any person who has become entitled to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy

of any member may instead of being registered himself request in writing that some person to be named by him be registed
as the transferee of such share or shares and such request shall likewise be treated as if it were a transfer.

18. What amounts to incompetence on the part of a person is a matter to be determined by the court having regard

to all the relevant evidence and the circumstances of the case.

Acquisition of own shares.
19. Subject to the provisions of the Act in this regard, the directors may, on behalf of the Company purchase, redeem

or otherwise acquire any of the Company's own shares for such consideration as they consider fit, and either cancel or
hold such shares as Treasury shares. The directors may dispose of any shares held as Treasury shares on such terms and
conditions as they may from time to time determine. Shares may be purchased or otherwise acquired in exchange for
newly issued shares in the Company.

Alteration in capital.
20. Subject to the terms of any resolution passed by the directors for the purpose of increasing the authorised capital

of the Company, such increased capital may be divided into shares of such respective amounts, and with such rights or
privileges (if any) as the directors think expedient.

21. Any capital raised by the creation of new shares shall be considered as part of the original capital and shall be

subject to the same provisions as if it had been part of the original capital.

22. The directors may by resolution:
(a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(b) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken

by any person and diminish the amount of its authorised share capital by the amount of the shares so canceled:

(c) sub-divide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association

and so that subject to the provisions of Regulation 10, the resolution whereby any share is sub-divided may determine
that as between the holders of the shares resulting from such sub-division one or more of the shares may have such
preferred or other special rights over or may have such qualified or deferred rights or be subject to any such restrictions
as compared with the other or others as the Company has power to attach to unused or new shares;

(d) subject to any confirmation or consent required by law, reduce its authorised and issued share capital or any capital

redemption reserve fund of any share premium account in any manner.

23. Where any difficulty arises in regard to any consolidation and division under this Regulation the directors may

settle same as they think expedient.

Meetings of members.
24. The directors may convene meetings of the members of the Company at such times and in such manner and places

as the directors consider necessary or desirable, and they shall convene such a meeting upon the written request of
members holding more than 50 percent of the votes of the outstanding voting shares in the Company.

25. Seven days notice at the least specifying the place, the day and the hour of the meeting and general nature of the

business to be conducted shall be given in the manner hereinafter mentioned to such persons whose names on the date
the notice is given appear as members in the share register of the Company.

26. A meeting of the members shall be deemed to have been validly held, notwithstanding that it is held in contravention

of the requirement to give notice in Regulation 25, in notice of the meeting is waived by an absolute majority in number
of the members having a right to attend and vote at the meeting.

27. The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to a member or to the agent or attorney as

the case may be, or the fact that a member or such agent or attorney has not received the notice, does not invalidate
the meeting.

Proceedings at meeting of members.
28. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum of members is present at the time when the

meeting proceeds to business. A quorum shall consist of the holder or holders present in person or by proxy of not less

41251

L

U X E M B O U R G

than one-third of the shares of each class or series of shares entitled to vote as a class or series thereon and the same
proportion of the votes of the remaining shares entitled to vote thereon.

29. If, within half an hour from the time appointed for the meeting, a quorum is not present, the meeting shall be

dissolved.

30. At every meeting the members present shall choose someone of their number to be the Chairman. If the members

are unable to choose a Chairman for any reason, then the person representing the greatest number of voting shares
present at the meeting shall preside as Chairman failing which the oldest individual person shall take the chair.

31. The Chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to

place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting
from which the adjournment took place.

32. At any meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands by simple majority

unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded:

(a) by the Chairman; or
(b) by any members present in person or by proxy and representing not less than one tenth of the total voting rights

of all the members having the right to vote at the meeting;

33. Unless a poll be so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has, on a show of hands, been

carried, and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company, shall be
sufficient evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against
such resolution.

34. If a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the Chairman directs, and the result of the poll shall

be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded. The demand for a poll may be withdrawn.

35. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands, or on a poll, the Chairman of the meeting at which

the show of hands takes place, or at which the poll is demanded, shall be entitled to a second or casting vote.

Votes of members.
36. At any meeting of members whether on a show of hands or on a poll every holder of a voting share present in

person or by proxy shall have one vote for every voting share of which he is the holder.

37. A resolution which has been notified to all members for the time being entitled to vote and which has been approved

by a majority of the votes of those members in the form of one or more documents in writing or by telex, telegram,
cable or other written electronic communication shall forthwith, without the need for any notice, become effectual as a
resolution of the members.

38. If a committee be appointed for any member who is of unsound mind he may vote by his committee.
39. If two or more persons are jointly entitled to a registered share and if more than one of such persons shall vote

in person or by proxy at meeting of members or in accordance with the terms of Regulation 36, the vote of that person
whose name appears first among such voting joint holders in the share register shall alone be counted.

40. Votes may be given either personally or by proxy.
41. The instrument appointing a proxy shall be produced at the place appointed for the meeting before the time for

holding the meeting at which the person name in such instrument proposes to vote.

42. An instrument appointing a proxy shall be in such form as the Chairman of the meeting shall accept as properly

evidencing the wishes of the member appointing the proxy.

43. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer unless the appointer is a

corporation or other form of legal entity other than one or more individuals holding as joint owner in which case the
instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of an individual duly authorised by such corporation or
legal entity to execute the same. The Chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy so authorised may call
for a notarially certified copy of such authority which shall be produced within seven days of being so requested or the
vote or votes cast by such proxy shall be disregarded.

Corporations acting by representatives at meetings.
44. Any corporation or other form of corporate legal entity which is member of the Company may by resolution of

its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of
the members or any class of members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the
same powers On behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual
member of the Company.

Directors.
45. Subject to any subsequent amendment to change the number of directors, the number of the directors shall be

not less than one nor more than fifteen.

46. The first director or directors shall be elected by the subscriber to the Memorandum of Association. Thereafter,

the directors shall be elected by the members or the directors for such terms as the members or directors may determine
and may be removed by them.

41252

L

U X E M B O U R G

47. Each director holds office until his successor takes office or until his earlier death resignation or removal.
48. A vacancy in the board of directors may be filled by a resolution of members or a majority of the remaining directors.
49. A director shall not require a share qualification, but nevertheless shall be entitled to attend and speak at any

meeting of the members and at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.

50. A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company may from time to time

appoint another director or an other person to be his alternate. Every such alternate shall be entitled to be given notice
of meetings of the directors and to attend and vote as a director at any such meeting at which the director appointing
him  is  not  personally  present  and  generally  at  such  meeting  to  have  and  exercise  all  the  powers,  rights,  duties  and
authorities director appointing him. Every such alternate shall be deemed to be an officer of the Company and shall not
be deemed to be an agent of the director appointing him. If undue delay or difficulty would be occasioned by giving notice
to a director of a resolution of which his approval is sought in accordance with Regulation 75 his alternate (if any) shall
be entitled to signify approval of the same on behalf of that director. The remuneration of an alternate shall be payable
out of the remuneration payable to the director appointing him and shall consist of such portion of the last mentioned
remuneration as shall be agreed between such alternate and the director appointing him. A director by writing under his
hand deposited at the Registered Office of the Company may at any time revoke the appointment of an alternate appointed
by him. If a director shall die or cease to hold the office of director, the appointment of his alternate shall thereupon
cease and terminate.

51. The directors may, by resolution, fix the emolument of directors in respect of services rendered or to be rendered

in any capacity to the Company. The directors may also be paid such traveling, hotel and other expenses properly incurred
by them in attending and returning from meetings of the directors, or any committee of the directors or meetings of the
members, or in connection with the business of the Company as shall be approved by resolution of the directors.

52. Any director who, by request, goes or resides abroad for any purposes of the Company, or who performs services

which in the opinion of the Board of Directors go beyond the ordinary duties of a director, may be paid such extra
remuneration (whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) as shall be approved by
resolution of the directors.

53. The Company may pay to a director who at the request of the Company holds any office (including a directorship)

in, or renders services to, any company in which the Company may be interested, such remuneration (whether by way
of salary, commission, participation in profits or otherwise) in respect of such office or services as shall be approved by
resolution of the directors.

54. The office of director shall be vacated if the director:
(a) is removed from office by a resolution of members or by a resolution of directors, or
(b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
(c) becomes of unsound mind, or of such infirm health as to be incapable of managing his affairs, or
(d) resigns his office by a notice in writing to the Company.
55. (a) A Director may hold any other office or position of profit under the Company (except that of auditor) in

conjunction with his office of director, and may act in a professional capacity to the Company on such terms as to
remuneration and otherwise as the directors shall arrange.

(b) A director may be or become a director or officer of, or otherwise be interested in any company promoted by

the Company, or in which the Company may be interested, as a member or otherwise and no such director shall be
accountable for any remuneration or other benefits received by him as director or officer or from his interest in such
other company. The directors may also exercise the voting powers conferred by the shares in any other company held
or owned by the Company in such manner in all respects as they think fit, including the exercise thereof in favour of any
resolutions appointing them, or of their number, directors or officers of such other company, or voting or providing for
the payment of remuneration to the directors or officers of such other company. A director may vote in favour of the
exercise of such voting rights in the manner aforesaid notwithstanding that he may be, or be about to become, a director
or officer of such other company, and as such in any other manner is, or may be, interested in the exercise of such voting
rights in the manner aforesaid.

(c) No director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either as a vendor, purchaser or

otherwise. nor shall any such contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any directors
shall be in any way interested be voided, or shall any director so contracting or being so interested be liable to account
to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement, by reason of such director holding that
office or of the fiduciary relationship thereby established. The nature of a director's interest must be declared by him at
the  meeting  of  the  directors  at  which  the  question  of  entering  into  the  contract  or  arrangement  is  first  taken  into
consideration, and if the director was not at the date of the meeting interested in the proposed contract or arrangement,
or shall become interested in a contract or arrangement after it is made, he shall forthwith after becoming so interested,
advise the Company in writing of the fact and nature of his interest. A general notice to the directors by a director that
he is a member of a specified firm or company, and is to be regarded as interested in any contract or transaction which
may, after the date of notice, be made with such firm or company shall (if such director shall give the same at a meeting
of the directors, or shall take reasonable steps to secure that the same is brought up and read at the next meeting of the

41253

L

U X E M B O U R G

directors after it is given) be a sufficient declaration of interest in relation to such contract or transaction with such firm
or company. A director may be counted as one of a quorum upon a motion in respect of any contract or arrangement
which he shall make with the Company, or in which he is so interested as aforesaid, and may vote upon such motion.

Officers.
56. The directors of the Company may, by resolution of directors, appoint officers of the Company at such times as

shall be considered necessary or expedient, and such officers may consist of a President, one or more Vice Presidents, a
Secretary, and a Treasurer and such other officers as may from time to time be deemed desirable. The officers shall
perform such duties as shall be prescribed at the time of their appointment subject to any modifications in such duties as
may  be  prescribed  by  the  directors  thereafter,  but  in  the  absence  of  any  specific  allocation  of  duties  it  shall  be  the
responsibility of the President to manage the day to day affairs of the Company, the Vice Presidents to act in order of
seniority in the absence of the President, but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the
President, the Secretary to maintain the registers, minute books and records (other than financial records) of the Company
and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by applicable law, and the Treasurer
to be responsible for the financial affairs of the Company.

57. Any person may hold more than one office and no officer need be a director or member of the Company. The

officers shall remain in the office until removed from office by the directors whether or not a successor is appointed.

58. Any officer who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of

representing it and of transacting any of the business of the officers.

Powers of directors.
59. The business of the Company shall be managed by the directors who may pay all expenses incurred preliminary

to and in connection with the formation and registration of the Company, and may exercise all such powers of the
Company as are not by the Act or by these Regulations required to be exercised by the members subject to any delegation
of such powers as may be authorised by these Regulations and to such requirements as may be prescribed by resolution
of the members, but no requirement made by resolution of the members shall prevail if it be inconsistent with these
Regulations nor shall such requirement invalidate any prior act of the directors which would have been valid if such
requirement had not been made.

60. The Board may entrust to and confer upon any director or officer any of the powers exercisable by it upon such

terms and conditions and with such restrictions as it thinks fit, and either collaterally with, or to the exclusion of, its own
powers, and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers. The directors may delegate
any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit. Any committees
so formed shall in the exercise of powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the
directors.

61. The directors may from time to time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons,

whether nominated directly or indirectly by the directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such
purposes and with such powers authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the directors,
under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they think fit, and any such powers of
attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney to
delegate all or any of the powers authorities and discretions vested in him.

62. Any director who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose

of representing it a Board Meeting and of transacting any of the business of the directors.

63. All cheques, promissory notes, drafts bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for monies

paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed as the case may be, in such
manner as the directors shall from time to time by resolution determine.

64. The directors may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its

undertakings, property and uncalled capital or any part thereof, to issue debentures, debenture stock and other securities
whenever money is borrowed or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

65. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, save that if the number of directors

shall have been fixed at two or more persons and by reason of vacancies having occurred in the Board there shall be only
one continuing director, he shall be authorised to act alone only for the purpose of appointing another director.

Proceedings of directors.
66. The meetings of the Board of Directors and any committee thereof shall be held at such place or places as the

directors shall decide.

67. The directors may elect a chairman of their meeting and determine the period for which he is to hold office; but

if no such chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present at the time appointed for holding the
same, the directors present may choose one of their number to be Chairman for the meeting.

68. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as

they think fit. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes; in case of an equality in votes the
Chairman shall have a second or casting vote. A director may at any time summon a meeting of the directors. If the

41254

L

U X E M B O U R G

Company shall have only one director, the provisions hereinafter contained for meetings of the directors shall not apply
but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of
a meeting shall record in writing and sign a note of memorandum of all matters requiring a resolution of the directors.
Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.

69. A director shall be given not less than seven days notice of a meeting of the directors.
70. Notwithstanding Regulation 69 above, a meeting of the directors held in contravention of that Regulation shall be

valid if a majority of the directors entitled to vote at the meeting have waived the notice of the meeting.

71. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the

notice does not invalidate the meeting.

72. A meeting of the directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are

present in person or by alternate not less than one-third of the total number of directors with a minimum of two, or in
the case of only one director a minimum of one.

73. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall be

dissolved.

74. Any one or more members of the Board of Directors or any committee thereof may participate in a meeting of

such Board or committee by means of a conference telephone or similar communications equipment allowing all persons
participating in the meeting to hear each other at the same time. Participating by such means shall constitute presence in
person at a meeting.

75. A resolution approved by a majority of the directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of

the directors or of committee of the directors and taking the form of one or more documents in writing or by telex,
telegram, cable or other written or electronic communication shall be as valid and effectual as if it had been passed at a
meeting of the directors or of such committee duly convened and held,

Indemnity.
76. Subject to the provisions of the Act and of any other statute for the time being in force every director or other

officer of the Company shall be entitled to be indemnified out of the assets of the Company against all losses or liabilities
which he may sustain ... in or about the execution of the duties of his office or otherwise in relation thereto, and no
director or other officer shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to, or be incurred by the
Company in the execution of the duties of his office, or in relation thereto.

Seal.
77. The directors shall provide for the safe custody of the common seal of the Company. The common seal when

affixed to any instrument except as provided in Regulation 3, shall be witnessed by a director or any other person so
authorised from time to time by the directors. The directors may provide for a facsimile of the common seal and approve
the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument
and it shall have the same force and validity as if the seal has been affixed to such instrument and the same had been
signed as hereinbefore described.

Dividends and Reserves.
78. The directors may, by resolution, declare a dividend but no dividend shall be declared and paid except out of surplus

and unless the directors determine that immediately after the payment of the dividend

(a) the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business; and
(b) the realisable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than

deferred taxes, as shown in the books of account, and its capital.

79. Dividends may be declared and paid in money, shares or other property.
80. In computing the surplus for the purpose of resolving to declare and pay a dividend, the directors may include in

their computation the net unrealised appreciation of the assets of the Company.

81. The directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the directors to be

justified by the surplus of the Company.

82. Subject to the rights of the holders of shares entitled to special rights as to dividends, all dividends shall be declared

and paid according to the par value of the shares in issue, excluding those shares which are held by the Company as
Treasury shares at the date of declaration of the dividend.

83. The directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as

they think proper as a reserve or reserves which shall, at their discretion, either be employed in the business of the
Company or be invested in such investments as the directors may from time to time think fit.

84. If several persons are registered as joint holders of any share, any of them may give effectual receipt for any dividend

or other monies payable on or in respect of the share.

85. Notice of any dividend that may have been declare shall be given to each member in manner hereinafter mentioned

and all dividends unclaimed for three years been declared may be forfeited by the directors for the benefit of the Company.

86. No dividend shall bear interest against the Company.

41255

L

U X E M B O U R G

Books, Records and Registers.
87. The Company shall keep such accounts and records as the directors consider necessary or desirable in order to

reflect the financial position of the Company.

88. The Company shall keep minutes of all meetings of directors, members, committees of directors, committees of

officers and committees of members, and copies of all resolutions consented to by the directors, members, committees
of directors, committees of officers and committees of members.

89. The Company shall maintain an accurate and complete Register of Directors and Register of Officers showing the

full names and addresses of all directors, officers and members, the date such person was appointed a director or officer
of the Company, as applicable, and the date such person was removed as a director or officer of the Company, as
applicable.

90. The Company shall maintain an accurate and complete Register of Members showing the full names and addresses

of all persons holding registered shares in the Company, the number of shares held by such person and where applicable,
the date such person ceased to hold any registered shares in the Company.

91. The records required by Regulations 89 and 90 shall be kept at the registered office of the Company and at such

other place as the directors may determine, and shall be open to the inspection of the directors at all times.

92. The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and

under what conditions or regulations the books, records and minutes of the Company or any of them shall be open to
the inspection of members not being directors, and no member (not being a director) shall have any right of inspecting
any book, record, minute or document of the Company except as conferred by Law or authorised by resolution of the
directors.

Audit.
93. The directors may by resolution call for the accounts of the Company to be examined by an auditor or auditors

to be appointed by them at such remuneration as may from time to time be agreed.

94. The auditor may be a member of the company but no director or officer shall be eligible during his continuance in

office.

95. Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers of

the Company, and shall be entitled to require from the officers of the Company such information and explanations as he
thinks necessary for the performance of his duties.

96. The report of the auditor shall be annexed to the accounts upon which he reports, and the auditor shall be entitled

to receive notice of, and to attend, any meeting at which the Company's audited Profit and Loss Account and Balance
Sheet is to be presented.

Notices.
97. Any notice, information or written statement required to be given to members shall be served by mail (airmail

service if available) addressed to each member at the address shown in the share register.

98. All notices directed to be given to the members shall, with respect to any registered shares to which persons are

jointly entitled, be given to whichever of such persons is named first in the share register, and notice so given shall be
sufficient notice to all the holders of such shares.

99. Any notice, if served by post, shall be deemed to have been served within ten days of posting, and in proving such

service it shall be sufficient to prove that the letter containing the notice was properly addressed and put into the Post
Office.

Pension and Superannuation fund.
100. The directors may establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any non-contributory

or contributory pension or superannuation funds for the benefit of, and give or procure the giving of donations, gratuities,
pensions, allowances or emoluments to any persons who are or were at any time in the employment or service of the
Company or any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with
any such subsidiary, or who are or were at any time directors or officers of the Company or of any such other company
as aforesaid or who hold or held any salaried employment or office in the Company or such other company, or any
persons in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid is, or has been at any time, interested,
and to the wives, widows, families and dependents of any such persons, and make payments for or towards the insurance
of such persons as aforesaid, and may do any of the matters aforesaid either alone or in conjunction with any such other
company as aforesaid. A director holding any such employment or office shall be entitled to participate in and retain for
his own benefit any such donation, gratuity, pension, allowance or emolument.

Winding up.
101. If the Company shall be wound up, the Liquidator may, in accordance with a resolution of members, divide amongst

the members in specie or in kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of
property of the same kind or not) and may for such purpose set such value as he deems fair upon any such property to
be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different

41256

L

U X E M B O U R G

classes of members. The Liquidator may vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trust for the
benefit of the contributors as the Liquidator shall think fit, but so that no member shall be compelled to accept any shares
or other securities whereon there is any liability.

Arbitration.
102. Whenever any difference arises between the Company on the one hand and any of the members, their executors,

administrators or assigns on the other hand touching the true intent and construction or the incidence or consequences
of these presents or of the Act touching anything done or executed omitted or suffered in pursuance of the Act touching
any breach or alleged breach or otherwise relating to the premises or to these presents or to any Act affecting the
Company or to any of the affairs of the Company such difference shall unless the parties agree to refer the same to a
single  arbitrator  be  referred  to  two  arbitrators,  one  to  be  chosen  by  each  of  the  parties  to  the  difference  and  the
arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire.

103. If either party to the reference makes default in appointing an arbitrator either originally or by way of substitution

(in the event that an appointed arbitrator shall die, be incapable of acting or refuse to act) for ten days after the other
party has given him notice to appoint the same, such other party may appoint an arbitrator to act in the place of the
arbitrator of the defaulting party.

Continuation.
104. The Company may by resolution of members or by a resolution passed unanimously by all directors of the

Company continue as a company incorporated under the laws of a jurisdiction outside the British Virgin Islands in the
manner provided under those laws.

Amendment to articles.
105. The Company may by resolution of its members or of its directors, amend or modify any of the conditions

contained in Articles of Association in any way which may be permitted by law.

We, the undersigned Subscriber, are desirous of being formed into a Company in pursuance of these Articles of

Association.

NAME ADRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER
S-HR&amp;M Financial Services Limited Kingston Chambers
P.O. Box 173
Road Town, Tortola British Virgin Islands

DATED this 15th day of April, 2003.

WITNESS to the above signature:
Deanna Trott-Rubaine (Sgd)
Kingston Chambers

Référence de publication: 2011016037/720.
(110017613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Norpa Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 31.241.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the twenty ninth day of December.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

Mr. Gerhard LYCKE, company director, residing at W2 1PW London (United Kingdom) Apt. 603, Munkenbeck Building

5 Hermitage Street, Paddington,

here represented by Mrs. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch-sur-

Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the public limited holding company (société anonyme holding) NORPA HOLDING S.A., with registered office

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 31241, was
incorporated by a deed received by Maître Marc ELTER, then notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg), on July 27, 1989, published in the Mémorial C number 382 of December 21, 1989, and that its articles of association
have been modified for the last time by deed received by Maître Tom METZLER, notary residing at Luxembourg-Bon-

41257

L

U X E M B O U R G

nevoie (Grand-Duchy of Luxembourg) on June 22, 2004, published in the Mémorial C number 980 of October 2, 2004
(the "Company").

2) That the Company's capital is fixed at thirty thousand nine hundred and eighty six Euro sixty nine Cent (EUR

30,986.69) represented by thousand (1,000) shares without a nominal value.

3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints himself as liquidator of the Company and in his capacity as liquidator of the

Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in his capacity as liquidator of the Company declares that he irrevocably undertakes to

settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

7) That the appearing party declares that he takes over all the assets of the Company and that he will assume any

existing debt of the Company pursuant to point 6).

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
9) That full and entire discharge is granted to the directors and to the supervisory auditor for the performance of their

assignment.

10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the

former registered office in L- 1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de l'acte:

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.
Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Gerhard  LYCKE, administrateur de  sociétés,  demeurant à W2 1PW  Londres  (Royaume-Uni) Apt.  603,

Munkenbeck Building 5 Hermitage Street, Paddington,

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, domicilié professionnellement à Esch-

sur-Alzette,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société anonyme holding NORPA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 31241, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Marc ELTER, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 27 juillet 1989, publié au
Mémorial C numéro 382 du 21 décembre 1989, et que ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par Maître Tom
METLZER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 22 juin 2009,
publié au Mémorial C numéro 980 du 2 octobre 2004 (la "Société").

2) Que le capital de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt- six Euros et soixante-neuf Cents (EUR

30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Que le comparant est l'actionnaire unique de la Société.
4) Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.

41258

L

U X E M B O U R G

5) Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura en sa qualité de liquidateur de la Société pleins

pouvoirs d’établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout
ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif

connu et inconnu actuellement de la Société dissoute.

7) Que le comparant déclare qu’il reprend tout l’actif de la Société et qu’il s’engagera à régler tout le passif de la Société

comme indiqué au point 6)

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme d’environ mille euros (€ 1.000,-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2011. Relation: EAC/2011/202. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011021181/102.
(110024917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Service VIP Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 65, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 158.752.

STATUTS

L’an deux mille onze, le dix-huit janvier.
Par devant Maitre Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg

A COMPARU

1) Monsieur Philip TIMMERMANS, gérant de société, né le 01 Juin 1970 à Etterbeek (B), demeurant au 167, Rue du

Centre B-5300 Andenne (Belgique),

2) Madame Francoise FAUX, gérant de société, née le 24 Janvier 1970 à Uccle, demeurant au 167, Rue du Centre

B-5300 Andenne (Belgique)

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «Service VIP Lux Sàrl»

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Huncherange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, la location de biens mobiliers ou immobiliers, le service, la consultance

en sécurité aux entreprises et particuliers, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobi-
lières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou caution-

nements à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect.

41259

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros représenté par cent (100,-) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt cinq (125,-) Euros chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles

ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du
capital social.

Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société comporte

plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société
ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n'en décident
autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes
les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraineront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir de leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social. La réunion de
toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entrainera pas la dissolution de la société.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de trois quarts du capital social.

Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des

associés. Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1er sont inscrites sur le procès-verbal ou
établies par écrit. De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur
un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les
conditions normales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2011.

<i>Souscription des parts

Les 100 (cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Philip Timmermans, précité: Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,-parts sociales
2) Madame Françoise Faux, précitée: Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,-parts sociales

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) Euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille cinq cents euros (1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué, se sont

réunis en assemblée générales extraordinaire et, à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés co-gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Philip TIMMERMANS, né le 01 Juin 1970 à Etterbeek (B), demeurant au 167, Rue du Centre, B-5300

Andenne (Belgique) et

41260

L

U X E M B O U R G

b) Madame Françoise FAUX, née le 24 Janvier 1970 à Uccle, demeurant au 167, Rue du Centre B-5300 Andenne

(Belgique).

La société est valablement engagée par la signature d'un seul des co-gérants.
2. Le siège social de la société est fixé au 65, Route d'Esch L-3340 Huncherange Avant la clôture du présent acte le

notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir une autorisation adminis-
trative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. TIMMERMANS, F. FAUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4242. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2011021261/92.
(110025486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Wireless M2M Subco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 136.589.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten on the twenty ninth day of December,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Flora Gibert, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg.
"the proxy"
acting as a special proxy of Hg Incorporations Limited, with registered office at 2, More London Riverside, SE1 2AP

London United Kingdom.

"the mandator"
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur
by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société à responsabilité limitée "Wireless M2M Subco S.à R.L.", having its head office at Luxembourg, 7A,

rue Robert Stumper, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 136589,
has been incorporated by deed enacted on the 21 February 2008, published in the Mémorial C number 732 of the 26
March 2008.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée "Wireless M2M Subco S.à R.L.", amounts

currently to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500)
shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)each fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

"Wireless M2M Subco S.à R.L.".

IV.- That the mandator acquired all the shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,

liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

41261

L

U X E M B O U R G

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the

English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi.

L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Hg Incorporations Limited, ayant son siège social au 2, More London

Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume Uni.

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "Wireless M2M Subco S.à R.L.", ayant son siège social à Luxembourg, 7A rue

Robert Stumper, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 136589, a
été constituée suivant acte reçu le 21 février 2008, publié au Mémorial C numéro 732 du 26 mars 2008.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée ""Wireless M2M Subco S.à R.L.", prédésignée, s'élève

actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-), chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"Wireless M2M Subco S.à R.L.",.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend

à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l'exécution de leurs

mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 30 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59978. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

Référence de publication: 2011020494/81.
(110024205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

FM Racing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 139.589.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

<i>Dépôt rectificatif au dépôt L110033785 Enregistré le 24 février 2011

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 février 2011 que:
1. La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS de son poste d'Administrateur de catégorie B a été acceptée.

41262

L

U X E M B O U R G

2. Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) demeurant professionnellement au 12, rue Guillaume

Schneider, L-2522 Luxembourg a été élue administrateur de catégorie B de la société en remplacement de Monsieur
Bruno BEERNAERTS, démissionnaire.

Le mandat du nouvel Administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au

31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 mars 2011.

Référence de publication: 2011036863/20.
(110040550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

G &amp; P Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 82.889.

<i>Principales résolutions prises par l'associé unique en date du 9 mars 2011

Il a été décidé comme suit:
- De constater le changement d'adresse du gérant unique, demeurant professionnellement à présent au 46, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

- D'engager valablement la société en toutes circonstances et sans limitation par la seule signature du gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011036867/17.
(110040548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Saran S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 17.623.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 février 2011

- Le Conseil d'Administration décide de transférer avec effet au 4 février 2011 le siège social de la Société de son

adresse actuelle à l'adresse suivante:

1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
- Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY en tant que Président du

Conseil d'Administration

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037111/17.
(110040255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.

NEIF S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 155.388.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil de gérance

<i>Résolution

Après avoir délibéré, le Conseil de Gérance décide, à l'unanimité:
- de transférer le siège social de la société NEIF SCA au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 LUXEMBOURG , avec effet au

04 février 2011.

41263

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011037253/15.
(110040606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Mouton S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 82.275.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.-  Madame  Lidia  SCHAAP-NEDERLOF,  née  à  Rotterdam  (Pays-Bas),  le  17  juin  1924,  demeurant  à  NL-2991  XX

Barendrecht, ‘t Ruin, 3 (Pays-Bas),

2.- Madame Evelyn SCHAAP-NEDERLOF, née à Rotterdam (Pays-Bas), le 15 juin 1960, demeurant à NL-3081 JD

Rotterdam, Pleinweg, 33D (Pays-Bas),

3.- Monsieur Pauwel SCHAAP, né à Rotterdam (Pays-Bas), le 21 octobre 1958, demeurant à NL-2991 WH Barendrecht,

Tocheleede, 1 (Pays-Bas)

4.- (i) Mark Paul SCHAAP, né à Rotterdam, le 2 novembre 1992,
(ii) Maximiliaan Erik SCHAAP, né à Rotterdam, le 30 août 1996, et
(iii) Benjamin Daniël SCHAAP, né à Rotterdam, le 30 août 1996, tous trois représentés par leurs administrateurs légaux

et parents, Monsieur Pauwel SCHAAP, préqualifié et Madame Erika Nicolasina JONGENELIS, demeurant tous ensemble
à NL-2991 WH Barendrecht, Tocheleede, 1 (Pays-Bas)

tous ici représentés par Monsieur Joseph ROTTEVEEL, administrateur de sociétés, demeurant à L-7626 Larochette,

26 Chemin J-A. Zinnen, en vertu de quatre (4) procurations lui délivrées sous seing privé, lui-même ici représenté par
pouvoir de substitution accordé à Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, les-
quelles après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

leurs déclarations:

a.- Que la société de gestion de patrimoine familial sous forme de société anonyme MOUTON S.A., SPF (ci-après la

«Société»), ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51.482, constituée originairement sous la dénomination de "
MOUTON HOLDING S.A.", suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mai 2001, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1136 du 10 décembre 2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçus par le notaire instrumentant en date du 2 février 2010, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 672 du 30 mars 2010, contenant notamment la refonte
complète des statuts et le changement de la dénomination en MOUTON S.A., SPF

b.- Que le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,EUR), représenté par cent cinquante (150) actions

d'une valeur nominale de mille euros (1.000,-EUR) chacune.

c.- Que les comparants sont les seuls et uniques actionnaires de ladite société.
d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'actionnaires uniques, siégeant en assemblée

générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société
avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e.- Que les actionnaires se désignent eux-mêmes comme liquidateurs.
f.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société

dissoute, moyennant reprise par les actionnaires de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au
profit des actionnaires.

g.- Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout

le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
i- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

j.- Que partant, la liquidation de la société est achevée.

41264

L

U X E M B O U R G

k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euros, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2010. Relation GRE/2010/4769. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011021165/65.
(110025417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Triangle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 42.212.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 février 2011

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social au 1 rue Joseph Hackin, L-1746 Luxem-

bourg avec effet au 4 février 2011.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011037293/13.
(110040598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Amber Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.646.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 3 janvier 2011

<i>Première résolution:

L'assemblée prend acte des démissions de Monsieur Claude SCHMITZ, Monsieur Guy HORNICK et Monsieur Thierry

FLEMING de leur fonction d'administrateur, et nomme, avec effet au 01.01.2011.

- Madame Beatriz GARCIA, née le 05 février 1966 à Madrid (Espagne), avocate à la cour, demeurant professionnelle-

ment 5 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Alfonso GARCIA, né le 13 décembre 1967 à Madrid (Espagne), directeur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement 5 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg;

- Madame Colette WOHL, née le 18 février 1959 à Luxembourg (Luxembourg), directrice de sociétés, demeurant au

5 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Leur mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015
De même l'Assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes, la société AUDIEX SA, et nomme

avec effet au 01.01.2011, la société Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro RCS Luxembourg: B 60.219 ayant son siège social 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg. Son
mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2015.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse du 11 A, boulevard Prince Henri L-1724 au 5

boulevard Royal L-2449 Luxembourg, avec effet au 01.01.2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

41265

L

U X E M B O U R G

AMBER HOLDING S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011039557/28.
(110044264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Xenia Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 39, rue Saint Vincent.

R.C.S. Luxembourg B 77.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011037305/10.
(110041105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

Dialna S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Dialna S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 54.213.

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DIALNA S.A., avec

siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 54.213,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Mondorf les Bains, en

date du 14 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 277 du 06 juin 1996

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du

24 septembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2676 du 03 novembre 2008.

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée

privée, demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à

Herserange (France).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à

Rodange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les VINGT-

QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (24.750) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'inté-
gralité du capital de UN MILLION D’EUROS (€ 1.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps

aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transformation de la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF"); suppression dans

les Statuts de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, à compter de ce jour;

2) Changement du libellé de l'objet social (article 3 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis

à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"), à l'exclusion
de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte. La société n'est admise à détenir une

participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes."

41266

L

U X E M B O U R G

3) Modification de la dénomination de la société en DIALNA S.A., SPF. Modification de l'article 1, des statuts pour lui

donner la teneur suivante: il existe une société anonyme, sous la dénomination de DIALNA S.A., SPF.

4) Réduction de capital social à concurrence de EURO 969.000,- (EUR neuf cent soixante-neuf mille), pour le ramener

de EUROS 1.000.000,- (EUR un million) à EUROS 31.000,- (EUR trente-et-un mille) par remboursement aux actionnaires
sans diminution du nombre d’actions.

5) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
6) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société de gestion de patrimoine familial ("SPF") à

compter de ce jour.

Toute référence dans les statuts à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée, notamment à l'article

dix-sept (17) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 17. Pour toutes les matières aui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposition

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la

teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"),
à l'exclusion de toute activité commerciale.

Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la

gestion de cette société.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en DIALNA S.A., SPF, de sorte que l'article premier

(1er!) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme, sous la dénomination de DIALNA S.A., SPF.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de neuf cent soixante-neuf mille euros (€ 969.000,-),

pour le ramener de un million d’euros (€ 1.000.000,-) à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) par remboursement
aux actionnaires sans diminution du nombre d'actions.

L'assemblée prend acte que suivant les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés le remboursement à un

actionnaire ne peut se faire qu'après 30 jours à compter de la publication de ce procès-verbal au Mémorial. Le rembour-
sement peut se faire antérieurement si tous les créanciers de la société donnent leur accord. Dans l'hypothèse où il n'y
a pas de créanciers le prédit délai n'est pas à respecter.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article cinq (5) - 1 

er

 alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 5. 1 

er

 alinéa.  Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par VINGT-

QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (24.750) ACTIONS sans désignation de valeur nominale.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: EAC/2011/502. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

41267

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011020953/97.
(110025762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

Ardea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.775.

Les comptes annuels au 30 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ARDEA S.A.
Signature

Référence de publication: 2011037386/12.
(110041689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Sparinvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 83.976.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 1 

er

 mars 2011:

- a pris note que les mandats d'administrateur de Messieurs:
Per NOESGAARD„ Managing Director, Sparinvest Holding A/S, Kingosvej 1, DK-2630 Taastrup,
Jan Stig RASMUSSEN, Managing Director &amp; CEO, Sparinvest S.A., 28 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Michael ALBRECHTSLUND, Director, Sparinvest Holding A/S, Kingosvej 1, DK-2630 Taastrup,
sont valables jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014
- a renouvelé le mandat d'Ernst &amp; Young, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach à la fonction de Réviseur d'En-

treprises pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2012.

Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2011.

<i>Pour SPARINVEST SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2011037762/20.
(110040841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.

M-F LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 85.643.

L'an deux mille onze, le sept février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "M-F LUX S.A.", établie et

ayant son siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert MULLER,
alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 709 du 8 mai
2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro numéro B 85643.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Antonio José DA FONSECA, agent immobilier,

né le 19 mai 1968 à Resende (P), demeurant à L-3521 Dudelange, 37, rue Karl Marx.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Paulo Carlos DOMINGUES CARMO, agent immobilier,

né le 17 octobre 1974 à Differdange, demeurant à L-8255 Mamer, 54, rue Mont-Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks à L-3850 Schifflange, 72-80, avenue

de la Libération et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts.

2.- Divers.

41268

L

U X E M B O U R G

II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de CENT MILLE EUROS (€ 100.000,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks à

L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des

statuts qui aura la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Schifflange."

Les autres alinéas de l'article 1 

er

 restent inchangés.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A.J. Da Fonseca, P.C. Domingues Carmo, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 février 2011. Relation: EAC/2011/1804. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 9 février 2011.

Référence de publication: 2011020323/50.

(110024154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Azimuth International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.239.

EXTRAIT

En date du 7 mars 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Johanna van Oort, en tant que gérant A, est acceptée avec effet au 23 février 2011.

- Monsieur Wim Rits, avec adresse professionnelle au "15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg", est élu nouveau

gérant A de la société avec effet au 23 février 2011.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037389/15.

(110041401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

41269

L

U X E M B O U R G

Azimuth International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.239.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 5 décembre 2010 que, sur base de l'acte de transfert de

parts sociales signé en date du 25 décembre 2010, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales
de la société ayant une valeur de EUR 1.000,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

MTM Nommées Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037390/17.
(110041792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Société d'Etude et de Recherche Appliquée en Cancérologie (SERAC) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 67.568.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 mars 2011

<i>Cinquième résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Luc HAN-
SEN, licencié en Administration des Affaires, né à Luxembourg le 08/06/1969, domicilié professionnellement à Luxem-
bourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Pierre LENTZ, licencié en Sciences Economiques,
né à Luxembourg le 22/04/1959, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg; Monsieur John SEIL, Expert-comptable, né à Luxembourg le 28/09/1948, domicilié professionnellement à
Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX
S.A., ayant son siège social au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire qui se prononcera sur la liquidation définitive de la société courant 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE APPLIQUEE EN CANCEROLOGIE (SERAC) S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011038684/22.
(110042630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.

Lieber Racing Team S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Ardennes Invest Lux Sàrl).

Siège social: L-8030 Strassen, 126, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 106.203.

L'an deux mille onze, le trente-et-un janvier.
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- "S.P.R.L. SOCOMA", société privée à responsabilité limitée de droit belge, avec siège social à B-4960 Malmédy, 39,

avenue de Norvège,

ici représentée par Monsieur Roland LIEBER, administrateur de sociétés, né à Malmédy (Belgique), le 7 octobre 1962,

demeurant à L8030 Strassen, 126, rue du Kiem,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 18 janvier 2011,
laquelle procuration, signée "ne varietur", restera annexée au 2004 24 31142 présent acte pour être formalisée avec

celui-ci,

41270

L

U X E M B O U R G

2.-"SOCOMA CONSTRUCTION LUXEMBOURG S.à r.l." (anciennement: "S.C.L. S.à r.l."), société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8030 Strassen, 126, rue du Kiem,

représentée par son gérant unique, Monsieur Roland LIEBER, prénommé,
3.- Monsieur Roland LIEBER, prénommé,
4.- Monsieur Cédric LIEBER, sans état particulier, né à Malmédy (Belgique), le 16 août 1992, demeurant à L-8030

Strassen, 126, rue du Kiem,

Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Les sociétés "S.P.R.L. SOCOMA" et "SOCOMA CONSTRUCTION LUXEMBOURG S.à r.l.", prénommées, sont les

associées de la société à responsabilité limitée "ARDENNES INVEST LUX S.à r.l.", avec siège social à L-9227 Diekirch,
52, Esplanade, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1120 du 24 juillet 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 7 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 629 du 29
juin 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 février 2005, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 588 du 18 juin 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 29 août 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2024 du 27 octobre 2006,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 106.203, au capital
social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros
(EUR 125,00) chacune.

2. "S.P.R.L. SOCOMA", prénommée, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Roland LIEBER, prén-

ommé, quatre-vingt (80) parts sociales de la société à responsabilité limitée "ARDENNES INVEST LUX", prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de dix mille euros (EUR 10.000,00), que la cédante reconnaît avoir

reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

3. "SOCOMA CONSTRUCTION LUXEMBOURG S.à r.l.", prénommée, déclare céder et transporter par les présentes

à Monsieur Cédric LIEBER, prénommé, vingt (20) parts sociales de la société à responsabilité limitée "ARDENNES INVEST
LUX S.à r.l.", prénommée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00), que la cédante

reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

4. Les cessionnaires sont propriétaires à compter de ce jour des parts leur cédées et ils ont droit aux revenus et

bénéfices dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées. Tous les associés dé-

clarent expressément accepter les cessions de parts qui précèdent.

5. Monsieur Roland LIEBER, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de

parts qui précède au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les
sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code civil.

6. Ensuite, Monsieur Roland LIEBER et Monsieur Cédric LIEBER, prénommés, seuls associés de la société après réa-

lisation des cessions de parts qui précèdent, décident de changer la dénomination sociale en "LIEBER RACING TEAM S.à
r.l.", et de modifier, par conséquent, l’article trois des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination de "LIEBER RACING TEAM S.à r.l.", société à responsabilité limitée."
7. Les associés de la société décident de modifier l’objet social, et de modifier, par conséquent, l’article deux des statuts

de la société, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la création, le développement et la gestion d’un ensemble de moyens matériels et

humains en vue de participer à des épreuves ou manifestations sportives impliquant des véhicules à moteur, en particulier,
des motos de toutes cylindrées.

La société a également pour objet toutes activités liées notamment à la préparation des moteurs, la vente de produits

dérivés, la recherche de pilotes et de sponsors, la négociation des droits à l’image, et le management des sportifs de haut
niveau.

La société peut également faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se

rattacher directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet."

8. Les associés décident de transférer le siège social à L-8030 Strassen, 126, rue du Kiem, et de modifier en conséquence

le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Strassen."
9. Les associés de la société décident de modifier l'article six des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune, intégralement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

41271

L

U X E M B O U R G

1.- Monsieur Roland LIEBER, prénommé, quatre-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur Cédric LIEBER, prénommé, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

10. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

11. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

<i>Déclaration:

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Lieber, C. Lieber, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 février 2011. Relation: LAC / 2011 / 5869. Reçu soixante-quinze euros

75,00€.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 11 février 2011.

Référence de publication: 2011021625/93.

(110026144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

JALUX, Société Civile.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg E 4.336.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des associés du 30 novembre 2010

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des associés en date du 30 novembre 2010 que le capital social de

la société, actuellement de mille euros (1.000 €), divisé en mille (1.000) parts sociales de un euro (1 €) chacune, est
augmenté par apport en nature d'un montant nominal de cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
euros (198.998 €), par l'émission de cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (198.998) parts so-
ciales de catégorie A d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune avec une prime d'apport égale à six millions cent-
trente-neuf mille neuf cent-soixante euros et soixante-six centimes ("6.139.960,66 €) entièrement libérées et attribuées
à Madame Jacqueline MAGGI-BACOU

La différence entre (i) la valeur nette des apports (soit six millions trois cent-trente-huit mille neuf cent-cinquante-huit

euros et soixante-six centimes (6.338.958,66 €) et (ii) la valeur nominale des parts sociales de catégorie A attribuées en
rémunération des apports en nature d'un montant de cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros
(198.998 €) sera inscrite au passif du bilan de la Société sous l'intitulé «Prime d'apport» pour un montant de six millions
cent-trente-neuf mille neuf cent-soixante euros et soixante-six centimes (6.139.960,66 €). Les droits de chaque part
sociale, ancienne et nouvelle, seront égaux sur la prime d'apport

L'émission susvisée aura pour effet de porter le capital social de la Société de mille euros (1.000€) à cent quatre-vingt-

dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (199.998 €).

Suite à cette augmentation de capital, l'article six (6) et le premier alinéa de l'article sept (7) des statuts auront doré-

navant la teneur suivante:

41272

L

U X E M B O U R G

« Art. 6. Apports. Les associés ont apporté aux fins de la libération du capital des avoirs pour les montants suivants:

- Madame Jacqueline MAGGI-BACOU,
demeurant au 5, Chemin de Chamblandes, Pully 1009,
Suisse, née le 22 novembre 1936, à Capendu,
De nationalité française, veuve
CENT QUATRE-VINGT-DIX- NEUF MILLE NEUF CENT
QUATRE-VINGT QUINZE EUROS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €199.995
- Finacap Holding SA,
39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg
TROIS EUROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 3

soit au total cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
quatre vingt dix huit euros, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 199.998

Ces apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué à l'Article 7 qui suit.»

«  Art. 7. 1 

er

 alinéa.  Le capital social est fixé à la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-

dix-huit euros (199.998 €). Il est divisé en cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (199.998) parts
de catégorie A de 1 euro (1 €) chacune, numérotées de 1 à 199.998, attribuées aux associés dans les proportions suivantes:

- Madame Jacqueline MAGGI-BACOU,
demeurant au 5, Chemin de Chamblandes, Pully 1009,
CENT QUATRE-VINGT-DIX- NEUF MILLE NEUF CENT
QUATRE-VINGT QUINZE EUROS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 199.995
- Madame Véronique MIRABEL,
Demeurant 4 rue de la Valfère,
F-34000 Montpellier
UNE PART SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- Monsieur Christophe BACOU,
Demeurant 12 rue de la Salle l'Evêque
F-34000 Montpellier,
UNE PART SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- Monsieur Philippe BACOU,
Demeurant 9 rue de la Colombière,
CH.-1260 Nyon,
UNE PART SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Soit au total cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit parts
du capital social, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199.998

Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011025980/64.
(110030726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Bellune Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.810.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011037393/11.
(110041466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

41273

L

U X E M B O U R G

Bio-Tech International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 28.341.

Le mandat d'administrateur de Madame Sabine KIRSCH ayant expiré, il a été procédé à son remplacement à l'occasion

de l'assemblée générale du 9 mars 2011 par la nomination comme administrateur de Maître Pablo RUIZ de PERALTA,
avocat, né à Grenade (Espagne), le 30 avril 1945, demeurant à E-29602 Marbella, calle La Retama n° 15bis (Espagne). Le
mandat du nouvel administrateur expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

<i>Pour la société
R. LUTGEN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2011037399/14.
(110041444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Biron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 122.255.

EXTRAIT

En date du 3 mars 2011, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Marjoleine van Oort, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 23 février 2011.
- Monsieur Wim Rits, avec adresse professionnelle au "15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg", est élu nouveau

gérant de la société avec effet au 23 février 2011.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 14 mars 2011.

Référence de publication: 2011037400/15.
(110041375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Safcon Air S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 110.266.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 31 mars 2010 :-

<i>Résolution 1.

Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1 

er

 étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-

bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.

Luxembourg, le 31 mars 2010.

<i>Pour SAFCON AIR S.A.

Référence de publication: 2011038059/14.
(110042103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.

Cergrafhold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 49.272.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 mars 2011

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la

période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

Conseil d'administration:

<i>- administrateurs de catégorie A:

M. Giancarlo Cerutti, demeurant Via Mameli 43, I-15133 Casale Monferrato (Italie), président;
Mme Mariella Cerutti, demeurant Via P. Micca 21, I-10121 Turin (Italie), administrateur;

41274

L

U X E M B O U R G

<i>- administrateurs de catégorie B:

M Sébastien Schaack, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
M. Leonardo Miocchi, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
M. Alfio Riciputo, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;
Mme Manuela D'Amore demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux comptes:

ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011039615/27.
(110044253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 7.910.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 février

2011 que:

- La démission de Monsieur Spyros GHIKAS de son poste d’administrateur est acceptée.
- Monsieur Bruno LANDRIEU, managing director Rémy Cointreau Belux, né le 27 janvier 1960 à Tournai, demeurant

Chemin de la Ramée, 11, B-7500 Tournai est nommé administrateur de la société pour un mandat qui prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Il résulte des décisions prises par le Conseil d’Administration en date du 11 février 2011 que:
- La démission de Monsieur Guillaume COCUDE de son poste d’administrateur-délégué est acceptée. Monsieur Guil-

laume COCUDE continuera néanmoins à occuper la fonction d’adminstrateur au sein du conseil d’administration.

- Monsieur Bruno LANDRIEU, managing director Rémy Cointreau Belux , né le 270 janvier 1960 à Tournai, demeurant

Chemin de la Ramée, 11, B-7500 Tournai a été nommé administrateur-délégué pour la durée de son mandat d’Adminis-
trateur.

Suite à cette nomination, la gestion journalière est par conséquent déléguée à Messieurs Yves BOUR et Bruno LAN-

DRIEU, lesquels ont pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.

Luxembourg, le 11 février 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011040508/26.
(110045113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

Ophrys Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 108.836.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the thirtieth day of December,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Ms. Fiona Finnegan, residing in Luxembourg
"the proxy"
acting as a special proxy of Lombard International Assurance SA, policy No.14608, incorporated under the laws of

Luxembourg, having its registered address at Airport Center, 2 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg,

41275

L

U X E M B O U R G

"the mandator"
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur
by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme "Ophrys Holding SA", having its head office at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Lu-

xembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 108836, has been
incorporated by deed enacted on the 21 

st

 June 2005, published in the Mémorial C number 1131 of the 2 

nd

 of November

2005 that their Articles of Incorporation have not been amended;

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme "Ophrys Holding SA" amounts currently to thirty-one

thousand euros (31,000 EUR), represented by three thousand one hundred (3,100) shares having a par value of ten euros
(10 EUR) each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

"Ophrys Holding SA".

IV.- That the mandator acquired 3100 shares of the predesignated company and that as the shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator takes over, as liquidator, the wiping out of the known or unknown liabilities and commitments

of the company, which must be terminated before any appropriation whatsoever of the assets to its own person as sole
shareholder.

VI.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, and to the statutory auditor for their mandate up to

this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the

English text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte

anglais fait foi.

L'an deux mille dix, le trente décembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mlle. Fiona Finnegan, demeurant à Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Lombard International Assurance SA, police No.14608, incorporée sous

la législation de Luxembourg, avec le siège social situé au Airport Center, 2 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "Ophrys Holding SA", ayant son siège social à 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 108836, a été
constituée suivant acte reçu le 21 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1131 du 2 novembre 2005.

II.- Que le capital social de la société anonyme "Ophrys Holding SA", prédésignée, s'élève actuellement à trente-et-un

mille euros (EUR 31,000), représentés par trois mille cent (3 100) actions de dix euros (EUR 10) chacune, entièrement
libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"Ophrys Holding SA ".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

41276

L

U X E M B O U R G

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des
actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, et au commissaire aux comptes de la

société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. FINNEGAN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 janvier 2011. Relation: LAC/2011/122. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011020366/83.
(110024209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

West Investment Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 70.813.

L'an deux mille dix, le vingt-sept décembre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "WEST INVESTMENT HOLDING

S.A.", ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 70.813, -constituée suivant acte notarié en date du 30 juin 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 748 du 8 octobre 1999, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant un acte sous seing privé en date du 14 mai 2001, dont un extrait a

été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 577 du 13 avril 2002.

L'assemblée est ouverte à 12.45 heures sous la présidence de Madame Anne-Lies Van den Eeckhaut, employée privée,

50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Sabinot, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Arpea, employée privée, 50, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante: «La société a pour objet social la

souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute
société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi
que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle -même.

La société a également pour objet la création , l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

2. Modifications afférentes des articles 1 et 4 des statuts.
3. Suppression de l'alinéa 2 de l'article 9.
4. Modification de l'article 17.

41277

L

U X E M B O U R G

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide d'abandonner le statut de société holding tel que prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur

les sociétés holding et de soumettre la Société au régime d'une société de participations financières («SOPARFI»).

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1, 4 et 17 des statuts

pour leur donner désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de «WEST INVESTMENT HOLDING S.A.»

« Art. 4. La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier,

sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle -même.

La Société a également pour objet la création , l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

« Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 9 des statuts.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A.-L. VAN DEN EECKHAUT, C. SABINOT, S. ARPEA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010. LAC/2010/59883. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 janvier 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011020052/82.
(110023189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Braveza Investments, Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 81.755.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la société en date du 21 février 2011:

- Kathryn Bergkoetter, ayant pour adresse 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, a démissionné de sa fonction

de gérant de la société avec effet immédiat.

41278

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011037401/13.
(110041581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

C.I.D., Céramique Internationale Développement, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5855 Hesperange, 8, rue Jos Sunnen.

R.C.S. Luxembourg B 153.442.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/03/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011037405/12.
(110041801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Grus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.240.

<i>Rectificative des comptes annuels se terminant au 31 décembre 2009, enregistrés à Luxembourg - Sociétés, le 23 février 2011

<i>référence L110032561

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2011.

GRUS INVESTMENTS S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2011038145/17.
(110041666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Baddon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 150.719.

Il résulte de l'assemblée générale en date du 15 mars 2011 de la société Baddon S.A. que l'actionnaire a pris les décisions

suivantes:

1. Démission de l'Administrateur suivant:
Manacor (Luxembourg) S.A., ayant son siège au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Nomination du nouvel Administrateur A pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale:
Vasco Alexandre Marques de Freitas, résidant au Casa do Lugar, 977, Candoso, S. Tiago, Guimarães, Protugal.
Nomination des nouveaux Administrateurs B pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale:
Patrick L.C. van Denzen, ayant pour adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Robert van 't Hoeft, ayant pour adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Baddon S.A.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Administrateur B

Référence de publication: 2011040093/20.
(110044178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2011.

41279

L

U X E M B O U R G

Britanica Asset Management SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 107.480.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte de l'assemble générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BRITANICA ASSET MANA-

GEMENT S.A.», en liquidation volontaire, tenue en l'étude de Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz en date
du 27 janvier 2011, enregistrée à Wiltz le 28 janvier 2011 (Relation: WIL/2011/73):

- L'assemblée approuve les comptes de liquidation basés sur la situation comptable au 31 Décembre 2010, date à

laquelle la société n'a plus d'activité.

- L'assemblée constate que le liquidateur, la société anonyme de droit luxembourgeois FIDUCIAIRE ARBO S.A., dont

le siège social est à L-9522 Witz, 21, rue du Fossé, inscrite au registre de commerce sous le numéro B97.573 a réalisé
les actifs et qu'il n'existe plus aucun actif ne nécessitant d'acte de liquidation particulier.

- Le liquidateur a pris les dispositions nécessaires de manière à ce que les provisions et les charges liées à la liquidation

soient apurées.

- L'assemblée décide que les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans au domicile du liquidateur.
- L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société anonyme BRITANICA ASSET MANAGEMENT

SA qui cessera d'exister avec effet au 31 décembre 2010.

Fait à Wiltz, le 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011040628/22.
(110043878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

International Allied Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 107.117.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte de l'assemble générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «INTERNATIONAL ALLIED

SERVICES S.A.», en liquidation volontaire, tenue en l'étude de Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz en date
du 27 janvier 2011, enregistrée à Wiltz le 28 janvier 2011 (Relation: WIL/2011/72):

- L'assemblée approuve les comptes de liquidation basés sur la situation comptable au 31 Décembre 2010, date à

laquelle la société n'a plus d'activité.

- L'assemblée constate que le liquidateur, la société anonyme de droit luxembourgeois FIDUCIAIRE ARBO S.A., dont

le siège social est à L-9522 Witz, 21, rue du Fossé, inscrite au registre de commerce sous le numéro B97.573 a réalisé
les actifs et qu'il n'existe plus aucun actif ne nécessitant d'acte de liquidation particulier.

- Le liquidateur a pris les dispositions nécessaires de manière à ce que les provisions et les charges liées à la liquidation

soient apurées.

- L'assemblée décide que les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans au domicile du liquidateur.
- L'assemblée prononce la clôture finale de la liquidation de la société anonyme INTERNATIONAL ALLIED SERVICES

S.A. qui cessera d'exister avec effet au 31 décembre 2010.

Fait à Wiltz, le 7 février 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011040631/22.
(110043877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Casuarina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 139.961.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011046901/10.
(110037326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

41280


Document Outline

Amber Holding S.A.

Ardea S.A.

Ardennes Invest Lux Sàrl

Azimuth International S.à r.l.

Azimuth International S.à r.l.

Baddon S.A.

Bellune Invest S.A.

Bio-Tech International S.A.

Biron S.à r.l.

Braveza Investments

Britanica Asset Management SA

Casuarina S.A.

Cergrafhold S.A.

C.I.D., Céramique Internationale Développement

Dialna S.A.

Dialna S.A., SPF

FIAL International S.A.

FM Racing S.A.

G &amp; P Properties S.à r.l.

Grus Investments S.à r.l.

International Allied Services S.A.

Internaxx Bank S.A.

JALUX

Lieber Racing Team S.à r.l.

M-F LUX S.A.

Mouton S.A., SPF

NEIF S.C.A.

Norpa Holding S.A.

Ophrys Holding S.A.

Rémy Cointreau Luxembourg S.A.

Safcon Air S.A.

Saran S.A., SPF

Service VIP Lux Sàrl

SHRM Financial Services (HK) Limited, Luxembourg Branch

SHRM Financial Services (HK) Limited, Luxembourg Branch

Société d'Etude et de Recherche Appliquée en Cancérologie (SERAC) S.A.

Sparinvest

Triangle S.A.

Ultimo Holding

West Investment Holding S.A.

Wireless M2M Subco S.à r.l.

Xenia Trade S.A.