This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 824
27 avril 2011
SOMMAIRE
2F Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39525
AB Events S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39536
Access Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39536
A.C. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39525
A.C. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39525
AIYA International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
39537
AIYA International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
39536
Aloha Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39536
Altraplan Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
39537
AMP Capital Investors (CIF European In-
frastructure No. 1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
39537
AMP Capital Investors (European Infra-
structure No. 3) S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
39545
AMP Capital Investors (FDF European In-
frastructure No. 1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
39545
Aprilis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39546
Aprilis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39546
ARE Hamburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39546
ATM Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39546
Badajoz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39550
Barclays Euro Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39552
Barclays European Infrastructure Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39547
Baren Entreprises S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39506
BENESHARE TRANSPORT GROUP (Lu-
xembourg) S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39550
Bioparticipations Développements S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39516
Birdsview Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39547
Bressaglia Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . .
39550
Build Germany 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39550
Car Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39516
Compagnie de Services et Gestion Indus-
triels S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39516
Copefi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39516
C.S.A.M. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39516
Egest Finance S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39524
EGEST Invest & Cie S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . .
39524
Espace "J" S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39524
Euro-Lux Construction S.à r.l. . . . . . . . . . . .
39525
Giroinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39551
GKS Prop Co. B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39506
Hydrofluide Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
39551
Hydrofluide Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . .
39551
LCB Invest Co. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39526
LGIG 2 Property C7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
39506
Needit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39537
Octinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39551
Primopiso Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
39517
Stratacache Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39547
Turkey SH II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39552
39505
L
U X E M B O U R G
LGIG 2 Property C7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 153.848.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 février 2011.i>
1) La liquidation de la société LGIG 2 Property C7 Sàrl (en liquidation) est définitivement close, la société est défini-
tivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés.
2) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux au 41, avenue de la Liberté L-1931
Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011036542/16.
(110038024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
Baren Entreprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 88.419.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011036695/10.
(110040239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
GKS Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 158.458.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of December,
before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney dated 28 December 2010.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered Office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "GKS Prop Co. B S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
39506
L
U X E M B O U R G
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1,-) each, all subscribed and fully paid-
up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing
three-quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
39507
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Board of managers.
If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board
are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
39508
L
U X E M B O U R G
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement
such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners
S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel
investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping
Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further
parties and such consent shall be documented in writing:
(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company’s ownership) acquisition of shopping centres.
(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company’s ownership) disposal of shopping centres.
(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion
of the Company’s ownership) real estate financings.
(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the
proportion of the Company’s ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
39509
L
U X E M B O U R G
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1,-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500,-).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at 19,
rue des Lilas, L-8035 Strassen;
b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and
c. Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is established at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
39510
L
U X E M B O U R G
Deutsche Uebersetzung des vorstehenden Textes
Am achtundzwanzigsten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendzehn,
ist vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxem-
burg,
Erschienen:
Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, Avenue Charles
de Gaulle. L-1653 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg,
aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 28. Dezember 2010 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „GKS Prop Co. B S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft
kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an inoder ausländischen Gesellschaften oder Unter-
nehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte
Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatzund andere Risiken abzusichern.
39511
L
U X E M B O U R G
3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-); die Gesellschafts-
anteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen der Gesetzbuches gegenüber Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
39512
L
U X E M B O U R G
(v) Der Rat ist nur tagungs-und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des
Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden. Die
Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn
kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeich-
net werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon-oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommuni-
kationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.
Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der
Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt
hat.
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von Hälfte des den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
39513
L
U X E M B O U R G
(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-
plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:
(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.
(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.
(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.
(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn-und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
39514
L
U X E M B O U R G
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-
beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon-oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet zwölftausendfünfhundert
(12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser
Geschäftsanteile in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) betragen.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Alleingesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeich-
neten Geschäftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Ulrich Binninger, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland,
geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen;
b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg; und
c. Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Stadler-Tjan, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert le 29 décembre 2010. Relation: RED/2010/2126. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
39515
L
U X E M B O U R G
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Rambrouch, den 26. Januar 2011.
Référence de publication: 2011015676/525.
(110018248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Bioparticipations Développements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 111.605.
Le bilan au 31 décembre 2010, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011036696/11.
(110040119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
C.S.A.M. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9639 Boulaide, 12, Cité an Elber.
R.C.S. Luxembourg B 111.339.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011036697/10.
(110040283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
Car Line S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 73.938.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011036699/10.
(110040238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
Compagnie de Services et Gestion Industriels S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 146.114.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen.
Signature.
Référence de publication: 2011036701/10.
(110040101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
Copefi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3590 Dudelange, 59, place de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 52.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011036702/10.
(110039997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
39516
L
U X E M B O U R G
Primopiso Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.942.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) J.P. Morgan Private Equity Limited, a company incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its
registered office at Arnold House, St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GYI 3NF, registered at the Companies
Register of Guernsey under number 43107,
here represented by Ms. Samiel OUHIBI, private employee, residing professionally at 412F, route d'Esch L-1030 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given in New York (USA) on 18 January 2011.
2) J. P. MORGAN SPECIALIST FUNDS, a SICAV-SIF (Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg and being registered with the Luxembourg trade register under number B.
151450, acting on behalf of its sub-fund J. P. MORGAN SPECIALIST FUNDS - J. P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES
FUND,
here represented by Ms. Samiel OUHIBI, prenamed, by virtue of a proxy given in New York (USA) on 18 January 2011.
The said proxies, after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders have requested the undersigned notary to document that the Shareholders are the shareholders of
the "société à responsabilité limitée" established in Luxembourg under the name of Primopiso Acquisition S.à r.l., with
registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 157942 and incorporated following a deed of Me Paul
DECKER, notary residing in Luxembourg, on December 13, 2010, not yet published in the Mémorial C (the "Company")
and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on today's date.
The Shareholders, represented as above mentioned, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the corporate capital by an amount of eight hundred twenty thousand five hundred thirty euro (EUR
820,530.-) so as to raise it from its present amount of one million eight hundred ninety eight thousand four hundred sixty
euro (EUR 1,898,460.-) to the amount of two million seven hundred eighteen thousand nine hundred ninety euro (EUR
2,718,990.-) by the creation and the issue of fifty four thousand six hundred eighty six (54,686) Class A Shares, fifty four
thousand six hundred eighty six (54,686) Class B Shares, fifty four thousand six hundred eighty six (54,686) Class C Shares,
fifty four thousand six hundred eighty six (54,686) Class D Shares, fifty four thousand six hundred eighty six (54,686)
Class E Shares, five hundred forty six thousand nine hundred fifty (546,950) Class F Shares, seventy five (75) Class G
Shares and seventy five (75) Class H Shares, to be fully paid up.
2. To subscribe and to accept the subscriptions of the newly issued shares.
3. To amend article 8, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company as a consequence of the increase
of the corporate capital of the Company.
4. To amend the articles of incorporation of the Company to provide for the possibility to have class A and class B
managers.
5. Acceptation of the resignations of Mr. Jean-Claude Buffin and Mr. Michel Lenoir as managers of the Company and
the appointments of Mr. Flavio Marzona and Mr. Dimitri Holderbach as class A managers for an indefinite period and Mr.
Michael Tose as a Class B manager for an indefinite period.
6. To approve new potential shareholders of the Company.
7. Miscellaneous.
The Shareholders have requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred twenty
thousand five hundred thirty euro (EUR 820,530.-) so as to raise it from its present amount of one million eight hundred
ninety eight thousand four hundred sixty euro (EUR 1,898,460.-) to the amount of two million seven hundred eighteen
thousand nine hundred ninety euro (EUR 2,718,990.-) by the creation and the issue of fifty four thousand six hundred
eighty six (54,686) Class A Shares, fifty four thousand six hundred eighty six (54,686) Class B Shares, fifty four thousand
six hundred eighty six (54,686) Class C Shares, fifty four thousand six hundred eighty six (54,686) Class D Shares, fifty
39517
L
U X E M B O U R G
four thousand six hundred eighty six (54,686) Class E Shares, five hundred forty six thousand nine hundred fifty (546,950)
Class F Shares, seventy five (75) Class G Shares and seventy five (75) Class H Shares.
<i>Subscription - Paymenti>
a) J.P. Morgan Private Equity Limited, prenamed, declared to subscribe for the following shares, with a nominal value
of one euro (EUR 1.-) each, and to make payment in full by a contribution in cash of an amount of one hundred ninety
four thousand two hundred thirty five euro (EUR 194,235.-) allocated to the Company's share capital, together with a
share premium of five hundred eighty two thousand one hundred sixty five euro (EUR 582,165.-):
Class of shares
Number
of shares
Share capital
(EUR)
Share
premium
(EUR)
Class A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,937
12,937.-
116,433.-
Class B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,937
12,937.-
116,433.-
Class C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,937
12,937.-
116,433.-
Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,937
12,937.-
116,433.-
Class E Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,937
12,937.-
116,433.-
Class F Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129,400
129,400.-
/
Class G Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75.-
/
Class H Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75.-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194,235.-
582,165.-
b) Thereupon has appeared PARISH CAPITAL EUROPE II LP, a limited partnership established and existing under the
laws of Scotland, having its registered office at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ and being
registered under number 6895;
represented by Ms. Samiel OUHIBI, prenamed, by virtue of a proxy given in USA on 18 January 2011, which, after
being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed
for the purpose of registration.
The person appearing declared to subscribe for the following shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
and to make payment in full by a contribution in cash of an amount of three hundred eighty nine thousand eighty five euro
(EUR 389,085.-) allocated to the Company's share capital, together with a share premium of one million one hundred
sixty seven thousand one hundred sixty five euro (EUR 1,167,165.-):
Type of Shares
Number
of shares
Share capital
(EUR)
Share
premium
(EUR)
Class A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,937
25,937.-
233,433.-
Class B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,937
25,937.-
233,433.-
Class C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,937
25,937.-
233,433.-
Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,937
25,937.-
233,433.-
Class E Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,937
25,937.-
233,433.-
Class F Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259,400
259,400.-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389,085.- 1,167,165.-
c) Thereupon has appeared MADSEN NOMINEES LIMITED, a limited company incorporated and existing under the
laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Geneva Place, 2
nd
Floor, #333 Waterfront Drive, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands and being registered under number 1467777;
represented by Ms. Samiel OUHIBI, prenamed, by virtue of a proxy given in Geneva (Switzerland) on 18 January 2011,
which, after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The person appearing declared to subscribe for the following shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
and to make payment in full by a contribution in cash of an amount of one hundred forty thousand six hundred twenty
five euro (EUR 140,625.-) allocated to the Company's share capital, together with a share premium of four hundred
twenty one thousand eight hundred seventy five euro (EUR 421,875.-):
Type of Shares
Number
of shares
Share capital
(EUR)
Share
premium
(EUR)
Class A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,375
9,375.-
84,375.-
Class B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,375
9,375.-
84,375.-
Class C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,375
9,375.-
84,375.-
Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,375
9,375.-
84,375.-
39518
L
U X E M B O U R G
Class E Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,375
9,375.-
84,375.-
Class F Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93,750
93,750.-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140,625.-
421,875.-
d) Thereupon has appeared BOVAL SERVICES S.A., a corporation incorporated and existing under the laws of Panama,
having its registered office at Via General Nicamor A. De Obarrio, 50
th
Street, Bancomer Plaza, 4
th
Floor, Panama and
being registered under Filing Card 324890, Roll 52545, Image 0019 of the Mercantile Sections of the Public Registry Office
of the Republic of Panama;
represented by Ms. Samiel OUHIBI, prenamed, by virtue of a proxy given in Zurich (Switzerland) on 18 January 2011,
which, after being initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
The person appearing declared to subscribe for the following shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
and to make payment in full by a contribution in cash of an amount of ninety-six thousand five hundred eighty five euro
(EUR 96,585.-) allocated to the Company's share capital, together with a share premium of two hundred eight nine
thousand six hundred sixty five euro (EUR 289,665.-):
Type of Shares
Number
of shares
Share capital
(EUR)
Share
premium
(EUR)
Class A Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,437
6,437.-
57,933.-
Class B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,437
6,437.-
57,933.-
Class C Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,437
6,437.-
57,933.-
Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,437
6,437.-
57,933.-
Class E Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,437
6,437.-
57,933.-
Class F Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,400
64,400.-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96,585.-
289,665.-
The amount of three million two hundred eighty one thousand four hundred euro (EUR 3,281,400.-) is at the free
disposal of the Company and proof was given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders unanimously resolved to amend article 8, paragraph
1, of the articles of incorporation of the Company. Such paragraph shall henceforth read as follows:
" Art. 8. The share capital of the Company is set at two million seven hundred eighteen thousand nine hundred ninety
euro (EUR 2,718,990.-), represented by one hundred eighty one thousand two hundred forty eight (181,248) Class A
Shares, one hundred eighty one thousand two hundred forty eight (181,248) Class B Shares, one hundred eighty one
thousand two hundred forty eight (181,248) Class C Shares, one hundred eighty one thousand two hundred forty eight
(181,248) Class D Shares, one hundred eighty one thousand two hundred forty eight (181,248) Class E Shares, one million
eight hundred twelve thousand six hundred (1,812,600) Class F Shares, seventy five (75) Class G Shares and seventy five
(75) Class H Shares, each with a nominal value of one euro (EUR 1.-)."
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend articles 12 and 13 of the articles of incorporation of the Company as follows, to
provide for the possibility to have class A and class B managers:
1. to include the following sentence at the end of article 12 of the articles of incorporation of the Company:
"In case there are several managers, these shall be either of Class A or Class B."
2. to include the following sentence at the end of paragraph (v) of article 13.2 of the articles of incorporation of the
Company:
"Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting, including the
vote of at least one Class A manager and one Class B manager."
3. to replace the first paragraph of article 13.3 of the articles of incorporation of the Company by the following new
wording:
"The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any one Class A manager
and any one Class B manager or by the joint or single signatures of any persons to whom signatory power has been validly
delegated in accordance with articles 13.1. (ii) or 13.3 (ii) of these Articles."
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolved to accept the resignations of Mr. Jean-Claude Buffin and Mr. Michel Lenoir as managers of
the Company with immediate effect.
The Shareholders resolved to appoint the following persons as class A managers of the Company for an indefinite
period:
39519
L
U X E M B O U R G
- Mr. Flavio MARZONA, born in Luxembourg, on 9 August 1971, with professional address at 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, and
- Mr. Dimitri HOLDERBACH, born in Woippy (France) , on 29 October 1973, with professional address at 4l2F, route
d'Esch, L-1030 Luxembourg.
The Shareholders resolved to appoint the following person as a class B manager of the Company for an indefinite
period:
- Mr. Michael TOSE, born on December 27
th
, 1972 in Johannesburg (Republic of South Africa), residing at 36, St Elmo
Road, London W12 9DX, United Kingdom.
<i>Fifth resolutioni>
In accordance with article 189 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
the following persons/entities are approved as potential new shareholders of the Company:
- CPL INVESTMENTS GUERNSEY L.P., a limited partnership (registered number 1388) acting by its general partner,
CPL GP Limited, incorporated and existing under the laws of Guernsey, having its registered office at Carinthia House,
9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF;
- Mr. AHMED HAMDANI, with address at 1 Zetland House, Marloes Road, London W8 5LB, United Kingdom;
- Mr. JOSE-MIGUEL ORTI, with address at Chemin de Gilly, 50, 1212 Grand-Lancy, Switzerland;
- RBC Trustees (CI) Limited, with address at La Motte Chambers, St. Helier, Jersey JE1 1PB, as trustee of the Vitol
Employee Benefit Trust;
- CPL GUERNSEY LIMITED, a limited liability company incorporated in Guernsey, having its registered office at Ca-
rinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF under registered number 52165.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at three thousand two hundred euro (EUR 3,200.-).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the notary by her
surname, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt et un janvier.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
1) J.P. Morgan Private Equity Limited, une société constituée et existant sous les lois de Guernesey, ayant son siège
social à Arnold House, St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernesey GYI 3NF, immatriculée auprès du Registre des
Sociétés de Guernesey sous le numéro 43107,
ici représentée par Mademoiselle Samiel OUHIBI, employée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York (USA) le 18 janvier 2011.
2) J. P. MORGAN SPECIALIST FUNDS, une SICAV-SIF (Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé) de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.151450,
agissant au nom de son compartiment J. P. MORGAN SPECIALIST FUNDS - J. P. MORGAN SPECIAL OPPORTUNITIES
FUND,
ici représentée par Mademoiselle Samiel OUHIBI, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée à New York (USA)
le 18 janvier 2011.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont les associés de la société à responsabilité
limitée établie au Luxembourg sous le nom de Primopiso Acquisition S.à r.l., ayant son siège social au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 157942 et constituée suivant acte par le notaire instrumentant en date du 13 décembre 2010, non encore
publié au Mémorial C (la "Société").
Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissent être parfaitement au courant des décisions à inter-
venir sur base de l'ordre du jour suivant:
39520
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de huit cent vingt mille cinq cent trente euros (EUR 820.530,-)
pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante euros (EUR
1.898.460,-) à un montant de deux millions sept cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 2.718.990,-)
par la création et l'émission de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie A,
de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie B, de cinquante-quatre mille six
cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie C, de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686)
Parts Sociales de Catégorie D, de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie E,
de cinq cent quarante-six mille neuf cent cinquante (546.950) Parts Sociales de Catégorie F, de soixante-quinze (75) Parts
Sociales de Catégorie G et de soixante-quinze (75) Parts Sociales de Catégorie H, à libérer intégralement.
2. Souscrire et accepter les souscriptions des nouvelles actions émises.
3. Modifier l'article 8, alinéa 1, des statuts en conséquence de l'augmentation du capital social de la Société.
4. Modifier les statuts de la Société pour prévoir la possibilité d'avoir des gérants de catégorie A et de catégorie B.
5. Acceptation de la résignation de M. Jean-Claude Buffin et de M. Michel Lenoir en tant que gérants de la Société et
nomination de M. Flavio Marzona et M. Dimitri Holderbach en tant que gérants de catégorie A pour une durée indéter-
minée et de M. Michael Tose en tant que gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
6. Approuver de nouveaux associés potentiels de la Société.
7. Divers.
Les associés ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de huit cent vingt mille
cinq cent trente euros (EUR 820.530,-) pour le porter de son montant actuel d'un million huit cent quatre-vingt-dix-huit
mille quatre cent soixante euros (EUR 1.898.460,-) à un montant de deux millions sept cent dix-huit mille neuf cent quatre-
vingt-dix euros (EUR 2.718.990,-) par la création et l'émission de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686)
Parts Sociales de Catégorie A, de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie B,
de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie C, de cinquante-quatre mille six
cent quatre-vingt-six (54.686) Parts Sociales de Catégorie D, de cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-six (54.686)
Parts Sociales de Catégorie E, de cinq cent quarante-six mille neuf cent cinquante (546.950) Parts Sociales de Catégorie
F, de soixante-quinze (75) Parts Sociales de Catégorie G et de soixante-quinze (75) Parts Sociales de Catégorie H.
<i>Souscription - Paiementi>
a) J.P. Morgan Private Equity Limited, prénommé, a déclaré souscrire pour les actions suivantes, d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1.-) chacune, et de payer l'intégralité par un apport en numéraire d'un montant de cent quatre-vingt-
quatorze mille deux cent trente-cinq euros (EUR 194.235,-) alloué au capital social de la Société, ensemble avec une prime
d'émission de cinq cent quatre-vingt-deux mille cent soixante-cinq euros (EUR 582.165,-):
Catégorie de parts sociales
Nombre
de parts
sociales
Capital social
(EUR)
Prime
d'émission
(EUR)
Parts Sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.937
12.937,-
116.433,-
Parts Sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.937
12.937,-
116.433,-
Parts Sociales de Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.937
12.937,-
116.433,-
Parts Sociales de Catégorie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.937
12.937,-
116.433,-
Parts Sociales de Catégorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.937
12.937,-
116.433,-
Parts Sociales de Catégorie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129.400
129.400,-
/
Parts Sociales de Catégorie G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75,-
/
Parts Sociales de Catégorie H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75,-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194.235,-
582.165,-
b) Ensuite s'est présenté PARISH CAPITAL EUROPE II LP, une société de droit écossais, avec siège social au 50, Lothian
Road, Festival Square, Edinburgh, Ecosse, EH3 9WJ et immatriculée sous le numéro 6895;
représentée par Mademoiselle Samiel OUHIBI, préqualifiée, employée, demeurant professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-1030 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux USA le 18 janvier 2011, laquelle, après avoir été
paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes
pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant a déclaré souscrire les parts sociales suivantes, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, et
de payer l'intégralité par un apport en numéraire d'un montant de trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre-vingt-cinq
euros (EUR 389.085,-) alloué au capital social de la Société, ensemble avec une prime d'émission d'un million cent soixante-
sept mille cent soixante-cinq euros (EUR 1.167.165,-):
39521
L
U X E M B O U R G
Type de parts sociales
Nombre
de parts
sociales
Capital social
(EUR)
Prime
d'émission
(EUR)
Parts Sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.937
25.937,-
233.433,-
Parts Sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.937
25.937,-
233.433,-
Parts Sociales de Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.937
25.937,-
233.433,-
Parts Sociales de Catégorie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.937
25.937,-
233.433,-
Parts Sociales de Catégorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.937
25.937,-
233.433,-
Parts Sociales de Catégorie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259.400
259.400,-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389.085,- 1.167.165,-
c) Ensuite s'est présenté MADSEN NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège
social à Geneva Place, 2
nd
Floor, #333 Waterfront Drive, Road Town, Tortoal, Iles Vierges Britanniques et immatriculée
sous le numéro 1467777;
représentée par Mademoiselle Samiel OUHIBI, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée à Genève (Suisse) le
18 janvier 2011, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant a déclaré souscrire les parts sociales suivantes, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, et
de payer l'intégralité par un apport en numéraire d'un montant de cent quarante mille six cent vingt-cinq euros (EUR
140.625,-) alloué au capital social de la Société, ensemble avec une prime d'émission de quatre cent vingt et un mille huit
cent soixante-quinze euros (EUR 421.875,-):
Type de parts sociales
Nombre
de parts
sociales
Capital social
(EUR)
Prime
d'émission
(EUR)
Parts Sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.375
9.375,-
84.375,-
Parts Sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.375
9.375,-
84.375,-
Parts Sociales de Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.375
9.375,-
84.375,-
Parts Sociales de Catégorie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.375
9.375,-
84.375,-
Parts Sociales de Catégorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.375
9.375,-
84.375,-
Parts Sociales de Catégorie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.750
93.750,-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140.625,-
421.875,-
d) Ensuite s'est présenté BOVAL SERVICES S.A., une société de droit panaméen, avec siège social à Via General
Nicamor A. De Obarrio, 50
th
Street, Bancomer Plaza, 4
th
Floor, Panama et immatriculée sous le Filing Card 324890,
Roll 52545, Image 0019 du Mercantile Sections du Public Registry Office of the Republic of Panama;
représentée par Mademoiselle Samiel OUHIBI, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée à Zurich (Suisse) le
18 janvier 2011, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Le comparant a déclaré souscrire les parts sociales suivantes, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune, et
de payer l'intégralité par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-cinq
euros (EUR 96.585,-) alloué au capital social de la Société, ensemble avec une prime d'émission de deux cent quatre-
vingt-neuf mille six cent soixante-cinq euros (EUR 289.665,-):
Type de parts sociales
Nombre
de parts
sociales
Capital social
(EUR)
Prime
d'émission
(EUR)
Parts Sociales de Catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.437
6.437,-
57.933,-
Parts Sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.437
6.437,-
57.933,-
Parts Sociales de Catégorie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.437
6.437,-
57.933,-
Parts Sociales de Catégorie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.437
6.437,-
57.933,-
Parts Sociales de Catégorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.437
6.437,-
57.933,-
Parts Sociales de Catégorie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.400
64.400,-
/
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.585,-
289.665,-
La somme de trois millions deux cent quatre-vingt-un mille quatre cents euros (EUR 3.281.400,-) se trouve à la libre
disposition de la Société tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le confirme expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, les Associés ont unanimement décidé de modifier l'article 8, alinéa 1,
des statuts de la Société. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
39522
L
U X E M B O U R G
" Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à deux millions sept cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros
(EUR 2.718.990,-), actuellement représenté par cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-huit (181.248) Parts So-
ciales de Catégorie A, cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-huit (181.248) Parts Sociales de Catégorie B, cent
quatre-vingt-un mille deux cent quarante-huit (181.248) Parts Sociales de Catégorie C, cent quatre-vingt-un mille deux
cent quarante-huit (181.248) Parts Sociales de Catégorie D, cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-huit (181.248)
Parts Sociales de Catégorie E, un million huit cent douze mille six cents (1.812.600) Parts Sociales de Catégorie F, soixante-
quinze (75) Parts Sociales de Catégorie G et soixante-quinze (75) Parts Sociales de Catégorie H, chacune d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1,-)."
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier les articles 12 et 13 des statuts de la Société comme suit, afin de prévoir la
possibilité d'avoir des gérants de catégorie A et de catégorie B:
1. inclure la phrase suivante à la fin de l'article 12 des statuts de la Société:
"Au cas où il y a plusieurs gérants, ils seront soit de Catégorie A soit de Catégorie B."
2. inclure la phrase suivante à la fin du paragraphe (v) de l'article 13.2 des statuts de la Société:
"Les décisions sont prises par une majorité des votes des gérants présents ou représentés à la réunion, en ce compris
le vote d'au moins un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B."
3. remplacer le premier paragraphe de l'article 13.3 des statuts de la Société par le nouveau texte suivant:
"La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie
A et d'un gérant de Catégorie B ou par les signatures conjointes ou individuelles de toutes personnes à qui pouvoir de
signature a été valablement délégué conformément aux articles 13.1 (ii) ou 13.3 (ii) de ces Statuts."
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés ont décidé d'accepter les démissions de M. Jean-Claude Buffin et de M. Michel Lenoir en tant que gérants
de la Société avec effet immédiat.
Les Associés ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une
durée indéterminée:
- M. Flavio MARZONA, né à Luxembourg le 9 août 1971, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, et
- M. Dimitri HOLDERBACH, né à Woippy (France) le 29 octobre 1973, demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
Les Associés ont décidé de nommer la personne suivante en tant que gérant de catégorie B de la Société pour une
durée indéterminée:
- M. Michael TOSE, né le 27 décembre 1972 à Johannesburg (République d'Afrique du Sud), résidant au 36, St Elmo
Road, Londres W12 9DX, Royaume-Uni.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément à l'article 189 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, les personnes/entités suivantes sont approuvées en tant que nouveaux associés potentiels de la Société:
- CPL INVESTMENTS GUERNSEY L.P., une société (numéro de registre 1388) agissant par son associé commandité,
CPL GP Limited, de droit de l'Etat de Guernesey, avec siège social à Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port,
Guernesey GY1 4BF;
- M. AHMED HAMDANI, avec adresse au 1, Zetland House, Marloes Road, Londres W8 5LB, Royaume-Uni;
- M. JOSE-MIGUEL ORTI, avec adresse à Chemin de Gilly, 50, 1212 Grand-Lancy, Suisse;
- RBC Trustees (CI) Limited, avec adresse à La Motte Chambers, St. Helier, Jersey JE1 1BP, en tant que trustee de
Vitol Employee Benefit Trust;
- CPL GUERNSEY LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat de Guernesey, avec siège social à
Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernesey GY1 4BF sous le numéro d'immatriculation 52165.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trois mille deux cents euros (EUR 3.200,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
39523
L
U X E M B O U R G
Signé: S. OUHIBI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 janvier 2011. LAC/2011/3987. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2011.
Référence de publication: 2011016545/393.
(110019553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2011.
Egest Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.
R.C.S. Luxembourg B 57.942.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société en
commandite par actions EGEST FINANCE S.C.A., ayant eu son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Michel Sinner
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011036707/16.
(110039977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
EGEST Invest & Cie S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 58.891.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société en
commandite simple EGEST INVEST ET Cie S.e.c.s., ayant eu son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Michel Sinner
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011036708/17.
(110039970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
Espace "J" S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9530 Wiltz, 5, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 107.147.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011036709/10.
(110040244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
39524
L
U X E M B O U R G
Euro-Lux Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 59.009.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 25 février 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à
responsabilité limitée EURO-LUX CONSTRUCTION S.à.r.l., ayant eu son siège social à L-1260 Luxembourg, 82, rue de
Bonnevoie, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Michel Sinner
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011036710/16.
(110039980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
2F Finance S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 85.545.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de:
- la société anonyme 2F FINANCE S.A., dont le siège social établi à Luxembourg, 6-12, Place d'Armes, a été dénoncé
en date du 19 décembre 2006, B 085545.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2010.
Pour extrait conforme
Me Asel Courmontagne
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2011036764/16.
(110040126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2011.
A.C. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2410 Strassen, 113, rue de Reckenthal.
R.C.S. Luxembourg B 80.979.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
Jean-Marie DUVIVIER
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2011036765/12.
(110040972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
A.C. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2410 Strassen, 113, rue de Reckenthal.
R.C.S. Luxembourg B 80.979.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
Jean-Marie DUVIVIER
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2011036766/12.
(110040973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
39525
L
U X E M B O U R G
LCB Invest Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 158.459.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of December,
before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney dated 30 December 2010;
2. ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney dated 30 December 2010;
3. ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 14, rue Erasme, L-2082 Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney dated 30 December 2010.
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "LCB Invest Co. S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may further acquire, develop, manage and/or sell directly or indirectly real estate assets in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad.
39526
L
U X E M B O U R G
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-), represented by one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) shares in registered form, having a par value of one eurocent (EUR 0.01,-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing
three-quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the shareholders,
which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board
are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded
39527
L
U X E M B O U R G
in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or
represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at least two managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law and that the manager has acted in good faith.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
10.3. Subject-Matters of Resolutions
(i) The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.
(ii) The shareholders shall resolve on the following subject matters whereas the legitimation of the Board to implement
such resolutions shall in addition require (1) the approval of the investment committee of the ECE Real Estate Partners
S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous decision of all parties to any parallel
investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF A, ECE European Prime Shopping
Centre SCS SICAF SIF B and ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF C and, as the case may be, further
parties and such consent shall be documented in writing:
(a) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres.
(b) Any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent
from the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres.
39528
L
U X E M B O U R G
(c) Any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion
of the Company's ownership) real estate financings.
(d) Any decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the
proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.
Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
15.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
39529
L
U X E M B O U R G
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for four hundred ninety-two thousand seven hundred eighty (492,780) shares in registered form, with a par
value of one eurocent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of four
thousand nine hundred twenty seven euro and eighty eurocents (EUR 4,927.80).
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for five hundred sixty thousand one hundred ten (560,110) shares in registered form, with a par value of one
eurocent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of five thousand six
hundred one euro and ten eurocents (EUR 5,601.10).
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to
subscribe for one hundred ninety-seven thousand one hundred ten (197,110) shares in registered form, with a par value
of one eurocent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of one thousand
nine hundred seventy-one euro and 10 eurocents (EUR 1,971.10).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a. Richard Neal Basire Goddard, Director, born on December 5, 1959 in Fareham, Great Britain, with professional
address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Director, born on November 16, 1958 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg; and
c. Jose Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, upon request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am dreißigsten Tag des Monats Dezember, im Jahre zweitausendzehn,
sind vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ERSCHIENEN:
Die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg,
aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 30. Dezember 2010 erteilt wurde;
39530
L
U X E M B O U R G
die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg,
aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 30. Dezember 2010 erteilt wurde;
die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxemburg, noch nicht eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister,
hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg,
aufgrund der Rechtsanwaltsvollmacht welche am 30. Dezember 2010 erteilt wurde.
Besagte Vollmachten, welche vom Stellvertreter der erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar unter-
zeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzurei-
chen.
Die erschienenen Parteien, vertreten wir oben dargestellt, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen.
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „LCB Invest Co. S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner
derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft
kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt
werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass
außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass
diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Ver-
bindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende
Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung und/oder der direkte oder indirekte
Verkauf von Immobilienvermögen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
39531
L
U X E M B O U R G
3.5. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Geschäftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), bestehend aus eine
Million zwei hundert fünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR
0,01); die Gesellschaftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch
einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen
keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer ernannt, so bilden diese den Ge-
schäftsführungsrat (der Rat).
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
39532
L
U X E M B O U R G
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse
des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden.
Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder,
wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern un-
terzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.
(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.
Art. 9. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Ver-
bindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäfts-
führer in gutem Glauben gehandelt hat.
IV. Gesellschafter
Art. 10. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Groβherzogtum Luxemburg abgehalten werden.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäβ einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
10.3. Gegenstände von Beschlüssen
(i) Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.
39533
L
U X E M B O U R G
(ii) Die Gesellschafter sollen über die folgenden Gegenstände entscheiden, wobei die Legitimation des Rates zur Im-
plementierung solcher Beschlüsse zudem von (1) der Genehmigung des Investment Komitees der ECE Real Estate
Partners S.à r.l., und eine solche Genehmigung soll schriftlich festgehalten werden und (2) der einstimmigen Entscheidung
aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen dem ECE European Prime Shopping Centre SCS
SICAF SIF A, dem ECE European Prime Shopping Centre SCS SICAF SIF B und dem ECE European Prime Shopping Centre
SCS SICAF SIF C und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung soll schriftlich festgehalten werden,
abhängt:
(a) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren.
(b) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren.
(c) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung.
(d) Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine
Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.
Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 13. Gewinnausschüttung.
13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten
ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
39534
L
U X E M B O U R G
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-
beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. A S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet vier hundert zweiund-
neunzig tausend sieben hundert achtzig (492.780) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR
0,01) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von vier tausend neunhundertsiebenund-
zwanzig Euro und achtzig Eurocent (EUR 4.927,80).
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet fünf hundert sechzig-
tausend ein hundert zehn (560.110) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) und erklärt
die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von fünf tausend sechshundertein Euro und zehn Eurocent
(EUR 5.601,10).
ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet ein hundert sieben-
undneunzigtausend ein hundert zehn (197.110) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01)
und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Geschäftsanteile in Höhe von ein tausend neunhundert einundsiebzig Euro
und zehn Eurocent (EUR 1.971,10).
Die Geschäftsanteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichneten Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) betragen.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, haben die Gesellschafter, welche die Gesamtheit der gezeichneten
Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
a. Richard Neal Basire Goddard, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 5. Dezember 1959 in Fareham, Großbritanien,
geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
b. Dr. Yves Marie Edmée Wagner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 16. November 1958 in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg; und
c. Jose Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in 2-8,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen
39535
L
U X E M B O U R G
Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichneten
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Stadler-Tjan, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 5 janvier 2011. Relation: RED/2011/25. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.
Rambrouch, den 26. Januar 2011.
Référence de publication: 2011015732/561.
(110018250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Aloha Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 125.573.
Les comptes annuels au 31/12/09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/03/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011036768/10.
(110040966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
AB Events S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 104, rue du Grunewald.
R.C.S. Luxembourg B 82.905.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour AB EVENTS S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2011036769/12.
(110040532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Access Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.876.
<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 11 mars 2011i>
DELOITTE S.A. est réélu en qualité de réviseur d’entreprises pour un nouveau mandat d’un an expirant à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2012.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour ACCESS FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2011036771/13.
(110040843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
AIYA International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 128.232.
Les administrateurs, Mmes Sonja Bemtgen, Virginie Derains et Stéphanie Bouju, et le commissaire aux comptes, Pici-
giemme S.à r.l., ont démissionné de leur mandat respectif avec effet immédiat le 11 mars 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
39536
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Référence de publication: 2011036773/12.
(110040638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
AIYA International S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 128.232.
Profida Luxembourg S.A., agissant en sa qualité de domiciliataire de la société Aiya International S.A., dénonce par la
présente le siège social de la société Aiya International S.A., numéro RCS Luxembourg B 128232 avec siège social au 31,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Référence de publication: 2011036774/11.
(110040837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Altraplan Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 55.381.
<i>Dépôt Rectificatif pour les comptes annuels au 31 décembre 2009, déposés le 28 juin 2010 sous la référence L100091212i>
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 10 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 476 du 24 septembre
1996.
Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALTRAPLAN LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2011036775/16.
(110040947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 100.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.773.
EXTRAIT
En date du 8 mars 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine Van Oort, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet immédiat.
- Wim Rits, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et
ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 mars 2010.
Référence de publication: 2011036776/14.
(110041188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Needit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 158.483.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fourth of January.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
39537
L
U X E M B O U R G
THERE APPEARED:
1) Mrs Natalie Van De Vorstenbosch-Richardson, Director, with professional address at Biezenlaan 34, NL 5708ZO
Helmond, Nederland born in Cologne (Deutschland), on April 15
th
, 1975;
2) Mr Johannes Van De Vorstenbosch, Director, with professional address at Mantelstraat 7, 3700 Tongeren, Belgium,
born in Leeuwarden (Nederland), on July 25
th
, 1958.
Being represented by Mrs Odette Alves, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given
under private seal, which, initialled "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with it.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated August
10
th
, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter
the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. Corporate object. The Company has for object the import, the export, the purchase and sale, in wholesale and
in detail, of textile products as well as all other articles of the textile branch.
The Company can make any commercial, industrial, real estate, movable and financial transactions, which could relate
directly or indirectly to the activities above or susceptible to facilitate the fulfillment of those activities.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "NEEDIT S.à r.l.".
Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole
director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).
5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by
12,500 (twelve thousand five hundred) shares (parts sociales) of EUR 1 (one euro) each, all fully subscribed and entirely
paid up.
6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him
and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 -Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’
meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance
with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-
quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
39538
L
U X E M B O U R G
6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the
Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the
provisions of Article 1690 of the Civil Code.
6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in
accordance with Article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants)
have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not
to be shareholder(s).
7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution
adopted by the shareholders.
7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be
compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of
directors (gérants).
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors
(conseil de gérance).
7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors
(gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.
7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors
(gérants), by the sole signature of any member of the board of directors (conseil de gérance).
7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
7.3.4 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of his agency.
7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by
the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.
7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed
by the chairman, by the secretary or by any director (gérant).
7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).
7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors
(gérants) present or represented at such meeting.
7.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions
passed at the directors’ (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
7.4.7 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by
telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.
7.5 - Liability of Directors (gérants)
Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him in the name of the Company.
39539
L
U X E M B O U R G
Art. 8. General shareholders’ meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.
8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous
vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share
capital, subject to the provisions of the Law.
8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not
exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held,
in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the last Tuesday of May, at 4 P.M..
9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circums-
tances so require.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be
supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 – Fiscal Year
The Company’s fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board
of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must
be made.
11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered
office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.
Art. 12. Distribution of profits.
12.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
12.2 The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward.
12.3 Subject to article 12.2, interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the board of directors;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the board of directors within two (2) months from
the date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
39540
L
U X E M B O U R G
13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant
to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles.
13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
Art. 15. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,
by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
<i>Transitional dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31
st
,
2011.
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share capital as follows:
1. Mrs Natalie Van De Vorstenbosch-Richardson, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250 shares
2. Mr Johannes Van De Vorstenbosch, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 shares
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,200 (one thousand two hundred euro).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1. The Company’s address is fixed at 63-65, Route de Merl, L-2146 Luxembourg;
2. The following have been elected as Director of the Company for a period of three (3) years:
- Mrs Natalie Van De Vorstenbosch-Richardson, Director, with professional address at Biezenlaan 34, 5708ZD Hel-
mond, Nederland, born in Cologne (Deutschland), on April 15
th
, 1975;
- Mr Johannes Van De Vorstenbosch, Director, with professional address at Mantelstraat 7, 3700 Tongeren, Belgium,
born in Leeuwarden (Nederland), on July 25
th
, 1958.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-quatre janvier.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Madame Natalie Van De Vorstenbosch-Richardson, Administrateur, ayant son adresse professionnelle au 34 Bie-
zenlaan, 5708ZD Helmond, Pays-bas, née à Cologne (Allemagne), le 15 avril 1975;
2) Monsieur Johannes Van De Vorstenbosch, Administrateur, ayant son adresse professionnelle au 7 Mantelstraat,
3700 Tongeren, Belgique, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 25 juillet 1958.
Etant représentés par Madame Odette Alves, employée privée, en vertu de deux procurations sous seing privé, les-
quelles, paraphées «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour
être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
39541
L
U X E M B O U R G
«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. La société a pour objet l’import, l’export, l’achat et la vente en gros et en détail, de produits
textiles ainsi que tous autres articles de la branche.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter l’accomplisse-
ment.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «NEEDIT S.à r.l.».
Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand -Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
5.3 L’adresse du siège social peut-être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Capital social – Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à 12.500.-EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de 1.-EUR (un euro), toutes entièrement souscrites et libérées.
6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société
est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la
Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.
6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable
en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne peuvent être opposables à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou
de leur acceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-
tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).
7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée
par les associés.
39542
L
U X E M B O U R G
7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/
leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.
7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la seule
signature d’un des membres du conseil de gérance.
7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du
mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres
conditions pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner
un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
associés.
7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et
le secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.
7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.
7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance.
7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par
les gérants présents ou représentés à ladite réunion.
7.4.6 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents
distincts.
7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conférence call"
via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants parti-
cipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements ré-
gulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour
lequel un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-
cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-
mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l'assemblée, le dernier mardi du moi de mai a 16h00.
39543
L
U X E M B O U R G
9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable
suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 -Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse
un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social
de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
12.2 Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider du paiement d’un
dividende, affecter le solde à un compte de réserve ou le reporter.
12.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le conseil de gérance dans les deux (2)
mois suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les associés doivent reverser l’excès à la Société.
Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
13.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur
décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.
Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des
associés selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand -Duché de Luxembourg.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Madame Natalie Van De Vorstenbosch-Richardson, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250 shares
2. Mr Johannes Van De Vorstenbosch, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,250 shares
12,500 shares
39544
L
U X E M B O U R G
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 12.500.-
EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille deux cents euros (1.200.-EUR).
<i>Résolution des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social et se con-
sidérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:
1. L'adresse de la Société est fixée au 63-65, Route de Merl, L-2146 Luxembourg;
2. Sont appelés aux fonctions de gérants pour une période de trois (3) ans:
- Madame Natalie Van De Vorstenbosch-Richardson, Administrateur, ayant son adresse professionnelle au 34 Bie-
zenlaan, 5708ZD Helmond, Pays-bas, née à Cologne (Allemagne), le 15 avril 1975;
- Monsieur Johannes Van De Vorstenbosch, Administrateur, ayant son adresse professionnelle au 7 Mantelstraat, 3700
Tongeren, Belgique, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 25 juillet 1958.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Alves et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2011. LAC/2011/4216. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Référence de publication: 2011015775/415.
(110018611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.
AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 3) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.471.
EXTRAIT
En date du 8 mars 2011, les associés ont décidé de nommer M. Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem (Belgique),
avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la société
avec effet immédiat et cela pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 mars 2011.
Référence de publication: 2011036777/14.
(110041175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 100.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.769.
EXTRAIT
En date du 8 mars 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Marjoleine Van Oort, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet immédiat.
39545
L
U X E M B O U R G
- Wim Rits, 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et
ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 mars 2010.
Référence de publication: 2011036778/15.
(110041164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Aprilis Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 80.981.
Les administrateurs, Mmes Sonja Bemtgen, Virginie Derains et M Raffaele Saurwein, et le commissaire aux comptes,
Picigiemme S.à r.l., ont démissionné de leur mandat respectif avec effet immédiat le 9 mars 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 9 mars 2011.
Référence de publication: 2011036783/12.
(110040530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Aprilis Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 80.981.
Profida Luxembourg S.A., agissant en sa qualité de domiciliataire de la société Aprilis Holding S.A., dénonce par la
présente le siège social de la société Aprilis Holding S.A., numéro RCS Luxembourg B 80.981 avec siège social au 31,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2011.
Référence de publication: 2011036784/11.
(110040611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
ATM Invest, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 42A, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 117.893.
Les comptes annuels au 31/12/09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11/03/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011036788/10.
(110040968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
ARE Hamburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.382.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 157.040.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 28 février 2011 les décisions suivantes:
- Accepter la démission de M. Raphael Küster en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
mars 2011;
- Nommer M. Ralf Steinmetz, contrôleur financier né le 16 octobre 1962 à Trèves, Allemagne, ayant pour adresse
professionnelle Wiesenstrasse 14 à 54441 Kanzem, Allemagne en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
mars et
ce pour une durée indéterminée;
- Nommer Grec Immobiliaris S.A., une société enregistrée au Registre des Sociétés du Gouvernement de Andorre
sous le numéro 9699 et ayant son siège social au 9 Plaça de la Germandat, Sant Julià de Lòira, Andorre, en tant que gérant
de la Société avec effet au 1
er
mars et ce pour une durée indéterminée.
39546
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
Référence de publication: 2011036785/19.
(110041174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Barclays European Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.028.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Barclays European Infrastructure Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011036789/11.
(110041177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Birdsview Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 117.597.
EXTRAIT
Monsieur Gavin Byrnes a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 28 février 2011.
De ce fait, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 28 février 2011:
- Mme Ann-Charlotte Lawyer, avec adresse professionnelle au 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxem-
bourg;
- M. Ulf Loeper, avec adresse professionnelle à Strandvägen 7A, S-11456 Stockholm;
- M. Robin Curry-Lindahl, avec adresse professionnelle à Avenue E. De Mot, 19, B-1000 Bruxelles;
- M. Hugo af Petersens avec adresse professionnelle à Cannon Street 2, UK- London EC4M 6XX;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011036792/16.
(110040822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Stratacache Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 158.584.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, am zwanzigsten Januar.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg);
Ist erschienen:
Christopher K. RIEGEL, Kaufmann, wohnhaft zu 5637 Mark Dale Dr. Dayton, OH 45459 (USA),
vertreten durch Katrin DUKIC, Diplomrechtspflegerin, geschäftsansässig zu L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph
II,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 10. Dezember 2010,
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparentin und den amtierenden Notar, gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigebogen bleibt.
Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "STRATACACHE SARL".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften,
unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar-und Immobiliarwerte beziehen sowie die Be-
teiligung an anderen Gesellschaften.
39547
L
U X E M B O U R G
Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch
Darlehen, Garantien und Vorschüsse.
Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- €) und ist in EINHUN-
DERTFÜNFUNDZWANZIG (125) Anteile von je EINHUNDERT EURO (100,- €) eingeteilt.
Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Sie können nur unter Lebenden oder von Todes wegen an Nichtgesellschafter abgetreten werden gemäss den Bes-
timmungen von Artikel 189 von dem koordinierten Text des Gesetzes vom 10. August 1915 und der diesbezüglichen
Abänderungsgesetze.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-
fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden
können, ohne Angabe von Gründen.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
Christopher K. RIEGEL, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT
EURO (12.500,-€) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.
<i>Schätzung der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf NEUN HUNDERT EURO (900,- €) abgeschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann nimmt die Gesellschafterin in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
Wird zum Geschäftsführer ernannt:
- Christopher K. RIEGEL, Kaufmann, wohnhaft zu 5637 Mark Dale Dr. Dayton, OH 45459 (USA).
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden
Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin,
daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text
der deutsche Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienene hat dieselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Follows the English translation:
In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of January.
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Christopher K. RIEGEL, businessman, residing in 5637 Mark Dale Dr. Dayton, OH 45459 (USA),
represented by Katrin DUKIC, Diplomrechtspflegerin, residing professionally in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard
Joseph II, by virtue of a proxy given under private seal on the 10
th
December 2010,
39548
L
U X E M B O U R G
which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities
The appearing party intend to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as
follows:
Art. 1. The Company is incorporated under the name of: "STRATACACHE SARL".
Art. 2. The Company has its Head Office in Luxembourg.
Art. 3. The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in the one hand, in whatever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with
the creation, management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies having any object in what-
ever form, as well as, in the other hand, the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio
created for this purpose.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 4. The Company is constitued for an undetermined period.
Art. 5. The Company's capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500,- €), represented by
ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE (125) shares of a par value of ONE HUNDRED EURO (100,- €) each, all fully
subscribed and entirely paid up.
Art. 6. The shares are freely transferable among members. They shall be transferable because of death to non-members
only in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915.
Art. 7. The Company is managed by one or many managers, members or not, appointed by the members who deter-
minate the period of their activity and the powers he (they) is (are) invested. They shall be revocated groundless.
Art. 8. The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 9. For all not provided for in the present deed, the appearing parties shall refer to the legal dispositions.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on the 31 December 2011.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as following:
Christopher K.RIEGEL, prenamed, one hundred twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: one hundred twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
They have been fully paid by a contribution in cash.
<i>Estimated of costsi>
The cost, expenses, fees and charges, which are to be borne by the Company in connection with its corporation have
been estimated at about NINE HUNDRED EURO (900,- €).
<i>Resolutionsi>
The member, representing the entirety of the subscribed capital, have passed the following resolutions:
1) The Company shall have its registered office at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
2) Number of managers shall be one (1).
Is appointed manager of the Company, for an undeterminated period:
- Christopher K. RIEGEL, businessman, residing in 5637 Mark Dale Dr. Dayton, OH 45459 (USA).
The Company is validly bound by the signature of the sole manager.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil
status and residences, the said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.
Gezeichnet: DUKIC, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 25 janvier 2011. REM 2011/126. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
39549
L
U X E M B O U R G
Mondorf-les-Bains, le 2 février 2011.
Référence de publication: 2011017820/125.
(110020809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
Bressaglia Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 15, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 138.956.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bressaglia Immobilière S.à r.l.
Référence de publication: 2011036794/10.
(110040831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Build Germany 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 156.188.
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 2 mars 2011 que Build Hotel S.à r.l. associé unique
de la Société a transféré toutes les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Build
Top Hotel S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.156185.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Référence de publication: 2011036795/16.
(110040944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Badajoz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 87.230.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 2011 que, Monsieur Michel Schaeffer, directeur
de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire aux comptes,
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.
Luxembourg, le 10 mars 2011.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011036798/15.
(110040683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de
Patrimoine Familial.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 61.232.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal d’une Assemblée Générale Ordinaire du 08 mars 2011 que:
Monsieur Michele CANEPA , employé privé, ne à Genève le 23 novembre 1972 demeurant professionnellement à 40,
Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Annalisa
CIAMPOLI.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
39550
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Référence de publication: 2011036803/16.
(110040951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2011.
Giroinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 44.566.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59255 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028314/10.
(110034244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.
Hydrofluide Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Hydrofluide Holding S.A.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 60.034.
Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 25 février 2011.
Référence de publication: 2011028325/11.
(110034320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.
Octinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 121.527.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2011i>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8-10 rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg au 19-21,
boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg avec effet immédiat;
L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur et président de Madame Sonia Still, employée privée,
demeurant professionnellement au 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en tant qu'administrateur de Madame
Mariateresa Battaglia, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
et de Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg.
L'Assemblée accepte également la démission en tant que commissaire aux comptes de la société "H.R.T. Révision S.A.",
société anonyme, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
51.238).
L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires:
- Monsieur Andrea Carini, né le 20 septembre 1967 à Tripoli, Lybie, demeurant professionnellement au 19-21, bou-
levard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'administration;
- Monsieur Gregorio Pupino, né le 26 février 1979 à Taranto, Italie, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard
du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur;
- Madame Hélène Mercier, née le 1
er
février 1972 à Mont-Saint-Martin, France, demeurant professionnellement au
19-21, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat la société «I.C. DOM-COM. S.à r.l.»,
société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, rue de la Semois, L - 2533 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,
section B numéro 133.127);
Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
39551
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 11 mars 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011038266/36.
(110041516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.
Turkey SH II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: TRY 50.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 134.241.
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société tenue au siège social le 13 octobre
2010 que les mandats suivants ont été reconduits pour une période d'un an courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
annuelle qui se tiendra en 2011:
<i>Gérants de classe A:i>
- Olivier Dorier, Directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach;
- Stewart Kam-Cheong, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach;
- Hermann-Gunter Schommarz, Comptable, demeurant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach;
<i>Gérants de classe B:i>
- Ayham Gharaibeh, demeurant professionnellement au 2495, Ahli United Bank Bldg, 2
nd
Floor Tenants, BRN - Ma-
nama.
Il résulte de la décision de l'associé unique prise en date du 28 février que:
Mr. Ayham Gharaibeh, résidant professionnellement au 2495, Ahli United Bank Bldg, 2
nd
Floor Tenants, BRN - Manama
a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la société avec effet à dater du 28 février 2011.
Mr. Marcus Robert Scott, résidant professionnellement au European Islamic Investment Bank, Almoayyed Tower, Al
Seef Area, 30
th
Floor, Suite 3002, Manama Kingdom of Bahrain a été nommé en qualité de gérant de catégorie B de la
Société avec effet immédiat et pour une durée déterminée allant jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui sera tenue
en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 28 février 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2011039441/33.
(110043268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2011.
Barclays Euro Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 66.581.
Les comptes annuels au 31 octobre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Barclays Euro Funds
i>CACEIS Bank Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2011038781/12.
(110042112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
39552
2F Finance S.A.
AB Events S.à r.l.
Access Fund
A.C. Lux S.A.
A.C. Lux S.A.
AIYA International S.A.
AIYA International S.A.
Aloha Corporation S.A.
Altraplan Luxembourg S.A.
AMP Capital Investors (CIF European Infrastructure No. 1) S.à r.l.
AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 3) S. à r.l.
AMP Capital Investors (FDF European Infrastructure No. 1) S.à r.l.
Aprilis Holding S.A.
Aprilis Holding S.A.
ARE Hamburg S.à r.l.
ATM Invest
Badajoz S.A.
Barclays Euro Funds
Barclays European Infrastructure Holding S.à r.l.
Baren Entreprises S.A.
BENESHARE TRANSPORT GROUP (Luxembourg) S.A.-SPF
Bioparticipations Développements S.à r.l.
Birdsview Fund
Bressaglia Immobilière S.à r.l.
Build Germany 3 S.à r.l.
Car Line S.A.
Compagnie de Services et Gestion Industriels S.A.
Copefi
C.S.A.M. S.à.r.l.
Egest Finance S.C.A.
EGEST Invest & Cie S.e.c.s.
Espace "J" S.à r.l.
Euro-Lux Construction S.à r.l.
Giroinvest S.A.
GKS Prop Co. B S.à r.l.
Hydrofluide Holding S.A.
Hydrofluide Holding S.A., SPF
LCB Invest Co. S.à r.l.
LGIG 2 Property C7 S.à r.l.
Needit S.à r.l.
Octinvest S.A.
Primopiso Acquisition S.à r.l.
Stratacache Sàrl
Turkey SH II S.à r.l.