This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 744
18 avril 2011
SOMMAIRE
Ades S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35702
Allibert Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35689
Ambiance S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35703
Bei der Kapell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35708
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV -
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35681
Centaur Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35695
Colways Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35701
Commerzbank Finance 3 S.à r.l. . . . . . . . . .
35697
D.A. Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35680
De Vlier Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35685
D.P. Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35700
Elckerlyc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35680
Elisenau Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35687
Elster Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35712
Ethofin S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35685
Fersen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35696
Fitair Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35700
Flantermaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35679
Fondation époux Robert Wagener-Ettin-
ger et époux Jean-Pierre Muller-Ettinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35693
Fortis Luxembourg-Vie S.A. . . . . . . . . . . . .
35695
GE Capital Real Estate Polish Retail S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35684
HF Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35689
Hurca Investment Holding SPF S.A. . . . . .
35708
Ideal Toitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35683
Inter Marine Investment Holding S.A. . . .
35704
Invesrus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35696
Kestrel Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
35693
Lag International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35707
La Montagne de Beaulieu S.A. . . . . . . . . . . .
35699
Le Kelie S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35701
Modern Como S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35688
NVB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35709
OI-Paper S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35711
Ossiam Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35666
PATIMA ELECTRO CENTER, Distribu-
tion-Réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35712
Résidence des Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35702
RP Bergen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35679
RP Medicentre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35704
Saint Guy Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35705
Société Luxembourgeoise ETAM . . . . . . . .
35687
Squale Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
35683
TARLETON REAL ESTATE Partnership,
S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35691
Tucson S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35692
Valentin Capital Management Holding
S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35681
Valentin Capital Management S.A. . . . . . .
35681
35665
L
U X E M B O U R G
Ossiam Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.071.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the fifth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Natixis Global Associates, a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
represented by Me Arnaud Cagi-Nicolau, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy given on
4 April 2011.
The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.
This appearing person, in his/her capacity, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation
of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" which it intends to incorporate in
Luxembourg.
Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There exists, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with
variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Ossiam Lux" (hereinafter the
"Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
(but in no event in the United States of America, its territories or possessions) by a decision of the board of directors.
The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by simple decision of the board
of directors. If and to the extent permitted by law, the board of directors may decide to transfer the registered office of
the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military economic or social events
have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
Company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of
any kind and other assets permitted by law with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders
the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and
accomplishment of its purpose to the full extent permitted by Part I of the law of December 20, 2002 relating to under-
takings for collective investment, as may be amended from time to time (the “Law”).
Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value
Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of
no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The
initial capital for incorporation is thirty one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310)
shares of no par value. The minimum capital shall be as provided by law, currently one million two hundred and fifty
thousand euros (EUR 1,250,000.-).
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different
classes. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in transferable securities of any kind and other
assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Sub-Fund (as
defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment restrictions
provided by law or determined by the board of directors.
The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a sub-fund ("Sub-Fund") within the meaning of
Article 133 of the Law for one class of shares or for multiple classes of shares in the manner described in Article 11
hereof. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class
35666
L
U X E M B O U R G
or classes of shares. The Company shall be considered as one single legal entity. With regard to third parties, in particular
towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if
not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of shares.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The board of directors shall determine whether the Company shall issue shares in bearer and/or in registered
form. Bearer shares, if issued, shall be represented by a global share certificate.
(2) All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept
by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the
name of each owner of record of registered shares, residence or elected domicile as indicated to the Company, the
number of registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each share.
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on
such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the
shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
If bearer shares are issued, registered shares may be exchanged for bearer shares and bearer shares may be exchanged
for registered shares at the request of the holder of such shares. An exchange of registered shares into bearer shares
will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, representation that the transferee is not a
Prohibited Person and issuance of one or more bearer share certificates in lieu thereof, and an entry shall be made in the
register of shareholders to evidence such cancellation. An exchange of bearer shares into registered shares will be effected
by cancellation of the bearer share certificate, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof,
and an entry shall be made in the register of shareholders to evidence such issuance. At the option of the board of
directors, the costs of any such exchange may be charged to the shareholder requesting it.
The share certificates shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile.
However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of directors; in the
latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of directors
may determine.
(3) If bearer shares are issued, transfer of bearer shares shall be effected by book entry credit to the securities account
of the shareholder's intermediary opened with the clearing agent, in accordance with applicable laws and any rules and
procedures issued by the clearing agent concerned with such transfer. Transfer of registered shares shall be effected (i)
if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Com-
pany along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii) if no share certificates have been issued,
by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor
and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall
be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more directors or officers of the
Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the board of directors.
(4) Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
(5) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the shareholder's share certificate has been
mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such
conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may
determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original
share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.
Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original share certificate.
(6) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to
represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such shares.
(7) The Company may decide to issue fractional shares up to the number of decimal places to be decided by the board
of directors. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets
35667
L
U X E M B O U R G
attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis. In the case of bearer shares, only certificates evidencing
full shares will be issued, and such Shares may not be purchased or redeemed in fractional amounts.
Art. 7. Issue of Shares. The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully
paid up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares
to be issued.
The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares;
the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be
the net asset value per share of the relevant class as determined in compliance with Article 11 hereof as of such Valuation
Day or Valuation Time during the course of a Valuation Day (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance
with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage
estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable
sales commissions, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be payable
within a period as determined by the board of directors which shall not exceed five business days from the relevant
Valuation Day.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them. If subscribed
shares are not paid for, the Company may redeem the shares issued whilst retaining the right to claim its issue fees,
commissions and any difference.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with
the conditions set forth by Luxembourg law, which may in particular provide for the obligation to deliver a valuation
report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with
the investment objectives and policies of the relevant Sub-Fund.
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may require the redemption of all or part of his shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the
limits provided by law and these Articles.
The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not
exceed five business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the board
of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents
have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class, as determined in accordance
with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales
documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant
currency as the board of directors shall determine.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors,
then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class.
Further, if on any given Valuation Day or Valuation Time during the course of a Valuation Day, redemption requests
pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the
board of directors in relation to the number of shares in issue in a specific class, the board of directors may decide that
part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the board
of directors considers to be in the best interest of the Company. On the next Valuation Day, or on the next Valuation
Time during the course of a Valuation Day, following that period, these redemption and conversion requests will be met
in priority to later requests.
The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in
connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the
Valuation Day, or the Valuation Time during the course of a Valuation Day, on which the redemption price is calculated,
to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined
on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant class
or classes of shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The
costs of any such transfers shall be borne by the transferee.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares. Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares, any
shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class,
subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of
directors shall determine.
35668
L
U X E M B O U R G
The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the
respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day, or the same Valuation Time
during the course of a Valuation Day.
If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares declines to, or fails to reach, such number or such value as determined by the board
of directors as the minimum appropriate level for the relevant Fund or Class, then the Company may decide that this
request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.
The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the
Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding (i) may be detrimental
to the Company, (ii) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, (iii) if as a result
thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have
otherwise incurred or (iv) if such person, firm or corporate body would not comply with the eligibility criteria of a given
Share Class. Such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred
to as "Prohibited Persons". For the purpose of these Articles of Incorporation, Prohibited Persons shall include without
limitation (i) any “U.S. Person” as this term is hereinafter defined or (ii) any person willing to subscribe for or to buy on
the secondary market or holding Shares of Classes reserved to Institutional Investors as such term is defined under the
Law who does not qualify as an Institutional Investor. "Prohibited Person" as used herein does not include (i) any subscriber
of Shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such
Shares or (ii) any securities dealer who acquires Shares with a view to their distribution in connection with an issue of
Shares by the Company. The term “U.S. Person” as used in these Articles of Incorporation shall mean U.S. persons as
that term is defined under Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or persons who are resident of
the United States at the time the Shares are offered or sold.
For such purposes the Company may:
A.- decline to issue any shares where it appears to it that such registry would or might result in legal or beneficial
ownership of such shares by a Prohibited Person; and
B.- at any time require any person whose name is entered into the registry, to provide the Company any information,
supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ow-
nership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person; and
C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and
D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares, compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held
by such shareholder in the following manner:
(1) The Company shall serve a notice (the "purchase notice") upon the shareholder holding such shares or appearing
in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed
to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall
thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares
specified in the purchase notice.
Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from
the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall
be cancelled.
(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net
asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day or Valuation Time during the course of a Valuation Day
specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company immediately preceding the date of the
purchase notice or immediately following the surrender of the share certificate or certificates representing the shares
specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge
provided therein.
(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be
deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates
specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as
aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the
Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such
bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable
by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the
35669
L
U X E M B O U R G
purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares of the relevant
Sub-Fund. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion
and to authorize such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case
the said powers were exercised by the Company in good faith.
Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class of shares shall be calculated
in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant Sub-Fund and, to the extent
applicable within a Sub-Fund, expressed in the currency of quotation for the relevant class of shares. It shall be determined
as of any Valuation Day, or any Valuation Time during the course of a Valuation Day, by dividing the net assets of the
Company attributable to each class of shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attri-
butable to such class, on any such Valuation Day, or any such Valuation Time during the course of a Valuation Day, by
the number of shares in the relevant class then outstanding, in accordance with the Valuation Rules set forth below. The
net asset value per share may be rounded up or down to the nearest 1/1000 of the relevant currency as the board of
directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in
the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares
are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company,
cancel the first valuation and carry out a second valuation.
The valuation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, war-
rants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company
(provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards
to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information
thereon is reasonably available to the Company;
5) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset;
6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off;
7) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) Securities and money market instruments traded on exchanges and Regulated Markets -last closing price (unless
the Company believes that an occurrence after the publication of the last market price and before any Sub-Fund next
calculates its net asset value will materially affect the security's value. In that case, the security may be fair valued at the
time the administrative agent determines its net asset value by or pursuant to procedures approved by the Company).
(b) Securities and money market instruments not traded on a Regulated Market (other than short-term money market
instruments) -based upon valuations provided by pricing vendors, which valuations are determined based on normal,
institutional-size trading of such securities using market information, transactions for comparable securities and various
relationships between securities which are generally recognized by institutional traders.
(c) Short-term money market instruments (remaining maturity of less than 90 calendar days or less) - amortized cost
(which approximates market value under normal conditions).
(d) Futures, options and forwards - unrealized gain or loss on the contract using current settlement price. When a
settlement price is not used, future and forward contracts will be valued at their fair value as determined pursuant to
procedures approved by the Company, as used on a consistent basis.
(e) Units or shares of open-ended funds - last published net asset value.
(f) Cash on hand or deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest
declared or accrued and not yet received -full amount, unless in any case such amount is unlikely to be paid or received
in full, in which case the value thereof is arrived at after the Company or its agent makes such discount as it may consider
appropriate in such case to reflect the true value thereof.
(g) All other assets - fair market value as determined pursuant to procedures approved by the Company.
The Company may also value securities at fair value or estimate their value pursuant to procedures approved by the
Company in other circumstances such as when extraordinary events occur after the publication of the last market price
but prior to the time the Sub-Funds' net asset value is calculated.
35670
L
U X E M B O U R G
The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into such
currency at rates last quoted by any major bank. If such quotations are not available, the rate of exchange will be deter-
mined in good faith by or under procedures established by the administrative agent.
The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that
such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including but not limited to administrative expenses, management fees, incentive
fees, custodian fees, and corporate agents' fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day or Valuation Time during
the course of a Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized
and approved by the board of directors, as well as such amount (if any) as the board of directors may consider to be an
appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which shall comprise formation expenses, fees payable to its investment managers, investment
advisers, fees and expenses payable to its auditors and accountants, custodian and its correspondents, domiciliary, ad-
ministrative, registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, and permanent representatives in places of
registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration of the directors and officers and
their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board
meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and maintaining
the registration of the Company with any Governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg
and in any other country, reporting and publishing expenses, the costs for the publication of the issue, conversion and
redemption prices, including the cost of preparing, printing, translating, advertising and distributing prospectuses, expla-
natory memoranda, periodical reports or registration statements, the costs of printing share certificates and the costs of
any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses, including
the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company
may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateably
for yearly or other periods.
III. The assets shall be allocated as follows:
The board of directors shall establish a Sub-Fund in respect of each class of shares and may establish a Sub-Fund in
respect of multiple classes of shares in the following manner:
(a) If multiple classes of shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such classes shall be commonly invested
pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the
board of directors is empowered to define classes of shares so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such
as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure
and/or (iii) a specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution, shareholder
services or other fees and/or (v) the currency or currency unit in which the class may be quoted and based on the rate
of exchange between such currency or currency unit and the reference currency of the relevant Sub-Fund and/or (vi) the
use of different hedging techniques in order to protect the assets of a specific class of Shares denominated in a currency
other than the reference currency of the relevant Sub-Fund against movements of the reference currency of the relevant
Sub-Fund and/or (vii) such other features as may be determined by the board of directors from time to time in compliance
with applicable law;
(b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to
the class or classes of shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase
the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the class of shares to be issued;
(c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the class or classes of
shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under (a);
(d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the
Company to the same class or classes of shares as the assets from which it was derived and on each revaluation of an
asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;
(e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset
values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where
assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by
an agent of the board of directors, the respective right of each class of shares shall correspond to the prorated portion
35671
L
U X E M B O U R G
resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary
in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the class of shares, as described in the
sales documents for the shares of the Company;
(f) Upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares
shall be reduced by the amount of such distributions.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken
by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for
the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.
IV. For the purpose of this article:
1) shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the board of directors on the Valuation Day on which such valuation is made
and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the board of
directors on the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until received by the Company
the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the
relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and
time for determination of the net asset value of shares; and
4) where on any Valuation Day or Valuation Time during the course of a Valuation Day the Company has contracted
to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, or such Valuation Time during the course of a Valuation Day, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and
Conversion of Shares. With respect to each class of shares, the net asset value per share and the price for the issue,
redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed
thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date being
referred to herein as the "Valuation Day"; provided that to the extent the net asset value per share is calculated at several
moments in time during the course of the same Valuation Day, each such moment shall be referred to herein as a
"Valuation Time" during the course of the relevant Valuation Day.
The Company may suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and the issue and
redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each class:
a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of
the investments of the Company attributable to such class of shares from time to time is quoted or dealt in is closed
otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such
restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to a class quoted thereon;
or
b) when for any reason the prices of any assets in which a Sub-Fund invests directly or indirectly and, for the avoidance
of doubt, where applicable techniques used to create exposure to certain assets, cannot promptly or accurately be
ascertained; or
c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Company as a result
of which disposals or valuation of assets owned by the Company attributable to such class of shares would be impracti-
cable; or
d) during any breakdown in the means of communication or computation normally used in determining the price or
value of any of the investments of such class of shares or the current price or value on any stock exchange or other
market in respect of the assets attributable to such class of shares; or
e) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to any class of shares
cannot promptly or accurately be ascertained; or
f) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of the shares of such class or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition of
investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Company be effected at normal rates
of exchange;
35672
L
U X E M B O U R G
g) from the time of publication of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose
of winding-up the Company or one or more Sub-Funds.
Any such suspension shall be publicized, if appropriate, by the Company and may be notified to shareholders having
made an application for subscription, redemption or conversion of shares for which the calculation of the net asset value
has been suspended.
Such suspension as to any class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the
issue, redemption and conversion of shares of any other class of shares.
Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of
the calculation of the net asset value.
Title III. Administration and Supervision
Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors
shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders, in particular by the shareholders at their annual
general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors are elected
and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by
resolution adopted by the shareholders. The shareholders shall further determine the number of directors, their remu-
neration and the term of their office.
If a legal entity is appointed as director, such legal entity must designate a physical person as its permanent represen-
tative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove
its permanent representative if it appoints his successor at the same time.
Directors shall be elected by the majority of the votes validly cast.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which shall
take a final decision regarding such nomination.
Art. 14. Board Meetings. The board of directors shall choose from among its members a chairman and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may choose a secretary, who need not be a director, who shall
write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors
shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders but in his absence the shareholders
or the board of directors may appoint another director and, in the case of a shareholders' meeting, in the absence of a
director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as
well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders
of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the rights and
duties conferred upon them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior
to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile
or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places
fixed in a resolution adopted by the board of directors.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means
of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting
by such means of communication shall constitute presence in person at such meeting. A meeting held through such means
of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the
Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors, or any other number of directors
that the board may determine, are present or represented.
Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of
extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two directors.
35673
L
U X E M B O U R G
Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting. In the
event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall
have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, facsimile or any other
similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that
proves that such decision has been taken.
Art. 15. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as deter-
mined in Article 18 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of
shareholders are in the competence of the board of directors.
Art. 16. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of
directors.
Art. 17. Delegation of Power. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily
management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or
corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of
directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The Company has appointed a management company (the “Management Company”) as its management company and
has delegated to the Management Company all powers related to the investment management, administration and dis-
tribution of the Company. The Management Company may delegate some of its responsibilities to affiliated and non-
affiliated parties.
In particular, the Management Company may enter into one or more investment management agreements with one
or several investment managers (the "Investment Managers"), as further described in the sales documents for the shares
of the Company, who shall supply the Company with recommendations and advice with respect to the Company's
investment policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the
Management Company, have actual discretion to purchase and sell securities and other assets of the Company pursuant
to the terms of a written agreement.
The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has
the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund, (ii) the hedging strategy to
be applied to specific classes of shares within particular Sub-Funds and (iii) the course of conduct of the management and
business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance
with applicable laws and regulations.
In compliance with the requirements set forth by the Law in particular as to the type of markets on which the assets
may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Sub-Fund may invest in any type of asset eligible
to be invested in by a UCITS and in particular:
(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other UCITS and/or UCI;
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which are
maturing in no more than 12 months;
(iv) financial derivative instruments.
The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of stocks or debt securities reco-
gnized by the Luxembourg supervisory authority.
The Company may also use all authorized techniques and instruments relating to transferable securities and money
market instruments.
The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market or other regulated
market of a State of Europe, being or not member of the EU, of America, Africa, Asia, Australia or Oceania.
The Company may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that
the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market or on an other regulated market (as described above) and that such admission be secured within one year of
issue.
No Sub-Fund of the Company may invest more than 10% of its net assets in other undertakings for collective invest-
ment, except for those Sub-Funds the investment policy of which, as provided for in the Prospectus, expressly authorizes
a higher percentage of investment in other undertakings for collective investment.
35674
L
U X E M B O U R G
In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorized to invest up to 100% of the net assets
attributable to each Sub-Fund in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU
member State, its local authorities, another member State of the OECD, Singapore, Brazil or public international bodies
of which one or more member States of the EU are members provided that if the Company uses the possibility described
above, it shall hold, on behalf of each relevant Sub-Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities
belonging to one issue can not exceed 30% of the total net assets attributable to that Sub-Fund.
Art. 19. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or
officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without
interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be
determined by the board of directors in its discretion.
Art. 20. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 21. Auditors. The general meeting of Shareholders shall appoint a “réviseur d'entreprises agréé” (auditor).
The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and until their successor is elected.
The auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Title IV. General Meetings - Accounting Year - Distributions
Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company
shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders
regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.
Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to notice and/or publication made in accordance
with the law. It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
The notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this
general meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding
the general meeting (the “Record Date”), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of
shareholders and to exercise the voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares
held by this shareholder as at the Record Date.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg City at a place specified
in the notice of meeting, on the third Friday in the month of May at 2.00 p.m. If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
If permitted by and on the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time
or place to be decided by the board of directors.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors,
exceptional circumstances so require (i.e. political or military requirements).
The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the
written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.
One or several shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request the adjunction
of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered
office of the Company by registered mail at least five days before the relevant meeting.
35675
L
U X E M B O U R G
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
Each whole share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the
decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against,
or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void.
The Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes validly cast.
Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Sub-Fund or in a Class of Shares. The shareholders of the class or
classes issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate
exclusively to such Sub-Fund.
In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are
specific to such class.
The provisions of Article 22, paragraphs 2, 7, 8, 9 and 10 shall apply to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation.
Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund
or of a class of shares are passed by a simple majority of the votes validly cast.
Art. 24. Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares. In the event that for any reason the value
of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund has decreased
to, or has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or
such class of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the
political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalization, the board of directors may decide
to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into account actual
realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day or Valuation Time during the
course of a Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of
the relevant class or classes of shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the
reasons of and the procedure for the redemption operations: registered holders shall be notified in writing; the Company
shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board of directors,
unless these shareholders and their addresses are known to the Company. Unless it is otherwise decided in the interests
of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund concerned may continue to
request redemption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices of
investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of
shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power,
upon proposal from the board of directors, to redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the
shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization
expenses) calculated on the Valuation Day, or the Valuation Time during the course of a Valuation Day, at which such
decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall
decide by resolution taken by simple majority of the votes validly cast.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
in accordance with applicable laws and regulations with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled
thereto.
All redeemed shares shall be cancelled.
In accordance with the Law and any implementing provisions, merger of a Sub-Fund may be decided by the board of
directors. The board of directors may however also decide to submit the decision for a merger to a meeting of share-
35676
L
U X E M B O U R G
holders of the Sub-Fund concerned for which no quorum is required and decisions are taken by the simple majority of
the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger needs to
be decided by a meeting of shareholders where the quorum and majority requirements for changing these Articles of
Incorporation are required.
Art. 25. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year
and shall terminate on the thirty-first of December of the same year. The Company‘s first fiscal year shall end on December
31, 2011.
Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Sub-Fund
shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of such
Sub-Fund shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare,
distributions.
For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in com-
pliance with the conditions set forth by law.
Payment of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders. Payment of distributions to holders of bearer shares are issued and transferred by book entry
credit to the securities accounts of the shareholder's financial intermediaries opened with clearing institutions.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from
time to time.
The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions
as may be set forth by the board of directors.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class
or classes of shares issued in respect of the relevant Sub-Fund.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final Provisions
Art. 27. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the
"Custodian").
The Custodian shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the Law.
If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor custodian
within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian
but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place
thereof.
Art. 28. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors. The general meeting,
for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the
meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall
be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the
votes of the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 29. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
Art. 30. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by a general
meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
Art. 31. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies and Law as such laws have been or may be amended from
time to time.
35677
L
U X E M B O U R G
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2011.
2) The first annual general meeting shall be held in 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed for three hundred and ten (310) shares and has paid in cash thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000.-).
Proof of this payment has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.
<i>Statementsi>
The notary drawing up this deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the law of August
10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing person has forthwith taken immediately the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company is set at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The following persons are appointed directors for a period ending at the first annual general meeting which will be
held in 2012:
- Bruno Poulin, Président, Ossiam, professionally residing at 6, place de la Madeleine, 75008 Paris, France;
- Antoine Moreau, Directeur Général, Ossiam, professionally residing at 6, place de la Madeleine, 75008 Paris, France;
- Fabrice Chemouny, Executive Vice President, Head of International Strategy and Marketing, Natixis Global Associates
International, professionally residing at 21, Quai d'Austerlitz, 75013 Paris France; and
- Jason Trepanier, Chief Operating Officer and General Counsel, Natixis Global Associates International, professionally
residing at 21, Quai d'Austerlitz, 75013 Paris, France.
<i>Third resolutioni>
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg has been appointed as auditor of the Company
for a period ending at the first annual general meeting.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his/her surname, first name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.
Signé: A. CAGI-NICOLAU - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 avril 2011. Relation: LAC/2011/16085. Reçu soixante-quinze euros (75,00
EUR).
<i>Le Receveur pd.i> (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.
Luxembourg, le huit avril de l'an deux mille onze.
Référence de publication: 2011049867/732.
(110055534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.
35678
L
U X E M B O U R G
RP Bergen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 130.438.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 janvier 2011 à 11h45i>
L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de M. Michaël Astarita, Gérant A, et décide de nommer en
remplacement comme gérant A pour une durée illimitée:
Monsieur Fess Wofse,
399, Park Avenue, 7
th
floor, New-York NY 10022 (USA)
L'Assemblée Générale des Associés accepte la démission de M. Edouard Georges, Gérant B, et décide de nommer en
remplacement comme gérant B pour une durée illimitée:
Monsieur Jérôme Wünsch
34a, Bd. Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour copie conforme
RP BERGEN S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2011034128/20.
(110037002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.
Flantermaus, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 1, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 128.883.
DISSOLUTION
L'an deux mil onze, le dix-huit janvier.
Par devant Maître Georges d"HUART, notaire de résidence à Pétange
A comparu:
Monsieur Paul DIEDERICH; comptable, demeurant à L- 8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, agissant au nom et pour
compte de:
- Monsieur Xhavit GASHI; gérant de sociétés, né à le 22 août 1962 à Rausic/Pec (YU), demeurant à L- 1637 Luxembourg,
43, rue Goethe,
en vertu d'une procuration annexée au présent acte. Lequel comparant a prié le notaire d'acter:
- qu'il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FLANTERMAUS S.àr.l., avec siège à L- 1463
Luxembourg, 1, rue Fort Elisabeth, (RCS Luxembourg B 128.883), constituée suivant acte notarié du 29 mai 2007, publié
au Mémorial C No 1581 du 27 juillet 2007.
- que le soussigné est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
- qu'en tant qu'associé unique, le soussigné déclare expressément procéder à la dissolution de la société, avec effet
rétroactif au 31 décembre 2010.
- qu'il déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait
qu'il répond personnellement du passif inconnu et de tous les engagements sociaux.
- que le soussigné donne décharge au gérant de la société.
- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au domicile du comparant,
Monsieur Xhavit GASHI.
Le notaire a donné acte de la liquidation et de la dissolution de ladite société avec effet rétroactif au 31 décembre
2010..
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent. quatre-vingt-cinq euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: DIEDERICH, D'HUART.
Enregistré à Esch/ALzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1059. Reçu: soixante-quinze euros. EUR 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
35679
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME
Pétange, le 27 janvier 2011.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2011017406/38.
(110020300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Elckerlyc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 147.438.
EXTRAIT
Il résultat du contrat daté du 7 mars 2011 que les parts sociales de la société de EUR 100,- chacune, sont désormais
réparties comme suit:
Désignation des associés
Nombre
de parts
sociales
Tweelandenpunt Holding S.A.
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
Roeland P. PELS
24, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000
Luxembourg, le 7 mars 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011034251/22.
(110038549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
D.A. Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, rue de Sanem.
R.C.S. Luxembourg B 155.666.
L'an deux mille onze.
Le douze janvier.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Antonio LEITE DA SILVA, retraité, né le 12 janvier 1963 à Celorico de Bastos (P), demeurant Lugar de
Rebodoes Infesta à P-4890-397 INFESTA CBT (Portugal),
2) Madame Danielle Marie WEBER, ouvrière, née à Wiltz, le 10 novembre 1964, demeurant 153, route de Soleuvre à
L-4670 DIFFERDANGE,
3) Monsieur Antonio MALHAO DA SILVA REIS, gérant technique, né à S. Silvestre Coimbra (Portugal), le 05 juin 1966,
demeurant à L-4170 Esch/Alzette, 72, Boulevard J. F. Kennedy.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée D.A. CONSTRUCTIONS
S. à r.l., avec siège social à L-4485 Soleuvre, 39, rue de Sanem,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 155666,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 06 septembre 2010, publié au Mémorial
C numéro 2061 du 02 octobre 2010,
Les comparants sont les seuls associés de la société suite à deux assemblées générales extraordinaires tenues sous
seing privé, en date du 06 septembre 2010, enregistrée à Luxembourg A.C., le 08 octobre 2010, relation: LAC/2010/44310
et en date du 29 novembre 2010, enregistrée à Luxembourg A.C., le 03 décembre 2010, relation: LAC/2010/54085, dont
un extrait a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, le 16 décembre 2010 sous le numéro
L100193068,
dont le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur
nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00.-) chacune est réparti comme suit:
35680
L
U X E M B O U R G
1) Monsieur Antonio LEITE DA SILVA, prénommé, DIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2) Madame Danielle Marie WEBER, prénommée, DIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3) Monsieur Antonio MALHAO DA SILVA REIS, prénommé, QUATRE-VINGT PARTS SOCIALES . . . .
80
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts relatif à l'objet social de la société est modifié de sorte qu'il a
dorénavant la teneur suivante:
La Société a pour objet d'effectuer à titre principal, pour compte propre ou pour compte de tiers, l'activité de marbrier-
tailleur de pierres et/ou l'activité d'entreprise de constructions. La société pourra également exercer toutes activités
relatives aux métiers secondaires par rapport au métier de marbrier-tailleur de pierres et/ou d'entreprises de construc-
tion.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Leite da Silva, Weber, Antonio Reis, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2011. Relation: EAC/2011/690. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2011017030/47.
(110020417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.403.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 février 2011i>
L’Assemblée Générale a reconduit le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à l’assem-
blée qui sera appelée à délibérer sur l’approbation des comptes au 31.12.2010 qui se tiendra en 2011.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
- Nico THILL, Président (résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 24bis, boulevard Royal)
- Mario KELLER (résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal)
- Josef HUTTER (résidant professionnellement à D-67117 LIMBURGERHOF, 11, Kropsburgstrasse)
- Wolfgang KERCK (résidant professionnellement à W1J 5HS LONDRES, 17a, Curzon Street)
<i>Réviseur d’Entreprises agrééi>
KPMG Audit S.à r.l.
(ayant son siège social à L-2520 LUXEMBOURG, 9, Allée Scheffer)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2011.
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2011024572/23.
(110030169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.
Valentin Capital Management S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Valentin Capital Management Holding S.A.H.).
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 75.100.
L'an deux mille dix, le quinze décembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALENTIN CAPITAL MA-
NAGEMENT HOLDING S.A.H, avec siège social à L-2128 Luxembourg, 22 rue Marie-Adelaïde, inscrite au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro B 75100, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de
résidence à Capellen, en date du 7 mars 2000, publié au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro
35681
L
U X E M B O U R G
517 en date du 19 juillet 2000, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean
SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du décembre 20 décembre 2004, publié au Mémorial Recueil Spécial C des
Sociétés et Associations, numéro 328 en date du 13 avril 2005.
L'Assemblée est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Jean-Pascal CAMBIER, employé privé, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’objet social de la société et modification afférente de l’article 2 des statuts.
2) Changement du régime fiscal de la société (la société n’étant plus soumis au régime fiscal des sociétés anonymes
holdings)
3) Modification de la dénomination sociale de la société et modification afférente du premier alinéa de l’article 1 des
statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents etre présentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée " ne varietur " par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.
III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a
donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- L’actionnaire unique, déclare avoir eu connaissance de l’ordre du jour. Se considérant comme réuni en assemblée
générale extraordinaire, et prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent l'article deux des statuts qui
aura dorénavant la teneur suivante:
“ Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre matière ainsi que l'aliénation par ventes, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ses intérêts.
La société a pour objet la prestation de services de consultances en tant que conseil et/ou expert.
Elle pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et
pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou
emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet la promotion immobilière, l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et
de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
industrielles, commerciales et civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale constate que suite à la modification de l’objet social pour donner à la société l’objet social d’une
société de participation financière avec le régime fiscal y afférent, la société sous sa forme actuelle ne pourra plus bénéficier
du régime fiscal des sociétés anonyme holding prévue par la loi du 31 juillet 1929.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et de modifier par conséquent le premier
alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. (Premier alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VALENTIN CAPITAL
MANAGEMENT S.A.»
35682
L
U X E M B O U R G
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du
présent acte, sont évalués approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- Euros).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.
Signé: Cambier; Muhovic; Kronshagen , Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2010. Relation: EAC/ 2010/ 16266. Reçu: soixante-quinze euros 75,00.-
€
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2011.
Référence de publication: 2011013122/83.
(110014768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.
Squale Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 96.315.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de carence tenue le 15/12/2009i>
<i>Deuxième résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,
l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat des Administrateurs de Monsieur Claude
SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, Monsieur Thierry FLEMING, Expert-comptable, né à Luxembourg le 24/07/1948,
domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Guy HOR-
NICK, Expert-comptable, né à Luxembourg le 29/03/1951, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue
Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social
au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Statutaire annuelle qui se tiendra en 2015.
L'assemblée prend note également du changement d'adresse professionnelle de Messieurs Claude SCHMITZ, Thierry
FLEMING et Guy HORNICK, anciennement sise 5, Boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg et transférée 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SQUALE INVESTISSEMENTS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2011029493/25.
(110035263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2011.
Ideal Toitures, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. im Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 61.997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2011.i>
1.- "FAREI SERVICES S.A.", la société anonyme avec siège social à L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. Im Bruch inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 46.627. ici représentée par son
Président du Conseil d’Administration Monsieur Claude FAMIANI, né à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 1959, demeurant
à L- 5639 Mondorf-les-Bains, 26, rue des Prunelles,
2.- Monsieur Marc BEREND, employé privé, demeurant à F-57190 Florange, 7, rue Montesquieu, (France)
35683
L
U X E M B O U R G
agissant en leur qualité d’associés uniques représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée
IDEAL TOITURES avec siège social à L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. Im Bruch inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 61.997 ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés acceptent la démission de la gérante FAREI SERVICES S.A. nomment pour une durée indéterminée aux
fonctions de gérant de la société Monsieur Claude FAMIANI, né à Esch-sur- Alzette, le 20 juillet 1959, demeurant à L-
5639 Mondorf-les-Bains, 26, rue des Prunelles.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés confirment aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée de la société Monsieur Marc BEREND,
employé privé, demeurant à F-57190 Florange, 7, rue Montesquieu, (France)
<i>Troisième résolutioni>
Dans le cadre de l’exploitation d'une entreprise de couverture, charpente, ferblanterie, étanchéité, ainsi que l'achat et
la vente de toutes marchandises en général et notamment de tous articles et matériaux de la branche, la société est
valablement engagée par la signature des deux gérants.
Pour tout autre engagement la société est valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Claude FA-
MIANI, y compris pour constituer hypothèque et pour accorder mainlevée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique confirme que l’associé unique de la société est FAREI SERVICES S.A. et non pas FAREI-SERVICES S.A.
comme inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour avis sincère et conforme
Référence de publication: 2011029350/33.
(110034867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2011.
GE Capital Real Estate Polish Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 158.396.
En date du 18 janvier 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes avec effet au 10 janvier 2011:
- d'accepter la démission de Madame Catherine Baudhuin de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 10 janvier
2011;
- de fixer le nombre de gérants à 7 et de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat et
ce pour une durée indéterminée les personnes suivantes:
* Monsieur Jonathan KERN, né le 5 janvier 1962 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse profes-
sionnelle: GE Capital Real Estate, 280 Park Avenue, 8
th
Floor, 10017 New York, Etats-Unis d'Amérique;
* Monsieur Michael JORDAN, né le 9 avril 1951 à Worcester Massachussetts, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme
adresse professionnelle: 901 Main Avenue, Norwalk, Connecticut, 06851-1168, Etats-Unis d'Amérique;
* Monsieur Thierry LELEU, né le 11 décembre 1967 à Versailles, France, ayant comme adresse professionnelle: 2-4,
rue Pillet-Will, 75009 Paris, France;
* Monsieur Karol PILNIEWICZ, né le 27 Août 1978 à Czetochowa, Pologne, ayant comme adresse professionnelle:
Emilii Plater 53, 00-113 Varsovie, Pologne;
* Monsieur Lennart STEN, né le 18 mars 1959 à Partille, Suède, ayant comme adresse professionnelle: GE Real Estate
AB, 15 Kungsgatan, boîte postale 7154 10388 Stockholm, Suède;
* Monsieur Richard VLIET, né le 5 avril 1950 à Oklahoma, Etats-Unis d'Amérique, ayant comme adresse professionnelle:
2-4, rue Pillet-Will, 75009 Paris, France;
* Monsieur Piotr ZIARKOWSKI, né le 4 Août 1968 à Rawa Mazowiecka, Pologne, ayant comme adresse profession-
nelle: Emilii Plater 53, 00-113 Varsovie, Pologne.
Suite à ces résolutions, le conseil de gérance de la Société se compose désormais des personnes suivantes:
- Monsieur Jonathan KERN;
- Monsieur Michael JORDAN;
- Monsieur Thierry LELEU;
- Monsieur Karol PILNIEWICZ;
- Monsieur Lennart STEN;
35684
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Richard VLIET;
- Monsieur Piotr ZIARKOWSKI.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2011.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011017084/39.
(110020108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Ethofin S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 79.157.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 février 2011 que, Monsieur Michel Schaeffer, di-
recteur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé commissaire
aux comptes, pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Schmit, démissionnaire.
Luxembourg, le 11 février 2011.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011034266/15.
(110038144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
De Vlier Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 82.683.
L'an deux mille dix, le trente décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DE VLIER LUX S.A." (numéro
d'identité 2001 22 15 747), avec siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 82.683; constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial
C numéro 1228 du 24 décembre 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 9 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 22 du 22 janvier 2007 et suivant acte reçu par le notaire
Camille MINES, de résidence à Capellen, en date du 27 janvier 2009, publié au Mémorial C numéro 582 du 17 mars 2009.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert DE VOS, directeur financier, demeurant profession-
nellement à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant d'un million cent cinquante mille euros (€ 1.150.000.-)
pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (€ 100.000.-) à un million deux cent cinquante mille euros (€
1.250.000.-), avec émission de mille cent cinquante (1.150) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (€
1.000.-) chacune.
2) Renonciation par l'actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel.
3) Souscription et libération des mille cent cinquante (1.150) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire, à savoir
la société anonyme "EURETPARK S.A.", ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent.
4) Modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
35685
L
U X E M B O U R G
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'un million cent cinquante mille euros
(€ 1.150.000.-) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (€ 100.000.-) à un million deux cent cinquante
mille euros (€ 1.250.000.-), avec émission de mille cent cinquante (1.150) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille
euros (€ 1.000.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire actuel a renoncé à son droit de souscription préféren-
tiel, accepte la souscription des prédites mille cent cinquante (1.150) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille
euros (€ 1.000.-) chacune, par l'actionnaire majoritaire, à savoir la société anonyme "EURETPARK S.A.", ayant son siège
social à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, Centre Helfent.
Est ensuite intervenue la société "EURETPARK S.A.", préqualifiée,
ici représentée, conformément à l'article 12 des statuts, par un administrateur de catégorie A, à savoir Monsieur Hubert
DE VOS, prénommé et un administrateur de catégorie B, à savoir la société "ARBORETUM CONSULTING S.A." ayant
son siège social à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 134.567, cette dernière étant
elle-même représentée par Monsieur Hubert DE VOS, prénommé, en vertu d'une des procurations dont question ci-
dessus, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle intervenante, représentée comme dit ci-dessus, a déclaré souscrire aux mille cent cinquante (1.150) actions
nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000.-) chacune, et les libérer intégralement par des paiements en
espèces, de sorte que le montant d'un million cent cinquante mille euros (€ 1.150.000.-) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la prédite résolution, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
" Art. 5. al. 1
er
. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (€ 1.250.000.-), représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille euros (€ 1.000.-) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à environ deux mille deux cents euros (€ 2.200.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DE VOS, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 10 janvier 2011. Relation: CAP/2011/126. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 24 janvier 2011.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2011013289/79.
(110014963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.
35686
L
U X E M B O U R G
Société Luxembourgeoise ETAM, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 35, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 1.428.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 avril 2010i>
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Carine Huon, 349 Brusselsesteenweg, B-3020
Herent jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013. Elle pourra engager la société conjointement avec un autre
administrateur.
2. L'assemblée prend acte de la démission de M. Laurent Milchior de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
3. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013 la
société ETAM SCE SAS, 57-59 rue Henri Barbusse, F-92110 Clichy, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 450.966.445. La société ETAM SCE SAS sera représentée par M. Laurent MILCHIOR
domicilié 6, rue de Casteres F-92614 Clichy, et pourra engager la société conjointement avec un autre administrateur.
4. L'assemblée prend acte de la démission de la société CONSTANTIN-LUX Sàrl de sa fonction de commissaire avec
effet immédiat.
5. L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013 la
société VAN CAUTER-SNAUWAERT & CO S.à .R.L., 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B52610.
<i>Extrait dit procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mars 2010i>
1. Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Mme Carine Huon, 349
Brusselsesteenweg, B-3020 Herent jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013. Elle pourra engager la société
conjointement avec un autre administrateur.
2. Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat à L-1611 Luxem-
bourg, 35 avenue de la Gare.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2011028818/29.
(110035105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.
Elisenau Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.402.
DISSOLUTION
L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la
Guardia, N° 8 (République du Panama), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le
mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations
et constatations:
a.- Que la société anonyme holding "Elisenau Holding S.A.", avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.402, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1299 du 30 novembre 2005.
b.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par quinze
mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (2,-EUR) chacune.
c.- Que la comparante est le seul et unique actionnaire de ladite société.
d.- Que la comparante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
e.- Qu'il s'ensuit que ladite société "Elisenau Holding S.A." est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
f.- Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la
liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
35687
L
U X E M B O U R G
g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
h.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société
dissoute.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la
société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2010. Relation GRE/2010/4844. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 3 février 2011.
Référence de publication: 2011017583/44.
(110021436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
Modern Como S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 146.613.
L'an deux mille onze, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand- Duché de Luxembourg).
a comparu:
la société de droit luxembourgeois "EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A.", ayant son siège social au 22, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, ici valablement représentée par son administrateur unique, à savoir Maître Philippe MO-
RALES, avocat, demeurant à Luxembourg.
La personne comparante est l’actionnaire unique (l’ «Actionnaire Unique») de la société anonyme «MODERN COMO
S.A.» (la «Société»), ayant son siège social au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 146 613. La Société a
été constituée suivant acte notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER prénommé, en date du 9 juin 2009, acte publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1289 du 4 juillet 2009.
Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société a requis le notaire instrumentant
d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de nommer Maître Philippe Morales, avocat, demeurant au 22, avenue de la Liberté L-1930
Luxembourg en tant que seul liquidateur de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles
144 à 148 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le liquidateur est en outre dispensé de l'obligation de dresser un inventaire et se référera entièrement sur les livres
et documents financiers de la Société.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. MORALES, J.J. WAGNER.
35688
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1285. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011017155/37.
(110020175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
HF Immobilier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 2, rue de la Tour Jacob.
R.C.S. Luxembourg B 150.970.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2011i>
- L'assemblée a ratifié la cooptation de Messieurs Edmond LIBENS, administrateur de sociétés, né le 20 juillet 1979,
demeurant à L-1123 Luxembourg, 11, plateau Altmünster et Max MAILLIET, avocat à la Cour, né le 17 juin 1979, de-
meurant professionnellement à L-2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, en tant qu'Administrateurs en rempla-
cement de Messieurs Lucien EMRINGER, Pierre HIPPERT, Carlo SCHLESSER et Edmond MULLER, démissionnaires.
Fait à Luxembourg, le 25 février 2011.
Certifié sincère et conforme
HF IMMOBILIER S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011034092/17.
(110036670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.
Allibert Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 79.443.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of January.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Morgan Guaranty Trust Company Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales under
registration number 01162870 whose registered office is situated at 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK (the ”Sole
Shareholder"),
here represented by Mrs Marie Rouvière, private employee, with professional address at 6H, route de Trèves, L –
2633 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal, in London on January 21, 2011.
The said proxy, signed ne varietur, by the attorney in fact of the appearing party, in her hereabove capacity, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Which appearing party, represented as mentioned hereabove, has requested the notary to state as follows:
- That the company ALLIBERT VENTURES S. à r.l., a société à responsabilité limitée under Luxembourg law, with
registered office at 7, Val Sainte-Croix, L – 1371 Luxembourg, has been incorporated according to a deed received by
the notary André-Jean-Joseph Schwachtgen then residing in Luxembourg on December 12, 2000 published in the Mémorial
C under number 518 of July 10, 2001 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B79443 (the "Company").
- That the share capital of the Company is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) divided into 500
(five hundred) shares of a par value of EUR 25 (twenty-five Euros) per share.
- That the Sole Shareholder has acquired the totality of shares of the Company and that it has full knowledge of the
by laws and the financial situation of the Company.
- That Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the anticipate dissolution of
the Company and to put it into liquidation.
- That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary
to act its declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close
down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore it declares that with respect to possible liabilities of the
Company presently unknown, it irrevocably assumes to pay all such liabilities; that as a consequence of the above, all the
liabilities of the Company are paid.
- That the possible remaining net assets have been paid or will be paid to the Sole Shareholder.
35689
L
U X E M B O U R G
- That the liquidation is thus considered as accomplished and closed.
- That full discharge is granted to the Company's Manager.
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's
former registered office i.e. 7, Val Sainte Croix, L – 1371 Luxembourg.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-
istration.
Drawn up in Senningerberg, on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read in the language of the attorney in fact of the person appearing, acting in her hereabove
capacity, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person signed together
with the notary the present deed.
Suit la version française
L'an deux mil onze, le vingt-huitième jour de janvier.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Morgan Guaranty Trust Company Limited, une société constituée sous le droit anglais, avec numéro d'enregistrement
01162870 et dont le siège social est situé au 125 London Wall, Londres EC2Y 5AJ, Royaume Uni (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Madame Marie Rouvière, employée privée, demeurant professionnellement au 6H, route de Trèves,
L – 2633 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante es qualité qu'elle
agit et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la société dénommée ALLIBERT VENTURES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
avec siège social au 7, Val Sainte-Croix, L- 1371 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire André-
Jean-Joseph Schwachtgen, alors de résidence à Luxembourg en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro
518 du 10 juillet 2001 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
79443 (la "Société").
- Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.
- Que l'Associé Unique s'est rendu propriétaire de la totalité des parts de la Société et a parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la Société.
- Que les activités de la Société ayant cessé, l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation.
- Que l'Associé Unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instru-
mentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la
dite Société est réglé.
- Que l'actif restant éventuel est réparti ou sera réparti à l'Associé Unique.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société.
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société
à savoir au 7, Val Sainte-Croix, L- 1371 Luxembourg.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le
présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie
comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Lecture faite en langue du pays à la mandataire de la partie comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire
instrumentant par nom, prénom, état et demeure, celle-ci signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Marie Rouvière, Paul Bettingen.
35690
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1
er
février 2011 LAC / 2011 / Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 février 2011.
Référence de publication: 2011020064/95.
(110024077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.
TARLETON REAL ESTATE Partnership, S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 121.256.
DISSOLUTION
L'an deux mille dix, le seize décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société Prespa Holdings Limited, ayant son siège social à Second Floor Elizabeth House Les Ruettes Brayes St Peter
Port Guernsey,
ici dûment représentée par son mandataire Monsieur Tim SOUTHERN, administrateur de sociétés, résidant profes-
sionnellement à Second Floor Elizabeth House Les Ruettes Brayes St Peter Port Guernsey.
Laquelle comparante a, par son représentant susnommé, requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit
ses déclarations et constatations:
I.- Que la société en commandite simple Tarleton Real Estate Partnership S.e.c.s. ayant son siège social à L-1511
Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B,
numéro 121.256 a été constituée sous seing privé, en date du 11 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2378 du 20 décembre 2006.
II.- Que le capital social de la société en commandite simple Tarleton Real Estate Partnership S.e.c.s prédésignée, s'élève
actuellement à mille euros (1.000,-EUR), représenté par une (1) part sociale de commandité d'une valeur de neuf-cents
quarante-huit euros (948,-EUR) et une (1) part sociale de commanditaire d'une valeur de cinquante-deux euros (52,-EUR)
III.- Que la comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les parts de la susdite société Tarleton
Real Estate Partnership S.e.c.s
IV.- Que l'activité de la société Tarleton Real Estate Partnership S.e.c.s ayant cessé et que la comparante prononce la
dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
V.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la
société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.
VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.
VIII.- Que partant, la liquidation de la société en commandite simple Tarleton Real Estate Partnership S.e.c.s. est à
considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux associés commandités et aux associés commanditaires pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social de la société dissoute.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 750,EUR, sont à charge de la société dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Tim SOUTHERN, , Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2010. Relation GRE/2010/4664. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
35691
L
U X E M B O U R G
Junglinster, le 2 février 2011.
Référence de publication: 2011017242/49.
(110020027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Tucson S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 82.442.
DISSOLUTION
L'an deux mille dix, le vingt décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg,
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GEDAR S.A., ayant son siège social à Monrovia, 80 Broad
Street, Libéria,
"la mandante"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
1. Que la société anonyme TUCSON S.A., R.C.S. Luxembourg numéro B 82442, ayant son siège social à Luxembourg,
2, avenue Charles de Gaulle, a été constituée suivant un acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1168 du 28 novembre
2005.
2. Que le capital social de la société anonyme TUCSON S.A. s'élève actuellement à EUR 32.000 (trente-deux mille
euros), représenté par 320 (trois cent vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement
libérées.
3. Que la mandante est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital
souscrit de la société anonyme TUCSON S.A.
4. Que par la présente, la mandante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que la mandante, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme TUCSON S.A., déclare que tout le passif de
ladite société est réglé.
6. Que la mandante requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement
inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investie de tout l'actif et qu'elle réglera tout passif
éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation des actions de la société.
10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de FIGESTOR S.A.,
Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire précité a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Philippe PONSARD, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2010. Relation GRE/2010/4742. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 2 février 2011.
Référence de publication: 2011017247/49.
(110020510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
35692
L
U X E M B O U R G
Kestrel Participations S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 68.698.
- Constituée en date du 25 février 1999 suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L -
LUXEMBOURG, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°362 du 20 mai 1999;
- Statuts modifiés en date du 14 décembre 2009 suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C n°77 du 12 janvier 2010.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 7 octobre
2010 que:
- les mandats des membres du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont
renouvelés pour une période de six ans, à savoir:
<i>* aux postes d'administrateurs:i>
- Mme Mara DE BIASI, demeurant professionnellement à CH-6830 CHIASSO, Via d'Alberti, 4,
- Mme Silvia LAVIO-SCHNEIDER, demeurant professionnellement à CH-6830 CHIASSO, Via d'Alberti, 4,
- M. Nello LAVIO, demeurant professionnellement à CH-6830 CHIASSO, Via d'Alberti, 4.
<i>* au poste de commissaire aux comptes:i>
- JPCA LIMITED, avec siège social au 17 City Business Centre - Lower Road, GB-SE16 2XB Londres, immatriculée
sous le no 3350966 auprès du Companies House en Grande-Bretagne.
Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 7 mars 2011.
<i>Pour la société KESTREL PARTICIPATIONS S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2011034327/26.
(110038148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
Fondation époux Robert Wagener-Ettinger et époux Jean-Pierre Muller-Ettinger.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 42, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg G 93.
<i>Bilan au 31.12.2010i>
ACTIF
PASSIF
A) ACTIF IMMOBILISE
Don initial 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241 522,66 €
Don 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 095 741,41 €
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 337 264,07 €
B ACTIF CIRCULANT
Résultat des années antérieures . . . . . . 1 700 193,18 €
Compte courant BCEE . . . . . . . . . . . .
10 853,05 € Résultat de l'exercice 2010 . . . . . . . . . .
-18 627,65 €
Compte à terme BCEE . . . . . . . . . . . . 3 007 976,55 €
3 018 829,60 €
3 018 829,60 €
<i>Budget 2011i>
Groupes et catégories budgétaires
Montant
Recettes
R 142 Résultat de l'exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18.627,65 €
R 142 Résultat des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.627,65 €
R 75 Autres produits: Intérêts du compte à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 €
Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 €
Dépenses
C 6064 Fournitures administratives - Frais de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,00 €
- Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00 €
C 6238 Affectation des libéralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.500,00 €
C 650 Autres charges de gestion - Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 €
Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 €
35693
L
U X E M B O U R G
<i>Balance de vérification au 31 Dezember 2010i>
Débit €
Crédit €
108 Compte de l'exploitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 037 457 75
512 Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 018 829,60
512 Banque: Trf du compte à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 000,00
512 Banque: Trf sur compte courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 000,00
6064 Fournitures administratives: Droits d'enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,00
6238 Dons et pourboires: Affectation des libéralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 725,00
627 Services bancaires: Commission de compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
627 Services bancaires: Intérêts de dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,49
6615 Intérêts comptes courants: Intérêts débiteurs en compte courant . . . . . . . . . . . .
95,53
75 Autres produits: Intérêts créditeurs en compte courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,56
75 Autres produits: Intérêts du compte à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 281,81
Total général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 105 746,62 3 105 746,62
<i>Compte de résultati>
<i>Période se terminant le 31 Dezember 2010i>
€
€
Marge commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Production de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
C&R: Consommations en provenance des tiers
6064 Fournitures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,00
6238 Dons et pourboires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 725,00
627 Services bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67,49
39 819,49
Valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-39 819,49
Excédent brut d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 39 819,49
Autres produits
75 Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -21 287,37
-21 287,37
Résultat d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-18 532,12
Charges financières
6615 Intérêts comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95,53
95,53
Résultat courant avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-18 627,65
Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-18 627,65
<i>Bilan au 31 Dezember 2010i>
€
€
P: Capitaux propres
108 Compte de l'exploitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 037 457,25
12 Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-18 627,65
3 018 829,60
P: Dettes à long terme
0,00
Capitaux permanents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 018 829,60
P: Dettes à court terme
0,00
Total passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 018 829,60
P: Immobilisations incorporelles nettes
0,00
P: Immobilisations corporelles nettes
0,00
P: Immobilisations financières nettes
35694
L
U X E M B O U R G
0,00
Actif immobilisé net
0,00
P: Actif circulant
0,00
P: Disponibilités
512 Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 018 829,60
3 018 829,60
Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 018 829,60
Référence de publication: 2011013302/90.
(110014892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2011.
Fortis Luxembourg-Vie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 30.415.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 février 2011i>
Le Conseil d'Administration de la société anonyme Fortis Luxembourg -Vie s'est réuni à Luxembourg, au siège de la
société, sise Bvd Royal nr 16 à L - 2449 - Luxembourg en date du 24 février 2011 à 11.30 heures.
Suite à la démission de M. Dirk Billemon en tant qu'administrateur et de dirigeant agréé (Administrateur Directeur
général) à effet au 1
er
mars 2011, le Conseil d'Administration nomme M. Fabrice Bagne en tant que Administrateur-
Directeur Général de la société Fortis Luxembourg Vie S.A., chargé de la gestion journalière, avec effet au 1
er
mars 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2011.
<i>Pour la société
i>Bernard Guillaume
<i>Secrétaire Générali>
Référence de publication: 2011034082/18.
(110036759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.
Centaur Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 130.884.600,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 116.538.
Le conseil de gérance confirme le changement de nom de la rue du siège social de la Société à compter du 1
er
janvier
2011 de:
9 Parc d'Activité Syrdall, 5365 Munsbach, Luxembourg
en
9, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg
Le conseil de gérance confirme le changement de nom de la rue du siège social de l'associé Vuvuzela 1 Luxco S.à r.l.
à compter du 1
er
janvier 2011 de:
9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg
en
9, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg
Le conseil de gérance confirme le changement de nom de la rue du siège social de l'associé Vuvuzela 2 Luxco S.à r.l.
à compter du 1
er
janvier 2011 de:
9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg
en
9, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg
Le conseil de gérance confirme le changement de nom de la rue du siège social de l'associé Monkwood Luxco S.à r.l.
à compter du 1
er
janvier 2011 de:
9 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg
en
9, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg
35695
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Centaur Luxco S.à r.l.
Frank Welman
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2011020668/32.
(110024297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.
Invesrus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 147.648.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 février 2011:i>
L'Assemblée constate les démissions de Monsieur Pascal CLEMENT, demeurant 1, bould. 6, 4, Beregovaya str., Moscou
(RUSSIE) et de Madame Tatiana KIM, demeurant Flat 44, Build. 5, Oktiyabrskiy Lane, Moscou (RUSSIE) de leurs fonctions
d'administrateurs.
Elle appelle en remplacement Monsieur Olivier MARC, demeurant 7, rue de Colmar, F-33000 BORDEAUX et Mon-
sieur Philippe CASTEL, demeurant 2, route de la Maqueline, F-33460 MACAU, qui termineront les mandats en cours,
c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2011034100/17.
(110036614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.
Fersen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 73.768.
L'an deux mille dix, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société «FERSEN S.A.», ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, à L-2180 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce à Luxembourg sous la section B et le n° 73.768,
représentée aux fins des présentes par la Société européenne de Banque, société anonyme, 19/21, bld du Prince Henri,
elle-même représentés par M. Dominique AUDIA et M. Christophe VELLE, employés privés, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société en vertu d'un pouvoir donné en date du 20 décembre 2010 et dont
une copie restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
<i>Exposéi>
La société comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en
application de l'article 274 de la loi sur les sociétés telle que modifiée.
Elle constate:
Qu'en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,
la prédite société de droit luxembourgeois dénommée FERSEN S.A., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet à
L-2180 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le n° 73.768,
constituée par acte du notaire soussigné en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C n° 253 du 4 avril 2000,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en
date du 9 décembre 2002 publié au Mémorial C n° 91 du 29 janvier 2003,
au capital social de EUR 123.827.656 (cent vingt-trois millions huit cent vingt-sept mille six cent cinquante-six Euros),
représentée par 61.913.828 (soixante et un millions neuf cent treize mille huit cent vingt-huit) actions d’une valeur no-
minale de EUR 2 (deux Euros) chacune, entièrement libéré,
détenant l’intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois dénommée «AUDRIEU S.àr.l.», avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg,
35696
L
U X E M B O U R G
inscrite au R.C.S Luxembourg section B numéro 156.418, constituée par acte du notaire Maître Ana Maria Moreira
Vela Nóbrega Araújo, notaire de résidence à Funchal (Madeira),
et transférée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 2010,
en voie de publication au Mémorial C,
au capital social de EUR 12.500 (deuze mille cinq cent euros) représentée par cinq (cinq) parts sociales d’une valeur
nominale de EUR 2.500 (deux mille cinq cents Euros) chacune, entièrement libéré,
a absorbé cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte authentique reçu par le notaire soussigné
en date du 29 octobre 2010, publié au Mémorial C n° 2522 du 20 novembre 2010.
Qu'aucune approbation de la fusion, ni par réunion des associés de «AUDRIEU S.àr.l.», ni par l’assemblée générale de
«FERSEN S.A.», n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 ayant été observées. La fusion se trouvait réalisée un
mois après le 20 novembre 2010, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 2522 du 20 novembre
2010, aucun actionnaire de la société absorbante, n'ayant requis la convocation d'une assemblée.
La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
intégrées et consolidées par la société absorbante, a été fixée au 1
er
août 2010, sous réserve des droits des tiers.
Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée au 20 décembre 2010, et a entraîné de plein droit et simultanément
les effets visés à l'article 274, notamment:
- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble
du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la société absorbée AUDRIEU S.àr.l. a cessé d'exister.
Les frais des présentes sont à la charge de la Société.
Pour l'exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en son siège social à Luxembourg.
Le notaire soussigné, à la requête de la société absorbante, constate que les conditions de l’article 279 de la loi sur les
sociétés sont remplies.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et interprétation du présent acte faite à la comparante celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. AUDIA, Ch. VELLE, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 23 décembre 2010, LAC/2010/58338. Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): T. BENNING.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 janvier 2011.
Référence de publication: 2011013581/64.
(110016433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.
Commerzbank Finance 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 158.287.
In the year two thousand and ten on the seventh day of December,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette
There appeared:
Commerzbank AG, a credit institution organized under the laws of Germany, with registered office at Kaiserplatz,
60311 Frankfurt/Main, Germany, registered with Handelsregister Amtsgericht Frankfurt/Main under registration number
HRB 32000, acting through its Luxembourg Branch at 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg with registered
number B 119317, represented by Me Marie-Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal, which shall be annexed hereto.
Said proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The above mentioned entity is the sole participant of “Commerzbank Finance 3 S.à r.l.”, a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in the process
of being registered with the Register of Commerce of Luxembourg and having its registered office in 25, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, incorporated on December 1
st
, 2010 by deed of the undersigned notary, not yet published
in the Memorial C (the “Company”).
Which appearing person, acting in her above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as
follows:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting of the Company is the following:
35697
L
U X E M B O U R G
Amendment of the fourth paragraph of article 6 of the Company’s articles of association (all other provisions remaining
unchanged) so as to read:
“Art. 6. (…)
The board of managers is hereby authorised to issue further parts so as to bring the total capital of the company up
to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such parts within a period of five (5) years from the date of incorporation of the company.
(…)”.
II. That the extraordinary general meeting of the Company, consisting of the above mentioned sole participant, has
taken the following resolution:
<i>Resolutioni>
The general meeting of the Company resolved to amend the fourth paragraph of article 6 of the Company’s articles
of association (all other provisions remaining unchanged) so as to read:
“Art. 6. (…)
The board of managers is hereby authorised to issue further parts so as to bring the total capital of the company up
to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such parts within a period of five (5) years from the date of incorporation of the company.
(…)”.
Nothing else being on the agenda, the meeting was adjourned.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (€ 1,000.-)
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set out at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by first and surnames, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version
L’an deux mille dix, le sept décembre,
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette
A comparu:
Commerzbank AG, un établissement de crédit organisé selon le droit allemand, avec siège social à Kaiserplatz, 60311
Frankfurt/Main, Allemagne, immatriculée auprès du Handelsregister Amtsgericht Frankfurt/Main sous le numéro d’im-
matriculation HRB 32000, agissant par sa succursale luxembourgeoise au 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
avec numéro d’immatriculation B 119317, représentée par Me Marie-Claude Frank, avocat à la Cour, demeurant à Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être
enregistrée avec celui-ci.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte aux fins d'enregistrement.
La société susmentionnée est l’associé unique de “Commerzbank Finance 3 S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit luxembourgeois en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg et dont le siège social est établi au 25, rue Edward Steichen, L_2540 Luxembourg, constituée en date du
1
er
décembre 2010 par acte du notaire instrumentant, non encore publié dans le Mémorial C (la «Société»).
Laquelle personne comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d’acter comme suit:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la Société est le suivant:
Modification du quatrième paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société (toute autre disposition demeurant in-
changée) comme suit:
«Art. 6. (…)
Le conseil de gérance est autorisé à émettre d’autres parts sociales afin de ramener le capital total de la société au
capital total autorisé de la société en tout ou en partie de temps à autre de manière discrétionnaire et d’accepter des
souscriptions pour de telles parts sociales dans une période de cinq (5) ans à partir de la date de constitution de la société.
(…)».
35698
L
U X E M B O U R G
II. Que l’assemblée générale extraordinaire de la Société, consistant en l’associé unique susmentionné, a pris la décision
suivante:
<i>Décisioni>
L’assemblée générale de la Société a pris la décision de modifier le quatrième paragraphe de l’article 6 des statuts de
la Société (toute autre disposition demeurant inchangée) comme suit:
«Art. 6. (…)
Le conseil de gérance est autorisé à émettre d’autres parts sociales afin de ramener le capital total de la société au
capital total autorisé de la société en tout ou en partie de temps à autre de manière discrétionnaire et d’accepter des
souscriptions pour de telles parts sociales dans une période de cinq (5) ans à partir de la date de constitution de la société.
(…)».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est close.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelle forme que ce soit, qui seront supportés par la Société suite au
présent acte sont estimés à approximativement mille euros (€ 1.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, expose que, sur demande de la personne comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise et suivi par une version en langue française. Sur demande de la même personne
comparante et dans l'hypothèse de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
En foi de quoi le présent acte a été passé à Luxembourg à la date mentionnée au début du présent acte.
Le présent acte ayant été lu à la personne comparante, que le notaire connaît par prénoms et noms, état civil et
résidence, ladite personne comparante a signé le présent acte conjointement avec le notaire.
Signé: Frank, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16058. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2011013519/102.
(110015710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2011.
La Montagne de Beaulieu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 142.576.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 2011 qu'il a été procédé à une reconstitution
des organes sociaux et qu'ont été:
a) renommés administrateurs
- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
- Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse, professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
b) nommé administrateur
- Monsieur Nicolas SCHAEFFER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve, en remplacement de Monsieur Gérard ZAPPA
c) nommé commissaire aux comptes
- Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont, en remplacement de Monsieur Pierre SCHMIT
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2016.
Luxembourg, le 2 mars 2011.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2011034333/26.
(110038146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
35699
L
U X E M B O U R G
D.P. Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4710 Pétange, 156, rue d'Athus.
R.C.S. Luxembourg B 62.455.
L'an deux mil onze, le onze janvier.
Par devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Abdallah BENJEAA, né à Salé (Maroc), le 5 octobre 1959, demeurant à B 6791 Athus, Quartier Schlauss
numéro 5, (propriétaire de 49 actions), agissant en nom personnel et au nom et pour compte de:
Monsieur Jean-Paul MARANGONI, né à Charleroi (B), le 4 décembre 1958, demeurant à B 4040 Herstal, rue Nicolas
Defraîcheux, numéro 146, (propriétaire de 1 action)
en vertu d'une procuration annexée au présent acte
agissant en leurs qualité d'uniques actionnaires de la société P.P. CONSULT S.A., avec siège à L- 4710 Pétange, 156,
rue d'Atnus (RCS B No 62.455); constituée suivant acte notarié du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C No 235 du
10 avril 1998,
Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter la modification suivante:
<i>Modification de l'objet sociali>
Les comparants entendent donner la teneur suivante à l'article 4 des statuts:
Art. 4. La société a pour objet.
- la société a pour objet toutes opérations de courtage en assurance conformément aux dispositions de la loi modifiée
du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées;
- la prestation de travaux administratifs, l'organisation de services comptables et marketing, le conseil en ces matières,
la tenue de la comptabilité et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales, à
l'exception toutefois de travaux d'expertise comptable;
- ainsi que l'acquisition, l'échange, la vente, la location d'immeubles, bâtis ou non bâtis, la prise à bail, tant pour son
propre compte que pour compte de tiers.
La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises
similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
La société peut d'une façon générale faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement.
Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements
à d'autres personnes physiques ou morales.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent dix euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: BENJEAA, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1063. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME
Pétange, le 27 janvier 2011.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2011017377/45.
(110020029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Fitair Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 71.216.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011034285/9.
(110038368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
35700
L
U X E M B O U R G
Colways Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 106.495.
L’an deux mille onze, le vingt-six janvier.
Par-devant le soussigné Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, demeurant professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
agissant en qualité de mandataire de la société ZED TRADE CO. CORP., ayant son siège social à Samuel Lewis Avenue
and 58
th
Street, ADR Tower, Office 600-A, City of Panama, Republic of Panama, en vertu d’une procuration qui est
restée annexée à un acte du notaire instrumentaire en date du 30 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 106.495.
Lequel a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Par acte en date du 30 décembre 2010, enregistré à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de Luxem-
bourg en date du 10 janvier 2011, avec les relations suivantes: LAC/2011/1452 et déposé au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg le 18 janvier 2011 et portant la référence L110010682, numéro 3020 de son répertoire, a
été tenu un acte de dissolution de la société anonyme dénommée COLWAYS INVESTMENTS S.A. avec siège social à
L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu’une erreur matérielle a été commise quant au nom et à l’adresse
de l’actionnaire et partout où il est fait référence à l’actionnaire ZED TRADE LLC, ayant son siège social au 25, Greystone
Manor, Lewes Delaware 19958, County of Sussex, il y a lieu de lire ZED TRADE CO. CORP., ayant son siège social à
Samuel Lewis Avenue and 58
th
Street, ADR Tower, Office 600-A, City of Panama, Republic of Panama.
Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture de l'acte faite au comparant, il a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Sabella et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4651. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR COPIE CONFORME , délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2011.
Référence de publication: 2011017554/35.
(110020786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
Le Kelie S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6142 Junglinster, 68, rue du Rham.
R.C.S. Luxembourg B 86.594.
DISSOLUTION
L'an deux mil onze, le dix-huit janvier.
Par devant Maître Georges d"HUART, notaire de résidence à Pétange
A comparu:
Monsieur Paul DIEDERICH; comptable, demeurant à L- 8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid, agissant au nom et pour
compte de:
- Monsieur Dominique MAGUER; cafetier, né le 29 août 1967 à Quimper (F), demeurant à L- 6225 Altrier, 41, Op der
Schanz,
en vertu d'une procuration annexée au présent acte.
Lequel comparant a prié le notaire d'acter:
- qu'il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LE KELIE S.àr.l. avec siège à L- 6142 Junglinster,
68, rue Rham, (RCS Luxembourg B 86.594), constituée suivant suivant acte notarié du 15 mars 2002, publié au Mémorial
C No 947 du 21 juin 2002.
- que le soussigné est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de ladite société.
35701
L
U X E M B O U R G
- qu'en tant qu'associé unique, le soussigné déclare expressément procéder à la dissolution de la société, avec effet
rétroactif au 31 décembre 2010.
- qu'il déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait
qu'il répond personnellement du passif inconnu et de tous les engagements sociaux.
- que le soussigné donne décharge au gérant de la société.
- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au domicile du comparant,
Monsieur Dominique MAGUER, avec effet rétroactif au 31 décembre 2010.
Le notaire a donné acte de la liquidation et de la dissolution de ladite société.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: DIEDERICH, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 25 janvier 2011. Relation: EAC/2011/1062. Reçu: soixante-quinze euros. EUR 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME
Pétange, le 27 janvier 2011.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2011017436/38.
(110020287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Ades S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 71.317.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 mars 2011i>
L'assemblée générale approuve la démission de Itaglio Services Ltd de sa fonction de liquidateur de la Société avec
effet immédiat.
L'assemblée générale décide de nommer HEADSTART MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B155181, ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers L-1835 Luxembourg, à la fonction de liquidateur de la Société
avec effet immédiat.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2011034159/16.
(110038547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
Résidence des Iris, Société Civile.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 13, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg E 2.459.
DISSOLUTION
L'an deux mil dix, le vingt-trois décembre.
Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Joseph WOLTER; docteur en droit, né à Luxembourg, le 22 février 1939 (1939 02 22 214), et son
épouse,
2) Madame Jeannine SCHULER, femme au foyer, née à Luxembourg, le 15 juillet 1945 (1945 07 15 282), les deux
demeurant à L- 2715 Luxembourg, 16, rue Walram,
ici représentés par Monsieur Anouar BELLI; demeurant professionnellement à L- 2146 Luxembourg, 63-65, rue de
Merl,
en vertu de deux procuration annexées au présent acte.
Ils sont les seuls associés (suite à une cession de parts annexée au présent acte) de la société civile immobilière
Résidence des Iris, avec siège à L- 1411 Luxembourg, 13, rue des Dahlias, (RCS Luxembourg E 2459), constituée suivant
35702
L
U X E M B O U R G
acte notarié du 23 mars 1998, publié au Mémorial C No 473 du 29 juin 1998, et demandent au notaire instrumentaire
de constater la dissolution de la société.
La liquidation a d'ores et déjà été opérée et les époux WOLTER-SCHULER déclarent formellement assumer person-
nellement tous éléments actifs et passifs de la société dissoute.
Les documents resteront pendant le délai de 5 ans au domicile desdits époux WOLTER-SCHULER:
La prédite société est propriétaire d'un rez-de-chaussée commercial dans une maison d'habitation sise à L-1411 Lu-
xembourg, 13, rue des Dahlias, inscrite au cadastre comme suit:
COMMUNE DE HOLLERICH, (ancienne Commune de Hollerich), Section HoF DE MERL-NORD
Numéro 590/2712, «rue Albert Philippe», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 5 ares 13 centiares, dont
369,128/1.000
<i>Origine de propriétéi>
Ladite société a acquis ledit appartement des époux Léon KINNEN-THILL; en vertu d'un acte de vente, reçu par le
notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1998, transcrit à Luxembourg 1
er
, le 17
avril 1998, volume 1541, Numéro 7.
Par la dissolution de la société civile immobilière Résidence des Iris, le prédit rez-de-chaussée commercial cadastré
comme ci-dessus appartient pour moitié à chacun des époux Jean-Joseph WOLTER et Jeannine SCHULER, préqualifiés,
de même que la dette hypothécaire afférente auprès de la FORTUNA.
Le prédit rez-de-chaussée commercial est estimé à 800.000.-€.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de neuf cent quatre-vingt-quinze euro.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: BELLI, d'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 janvier 2011. Relation: EAC/2011/130. Reçu soixante-quinze euros. 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME
PETANGE, le 24 janvier 2011.
Georges d'HUART.
Référence de publication: 2011017460/47.
(110020283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Ambiance S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9806 Hosingen, 42, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 151.710.
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du
18 février 2010, publié Mémorial C numéro 783 du 15 avril 2010,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 151.710
au capital social de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES
d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune
EXTRAIT
Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire prénommé, en date du 08 décembre 2010,
enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2010, relation: EAC/2010/16026,
- que Madame Anna PALMISANO, commerçante, née à Sammichele Di Bari (Italie), le 05 avril 1959, demeurant à
L-1531 Luxembourg, 26, rue de la Fonderie a cédé ses TRENTE (30) parts sociales à Monsieur Hasan YAGBASAN,
restaurateur, né à Bafi (Turquie), le 01 janvier 1965, demeurant à L-9806 Hosingen, 42, Haapstrooss,
- Madame Ceylan YAGBASAN, serveuse, née à Idil (Turquie), le 03 octobre 1989, demeurant à L-9806 Hosingen, 42,
Haaptstrooss a cédé ses SOIXANTE-DIX (70) parts sociales à Monsieur Hasan YAGBASAN, restaurateur, né à Bafi
(Turquie), le 01 janvier 1965, demeurant à L-9806 Hosingen, 42, Haapstrooss,
- que suite à aux cessions de parts sociales, les parts sociales sont détenues comme suit:
Monsieur Hasan YAGBASAN, restaurateur, né à Bafi (Turquie), le 01 janvier 1965, demeurant à
L-9806 Hosingen, 42, Haapstrooss, CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
35703
L
U X E M B O U R G
- que la démission de Madame Anna PALMISANO, prénommée, en tant que gérant technique de la société a été
acceptée,
- que la démission de Madame Ceylan YAGBASAN, prénommée, en tant que gérante administrative de la société a
été acceptée,
- que Monsieur Hasan YAGBASAN, prénommé, a été nommé en tant que gérant de la société.
- que la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 6 janvier 2011.
Référence de publication: 2011017516/34.
(110021461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
RP Medicentre S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 124.837.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 janvier 2011 à 12h00i>
L'Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de M. Michaël Astarita, Gérant A, et décide de nommer en
remplacement comme gérant A pour une durée illimitée:
Monsieur Fess Wofse,
399, Park Avenue, 7
th
floor, New-York NY 10022 (USA)
L'Assemblée Générale des Associés accepte la démission de M. Edouard Georges, Gérant B, et décide de nommer en
remplacement comme gérant B pour une durée illimitée:
Monsieur Jérôme Wünsch
34a, Bd. Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Pour copie conforme
RP MEDICENTRE S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2011034129/20.
(110036930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2011.
Inter Marine Investment Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 46.160.
DISSOLUTION
L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
WHITE DEVELOPMENT CORP la société ayant son siège social à Salduba Building, Urbanizacion Obarrio, Calle 53,
Este Apartado, Postal 7284, 5 Panama-City, République de Panama
ici représentée par Madame Annie SWETENHAM, Corporate Advisor, avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons-Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit
ses déclarations et constatations:
a) Que la société anonyme holding “INTER MARINE INVESTMENT HOLDING S.A.”, (ci-après la "Société"), avec siège
social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 46.160, a été constituée originairement sous le nom de Garda S.A., suivant acte reçu
par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 102 du 19 mars 1994. Les statuts ont
35704
L
U X E M B O U R G
été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le même notaire en date du 20 juin 2002 publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1294 du 6 septembre 2002
b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de deux cent vingt-huit mille (228.000,-) euros (EUR), divisé
en deux cent vingt-huit (228) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune, entièrement libérées.
c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions
de la Société.
d) Que l'activité de la Société ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec
effet immédiat et sa mise en liquidation.
e) Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
f) Que la partie comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article
151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après
l'autre.
g) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, la comparante requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare
avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
h) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.
i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par Monsieur Marco RIES, réviseur d'entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons-Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, désigné "commissaire-vérificateur" par l'actionnaire uni-
que de la Société.
j) Que la comparante approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au commissaire-véri-
ficateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
k) Que la comparante, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la
Société a définitivement cessé d'exister.
l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société.
n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social au 231, Val des Bons-Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 950,-EUR et la partie
comparante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Annie SWETENHAM, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation GRE/2010/4703. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME
Junglinster, le 2 février 2011.
Référence de publication: 2011017111/66.
(110020370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2011.
Saint Guy Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 119.337.
L'an deux mil dix, le vingt-huit décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Forbach Invest S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer,
R.C.S. Luxembourg B 119224,
ici représentée par Madame Aurélie WOJAS-ZEIMETH, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
35705
L
U X E M B O U R G
en vertu d’une procuration datée du 24 décembre 2010.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Saint Guy Immo S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 août 2006,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2056 du 3 novembre 2006. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 30 novembre 2007, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 279 du 2 février 2008;
- Qu'elle a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associée unique décide d’insérer un nouveau paragraphe à l’article 17 des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
" Art. 17. Troisième paragraphe. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions
suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) sur recommandation du Conseil, la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les
associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand ten, on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Forbach Invest S.à r.l., having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer, R.C.S. Luxembourg B
119224,
here represented by Ms Aurélie WOJAS-ZEIMETH, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 24, 2010.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, Forbach Invest S.à r.l., prenamed, is the sole actual shareholder of Saint Guy Immo S.à r.l. a société à responsabilité
limitée, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer, incorporated by a deed of the undersigned
on August 22, 2006, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 2056 of November 3, 2006.
The articles of Association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on November 30,
2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 279 of 2 February 2008;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder decides to insert a new paragraph to article 17 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
35706
L
U X E M B O U R G
“ Art. 17. Third paragraph. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) subject to the proposal of the Board, the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders
within two (2) months from the date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately ONE THOUSAND EURO (1.000.- EUR).
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, she signed together with the notary the present original deed.
Signé: A.WOJAS-ZEIMETH, G.LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59738. Reçu: soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): T.BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2011.
Référence de publication: 2011014263/91.
(110016412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2011.
Lag International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 111.026.
L’an deux mille dix, le deux juillet.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Gentiane PREAUX, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Char-
les de Gaulle.
Laquelle comparante, ayant agi comme mandataire spéciale de tous les actionnaires lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 25 juin 2010 de la société anonyme LAG INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 9, rue du
Laboratoire, L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous
le numéro 111.026, en vertu des procurations qui sont restées annexées à la prédite assemblée générale extraordinaire
documentée par acte du notaire soussigné, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il a été omis d'insérer lors de la
refonte des statuts un 5
ème
alinéa à l'article 19 des statuts, relatif aux droits attachés aux actions privilégiées, lequel aura
la teneur suivante:
«Les actions privilégiées de la catégorie B donnent droit à un dividende privilégié récupérable, égal à 5% de leur valeur
nominale, sans préjudice de leur droit dans la répartition pari passu avec les autres actions du surplus des bénéfices.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Gentiane PRÉAUX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 juillet 2010. Relation GRE/2010/2390. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
35707
L
U X E M B O U R G
Junglinster, le 30 décembre 2010.
Référence de publication: 2011018357/28.
(110021647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2011.
Bei der Kapell, Société Civile.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, route d'Eschdorf.
R.C.S. Luxembourg E 586.
L'an deux mille dix, le quinze décembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
1.- Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, né à Luxembourg, le 28 février 1960, demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre,
29, rue d'Eschdorf;
2.- Madame Isabelle HERMAN, employée privée, née à Tournai (Belgique) le 17 novembre 1958, demeurant à L-9650
Esch-sur-Sûre, 29, rue d'Eschdorf
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société civile immobilière BEI DER KAPELL, avec siège
social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 23, rue d'Eschdorf,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro E 586,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27
novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 98 du 18 février 1999,
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Emile
Schlesser, notaire prénommé, en date du 23 avril 2004, publié au Mémorial C numéro 546 du 7 juin 2005,
dont le capital social de CENT QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (€ 143.000,-), représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS (€ 1.430,-) chacune est reparti comme
suit:
1.- Monsieur Gilles KINTZELE, prénommé, QUATRE-VINGTS PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2.- Madame Isabelle HERMAN, prénommée, VINGT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Le paragraphe suivant est rajouté à l'article un (1) des statuts relatif à l'objet social de la société après le premier alinéa
comme suit:
"Elle pourra se porter caution à titre personnel et réel pour des sociétés dans lesquelles l'associé unique ou les associés
détiennent la majorité du capital, ainsi que pour cautionner des engagements de ses associés."
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et près lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signés avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Kintzele, Herman, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16134. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011017540/39.
(110021411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
Hurca Investment Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 61.149.
EXTRAIT
En date du 7 juin 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a approuvé les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est transféré du «12 rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg» au «15 rue Edward Steichen
à L-2540 Luxembourg».
2. Le mandat de Monsieur Stefan Müller en tant qu’Administrateur est renouvelé avec effet au 1
er
juin 2009, pour une
période de cinq ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2014.
35708
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 7 juin 2010.
Référence de publication: 2011034309/15.
(110038552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2011.
NVB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 139.459.
In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NVB S.A., a public liability company incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Thomas Edison L-1445 Strassen and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139.459 (the “Company”). The Company has
been incorporated by deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg on 11 June 2008 and published
in the ‘Mémorial C' number 1671 of 8 July 2008.
The meeting is presided by Me Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Me Nicolas RONZEL, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Me Matthias PONS, avocat, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to
state that:
I. - The shareholders of the Company present or represented at the meeting and the number of shares they hold are
indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the repre-
sentatives of the shareholders and the members of the bureau.
The proxies from the shareholders of the Company represented at the present Meeting will also remain attached to
the present minutes and signed by all the parties.
II. - It appears from the attendance list that all the one thousand (1,000) shares with a par value of one Euro (€ 100.-)
each, representing the entire capital of the Company of one hundred thousand Euros (€ 100,000.-), are represented at
the present meeting. All shareholders have waived convening requirements in the proxies.
III. - The meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the shareholders
have been advised in advance.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company from its current registered office to the following address: 26-28
rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, with effect as of 29 December 2010.
2. Amendment of the first paragraph of article 2 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above transfer of register office.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to transfer the registered office of the Company from its current re-
gistered seat to the following address: 26-28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, with effect as of 29 December 2010.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend the first paragraph of article 2 of the articles of association of the Company
in order to reflect the above resolution as follows:
“Le siège de la société est établi à Luxembourg.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at EUR 1,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
35709
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the appearing persons, all of whom are know to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Follows the french version
L'an deux mille dix, le vingt-neuf décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de NVB S.A., une société anonyme, avec siège social au
7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 139.459 (la “Société”). La Société a été constituée suivant acte reçu par Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence
à Luxembourg, le 11 juin 2008, publié au Mémorial C, numéro 1671 le 8 juillet 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Me Marcus PETER, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Me Nicolas RONZEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Me Matthias PONS, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant été valablement constitué, le président expose et prie le notaire soussigné d'acter:
I. - Les actionnaires de la Société présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent
sont indiqués sur une liste de présences qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les
représentants des actionnaires ainsi que par les membres du bureau.
Les procurations des actionnaires de la Société représentés à la présente Assemblée resteront également annexées
au présent procès-verbal après avoir été signées par toutes les parties.
II. - Qu'il apparaît de cette liste de présence que l'intégralité des mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale
de cent Euro (EUR 100,-) chacune, représentant l'entier capital social de cent mille Euros (EUR 100.000,-) de la Société
sont représentées à la présente assemblée générale. Tous les associés ont renoncé aux formalités de convocation dans
les procurations.
III. - Que l'assemblée est par conséquent valablement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont les associés ont été informés avant l'assemblée.
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la Société de son siège actuel à l'adresse suivante: 26-28 rives de Clausen, L-2165
Luxembourg, prenant effet à partir du 29 décembre 2010.
2. Modification du premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le transfert de siège social
mentionné ci-dessus.
L'assemblée générale, après délibération, prend unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social de la Société de son siège actuel à l'adresse
suivante: 26-28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, prenant effet à partir du 29 décembre 2010.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société
afin de refléter la première résolution de cette façon:
“Le siège de la société est établi à Luxembourg.”
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.000.-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. PETER, N. RONZEL, M. PONS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/232. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
35710
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 7 février 2011.
Référence de publication: 2011019702/103.
(110023773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.
OI-Paper S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.211.
L'an deux mille onze, le premier février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société d'investissement en capital à risque sous la forme d'une société en commandite par actions “Orlando Italy
Special Situations SICAR (SCA)”, établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31 Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116814,
ici représentée par Madame Carole FARINE, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration,
signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société anonyme “OI-Paper S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
157211, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 novembre 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 161 du 26 janvier 2011;
-Que la partie comparante est le seul actionnaire actuel (l'"Actionnaire Unique") de la Société et qu'elle a pris, par sa
mandataire, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'échanger les trois mille cent (3.100) actions existantes contre trois mille cent (3.100)
Actions Ordinaires de Classe A (les Actions de Classe A) d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et de
modifier subséquemment le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:
Version anglaise:
" 5.1. The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided into 3,100 (three
thousand one hundred) Ordinary Class A Shares at a par value of EUR 10.- (ten Euros) each."
Version française:
" 5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 3.100 (trois mille cents)
Actions Ordinaires de Classe A d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. FARINE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2011 LAC/2011/5649. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 4 février 2011.
Référence de publication: 2011019101/47.
(110022931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.
35711
L
U X E M B O U R G
Elster Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 109.413.
DISSOLUTION
L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la
Guardia, N° 8 (République du Panama), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le
mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations
et constatations:
a.- Que la société anonyme holding "ELSTER HOLDING S.A.", avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guil-
laume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.413, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1291 du 29 novembre 2005.
b.- Que le capital social a été fixé lors de la constitution à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par quinze
mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (2,-EUR) chacune.
c.- Que la comparante est le seul et unique actionnaire de ladite société.
d.- Que la comparante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
e.- Qu'il s'ensuit que ladite société "ELSTER HOLDING S.A." est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
f.- Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la
liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
h.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société
dissoute.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la
société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2010. Relation GRE/2010/4838. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME
Junglinster, le 3 février 2011.
Référence de publication: 2011017584/44.
(110021012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
PATIMA ELECTRO CENTER, Distribution-Réparations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7766 Bissen, 66, route de Colmar.
R.C.S. Luxembourg B 25.207.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011028388/10.
(110034486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35712
Ades S.A.
Allibert Ventures S.à r.l.
Ambiance S. à r.l.
Bei der Kapell
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF
Centaur Luxco S.à r.l.
Colways Investments S.A.
Commerzbank Finance 3 S.à r.l.
D.A. Constructions S.à r.l.
De Vlier Lux S.A.
D.P. Consult S.A.
Elckerlyc S.à r.l.
Elisenau Holding S.A.
Elster Holding S.A.
Ethofin S.A. SPF
Fersen S.A.
Fitair Luxembourg
Flantermaus
Fondation époux Robert Wagener-Ettinger et époux Jean-Pierre Muller-Ettinger
Fortis Luxembourg-Vie S.A.
GE Capital Real Estate Polish Retail S.à r.l.
HF Immobilier S.A.
Hurca Investment Holding SPF S.A.
Ideal Toitures
Inter Marine Investment Holding S.A.
Invesrus S.A.
Kestrel Participations S.A.
Lag International S.A.
La Montagne de Beaulieu S.A.
Le Kelie S.àr.l.
Modern Como S.A.
NVB S.A.
OI-Paper S.A.
Ossiam Lux
PATIMA ELECTRO CENTER, Distribution-Réparations
Résidence des Iris
RP Bergen S.à r.l.
RP Medicentre S.à r.l.
Saint Guy Immo S.à r.l.
Société Luxembourgeoise ETAM
Squale Investissements S.A.
TARLETON REAL ESTATE Partnership, S.e.c.s.
Tucson S.A.
Valentin Capital Management Holding S.A.H.
Valentin Capital Management S.A.