logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 680

9 avril 2011

SOMMAIRE

4U Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32633

Amber Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32637

Ananas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32637

APERAM HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

32639

APERAM Sourcing S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . .

32636

APERAM Treasury S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

32639

Arctic Lake S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32640

Arjufra Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

32633

A. Rolf Larsen Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

32634

Artmarkt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32633

Astriger Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32634

Audit Value International S.A.  . . . . . . . . . .

32640

Aviva Investors Portefeuille II  . . . . . . . . . . .

32639

Avolon Holding Corporation (Luxem-

bourg) II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32637

Banco Popolare Luxembourg S.A.  . . . . . . .

32640

CMP German Opportunity Fund II (SCA)

SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32594

Elite S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32640

Medinvest International (Invecom Manage-

ment) S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32636

Michel Albert Investissements S.A.  . . . . . .

32617

Milleknapp S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32594

Nivard S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32624

Orfeo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32594

People Skill S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32618

Pol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32618

Polychord S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32618

Potosi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32619

Pranceworth Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . . .

32619

Quattro Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

32619

Ribeaumont Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

32629

Ribeaumont Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . .

32629

Rootness S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32620

Saint-James Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32620

Sami-Bau G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32618

S A S Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32619

Savelec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32621

SBSM S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32618

Schmit & Klein Invest SA  . . . . . . . . . . . . . . .

32621

Silvretta Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

32621

Snera Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32620

Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32620

Spes Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32621

Syrius S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32622

Triplane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32622

TTC Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32622

Um Gruew S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32623

Unistar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32623

Usines Roboto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32623

VAN GEET, DERICK & Co, réviseurs d'en-

treprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32623

Venoplas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32624

Veroninvest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

32624

Versale Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

32627

Villa Romaine Immobilière S.A.  . . . . . . . . .

32628

VoiceCom GmbH (S.à r.l.)  . . . . . . . . . . . . . .

32623

Wollbuttek S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32628

World Power Holdings Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32628

World Trade Polymers S.A. . . . . . . . . . . . . .

32628

Xenon Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

32633

32593

L

U X E M B O U R G

Milleknapp S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9772 Troine, Maison 89.

R.C.S. Luxembourg B 135.433.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011028370/10.
(110034142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Orfeo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 28, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 39.964.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028379/10.
(110034414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.131.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) CMP German Opportunity, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg with its

registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg
trade and companies register, as managing general partner of CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR; and

2) CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR, a société en commandite simple (S.C.S.), organized as a

société d'investissement en capital à risque, incorporated under the laws of Luxembourg with its registered office at 7A,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg trade and companies
register; represented by its managing partner CMP German Opportunity, as limited partner.

Both parties are here represented by Me Hana Witzke, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg,

pursuant to proxies given on December 22, 2010.

The proxies signed “ne varietur” by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation (the “Articles”) of a Company formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite
par actions), which they form between themselves:

<i>Definitions

“Articles” shall mean the articles of association of the Company pursuant to this deed.
“Associate” shall mean in relation to any individual or undertaking (“U”), a parent undertaking of U, a subsidiary

undertaking of U, a subsidiary undertaking of a parent undertaking of U, any undertaking directly or indirectly controlled
by U, or any undertaking which directly or indirectly controls U. Members of CMP shall be considered to be Associates
of each other.

“Business Day” shall mean any day when banks in Luxembourg are open to the public.
“Capital Call” shall mean the written notification from the General Partner to the Shareholders to subscribe Shares

pursuant to their Capital Commitments upon not less than 10 Business Days advance notice.

“Capital Commitments” shall mean the maximum amount (denominated in Euro) contributed or agreed to be con-

tributed  to  the  Company  by  a  Shareholder  by  way  of  subscription  for  Limited  Partner  Shares  pursuant  to  such
Shareholder's Subscription Certificate.

32594

L

U X E M B O U R G

“Cause” shall mean (i) the material breach by CMP of any of their obligations under the Prospectus or these Articles

or any side letter by CMP, which is not cured within [thirty (30) days] of notice from any Shareholder requiring that such
breach be cured (ii) the gross negligence, willful misconduct, fraud, bad faith or reckless disregard by CMP, (iii) the
insolvency, administration, involuntary reorganization and bankruptcy of the General Partner (iv) or the failure by the
General Partner to recommend a proposal on the future management of the Company in case of departure of a Key
Person.

“Classes” shall mean the classes of Shares as might be issued by the Company.
“CMP” shall mean (i) the General Partner, (ii) CMP Capital Management-Partners GmbH (Berlin), (iii) the Associates

of the General Partner, (iv) any of their respective managing shareholders or partners and employees as well as (v) the
Key Persons.

“Commercial Companies Law” shall mean the law of the Grand Duchy of Luxembourg as of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended.

“Company” shall mean CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, an investment company in risk capital formed

as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) in Luxembourg.

“CSSF” shall mean the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg financial supervisory au-

thority.

“Custodian” has the meaning ascribed to it in § 25.
“Final Closing” shall mean the end of the subscription period, being earlier of (i) the expiry of an eighteen (18) month

period after the First Closing provided that the General Partner may with the approval of the Fund SCS extend such
eighteen (18) month period for an additional six (6) month period and (ii) the date specified by the General Partner as
the Final Closing.

“First Closing” shall mean the date of the first closing which will be held as soon as practicable.
“Fund SCS” shall mean CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR and the parallel pools as defined in

the Prospectus.

“General Partner” shall mean CMP German Opportunity, the managing general partner of the Company from time to

time.

“Investment Period” shall mean the period commencing on the First Closing and terminating on the earlier of (i) the

fifth anniversary of the First Closing provided that the General Partner may with the consent of the Funds SCS extend
such period for one additional year, or (ii) the date on which the General Partner decides to early terminate the Investment
Period because (x) 70% of the total Capital Commitments have been drawn down or committed and reserved for in-
vestments  (including  follow-on  investments)  in  Portfolio  Companies;  provided  that  for  purposes  of  determining  the
Investment Period reservation of Capital Commitments for investments (including follow-on investments) in excess of
10% of the total Capital Commitments shall require the approval of the Shareholders, or (y) changes in applicable law or
regulations or business conditions make an early termination necessary or advisable in the reasonable discretion of the
General Partner, or (iii) the date on which a proposal for future management of the Company in case of departure of a
Key Person is finally not approved with the required majority.

“Key Managing Directors” shall mean Kai Brandes and Dr. Ludger Vonnahme and their respective successors appointed

with the approval of the Shareholders.

“Key Investment Directors” means Ralf Boberg, Andreas Böttger, Andreas Hien, Ralph Kudla and Eric Sommer and

their respective successors appointed with the approval of the Shareholders.

“Key Persons” shall mean the Key Managing Directors and the Key Investment Directors.
“Limited Partner Shares” shall mean the fully paid-up shares of no par value representing the Share Capital.
“Lux GAAP” shall mean the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles.
“Net Asset Value” shall mean the value of the assets less the value of the liabilities which shall be determined according

to the provisions in § 22.

“Non CMP Shareholders” shall mean any Shareholder not being Fund SCS.
“Organizational Expenses” shall mean third party fees and expenses incurred in connection with the organization and

formation of the Company accounted for in accordance with Lux GAAP.

“Partners” shall mean the General Partner and the Shareholders.
“Portfolio Companies” shall mean companies in which the Company directly or indirectly holds an investment of any

type.

“Profits” shall mean the Company's balance sheet profits within the meaning of the Luxembourg law of December 19,

2002; the General Partner shall have the right to withdraw amounts from the capital reserves to increase the Company's
balance sheets profits according to the Commercial Companies Law if and to the extent necessary to make the allocations
pursuant to the Articles.

“Prohibited Person” shall mean any person as defined in § 15 subsection (2).
“Prospectus” shall mean the separate offering document of the Company as approved by the CSSF.

32595

L

U X E M B O U R G

“Purchase Notice” shall mean the notice to the Shareholders of pur-chase of their Shares according to § 15 subsection

(2) lit. d) no. (i).

“Purchase Price” shall mean the purchase price for Shares of a Shareholder according to § 14 subsection (2) lit. d) no.

(ii).

“Register” shall mean the register of Shares pursuant to § 6 subsection (4).
“Shareholder” shall mean any owner of Limited Partner Shares.
“Shares” shall mean the fully paid-up shares of no par value representing the Share Capital, i.e. the Limited Partner

Shares.

“Share Capital” shall mean the capital of the Company pursuant to § 6 subsection (2).
“SICAR Law” shall mean the law of the Grand Duchy of Luxembourg as of June 15, 2004 on the investment company

in risk capital, as amended from time to time.

“Subscription Certificate” shall have the meaning ascribed to it in § 6 subsection (3).
“Successor Fund” shall mean a new private equity fund or other investment vehicle having an investment strategy

substantially similar to the Fund SCS and the Company and which is managed or advised by CMP.

“Well-Informed Investor” means a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law. A Well-

Informed Investor shall be any:

(i) institutional investor, or
(ii) professional investor,
(iii) or any other investor who meets the following conditions:
(a) it has confirmed in writing that it adheres to the status of Well-Informed Investor; and
(b) either (i) invests a minimum of EUR 125,000 in the Company; or (ii) he/she/it has obtained an assessment made by

a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive
2004/39/EC, or a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC, certifying its expertise, its expe-
rience and its knowledge in adequately appraising an investment in risk capital.

Art. 1. Formation of the Company.
§ 1 Formation, Commencement
(1) Formation
There exists among the General Partner and the subscribers of the Limited Partner Shares and all those who may

become Partners in the future, an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque, SICAR),
organized in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions, SCA) (the “Com-
pany”), governed by the present Articles, the Commercial Companies Law and the SICAR Law.

(2) Commencement
The Company shall commence on December 22, 2010.
§ 2 Name
(1) The Company shall have the name:
CMP German Opportunity Fund II SCA (SICAR)
(2) All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must

bear the registered name of the Company followed by “société en commandite par actions” or “SCA” qualifying as a
“société d'investissement en capital à risque” or “SICAR”, the address of the registered office of the Company and the
initials “RCS Luxembourg”, followed by the number under which the Company is registered with the Luxembourg trade
and companies register.

§ 3 Purpose of the Company
The Company's purpose is to invest its assets in securities and other as-sets representing risk capital within the widest

possible meaning as permitted under Article 1 of the SICAR Law in order to provide its Partners with the benefit of the
result of the management of its assets in consideration of the risk they incur in this respect.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Prospectus.
The Company may also carry out whatever transactions are deemed necessary in order to develop, administer, manage

and control these participating interests. Subject to the provisions of the Prospectus, the Company may fund itself by
borrowing funds from affiliate companies and/or unrelated third party lenders and capital markets parties, entering into
loan and finance agreements, issuing bonds, notes or other debt or equity instruments (convertible or not) both in public
and private placements, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies.

In particular, the Company may use its funds whether borrowed or not for the creation, development and control of

any enterprise and the grant to companies in which the Company has a direct or indirect participating interest, and/or
to any affiliates of the group the Company is a member of and/or any parent company of the Company, of any financial
assistance, support, loans, advances, security or guarantees.

32596

L

U X E M B O U R G

Further, the Company may take any measures and carry out any operation or transaction, which it may deem useful

in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the SICAR Law.

§ 4 Limitation of Purpose, Investment Restrictions
The purpose of the Company shall be subject to the limitations and investment restrictions set out in the Prospectus.
§ 5 Fiscal Year, Registered Office, Currency
(1) Fiscal Year
The fiscal year of the Company shall be the calendar year. The first fiscal year of the Company shall commence on the

date on which the Company commenced pursuant to § 1 subsection (2) and shall terminate on December 31, 2011.

(2) Registered Office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the General

Partner.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by

means of a resolution of a general meeting of Partners, but cannot be transferred abroad, except as otherwise provided
hereunder.

The  Company  may  have  offices,  branches  (whether  or  not  a  permanent  establishment)  and  subsidiaries  either  in

Luxembourg or abroad.

(3) Currency
The currency of the Company shall be the Euro.

Art. 2. Company Capital, Shares.
§ 6 Partners, Capital
(1) Partners
The Company exists between one or more partner(s), one of which shall be the managing general partner (associé

gérant commandité) of the Company, and the owners of the Limited Partner Shares, which shall be the limited partners
(actionnaires commanditaires) of the Company (the “Shareholders”). The Limited Partner Shares are exclusively restric-
ted to persons qualifying as a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law, (a “Well-Informed
Investor”).

(2) Share Capital
The share capital of the Company (the “Share Capital”) shall be represented by fully paid-up shares of no par value

(the “Shares”) and shall at any time be equal the total net assets of the Company pursuant to § 22 hereof.

The minimum capital of the Company shall be EUR 1 million and must be achieved within twelve (12) months after

the date on which the Company has been authorized as société d'investissement en capital à risque by the CSSF as required
by the SICAR Law.

The share capital of the Company shall be represented by Limited Partner Shares only and which have been or will be

subscribed by Shareholders.

The Company has been incorporated with a subscribed share capital of EUR 31,000 divided into one (1) General

Partner Share and thirty (30) Limited Partner Shares of no par value. Upon incorporation, the Shares were fully paid-up.

(3) Capital Commitments
The General Partner shall not have a capital commitment; the Shareholders shall be committed to subscribing Limited

Partner Shares as set out in the Prospectus.

Investors wishing to subscribe for Limited Partner Shares shall execute a subscription certificate (the “Subscription

Certificate”), which upon acceptance will be signed by the General Partner. Investors thus commit themselves to sub-
scribing and accepting Limited Partner Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set
forth  in  the  Prospectus.  The  subscription  of  a  Shareholder  shall  become  effective  in  relation  to  the  Company  upon
acceptance of the Subscription Certificate by the General Partner and the admission to the Company shall become
effective upon the issuance of Limited Partner Shares of the Company to the Shareholder.

The capital commitments of the Shareholders to the Company are hereinafter collectively referred to as “Capital

Commitments”. Capital Commitments shall be called by the General Partner (a “Capital Call”) in accordance with the
provisions in the Prospectus. Upon payment on the Capital Call the General Partner shall issue the equivalent Limited
Partner Shares to the Shareholders.

Capital Commitments can be called only during the Investment Period. After the expiration of the Investment Period,

Capital Commitments can be called only for the following purposes:

(i) to fund investments of the Company which were, as per the expiration of the Investment Period, committed or in

process according to a letter of intent already submitted prior to the expiration of the Investment Period, if such invest-
ments in process are consummated within six (6) months of the expiration of the Investment Period;

32597

L

U X E M B O U R G

(ii) to fund follow-on investments in Portfolio Companies of the Company in which the Company holds an investment

upon expiration of the Investment Period, provided that the total amount that can be drawn down for follow-on invest-
ments following the expiration of the Investment Period shall not exceed 10% of the total Capital Commitments;

(iii) to fund the General Partner priority allocation out of Profits as described in the Prospectus;
(iv) to fund the fees, expenses, obligations and liabilities to be borne by the Company pursuant to the Prospectus.
The General Partner shall, subject to the approval of the Partners, have the right to finally fix the aggregate maximum

amount pursuant to (i) through (iv) that can be drawn down from the Shareholders' uncalled Capital Commitments after
expiration of the Investment Period. If such right was exercised, Capital Calls requesting capital contributions exceeding
such  maximum  amount  shall  not  be  permitted  and  the  aggregate  sum  of  (x)  all  capital  contributions  made  until  the
expiration of the Investment Period and (y) such maximum amount shall constitute the Capital Commitments of the
Shareholders for the purposes of these Articles and the Prospectus.

(4) Form of Shares / Register of Shares
All Shares shall be issued in registered form.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shares (the “Register”) which shall be kept by

the General Partner or by an entity designated therefore by the Company (the “Registrar and Transfer Agent”) and shall
contain the name of each Partner, its residence, registered office or elected domicile, the number of Shares (and their
Class, if any) held by it, the amount paid in for each Share, banking references, and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the Partner's name in the Register evidences its right of ownership over such registered Shares.

No Share certificates shall be issued.

Each Partner may change the data contained in the Register by notice to the General Partner. Any changed data shall

be authoritative for any action at least two (2) weeks thereafter.

The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per Share. In the event that a

Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
Share until one person has been appointed or designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

§ 7 Issuance of Shares
(1) General Rule
The General Partner is authorized to issue, in accordance with the Prospectus and § 7 hereof, an unlimited number

of Limited Partner Shares without reserving to the existing Partners a preferential right to subscribe for the Limited
Partner Shares to be issued. Subject to the Prospectus, the General Partner may decide on the issuance of Limited Partner
Shares in  its sole  and  absolute  discretion. The Limited  Partner  Shares  may only be  subscribed  to  by  Well-Informed
Investors. Each newly issued Limited Partner Share entitles its holder to the same rights and obligations as the holders
of existing Limited Partner Shares.

(2) Price, Payment, Additional Shareholder
The price per Limited Partner Share is fixed at one thousand Euros (EUR 1,000.-). This issue price per Limited Partner

Share shall be payable within a period as set out in the Prospectus. The General Partner may delegate to any director,
manager, officer, or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of
the Limited Partner Shares to be issued and to deliver them.

The General Partner may, in its sole discretion, admit additional Shareholders and permit existing Shareholders to

increase their Capital Commitments (additional Shareholders, as well as existing Shareholders in respect of the increase
in their Commitments, referred to as “Additional Shareholder(s)”) at one or more subsequent closings (“Subsequent
Closings”) during the period following the First Closing and ending on the Final Closing.

On or after a Subsequent Closing the General Partner shall first draw down Capital Contributions from the Additional

Shareholders and continue to make such drawdowns from the Additional Shareholders up to and until such time as the
contributed capital of all Shareholders bears the same proportion to their respective Capital Commitments.

(3) No Contributions in Kind
The Company may not agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities.
§ 8 Share in the Company's Assets
Subject to the provisions in § 10 regarding allocations and distributions, the Shareholders shall share the assets of the

Company pro rata to their Shares.

§ 9 Liability of the Partners
The Shareholders are only liable up to the amount of their respective Capital Commitment made to the Company.
The General Partner bears an unlimited and joint liability for the debts of the Company.

Art. 3. Distribution of Proceeds, Expenses and Fees.
§ 10 Distribution of Proceeds
The Partners' meeting shall, upon proposal of the General Partner and within the time limits provided by the Luxem-

bourg laws and regulations, these Articles and the Prospectus, determine how the results of the Company shall be disposed
of and may declare, or may authorize the General Partner to declare, distributions as well as decide, or authorize the

32598

L

U X E M B O U R G

General Partner to decide, to pay interim dividends in compliance with the applicable law. The allocations and distributions
shall be made in accordance with the provisions set forth in the Prospectus and the results of the Company shall be
distributed to the Shareholders pro-rata to their share in the Share Capital of the Company.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the Net Asset Value of the Company would

fall below one million Euro (EUR 1,000,000).

Art. 4. Expenses and Costs.
§ 11 Expenses and Fees.
The Company shall bear the fees and expenses as provided for in the Prospectus.

Art. 5. Management and Representation.
§ 12 Management Authority
(1) Basic Rule
The affairs of the Company shall be managed by the General Partner in accordance with the provisions and limitations

in this Articles and the Prospectus, and as may be otherwise required by mandatory law. The Shareholders may not
participate or interfere in the management of the Company.

The General Partner's remuneration for the management of the affairs of the Company shall consist in a priority

allocation out of Profits (profit priority share) and no other compensation or remuneration shall be due. The profit priority
share mentioned above shall be calculated and allowed in accordance with the provisions set forth in the Prospectus. In
general, all remunerations of the General Partner shall be described in the Prospectus.

(2) Management Authority-Power
Unless otherwise provided by Commercial Companies Law, the Prospectus or by these Articles, the General Partner

shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition of the Company.

All powers not expressly reserved by the Commercial Companies Law, the Prospectus or these Articles to the general

meeting of Partners shall be exercised by the General Partner.

In particular, subject to the restrictions contained in the Prospectus and the Commercial Companies Law, the General

Partner shall have the broadest powers to implement the investment strategy and borrowing restrictions, as well as the
course of conduct of the management and business affairs of the Company and to manage the investments for the account
of the Company with a view to achieving its investment strategy.

(3) Termination of Management Authority
The management authority of the General Partner shall terminate automatically upon its resignation or removal from

the Company.

Any change in the management or replacement of the General Partner will have to be agreed by the CSSF (Commission

de Surveillance du Secteur Financier).

(4) Delegation of Powers
The General Partner may, from time to time and always under its responsibility, appoint officers or agents of the

Company considered necessary for the operation and management of the Company, provided however that the Share-
holders may not act on behalf of the Company without risking their limited liability status.

The General Partner may from time to time and under its responsibility subdelegate its power to perform specific

tasks to one or more ad hoc agent(s). In particular, the General Partner may, from time to time, appoint one or more
committees and delegate certain of its functions to such committees.

The General Partner will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and/or committees,

the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their appointment.

§ 13 Restrictions on Management Authority, Compliance
(1) Basic Rule
The management authority of the General Partner shall be limited to Company assets.
(2) Investment Restrictions
The investments of the Company shall be restricted as described in the Prospectus.
(3) Conflict of Interest
No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invali-

dated by the fact that the General Partner or any one or more of the Shareholders, managers, agents, affiliates, personnel
or officers of the General Partner is interested in, or is a partner, director, officer or employee of such other company
or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business. The General Partner or such officers
shall not by reason of such affiliation with such other company or entity be prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business

§ 14 Representation

32599

L

U X E M B O U R G

The Company shall be represented by the General Partner. The General Partner shall have complete discretion and

full power, authority and right to represent and bind the Company. The General Partner and its board of managers may
enter into any legal transactions on behalf of the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the individual or

joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General
Partner shall determine in its discretion.

Art. 6. Withdrawal of Partners.
§ 15 Redemption of Shares
(1) Redemption of Shares
Unless otherwise determined in the Prospectus or in applicable mandatory law, the Shareholders shall not be entitled

to require the redemption of their Limited Partner Shares by the Company. The General Partner may, at its discretion,
resolve to redeem Limited Partner Shares for distribution purposes. Subject to the provisions of the Prospectus, the
General Partner shall decide on the details of any redemption in its sole and absolute discretion. Any redemption request
shall be addressed to all the Shareholders.

(2) Restriction of Ownership
The General Partner on behalf of the Company may restrict or prevent any person (the “Prohibited Person”) to be

or become owner of Limited Partner Shares, if such person is not the General Partner, Fund SCS or a limited partner of
the Fund SCS and/or in the opinion of the General Partner such ownership may be detrimental to the Company, may
result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign or as a result thereof the Company may
become exposed to tax disadvantages that it would not have otherwise incurred. For such purposes the Company may:

a) decline to issue any Limited Partner Share and decline to register any transfer of a Limited Partner Share, where it

appears to it that such issuance or transfer would or might result in a Prohibited Person being the legal or beneficial
owner of such Limited Partner Shares; and

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register a transfer of Limited

Partner Share in the Register, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether such entry or registry will result in a Prohibited Person being the legal or beneficial
owner of Limited Partner Shares; and

c) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any Partners' meeting of the Company; and
d) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person

is a beneficial owner of Limited Partner Shares, direct such Shareholder to sell its Limited Partner Shares and to provide
to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such Shareholder fails to comply with the
direction, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such Shareholder all Limited Partner
Shares held by such Shareholder in the following manner:

(i) The Company shall serve a second notice (the “Purchase Notice”) upon the Shareholder holding such Limited

Partner Shares or appearing in the Register as the owner of the Limited Partner Shares to be purchased, specifying the
Limited Partner Shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the Purchase Price will be calculated and the
name of the purchaser. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such Shareholder at its last address known to the Company or appearing in the Register. Imme-
diately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Shareholder shall cease to be the
owner of the Limited Partner Shares specified in such notice; its name shall be removed from the Register.

(ii) The price at which each such Limited Partner Shares is to be purchased (the “Purchase Price”) shall be the Net

Asset Value of the relevant Class (if any) for redemption of such Limited Partner Shares, on the last valuation day preceding
the date of the Purchase Notice.

(iii) Payment of the Purchase Price will be made available to the former owner of such Limited Partner Shares in Euro

and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified
in the Purchase Notice) upon final determination of the Purchase Price. Upon service of the Purchase Notice as aforesaid
such former owner shall have no further interest in such Limited Partner Shares or any of them, nor any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Purchase Price (without interest) from such
bank. Any redemption proceeds receivable by a Shareholder under this section, but not collected within a period of five
(5) years from the date specified in the Purchase Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant
Class or Classes of Limited Partner Shares. The General Partner shall have power from time to time to take all steps
necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

The exercise by the Company of the power conferred by this § 15 shall not be questioned or invalidated in any case,

on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Limited Partner Shares by any person or that the true
ownership of any Limited Partner Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Purchase
Notice, provided in such case the said powers were exercised in good faith.

§ 16 Removal of Partner
(1) Removal For Cause

32600

L

U X E M B O U R G

In the event of Cause the Non CMP Shareholders with a majority of more than 50% of their votes expressed in a

general meeting may resolve to remove the General Partner as manager of the Company and to appoint a successor.

Notice of a Shareholders' resolution resolving upon removal shall be given in writing and shall be served upon the

removed General Partner without undue delay by a representative to be appointed in the Shareholders' resolution. The
removal shall become effective as of the date specified in such notice, at the earliest on the date of service of the notice.

The management authority of the General Partner shall terminate as per the date specified in the notice. The General

Partner's entitlement to the profit priority share described in the Prospectus shall terminate as of the effective date of
revocation of the General Partner's management authority.

(2) Removal Without Cause
Upon resolution to be passed by the a general meeting of Shareholders (with the positive vote of Non CMP Share-

holders (excluding CMP)) with a majority of at least 80% of their votes, the General Partner may be removed from the
Company without Cause and a successor can be appointed. A removal can only be resolved upon if the General Partner
is removed from the Company and Fund SCS. The provisions in subsection (1) shall correspondingly apply. The manage-
ment authority of the General Partner shall terminate upon service of the removal resolution. The General Partner shall
still be entitled to such compensation as determined in the Prospectus.

§ 17 Transfer of Shares
(1) Limited Partner Shares may be transferred only upon approval by the General Partner. Subject to the provisions

of the Prospectus, such approval shall only be given in the case of good cause on the side of the requesting Shareholder.

(2) Subject to the provisions of the Prospectus, transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in

the Register.

Art. 7. Partners' Meetings.
§ 18 Partners' Meetings
(1) Proceedings
The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice for,

and conduct of, the meetings of Partners of the Company, unless otherwise provided herein.

Meetings of the Partners of the Company shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at such place and time as

may be specified in the respective convening notices of the meetings.

If all the Partners of the Company are present or represented at a meeting of the Partners of the Company, and

consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without
prior notice.

A Partner may act at any meeting of the Partners of the Company by appointing another person (who need not be a

Partner) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Each Partner may also participate in any meeting of Partners of the Company by telephone or video conference call

or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.

Each Partner may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain the date

and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each proposed
resolution,  three  boxes  allowing  the  Shareholders  to  vote  in  favor,  against  or  abstain  from  voting  on  the  proposed
resolution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to the registered
office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the time of the meeting
specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favor or against the proposed resolutions)
nor an abstention shall be void.

Except as otherwise required by Commercial Companies Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the

Partners of the Company duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting,
regardless of the proportion of the Share Capital represented at such meeting.

An  extraordinary  general  meeting  of  Partners  convened  to  amend  any  provisions  of  the  Articles  shall  not  validly

deliberate unless at least one-half of the Share Capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments
to the Articles. If this quorum is not reached, a second meeting shall be convened, in the manner prescribed by the
Articles. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Share Capital represented at such
meeting, if so stated in the notice for such subsequent meeting. At both meetings, resolutions, in order to be adopted,
must be carried by the majority as provided for in no. 2 below.

One Partners' meeting shall be held annually at the registered office of the Company or elsewhere as may be specified

in the notice of meeting on the first day of June of each year.

A Partners' meeting will be called by the General Partner (i) whenever deemed necessary or advisable, or (ii) upon

request of Non CMP Shareholders representing at least 10% of their aggregate Shares of the Share Capital, by giving at
least 15 Business Days' advance notice in writing, which notice shall include the time and place of such meeting and state
the agenda for such meeting. The determination of the 15 Business Days period is to be made on the beginning of the

32601

L

U X E M B O U R G

third Business Day after such notice is given. If the agenda is subsequently amended, such amended agenda must be
received by the Partners by the third day before the scheduled date of a Partners' meeting, and each Partners shall have
the right to request that the agenda shall be amended.

(2) Subject Matters
The Partners' meeting will inter alia resolve upon the following subject-matters:
a) approval of the annual financial statements of the Company submitted by the General Partner;
b) discharge of the General Partner for its activities during the past fiscal year;
c) appointment of an auditor for the fiscal year's financial statements of the Company;
d) changes of, and amendments to, these Articles, the Prospectus and dissolution of the Company (in each case subject

to the prior approval of the CSSF as necessary under the SICAR Law, see below);

e) abandonment of the SICAR status of the Company (subject to the prior approval of the CSSF, see below); and
f) other subject-matters as provided for under the Prospectus or any mandatory law;
each time in accordance with the subject matter relevant mandatory quorum and voting requirements.
The Fund SCS shall not be entitled to vote on resolutions according to this subsection 2. lit. b) and § 16 (and any other

item as determined in the Prospectus) in order to avoid a potential conflict of interests. Unless as required by mandatory
law or otherwise provided for in these Articles, the General Partner shall abstain from voting at the Partners' meetings.

Subject to the provisions of these Articles and mandatory law, majority requirements shall be as follows: Partners'

resolutions shall be passed upon the simple majority of votes cast. The simple majority of votes cast shall mean more
than 50% of votes cast.

Resolutions according to this subsection (2) lit. d) shall require a majority of at least 75% of the Share Capital and

require in addition the consent of the General Partner and the prior approval of the CSSF. Resolutions according to this
subsection (2) lit. e) shall require the unanimous consent of all Partners and the prior approval of the CSSF.

Any amendment of this subsection (2) shall require the unanimous consent of the Partners of the Company.
The commitments of its Partners may be increased only with the unanimous consent of the Partners and bondholders.
The SICAR status may only be abandoned by the Company with the prior approval of the CSSF and the unanimous

consent of the Partners.

(3) Chairman, Minutes
The chairman of any meeting of the Partners shall be one of the managers of the General Partner who shall keep

written minutes of all the proceedings and votes in any such meeting. Copies of the minutes shall be sent by the General
Partner to the other Partners without undue delay after such meeting.

(4) Term of Preclusion
A Partner can object to Shareholders' resolutions within a period of four (4) weeks after knowledge of the respective

resolution by initiating arbitration proceedings as provided for in the Prospectus.

Art. 8. Term, Termination, Dissolution.
§ 19 Term of the Company
The term of the Company shall commence as of the date specified in § 1 subsection (2) and shall continue for a period

ending on the earlier of:

a) the tenth anniversary of the Final Closing; provided that the General Partner may extend the term for two (2)

additional consecutive one-year periods and any such extension shall be notified to the Shareholders three (3) months
in advance; or

b) the date of occurrence of any of the events set forth in § 20, subject to the provision thereof.
§ 20 Early Termination
(1) The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Partners deliberating as

prescribed for amendment of these Articles, with the consent of the General Partner.

(2) Notwithstanding the provisions of § 19 of this Articles, the Company shall dissolve upon the occurrence of any of

the following events: (a) dissolution of the General Partner; (b) commencement of insolvency proceedings over the assets
of the General Partner or rejection of a petition to commence such proceedings for lack of assets; or (c) removal of the
General Partner from the Company; provided that the Company shall not terminate if, within 90 days after such an event,
Non CMP Shareholders holding at least 75% of the total Capital Commitments of all Non CMP Shareholders elect to
continue the business of the Company and to appoint a successor; each time subject to the prior approval of the CSSF.

§ 21 Dissolution
(1) Liquidator
Upon dissolution of the Company, the General Partner shall be appointed as liquidator of the Company by the Partners

and shall liquidate all or any part of the assets of the Company; provided that upon dissolution according to § 20 because
of an event relating to the General Partner, the Company shall be wound up by a liquidator appointed by the Partners
with a majority of more than 50% of the total Shares in the Company.

32602

L

U X E M B O U R G

Such appointed liquidator(s) must be approved by the CSSF and must provide all requisite guarantees of honorability

and professional skills.

(2) Allocation of Liquidation Proceeds
Profits and losses arising from the liquidation of the assets of the Company upon liquidation shall be allocated among

the Partners pursuant to the formula as set forth in the applicable subsection of § 10 of these Articles.

Art. 9. Valuation, Accounting, Reporting.
§ 22 Valuation of Company Assets
The assets of the Company shall be valued by the General Partner on the basis of the fair value. Such value shall be

the value of the assets less the value of the liabilities and shall be determined as follows:

(i) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at
after making such discount as the General Partner may consider, on a consistent basis, appropriate in such case to reflect
the true value thereof;

(ii) securities dealt in on a regulated market will be valued on the basis of their quoted mid-market price on the last

day of trading prior to the valuation date, subject to any discounts which in accordance with EVCA valuation guidelines
and on a consistent basis may be applicable due to the nature of such security, on the market which is normally the
principal market for such securities;

(iii) all other assets of any kind or nature will be valued at fair market value, as determined in good faith and on a

consistent basis by or under the responsibility of the General Partner in accordance with generally accepted valuation
principles and procedures prescribed by EVCA. For the purpose of determining the fair market value of the assets under
this provision, the General Partner may have regard to all factors that it reasonably considers relevant on a consistent
basis in relation to such assets which factors may include (when applicable) inter alia: (a) the characteristics of and fun-
damental analytical data relating to the assets including the costs, size, current interest rate, period until next interest
rate reset, maturity and lending rate of the assets, the terms and conditions of the assets' debt structure; (b) the nature
and adequacy of the Company's rights, remedies and interests; (c) the creditworthiness of the assets business, cash flows,
capital structure and future prospects; (d) information relating to recent relevant market transactions; (e) the reputation
and financial condition of the and recent reports relating to the assets; (f) general economic market conditions affecting
the fair value of the assets.

(iv) the value of assets denominated in a currency other than Euro shall be determined by taking into account the rate

of exchange prevailing at the time of the determination of the net asset value; and

Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner is authorized to apply other fair valuation principles

for the assets of the Company, when circumstances or market conditions so justify, but on a consistent basis. When
evaluating any assets which are held subject to any restriction on transfer or sales, such assets will be valued at a reasonable
discount. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and applied in accordance with Lux GAAP.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the General Partner or by any custodian, company or other organization which the General Partner may appoint for
the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and on its present, past or
future Partners, subject to the year end audit by the auditor of the Company being a réviseur d'entreprises agréé.

(1) Assets
The assets of the Company shall include (without limitation):
(i) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(ii) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(iii) all shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants or other securities, financial instru-

ments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments
with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);

(iv) all stock dividends, if any, cash dividends and cash distributions received by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

(v) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

(vi) the liquidation value of all contracts and options the Company has an open position in;
(vii) the Organizational Expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(viii) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
(2) Liabilities
The liabilities of the Company shall include (without limitation):
(i) all loans, bills and accounts payable;

32603

L

U X E M B O U R G

(ii) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
(iii) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, custodian fees and any other agents' fees);
(iv) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

(v) an appropriate provision for future taxes based on capital and income on the accounting date, and other reserves

(if any) authorized and approved by the General Partner as well as such amount (if any) as the General Partner may
consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company; and

(vi) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature assessed in accordance with Lux GAAP. In

determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company
pursuant to Section E.II. hereof. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring
nature based on an estimated amount ratably for annual or other periods.

(3) Suspension of Calculation of the Net Asset Value
The General Partner may suspend calculation of the Net Asset Value when:
a) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Company is

not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

b) any period when any of the principal stock exchanges on which Investments of the Company are quoted are closed

(otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or

c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned

by the Company would be impractical; or

d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the

price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.

§ 23 Accounting
The administrative agent of the Company shall maintain complete and accurate books of account of the Company's

affairs at the Company's office, which books (i) will be open to inspection by any Shareholder or a Shareholder's authorized
representative - which can be an external adviser, bound by a legal confidentiality obligation - at any time during ordinary
business hours and (ii) will be preserved during the longer of (x) the periods required by law and (y) the term of the
Company and for a period of five years thereafter. Legal inspection rights of Shareholders under mandatory law shall
remain unaffected. The accounts of the Company shall be maintained in Euro. Within the time periods required by law,
the financial statements of the Company shall be prepared and audited in accordance with the provisions of the general
accounting principles accepted in Luxembourg and the Commercial Companies Law.

§ 24 Reporting
(1) Annual Reports
Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner shall provide to the Partners annual reports of the

Company as required by the SICAR Law and the Commercial Companies Law.

(2) Other Information
The Company shall provide to the Partners the other information as set out in the Prospectus.

Art. 10. General Provisions.
§ 25 Custodian, Statutory Auditor
(1) Custodian
The Company has entered into a custodian agreement with a custodian bank, which shall satisfy the requirements of

the SICAR Law (the “Custodian”). All securities and cash of the Company are to be held by the Custodian or under its
responsibility by duly authorized agents appointed in good faith, who shall assume towards the Company and its Partners
the duties and responsibilities provided by the SICAR Law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the General Partner shall use its best endeavors to find a successor

to act as custodian within two (2) months of the effective date of such retirement and upon doing so the General Partner
shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The General Partner may terminate the
appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been
appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

The duties of the Custodian shall cease:
(i) in the case of the voluntary withdrawal of the Custodian or its removal by the Company; until it is replaced, the

Custodian shall take all necessary steps for the successful maintaining of the interests of the Partners; or

(ii) in the event that the Custodian or the Company have (a) been declared bankrupt, (b) obtained a suspension of

payments, (c) entered into a composition with creditors, (d) been placed under controlled management or any similar
proceedings, or (e) been put into liquidation; or

(iii) where the CSSF withdraws its authorization of the Custodian or the Company.
(2) Independent Auditor

32604

L

U X E M B O U R G

The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one

authorized auditor (“réviseur d‘entreprises”), who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness
and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the SICAR Law. The auditor shall be elected
by the General Partner and continue to carry out its duties until its successor is elected.

§ 26 Indemnification
The Company shall provide indemnification to the General Partner, its respective partners, shareholders, managers,

employees, advisers and agents to the Partners as set out in the Prospectus.

§ 27 Amendments to the Articles; Governing Law
(1) Subject to the prior approval of the CSSF, these Articles may be amended from time to time by a meeting of

Partners', subject to the quorum and majority requirements of § 18.

(2) These Articles shall be governed by law of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Partner

Subscribed

Capital

CMP German Opportunity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 EUR

CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) (SICAR): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 EUR

Proof of such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at two thousand two hundred euro (EUR 2,200).

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the Commercial Companies Law, as

amended, have been observed.

<i>General meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolution by unanimous vote.

<i>Sole resolution

The registered office of the Company is fixed at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, surname, civil status

and residence, the said persons appearing signed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzehn, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor uns, Maitre Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. CMP German Opportunity, eine nach den Gesetzen von Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (société à responsabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg, dessen
Eintragung im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister anhängig ist, als geschäftsführende Komplementärin
der CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR; und

2. CMP German Opportunity Fund II (SCS) SICAR, eine nach den Gesetzen von Luxemburg gegründete Kommandit-

gesellschaft (société en commandite simple), organisiert als eine Investmentgesellschaft in Risikokapital (société d'inves-
tissement en capital à risque) mit Gesellschaftssitz in 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg, dessen Eintragung im
luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister anhängig ist, vertreten durch ihre geschäftsführenden Gesellschafterin
CMP German Opportunity als geschäftsführende Komplementärin.

32605

L

U X E M B O U R G

Beide Parteien sind hier vertreten durch Hana Witzke, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund

von Vollmachten welche am 22. Dezember 2010 erteilt wurden.

Die Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet

wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei den Registrierungsbehörden einzureichen.

Die erschienenen Parteien, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, um die Gründungsurkunde (die “Satzung”)

einer  von  ihnen  zu  gründenden  Kommanditgesellschaft  auf  Aktien  (société  en  commandite  par  actions)  wie  folgt  zu
beurkunden:

<i>Definitionen

Die nachfolgenden Definitionen sind Bestandteil dieser Satzung.
„Aktionär“ bedeutet jeden Eigentümer von Kommanditaktien.
„Aktien“ bedeutet die voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert aus denen das Grundkapital besteht, d.h. die Kom-

manditaktien.

„Ankaufserklärung“ bezeichnet die Erklärung gegenüber einem Aktionär zum Ankauf seiner Aktien gemäß § 15 Abs.

(2) lit. d) Nr. (i).

„Ankaufspreis“ bezeichnet den Kaufpreis für Aktien eines Aktionärs gemäß § 15 Abs. (2) lit. d) Nr. (ii).
„Anlageperiode“ bedeutet den Zeitraum beginnend am Ersten Zeichnungsschluss der Gesellschaft und endend am

früheren der folgenden Ereignisse: (i) Der fünfte Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses, es sei denn der Komplementär
verlängert den Zeitraum mit Einwilligung des Fonds SCS um ein weiteres Jahr, oder (ii) der Tag, an dem der Komplementär
die Anlageperiode vorzeitig beendet, (x) weil entweder mindestens 70% der Kapitalzusagen abgerufen bzw. für Investi-
tionen (einschließlich Nachfolgeinvestitionen) in Portfolio-Gesellschaften, zugesagt und reserviert sind, wobei hinsichtlich
der Bestimmung der Anlageperiode die Reservierung von mehr als 10% der gesamten Kapitalzusagen der Zustimmung
der Aktionäre bedarf, oder (y) weil nach der vernünftigen Einschätzung des Komplementärs eine vorzeitige Beendigung
wegen der Änderungen von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften oder der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen notwendig
oder sinnvoll ist oder (iii) der Tag, an dem dem Vorschlag über die zukünftige Führung der Geschäfte der Gesellschaft
nicht mit der notwendigen Mehrheit endgültig nicht zugestimmt wurde.

„Bilanzgewinn“ ist der Bilanzgewinn der Gesellschaft gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 19. Dezember 2002; der

Komplementär hat das Recht, Kapitalrücklagen der Gesellschaft zu Gunsten des Bilanzgewinns aufzulösen gemäß dem
Handelsgesellschaftengesetz, wenn und soweit dies für die Ergebniszuweisungen gemäß dieser Satzung erforderlich ist.

„CMP“ bedeutet (i) den Komplementär, (ii) CMP Capital Management-Partners GmbH (Berlin), (iii) Verbundunter-

nehmen des Komplementärs, (iv) jeden seiner geschäftsführenden Aktionäre oder Geschäftspartner und Angestellte,
sowie (v) Schlüsselpersonen.

„CSSF“ bedeutet die Commission de Surveillance du Secteur Financier, die Luxemburger Aufsichtsbehörde für den

Finanzsektor.

„Depotstelle“ hat die Bedeutung gemäß § 25.
„Erster Zeichnungsschluss“ bedeutet den Tag des baldmöglichsten Letzten Zeichnugsschlusses.
„Ergebnis-Vorab“ bedeutet den Gewinn der Handelsbilanz der Gesellschaft entsprechend des luxemburgischen Ge-

setzes vom 19. Dezember 2002; der Komplementär hat das Recht aus der Kapitalsreserve der Gesellschaft Kapital zu
entnehmen um den Gewinn der Handelsbilanz entsprechend des Handelsgesellschaftengesetz und dieser Satzung zu er-
höhen.

„Fonds SCS“ bedeutet CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) SICAR und die Parallel-Pool, wie sie im

Prospekt definiert sind.

„Geschäftstage“ sind diejenigen Tage, an denen die Geschäftsbanken in Luxemburg für den Publikumsverkehr geöffnet

sind.

„Gesellschaft“ bedeutet die CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR, eine Investmentgesellschaft in Risikoka-

pital gegründet als Kommanditgesellschaft auf Aktien in Luxemburg.

„Gesellschafter“ bedeutet den Komplementär und die Aktionäre.
„Grundkapital“ bedeutet das Grundkapital der Gesellschaft gemäß § 6 Abs. (2).
„Gut Informierter Investor“ bezeichnet einen gut informierten Investor im Sinne des Artikel 2 des SICAR-Gesetzes.

Ein Gut Informierter Investor ist jeder:

(i) Institutionelle Investor, oder
(ii) professionelle Investor,
(iii) oder jeder Investor, der die folgenden Bedingungen erfüllt:
(a) er hat schriftlich bestätigt, das er den Status eines Gut Informierten Investors einhält; und
(b) entweder (i) investiert einen Minimalbetrag von Euro 125.000 in die Gesellschaft oder (ii) er/sie hat eine Beurteilung

eines Kreditinstitutes im Sinne der Verordnung 2006/48/EG oder einer Investmentgesellschaft im Sinne der Verordnung
2004/39/EG, oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Verordnung 2001/107/EG erhalten, die seine/ihre Expertise
und Wissen zur Einschätzung von Risikokapital bestätigt.

32606

L

U X E M B O U R G

„Handelsgesellschaftengesetz“ bezeichnet das Gesetz des Großherzogstums Luxemburg vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaft in seiner jeweils gültigen Form.

„Kapitalabruf“ bedeutet den schriftlichen Abruf durch den Komplementär an die Aktionäre, Aktien gemäß ihrer Ka-

pitalzusagen zu zeichnen mit einer Abruffrist von mindestens 10 Geschäftstagen.

„Kapitalzusage“ bedeutet den auf Euro lautenden Höchstbetrag, der von einem Aktionär in die Gesellschaft eingezahlt

wurde oder zu dessen Einzahlung in die Gesellschaft sich der Aktionär verpflichtet hat, durch die Zeichnung von Kom-
manditaktien gemäß dem Zeichnungsschein dieses Aktionärs.

„Klassen“ bedeutet die Aktienklassen, die durch die Gesellschaft ausgegeben werden können.
„Kommanditaktien“ bedeutet alle voll einbezahlten Aktien ohne Nennwert des Grundkapitals.
„Komplementär“ bezeichnet den jeweiligen geschäftsführenden Komplementär der Gesellschaft.
„Letzter Zeichnungsschluss“ bezeichnet das Ende der Zeichnungsperiode und (i) den Ablauf eines Zeitraumes von

achtzehn (18) Monaten nach dem Ersten Zeichnungsschluss, es sein denn der Komplementär verlängert diesen Zeitraum
von achtzehn (18) Monaten mit der Einwilligung des Fonds SCS zusätzliche sechs (6) Monate und (ii) der Tag, den der
Komplementär als Letzten Zeichnungsschluss bestimmt.

„Lux GAAP“ bezeichnet die in Luxemburg grundsätzlich anerkannten Bewertungsmethoden.
„Management-Verstoß“ bedeutet (i) einen erheblichen Verstoß des CMP gegen seine im Prospekt, dieser Satzung oder

in einer Nebenabrede festgelegten Pflichten, welcher nicht durch schriftliche Benachrichtigung eines Aktionärs innerhalb
von dreißig (30) Tagen geheilt wurde, (ii) eine grob fahrlässige, vorsätzliche, betrügerische, bösgläubige oder rücksichtslos
missachtende Schädigung durch CMP, (iii) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder die Ablehnung der Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens mangels Masse über das Vermögen des Komplementärs oder (iv) das Nichtunterbreiten eines Vor-
schlags über die zukünftige Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Komplementär.

„Nachfolgefonds“ bedeutet einen neuen Private-Equity-Fonds oder ein anderes Investitionsvehikel, welches eine An-

lagestrategie verfolgt, die mit der Anlagestrategie der Gesellschaft und des Fonds SCS im Wesentlichen übereinstimmt
und durch CMP verwaltet oder beraten wird.

„Nettoinventarwert“  bedeutet  der  Wert  der  Vermögensgegenstände  abzüglich  des  Wertes  der  Verbindlichkeiten

welche gemäß den Bestimmungen des § 22 bestimmt werden.

„Nicht CMP Aktionäre“ bedeutet alle Aktionäre mit Ausnahme des Fonds SCS.
„Organisatorische Ausgaben“ bedeutet Ausgaben gegenüber Drittparteien sowie Ausgaben welche im Zusammenhang

mit der Einrichtung und Gründung der Gesellschaft entstanden sind und gemäß der Lux GAAP als solche ausgewiesen
wurden.

„Portfolio-Gesellschaften“ bedeuten die Unternehmen, in die die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar Investitionen

jeder Art hält.

„Prospekt“ bedeutet das separate Angebotsdokument der Gesellschaft wie von der CSSF genehmigt.
„Register“ bedeutet das Aktienregister gemäß § 6 Abs. (4).
„Satzung“ ist die Satzung der Gesellschaft gemäß dieser Urkunde.
„Schlüsselpersonen“ bedeutet die Schlüsselpersonen des Geschäftsführers sowie des Investment Direktors Herren

Karsten Henco, Edward Stuart und Justin Duckworth sowie die mit Zustimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger
bzw. weiteren Personen.

„Schlüsselperson des Geschäftsführers“ bedeutet die Herren Kai Brandes und Dr. Ludger Vonnahme und ihre jewei-

ligen mit Zustimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger.

„Schlüsselperson des Investment Direktors“ bedeutet die Herren Ralf Boberg, Andreas Böttger, Andreas Hien, Ralph

Kudla und Eric Sommer und ihre jeweiligen mit Zustimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger.

„SICAR-Gesetz“ bedeutet das Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 15. Juni 2004 über Investmentgesell-

schaften in Risikokapital in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Unzulässige Person“ bezeichnet jede Person gemäß § 15 Abs. (2).
„Verbundunternehmen“ bedeutet in Bezug auf eine Unternehmen oder eine natürliche Person („U“), ein Mutterun-

ternehmen von U, ein Tochterunternehmen von U, ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens von U, jedes
Unternehmen, dass direkt oder indirekt von U kontrolliert wird, sowie jedes Unternehmen, dass U direkt oder indirekt
kontrolliert. Die Mitglieder von CMP gelten untereinander als Verbundunternehmen.

„Zeichnungsschein“ hat die Bedeutung gemäß § 6 Abs. (3).

Art. 1. Errichtung der Gesellschaft.
§ 1 Errichtung, Beginn.
(1) Errichtung
Zwischen dem Komplementär und den Zeichnern von Kommanditaktien und allen, die in der Zukunft Gesellschafter

werden besteht eine Investmentgesellschaft in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) (die
„Gesellschaft“), in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions, SCA) nach
dieser Satzung, dem Handelsgesellschaftengesetz und dem SICAR-Gesetz.

32607

L

U X E M B O U R G

(2) Beginn
Die Gesellschaft beginnt am 22. Dezember 2010.
§ 2 Firma
Die Gesellschaft führt die Firma:
CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR.
Alle Dokumente der Gesellschaft, die sich an Dritte richten, wie Briefe, Rechnungen oder Veröffentlichungen, müssen

die eingetragene Firma der Gesellschaft tragen gefolgt von dem Zusatz „société en commandite par actions“ oder „SCA“,
welche als „société d'investissement en capital à risque“ oder „SICAR“ qualifiziert, die Adresse des eingetragenen Sitzes
der Gesellschaft und die Buchstaben „RCS Luxemburg“ gefolgt von der Nummer unter der die Gesellschaft im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen ist.

§ 3 Gesellschaftszweck
Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, ihre Vermögensgegenstände in Wertpapiere oder andere Vermögenswerte,

welche Risikokapital im weitesten Sinn gemäß Artikel 1 SICAR-Gesetz darstellen, um ihren Gesellschaftern in den Genuss
des Ergebnisses der Verwaltung dieser Vermögensgegenstände kommen zu lassen als Gegenleistung für die Eingehung
des diesbezüglichen Risikos.

Der Investitionsfokus und die Strategie der Gesellschaft sind umfangreicher im Prospekt beschrieben.
Die Gesellschaft kann jede Transaktion vornehmen, die als notwendig angesehen wird, um diese teilnehmenden Anteile

zu entwickeln, verwalten und zu kontrollieren. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospektes kann die Gesellschaft
sich durch Darlehen von verbundenen Unternehmen und/ oder nicht-verbundenen Drittkapitalgebern und Kapitalmärkten
finanzieren, Schuld-und Finanzierungsvereinbarungen eingehen, (wandelbare und nicht wandelbare) Schuldverschreibun-
gen, Anleihen oder andere Fremd-und Eigenkapitalinstrument in öffentlichen und nicht-öffentlichen Platzierungen ausge-
ben, in als Inhaber- oder Registerpapier, zu jeden Nennwert und in jeder Währung.

Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen, egal ob kreditfinanziert oder nicht für die Gründung, Entwicklung

und die Kontrolle von allen Unternehmungen einsetzen und Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt
beteiligt ist, sowie allen verbundenen Unternehmen der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört sowie jeder Mutterge-
sellschaft der Gesellschaft jede Art finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorteile, Wertpapier oder Garantien gewähren.

Des Weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen und Geschäfte vornehmen, die sie für sinnvoll hält, um ihren

Unternehmenszweck im weitesten nach dem SICAR-Gesetz zulässigen Rahmen zu entwickeln und zu erfüllen.

§ 4 Begrenzung des Gesellschaftszwecks
Der Zweck der Gesellschaft steht unter den Beschränkungen und Investitionsbeschränkungen, welche sich aus dem

Prospekt ergeben.

§ 5 Geschäftsjahr, Sitz, Währung
(1) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft von

dem Tag, an dem die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb gemäß § 1 Absatz 2 begonnen hat, und endet am 31. Dezember
2011.

(2) Sitz
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden, jedoch nicht ins Ausland, soweit nicht hierin anderweitig geregelt.

Die Gesellschaft kann Büros, Filialen (dauerhaft oder nicht) und Tochterunternehmen in Luxemburg und im Ausland

haben.

(3) Währung
Die Gesellschaft wird in der Währung Euro geführt.

Art. 2. Gesellschaft und Gesellschaftsvermögen.
§ 6 Gesellschafter, Kapital
(1) Gesellschafter
Die Gesellschaft besteht zwischen einem oder mehreren Komplementären, von denen einer der geschäftsführende

Komplementär (associé gérant commandité) ist, und den Eigentümern der Kommanditaktien, welche die Kommanditak-
tionäre der Gesellschaft (die „Aktionäre“) sind. Die Kommanditaktien können nur von Personen gehalten werden, die
gut informierte Investoren im Sinne des SICAR-Gesetzes sind (ein „Gut Informierter Investor“).

(2) Grundkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft (das „Grundkapital“) setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Aktien ohne

Nennwert (die „Aktien“) und muss zu jeder Zeit gleich dem Nettoinventarwert der Gesellschaft gemäß § 22 sein.

Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1 Million und muss innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem

Datum, an dem die Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque von der CSSF zugelassen wurde, erreicht
werden.

32608

L

U X E M B O U R G

Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus Kommanditaktien, welche nur von Aktionären gezeichnet

wurden und werden.

Die Gesellschaft wurde gegründet mit einem gezeichneten Grundkapital von einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000)

aufgeteilt in eine (1) Aktie des Komplementärs und dreißig (30) Kommanditaktien ohne Nennwert. Bei Gründung der
Gesellschaft waren die Aktien voll eingezahlt.

(3) Kapitalzusagen
Der Komplementär hat keine Verpflichtung, Kapitaleinzahlungen zu leisten und hat keinen Kapitalanteil. Die Aktionäre

sind gemäß den Bestimmungen des Prospektes verpflichtet, Kommanditaktien zu zeichnen.

Investoren, die Kommanditaktien zeichnen wollen, füllen einen Zeichnungsschein (den „Zeichnungsschein“) aus, wel-

cher bei Annahme durch den Komplementär unterzeichnet wird. Damit verpflichten sich die Investoren, Kommanditak-
tien gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Prospektes zu zeichnen. Die Zeichnung wird wirksam im Verhältnis
zur Gesellschaft mit Annahme des Zeichnungsscheins des Kommanditaktionärs durch den Komplementär, und der Beitritt
zur Gesellschaft wird wirksam mit der Ausgabe von Kommanditaktien an den Aktionär.

Die übernommenen Kapitalzusagen der Aktionäre werden nachfolgend zusammen als die „Kapitalzusagen“ bezeichnet.

Kapitalzusagen werden, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Prospekt, durch den Komplementär abgerufen (ein
„Kapitalabruf“). Nach Zahlung des Kapitalabrufs wird der Komplementär den Gesellschaftern die entsprechende Anzahl
an Aktien ausgeben.

Kapitalzusagen können nur während der Anlageperiode zur Einzahlung abgerufen werden. Nach Ablauf der Anlage-

periode können Kapitalzusagen nur für folgende Zwecke zur Einzahlung abgerufen werden:

(i) zur Finanzierung von Investitionen der Gesellschaft, die zum Ablauf der Anlageperiode bereits zugesagt oder nach

Abschluss einer Absichtsvereinbarung in Bearbeitung waren, wenn diese bearbeiteten Investitionen innerhalb von sechs
(6) Monaten nach Ablauf der Anlageperiode getätigt werden;

(ii) zur Finanzierung von Nachfolge-Investitionen in Portfolio-Gesellschaften, an denen die Gesellschaft zum Ablauf der

Anlageperiode bereits eine Beteiligung hält, jedoch nur wenn der insgesamt abrufbare Betrag für Nachfolge-Investitionen
im Anschluss des Ablaufs der Anlageperiode nicht 10% gesamten der Kapitalzusage übersteigt;

(iii) zur Finanzierung der Vorabausschüttungen auf den Ergebnis-Vorab des Komplementärs gemäß dem Prospekt;
(iv) zur Finanzierung der von der Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu tragenden Kosten, Ausgaben, Verpflichtungen

und Verbindlichkeiten.

Mit Zustimmung der Gesellschafter kann der Komplementär den maximalen Gesamtbetrag festlegen, der nach Ablauf

der Anlageperiode von den abrufbaren Kapitalzusagen der Aktionäre für die Zwecke der vorstehenden Ziffern (i) bis (iv)
noch abgerufen werden kann. In diesem Fall sind Kapitalabrufe, die diesen maximalen Gesamtbetrag übersteigen nicht
zulässig und bildet die Summe aus (x) allen Kapitaleinzahlungen bis zum Ablauf der Anlageperiode und (y) diesem maxi-
malen Gesamtbetrag die Kapitalzusage der Investor-Partner für die Zwecke dieser Satzung und des Prospektes.

(4) Art der Aktien / Aktienregister
Alle Aktien werden in registrierter Form ausgegeben.
Alle ausgegebenen Aktien sind im Aktienregister (das „Register“) einzutragen, welche vom Komplementär oder einer

von der Gesellschaft bestimmten Person geführt wird (die „Registrierungs- und Umschreibungsstelle“) und welches den
Namen, die Anschrift, den Sitz oder den Wohnort jedes Gesellschafters, die Anzahl seiner Aktien (und ihre Klassen,
soweit vorhanden), den für jede Aktie eingezahlten Betrag, Bankverbindungen und - soweit einschlägig - das Übertra-
gungsdatum enthalten.

Die Eintragung des Namens des Gesellschafters im Register bezeugt sein Eigentum an den eingetragenen Aktien. Es

werden keine Aktienzertifikate ausgegeben.

Jeder Gesellschafter kann seine im Register eingetragenen Daten ändern durch Mitteilung an den Komplementär. Jede

Änderung ist ausschlaggebend für alle Handlungen spätestens zwei (2) Wochen nach der Änderung.

Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, die Gesellschaft akzeptiert nur einen Eigentümer pro Aktie. Falls

eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, die mit
dieser Aktie verbunden sind, auszusetzen, bis die gemeinsamen Inhaber eine Person als alleinigen Eigentümer gegenüber
der Gesellschaft benannt haben.

§ 7 Ausgabe von Aktien
(1) Allgemeine Regel
Der Komplementär ist gemäß dem Prospekt und § 7 berechtigt, eine unbeschränkte Anzahl von Kommanditaktien

auszugeben, ohne den bestehenden Gesellschaftern ein Vorzugsrecht einzuräumen, die auszugebenen Kommanditaktien
zu zeichnen. Vorbehaltlich der Regelungen des Prospektes entscheidet der Komplementär nach eigenem Ermessen über
die Ausgabe von Kommanditaktien. Die Kommanditaktien können nur von GUT INFORMIERTEN Investoren gezeichnet
werden. Jede neue ausgegebene Kommanditaktie berechtigt ihren Inhaber mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die
Inhaber der bestehenden Kommanditaktien.

(2) Preis, Zahlung, Weiterer Aktionär

32609

L

U X E M B O U R G

Der Preis pro Kommanditaktie ist auf eintausend Euro (EUR 1.000,00) festgelegt. Der Ausgabepreis pro Kommandit-

aktie ist innerhalb einer im Prospekt angegebenen Frist einzuzahlen. Der Komplementär kann an jeden Geschäftsführer,
Manager oder sonstigen Bevollmächtigten die Berechtigung delegieren, Zeichnungen anzunehmen, Zahlungen des Preises
für die auszugebenden Kommanditaktien entgegenzunehmen und die Kommanditaktien auszugeben.

Der  Komplementär  kann  nach  seinem  Ermessen  zu  einem  oder  mehreren  Terminen  (jeweils  ein  „Nachfolgender

Zeichnungsschluss“) während des Zeitraums vom ersten Zeichnungsschlusses bis zum letzten Zeichnungsschluss weitere
Aktionäre in die Gesellschaft aufnehmen und bestehenden Aktionären das Recht einräumen, ihre Kapitalzusage zu erhö-
hen (weitere Aktionäre sowie bestehende Aktionäre in Bezug auf die Erhöhung ihrer Kapitalzusage werden bezeichnet
als „Weitere(r) Aktionär(e)“).

Im Zeitpunkt oder nach dem Nachfolgenden Zeichnungsschluss ruft der Komplementär zunächst von den Weiteren

Aktionären Kapitalzusagen ab bis zu dem Zeitpunkt, in dem alle Aktionäre zum Kapital der Gesellschaft den gleichen
Anteil ihrer Kapitalzusage beigetragen haben.

(3) Keine Sacheinlagen
Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage auszugeben.
§ 8 Anteile am Gesellschaftsvermögen
Vorbehaltlich der Regelungen in § 10 hinsichtlich Zuweisungen und Ausschüttungen sind alle Aktionäre am Kapital der

Gesellschaft im Verhältnis ihrer Aktien beteiligt.

§ 9 Haftung der Gesellschafter
Die Gesellschafter haften nur bis zu dem Betrag ihrer jeweiligen Kapitalzusage gegenüber der Gesellschaft.
Der Komplementär trägt die unbeschränkte und gemeinschaftliche Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Art. 3. Ergebnisverteilung, Auslagen und Kosten.
§ 10 Ergebnisverteilung
Auf Vorschlag des Komplementärs und innerhalb der nach den luxemburger Gesetzen und Vorschriften dieser Satz-

ungen und dem Prospekt vorgegebenen Zeiträume beschließt die Gesellschafterversammlung über die Verteilung des
Ergebnisses der Gesellschaft und kann Ausschüttungen beschließen oder kann den Komplementär ermächtigen, Aus-
schüttungen zu beschließen oder kann beschließen oder den Komplementär ermächtigen zu beschließen, Zwischendi-
videnden  zu  zahlen,  soweit  dies  nach  dem  anwendbaren  Recht  zulässig  ist.  Die  Zuweisung  und  Ausschüttung  in
Übereinstimmung mit den Vorschriften des Prospektes und das Ergebnis der Gesellschaft ist an die Aktionäre auszu-
schütten im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft.

Ausschüttungen sind unzulässig, soweit danach der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter eine Million Euro (EUR

1.000.000) fallen würde.

Art. 4. Auslagen und Kosten.
§ 11 Auslagen und Kosten.
Die Gesellschaft trägt Auslagen und Kosten gemäß dem Prospekt.

Art. 5. Geschäftsführung und Vertretung.
§ 12 Geschäftsführungsbefugnis
(1) Grundregel
Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Komplementär in Übereinstimmung mit den Beschränkungen dieser Sat-

zung und des Prospektes sowie des zwingend anwendbaren Gesetzesrecht geführt. Die Aktionäre sind nicht berechtig,
die Geschäfte der Gesellschaft zu führen.

Der Komplementär hat Anspruch auf Vergütung für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft durch einen Vorab-

anteil am Ergebnis der Gesellschaft (Ergebnis-Vorab), eine andere Vergütung oder Entschädigung wird nicht geschuldet.
Der vorgenannte Ergebnis-Vorab wird berechnet und bezahlt gemäß den Regeln des Prospekts. Alle Vergütungen des
Komplementärs sind im Prospekt beschrieben.

(2) Geschäftsführungsbefugnis
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Handelsgesellschaftengesetzes, des Prospektes und dieser Satzung hat der Kom-

plementär die weitestgehenden Rechte zur Verwaltung der Gesellschaft.

Alle Rechte, die nicht nach dem Handelsgesellschaftengesetz ausdrücklich der Hauptversammlung der Gesellschafter

vorbehalten sind, werden durch den Komplementär ausgeübt.

Insbesondere, jedoch vorbehaltlich der Beschränkungen gemäß Prospekt und Handelsgesellschaftengesetz, hat der

Komplementär die weitestgehenden Befugnisse, um die Investitionsstrategie, die Kapitalaufnahmebeschränkungen sowie
den Gang der Verwaltung und der Geschäfte der Gesellschaft umzusetzen und die Investitionen für die Gesellschaft zu
verwalten im Hinblick auf die Erreichung der Investitionsstrategie.

(3) Beendigung der Geschäftsführungsbefugnis
Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kommanditisten endet automatisch

mit ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft.

32610

L

U X E M B O U R G

Jede Änderung in der Geschäftsführung oder Auswechslung des Komplementärs muss von der CSSF genehmigt werden.
(4) Übertragung von Befugnissen
Der Komplementär kann von Zeit zu Zeit und unter seiner Verantwortung Geschäftsführer und Bevollmächtigte der

Gesellschaft benennen, welche er für notwendig hält, um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen, vorausgesetzt jedoch,
dass die Aktionäre nicht für die Gesellschaft handeln dürfen ohne ihre beschränkte Haftung zu riskieren.

Der Komplementär kann von Zeit zu Zeit und unter seiner Verantwortung seine Befugnis, bestimmte Aufgaben zu

erfüllen, an einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte übertragen. Insbesondere kann der Komplementär von Zeit zu
Zeit ein oder mehrere Komitees benennen und bestimmte seiner Funktionen an solche Komitees übertragen.

Der Komplementär bestimmt die Befugnisse, Pflichten und über die Vergütung (soweit vorhanden) seiner Bevoll-

mächtigten und/oder Komitees, den Zeitraum ihrer Berufung und alle weiteren relevanten Bedingungen der Benennung.

§ 13 Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis
(1) Grundsatz
Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kommanditisten ist auf das Gesell-

schaftsvermögen beschränkt.

(2) Anlagebeschränkungen
Die Investitionen der Gesellschaft sind gemäß den Regelungen des Prospekts beschränkt.
(3) Interessenkonflikte
Die Wirksamkeit der Verträge und sonstigen Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften

oder Unternehmen wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Komplementär oder einer oder mehrere seiner Aktionäre,
Geschäftsführer, Bevollmächtigten, verbundenen Unternehmen, Angestellten oder Mitarbeiter einen Anteil halten oder
Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellte oder Mitarbeiter dieser anderen Gesellschaft oder dieses anderen Unter-
nehmens sind, mit welchem die Gesellschaft diesen Vertrag abgeschlossen hat oder anderweitig in Geschäftsbeziehung
steht. Der Komplementär und diese Angestellten sind nicht aufgrund der Verbundenheit mit jener anderen Gesellschaft
oder jenem anderen Unternehmen davon ausgeschlossen, sich mit solchen Verträgen oder anderen Geschäften zu be-
fassen, darüber abzustimmen oder sonst diesbezüglich tätig zu werden.

§ 14 Vertretung
Die Gesellschaft wird durch den Komplementär vertreten. Der Komplementär hat freies Ermessen und volle Berech-

tigung und Bevollmächtigung die Gesellschaft zu vertreten und zu verpflichten. Der Komplementär und seine Geschäfts-
führung können jede rechtliche Transaktion als Bevollmächtigter der Gesellschaft abschließen.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des Komplementärs oder die alleinige oder gemein-

same Unterschrift solcher anderer Personen gebunden, denen der Komplementär diese Berechtigung nach seinem freien
Ermessen übertragen hat.

Art. 6. Ausscheiden und Kündigung von Gesellschaftern.
§ 15 Ausscheiden von Gesellschaftern
(1) Einziehung von Aktien
Soweit nicht vom Prospekt oder dem zwingend anwendbaren Recht vorgeschrieben sind die Aktionäre nicht berechtigt

die Einziehung ihrer Kommanditaktien zu verlangen. Der Komplementär kann nach seinem Ermessen beschließen, Kom-
manditaktien einzuziehen, um Ausschüttungen vorzunehmen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts entscheidet
der Komplementär nach seinem alleinigen Ermessen über die Details einer solchen Einziehung. Jede Einziehung ist ge-
genüber allen Aktionären zu erklären.

(2) Beschränkung der Inhaberschaft
Der Komplementär handelnd für die Gesellschaft kann beschränken oder verhindern, dass eine Person (die „Unzu-

lässige Person“) Eigentümer von Kommanditaktien ist oder wird, wenn eine solche Person nicht der Komplementär,
Fonds SCS oder ein Kommanditist von Fonds SCS ist und/oder wenn nach der Beurteilung des Komplementärs eine
solche Inhaberschaft zum Nachteil für die Gesellschaft ist, zu einem Verstoß gegen luxemburger oder ausländische Gesetze
oder Vorschriften führt, oder wenn die Gesellschaft in dessen Ergebnis steuerlichen Nachteilen ausgesetzt wäre, die
anderenfalls nicht aufgetreten wären. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

a) es ablehnen, Kommanditaktien auszugeben und es ablehnen, eine Übertragung einer Kommanditaktie einzutragen,

wenn es den Anschein hat, dass eine solche Ausgabe oder Übertragung möglicherweise dazu führt, dass eine Unzulässige
Person der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer dieser Kommanditaktie wird; und

b) zu jeder Zeit von jeder Person, die im Register eingetragen ist oder die eine Übertragung von Kommanditaktien im

Register eintragen lassen will, zu verlangen, ihr jede Information, unterstützt von eidesstattlicher Erklärung, zukommen
zu lassen, die sie für notwendig hält, um zu bestimmen, ob ein solcher Eintrag dazu führt, dass eine Unzulässige Person
der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer von Kommanditaktien wird oder ist; und

c) die Stimmabgabe jeder Unzulässigen Person auf jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ablehnen; und
d) wenn es für die Gesellschaft den Anschein hat, dass eine Unzulässige Person allein oder zusammen mit anderen

Personen der wirtschaftliche Eigentümer von Kommanditaktien ist, diesen Aktionär anweisen, seine Kommanditaktien

32611

L

U X E M B O U R G

zu verkaufen und der Gesellschaft den Verkauf innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem entsprechenden Hinweis
nachzuweisen. Wenn ein solcher Aktionär dieser Anweisung nicht nachkommt, kann die Gesellschaft alle Kommanditak-
tien, die von diesem Aktionär gehalten werden, wie folgt einziehen:

(i) Die Gesellschaft übersendet dem Aktionär, der diese Kommanditaktien hält, oder der im Register als der Eigentümer

dieser Kommanditaktien erscheint, eine zweite Mitteilung (die an „Ankaufserklärung“), in der die zu erwerbenden Kom-
manditaktien verzeichnet sind, die Art und Weise der Berechnung des Ankaufspreises und der Name des Käufers. Diese
Erklärung kann an den Aktionär durch Einschreiben an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse oder die Adresse,
welche im Register erscheint, gesandt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss des in der Ankaufserklärung genannten
Termins hört der Aktionär auf, Eigentümer der Kommanditaktien zu sein; sein Name ist aus dem Register zu löschen.

(ii) Der Preis, zu dem solche Kommanditaktien erworben werden (der „Ankaufpreis“) entspricht dem Nettoinven-

tarwert  der  jeweiligen  Klasse  zur  Einziehung  dieser  Kommanditaktien  am  letzten  Bewertungstag  vor  dem  Tag  der
Ankaufserklärung.

(iii) Die Zahlung des Ankaufspreises an den vorherigen Eigentümer dieser Kommanditaktien erfolgt in Euro und wird

durch die Gesellschaft zur Zahlung an diesen Eigentümer hinterlegt bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (wie in
der Ankaufserklärung angegeben) im Zeitpunkt der endgültigen Bestimmung des Ankaufspreises. Mit der Übermittlung
der Ankaufserklärung verliert der vorherige Eigentümer alle Rechte bezüglich der Kommanditaktien und er hat auch keine
weiteren Ansprüche gegen die Gesellschaft oder ihr Vermögen in Bezug auf die Kommanditaktien, mit Ausnahme des
Rechtes, den Ankaufspreis (ohne Zins) von einer solchen Bank zu erhalten. Alle Einziehungsvergütungen für einen Aktionär
nach diesem Abschnitt, welche nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach dem in der Ankaufserklärung angegebenen Datum
eingefordert wurden, können danach nicht mehr eingefordert werden und sind der jeweiligen Klasse oder den jeweiligen
Klassen von Kommanditaktien zuzuführen. Der Komplementär ist berechtigt, von Zeit zu Zeit alle notwendigen Schritte
vorzunehmen, um eine solche Rückführung vorzunehmen oder eine solche Handlung für die Gesellschaft vornehmen zu
lassen.

Die Ausübung der Rechte nach diesem § 15 durch die Gesellschaft kann nicht in Frage gestellt werden oder unwirksam

gemacht werden dadurch, dass unzureichende Nachweise für die Eigentümerstellung an Kommanditaktien durch irgend-
eine Person bestand oder dass die wahre Eigentümerstellung an den Kommanditaktien anders war, als es der Gesellschaft
erschien zum Zeitpunkt der Ankaufserklärung, soweit nicht in diesem Fall die Rechte gutgläubig ausgeübt wurden.

§ 16 Ausschluss der Gesellschafter
a) Ausschluss bei Management-Verstoß
Bei einem Management-Verstoß können die Nicht CMP Aktionäre mit einer Mehrheit von mehr als 50% ihrer Stimmen

in einer Hauptversammlung beschließen, den Komplementär als Geschäftsführer aus der Gesellschaft auszuschließen und
einen Nachfolger bestimmen.

Der Beschluss der übrigen Gesellschafter über den Ausschluss ist dem auszuschließenden Komplementär schriftlich

unverzüglich nach Fassung des Beschlusses durch einen in dem Gesellschafterbeschluss zu benennenden Bevollmächtigten
anzuzeigen. Der Ausschluss wird wirksam zu dem in dem Beschluss angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Zu-
stellung des Beschlusses.

Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs endet zu dem in dem Beschluss angegebenen Zeitpunkt. Der An-

spruch des Komplementärs auf den Ergebnis-Vorab endet mit Wirksamkeit des Erlöschens der Geschäftsführungsbefugnis.

b) Ausschluss ohne Management-Verstoß
Ohne Vorliegen eines Management-Verstoßes kann der Komplementär durch Beschluss der Gesellschafter (mit der

Zustimmung der Nicht CMP Aktionäre (mit Ausnahme von CMP)) mit einer Mehrheit von mindestens 80 % ihrer Stimmen
ausgeschlossen werden und können die Zeichnenden Kommanditisten mit der nämlichen Mehrheit einen Nachfolger
bestellen. Über den Ausschluss kann nur Beschluss gefasst werden, wenn der Komplementär sowohl aus der Gesellschaft
als auch aus Fonds SCS ausgeschlossen wird. Die Bestimmungen in Absatz (1) gelten entsprechend. Die Geschäftsfüh-
rungsbefugnis des Komplementärs endet mit der Zustellung des Ausschließungsbeschlusses. Der Komplementär bleibt
zu den im Prospekt angegebenen Entschädigungen berechtigt.

§ 17 Verfügung über Gesellschaftsanteile
(1) Kommanditaktien können nur mit Zustimmung des Komplementärs übertragen werden. Vorbehaltlich der Be-

stimmungen des Prospektes ist diese Zustimmung nur zu geben, wenn der Aktionär einen wichtigen Grund hat.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospektes werden Übertragungen durch Eintragung der Übertragung in das

Register vorgenommen.

Art. 7. Gesellschafterversammlungen.
§ 18 Gesellschafterversammlungen
(1) Verfahren
Die Ladungsfristen, das Verfahren sowie das Diskussionsverfahren folgen den gesetzlichen Regelungen, soweit es nicht

abweichend hierin geregelt ist. Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft werden im Großherzogtum Luxemburg an
einem solchem Ort und zu der Zeit abgehalten, wie sie sich aus der Einladung zu dieser Versammlung ergibt.

32612

L

U X E M B O U R G

Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und sie

sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert ansehen, kann die Versammlung ohne vorherige
Ankündigung stattfinden.

Ein Gesellschafter auf jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschaft handelt durch Bestellung einer anderen Person

(welche kein Gesellschafter sein muss) als sein Vertreter; die Bestellung muss schriftlich erfolgen, dies kann im Original
passieren oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail.

Jede Gesellschafter kann an den Gesellschafterversammlungen per Telefon oder Videokonferenz oder jeder andere

Kommunikationsmöglichkeit, die allen teilnehmenden Personen erlaubt einander zu identifizieren, zu hören und mitei-
nander  zu sprechen,  teilnehmen. Die Teilnahme  an einer  Gesellschafterversammlung  mit  Hilfe  dieser  Mittel  wird  als
gleichwertig zu einer persönlichen Teilnahme angesehen.

Jeder Gesellschafter kann auch mittels Abstimmungsformularen, welche von der Gesellschaft ausgegeben wurden,

abstimmen. Diese Abstimmungsformulare enthalten das Datum und den Ort der Gesellschafterversammlung. Die Ta-
gesordnung der Gesellschafterversammlung, den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse sowie für jeden vorgeschlagenen
Beschluss drei Kästen, welche es dem Aktionär erlauben, für oder gegen eine vorgeschlagenen Beschlussfassung zu stim-
men oder sich der Stimme zu enthalten. Die Abstimmungsformulare sind durch den Aktionär per Post, Telegramm, Telex,
Fax oder E-Mail an den Sitz der Gesellschaft zu senden. Die Gesellschaft akzeptiert nur solche Abstimmungsformulare,
welche  sie  vor  dem  in  der  Einladung  zu  der  Gesellschafterversammlung  angegebenen  Termin  der  Gesellschafterver-
sammlung erhält. Abstimmungsformulare, welche weder eine Abgabe der Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen
Beschluss) noch eine Stimmenthaltung zeigen, sind nichtig.

Vorbehaltlich  dem  Handelsgesellschaftengesetz  und  den  weiteren  Regeln  dieser  Satzung  werden  Beschlüsse  einer

ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit der einfachen Mehrheit der Anwesenden
oder Vertretenen und Abstimmenden gefasst, unabhängig von dem Anteil des Grundkapitals, welches bei einer solchen
Versammlung vertreten ist.

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um irgendeine Bestimmung dieser Sat-

zung abzuändern, ist nicht beschlussfähig, soweit nicht mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist und die
Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält. Wenn dieses Quorum nicht erreicht ist, wird eine
zweite Versammlung einberufen in der Art und Weise, wie sie in der Satzung beschrieben ist. Die zweite Versammlung
ist beschlussfähig unabhängig vom Anteil des vertretenen Grundkapitals in einer solchen Versammlung, wenn dies in der
Einladung zu solch einer Versammlung vermerkt war. In beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, um angenommen zu
werden, die Unterstützung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, wie dies unter Absatz (2) gefordert wird.

Eine Gesellschafterversammlung ist jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einladung benannten Ort

abzuhalten am ersten Tag im Juni eines jeden Jahres.

Gesellschafterversammlungen werden durch den Komplementär mit der Ladungsfrist von mindestens fünfzehn (15)

Tagen schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung einberufen (i) wenn der Komplementär eine
Gesellschafterversammlung für notwendig oder sinnvoll erachtet, (ii) auf Verlangen des Nicht CMP Aktionärs, die min-
destens 10% des Zeichnungskapitals auf sich vereinigen. Die Ladungsfrist beginnt zu laufen mit Beginn des dritten Tags
nach Absendung der Einladung. Soll die Tagesordnung ergänzt werden, muss die Ergänzung den Gesellschaftern spätestens
drei (3) Tage vor Abhaltung der Gesellschafterversammlung zugehen; jeder Gesellschafter hat das Recht, eine Ergänzung
der Tagesordnung zu verlangen.

(2) Beschlussgegenstände
Die Gesellschafterversammlung beschließt über die folgenden Gegenstände:
a) Feststellung des von dem Komplementär erstellten Jahresabschlusses der Gesellschaft;
b) Entlastung des Komplementärs für seine Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr;
c) Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses;
d) Änderungen und Ergänzungen der Satzung, des Prospekts sowie die Auflösung der Gesellschaft (vorbehaltlich der

vorherigen Genehmigung durch die CSSF gemäß SICAR Gesetz, wie nachfolgend);

e) Aufgabe des SICAR-Status (vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die CSSF, wie nachfolgend); und
f) sonstige Beschlussgegenstände, soweit dies in dem Prospekt oder gemäß zwingendem deutschem Gesetzesrecht

vorgesehen ist,

jedes Mal gemäß den Anwesenheits-und Mehrheitsanforderungen für den jeweiligen Beschlussgegenstand.
Das Stimmrecht von Fonds SCS ist ausgeschlossen in Bezug auf Abstimmungen gemäß Absatz (2) lit. b) sowie § 16 (und

jede  weitere  Beschlussfassung  gemäß  Prospekt),  um  einen  möglichen  Interessenkonflikt  zu  vermeiden.  Vorbehaltlich
zwingenden Gesetzesrechtes und den Bestimmungen dieser Satzung ist der Komplementär vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen auf Gesellschafterversammlungen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß diesem Vertrag und zwingendem Gesetzesrecht gilt für die Mehrheitserfor-

dernisse Folgendes: Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Begriff
„Mehrheit“ umfasst mehr als 50% der abgegebenen Stimmen.

32613

L

U X E M B O U R G

Beschlüsse gemäß Absatz 1 Buchstabe d) bedürfen einer Mehrheit von mindestens 75% des Grundkapitals sowie der

Zustimmung des Komplementärs und der vorherigen Zustimmung durch die CSSF. Beschlüsse gemäß diesem Absatz 1
Buchstabe f) bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter und der vorherigen Genehmigung durch die CSSF.

Jede Änderung dieses Absatzes (2) bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter.
Die Kapitalzusagen der Gesellschafter können nur erhöht werden mit der Zustimmung aller Gesellschafter und An-

leihegläubiger.

Der SICAR-Status kann von der Gesellschaft nur mit der vorherigen Genehmigung der CSSF und der Zustimmung

aller Gesellschafter aufgegeben werden.

(3) Vorsitz, Niederschrift
Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung übernimmt einer der Geschäftsführer des Komplementärs, der über

den Gang der Gesellschafterversammlung eine schriftliche Niederschrift anzufertigen hat. Eine Kopie der Niederschrift
versendet der Komplementär an jeden Gesellschafter unverzüglich nach Abhaltung der Gesellschafterversammlung.

(4) Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen
Gesellschafterbeschlüsse können durch Einleitung eines Schiedsverfahrens gemäß dem Prospekt innerhalb von vier

Wochen ab Kenntnis von der Fassung des Gesellschafterbeschlusses angefochten werden.

Art. 8. Laufzeit, Beendigung, Auflösung.
§ 19 Laufzeit
Die Gesellschaft beginnt zu dem in § 1 Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt und endet mit Eintritt eines der nachfolgenden

Ereignisse:

a) am zehnten Jahrestag des Letzten Zeichnungsschlusses, wobei der Komplementär das Recht hat, die Laufzeit der

Gesellschaft zwei (2) Mal um jeweils ein Jahr zu verlängern; eine solche Verlängerung ist den Gesellschaftern drei (3)
Monate zuvor bekanntzugeben; oder

b) bei Eintritt eines der Ereignisse gemäß § 20, vorbehaltlich der dort vorgesehenen Verlängerungsmöglichkeit.
§ 20 Vorzeitige Beendigung
Die Gesellschaft kann willentlich aufgelöst werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welche beschluss-

fähig ist gemäß den Vorschriften für die Abänderung dieser Satzung und der Zustimmung des Komplementärs.

Ungeachtet der Bestimmungen in § 19 endet die Gesellschaft bei Eintritt eines der nachfolgenden Ereignisse: (a) Auf-

lösung  des  Komplementärs;  (b)  Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  über  das  Vermögen  des  Komplementärs  oder
Ablehnung der Eröffnung eines derartigen Verfahrens mangels Masse; oder (c) Ausschluss des Komplementärs. Trotz
Eintritts eines der vorstehenden Ereignisse endet die Gesellschaft vorzeitig nicht, wenn innerhalb von 90 Tagen nach
Eintritt eines der vorstehenden Ereignisse Nicht CMP Aktionäre, die mindestens 75% der Kapitalzusagen der Nicht CMP
Aktionäre auf sich vereinigen, die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen und für den Ausscheidenden einen Nachfolger
bestellen, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der CSSF.

§ 21 Auflösung
(1) Liquidator
Bei Auflösung der Gesellschaft wird der Komplementär zum Liquidator bestellt und liquidiert das Gesellschaftsver-

mögen. Endet die Gesellschaft bei Eintritt eines der in § 27 bezeichneten Ereignisse in Bezug auf den Komplementär, wird
die Gesellschaft liquidiert durch einen Liquidator, der durch Beschluss der Gesellschafter bestellt wird, die mehr als 50%
des Zeichnungskapitals der Gesellschaft auf sich vereinigen.

Diese Liquidatoren müssen von der CSSF genehmigt werden und ihre Redlichkeit und ihre professionellen Fähigkeiten

müssen garantiert sein.

(2) Verteilung des Liquidationserlöses
Die Gewinne und Verluste bei Liquidation des Gesellschaftsvermögens werden auf die Gesellschafter verteilt in ent-

sprechender Anwendung der Bestimmungen in § 10 dieser Satzung.

Art. 9. Bewertung, Buchführung und Berichtswesen.
§ 22 Bewertung des Gesellschaftsvermögens
Das Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft wird auf der Basis des fair value durch den Komplementär bewertet.

Dieser Wert entspricht dem Wert der Vermögensgegenstände abzüglich des Wertes der Verbindlichkeiten und wird wie
folgt ermittelt:

(i) der Wert der Barmittel oder Bareinlagen, Wechsel, Schuldscheine und Forderungen, der transitorischen Aktiva,

noch nicht vereinnahmten, wie vorstehend erklärten oder aufgelaufenen Bardividenden und Zinsen, ist mit dem vollem
Betrag anzusetzen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass der volle Betrag gezahlt bzw. vereinnahmt wird, in welchem
Fall sei nach Vornahme eines vom Komplementär einheitlich zwecks Wiedergabe des wahren Werts als angemessen
erachteten Abschlags bewertet werden;

(ii) Wertpiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis ihres notierten mittleren Handels-

kurses am letzten Handelstag vor dem Bewertungstag bewertet, vorbehaltlich eventueller Abzüge die in Übereinstimmung

32614

L

U X E M B O U R G

mit den EVCA Bewertungsrichtlinien und einheitlich angesichts der Art der Wertpapiere und des Marktes auf dem diese
gehandelt werden vorzunehmen sind;

(iii) alle sonstigen Vermögenswerte gleich welcher Art oder Gattung werden zum üblichen Marktwert bewertet, dieser

wird in gutem Glauben und einheitlich durch oder unter der Verantwortung des Komplementärs unter Übereinstimmung
mit den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und Marktstandards wie durch die EVCA vorgegeben ermittelt.
Zwecks Ermittlung des üblichen Marktwertes der unter diese Bestimmung fallenden Vermögenswerte, kann der Kom-
plementär sämtlichen Faktoren einheitlich Rechnung tragen, die er im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten für
relevant erachtet, wobei diese Faktoren (falls anwendbar) unter anderem folgendes umfassen: (a) die Merkmale und
grundlegenden analytischen Daten dieser Vermögenswerte, einschließlich Kosten, Umfang, derzeitiger Zinssatz, Zeitraum
bis zur nächsten Zinssatzneufestsetzung, Fälligkeit und Lombardzinssatz der Vermögenswerte, Bedingungen und Modali-
täten  der  Schuldenstruktur  der  Vermögenswerte;  (b)  die  Art  und  Angemessenheit  der  Rechte,  Rechtsbehelfe  und
Interessen der Gesellschaft; (c) die Kreditwürdigkeit der Geschäfte in Verbindung mit den Vermögenswerten, Cashflow,
Kapitalstruktur und Zukunftsaussichten; (d) Informationen zu jüngsten erheblichen Markttransaktionen; (e) den guten
Ruf, die Finanzlage und jüngste Berichte in Bezug auf die Vermögenswerte; (f) allgemeine wirtschaftliche Marktbedingun-
gen, welche den üblichen Marktwert der Vermögenswerte beeinflussen.

(iv) Die Vermögenswerte welche nicht in Euro bewertet werden, sind unter Beachtung des jeweiligen Kurswertes vor

Bestimmung des Nettoinventarwertes zu bewerten.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts, ist der Komplementär berechtigt andere Bewertungsgrundsätze auf

die Vermögenswerte der Gesellschaft anzuwenden, wenn die Marktumstände dies verlangen., dies hat jedoch auf einer
einheitlichen Grundlage zu geschehen. Wenn Vermögenswerte bewertet werde, die in ihrer Übertragbarkeit oder ihrem
Verkauf beschränkt sind, so werden diese Vermögenswerte mit einem angemessenen Abschlag bewertet. Alle Bewer-
tungsmethoden und Bestimmungen sind in Übereinstimmung mit den in Lux GAAP anzuwenden.

Außer im Falle von Bösgläubigkeit, Betrug oder einem offensichtlichen Fehler, ist jede Entscheidung des Komplementärs

in Bezug auf die Bewertung des Nettoinventarwerts oder durch die Depotstelle, die Gesellschaft oder andere Organi-
sation,  die  eventuell  durch  den  Komplementär  zur  Bewertung  des  Nettoinventarwerts  bestimmt  wurde  für  die  die
Gesellschaft und ihre bestehenden oder zukünftigen Gesellschafter bindend, vorbehaltlich des Jahresabschlusses durch
den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft als réviseur d'entreprises agréé.

(1) Vermögenswerte
Die Vermögenswerte der Gesellschaft (die „Vermögenswerte“) beinhalten (nicht abschließend)
(i) sämtliche Verfügbaren Barbestände oder Kontoguthaben, inklusive der darauf aufgelaufenen Zinsen;
(ii) sämtlichen Rechnungen und Zahlungsaufforderungen und Forderungen (einschließlich der Erlöse aus verkauften

aber noch nicht ausbezahlten Wertpapieren);

(iii)  sämtliche  Anteile,  Lagerbestände,  Obligationen,  Pfandbriefe,  Zeichnungsrechte,  Optionsscheine  oder  andere

Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte die im Eigentum oder in einem Vertragsverhältnis zur
Gesellschaft stehen (unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft Anpassungen in Bezug auf die Änderung des Markt-
wertes der Wertpapiere hervorgerufen durch Dividenden oder Rechte oder ähnliche Praktiken vornehmen kann);

(iv) sämtliche Aktiendividenden, falls vorhanden, Bardividenden und Barausschüttungen die die Gesellschaft erhält,

soweit die Gesellschaft in einem zumutbaren Maß hiervon Kenntnis erlangt;

(v) sämtliche fälligen Zinsen oder zinsbringenden Vermögenswerte im Vermögen der Gesellschaft, ausgenommen in

dem Umfang, wie diese bereits im Grundkapital solcher Wertpapiere enthalten sind oder darin wiedergegeben werden;

(vi) die liquidierten Erlöse aus sämtlichen Verträgen und Optionen, in welcher die Gesellschaft offene Positionen hat;
(vii) die Organisatorischen Ausgaben der Gesellschaft soweit dies nicht abgeschrieben sind; und
(viii) sämtliche anderen Vermögenswerte jeder Art und Weise einschließlich vorausbezahlter Ausgaben.
(2) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten (nicht abschließend)
(i) sämtliche Darlehen, Rechnungen und Abrechnungsverbindlichkeiten;
(ii) sämtliche angefallenen Zinsen oder Darlehen der Gesellschaft (einschließlich angefallener Gebühren oder Ver-

pflichtungen für solche Darlehen);

(iii)  sämtliche  angefallene  Kosten  (einschließlich  Verwaltungskosten,  Depotstellengebühren  und  jeglichen  anderen

Agentengebühren);

(iv) sämtliche bekannten Verbindlichkeiten, sowohl gegenwärtige als auch zukünftige, einschließlich vertraglich gereifter

Verpflichtungen für Geldund Besitzzahlungen, einschließlich des Betrages eventueller nicht ausgezahlter Dividenden durch
die Gesellschaft;

(v) eine angemessene Vorhaltung für zukünftige Steuern, basierend auf Kapital und Einkommen der Gesellschaft am

Bewertungstag und andere Reserven (soweit vorhanden) gestattet und bestätigt durch den Komplementär, sowie einen
Betrag (soweit vorhanden) als angemessene Rücklage in Bezug auf mögliche weitere Verbindlichkeiten der Gesellschaft;

(vi) sämtliche weiteren Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art und Weise bemessen nach den Lux GAAP. Bei

der Feststellung des Betrages dieser Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft die zu Zahlenden Ausgaben entsprechend

32615

L

U X E M B O U R G

Abschnitt E.II dieser Satzung in Betracht zu ziehen. Die Gesellschaft kann verwaltungstechnische und andere Ausgaben
laufender oder periodisch wiederkehrender Art auf einer geschätzten Zahl für jährliche oder andere Zeiträume im Voraus
berechen.

(3) Aufhebung der Kalkulation des Nettoinventarwertes
Der Komplementär kann die Kalkulation des Nettoinventarwertes in folgenden Fällen aufheben:
a) wenn es aufgrund außerhalb der Gesellschaft liegender Umstände nach vernünftiger Ansicht des Komplementärs

nicht möglich ist den Nettoinventarwert zu ermitteln; oder

b) wenn die Börse, an der Investitionen der Gesellschaft notiert sind geschlossen hat (außer an Feiertagen), oder

während eines Zeitraumes in dem ein Handeln an einer solchen Börse nicht erlaubt oder ausgesetzt ist; oder

c) in Notsituationen in denen eine Bewertung des Nettoinventarwertes nicht möglich ist; oder
d) im Falle eines Zusammenbruchs oder Nutzungseinschränkungen von Kommunikationsmitteln welche normaler-

weise zur Ermittlung des Wertes oder Preises einer Investition oder Tageskurses an einer Börse benutzt werden.

§ 23 Buchführung
Die Verwaltungsstelle führt die Bücher der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter oder ein ge-

setzlich  zur  Berufsverschwiegenheit  verpflichteter  Beauftragter,  einschließlich  externer  Berater,  hat  das  Recht  zur
jederzeitigen Einsichtnahme in die Geschäftsbücher zu den regulären Geschäftszeiten. Die Geschäftsbücher sind während
der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume aufzubewahren, mindestens jedoch während der Dauer der Gesellschaft und
fünf Jahre danach. Die zwingenden gesetzlichen Einsichtsrechte der Gesellschafter bleiben unberührt. Die Bücher der
Gesellschaft werden in Euro geführt. Der Jahresabschluss wird innerhalb der gesetzlichen Fristen nach den allgemein
anerkannten Luxemburger Rechtsvorschriften und dem Handelsgesellschaftengesetz aufgestellt und geprüft.

§ 24 Berichtswesen
(1) Jahresbericht
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts legt der Komplementär des Gesellschafters einen Jahresbericht der

Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des SICAR-Gesetzes und des Handelsgesellschaftengesetzes vor.

(2) Sonstige Informationen
Die Gesellschaft stellt den Gesellschaftern die weiteren Informationen gemäß Prospekt zur Verfügung.

Art. 10. Schlussbestimmungen.
§ 25 Depotstelle, Gesetzlicher Prüfer
(1) Depotstelle
Die Gesellschaft hat einen Depotvertrag mit einer Depotbank abgeschlossen, welche den gesetzlichen Bestimmungen

des SICAR-Gesetzes genügen muss (die „Depotstelle“). Sämtliche Gelder und Wertpapiere der Gesellschaft werden von
der Depotstelle oder in gutem Glauben ordnungsgemäß bevollmächtigten Agenten gehalten, welche gegenüber der Ge-
sellschaft und ihren Gesellschaftern die ihnen durch das SICAR-Gesetz vorgesehenen Aufgaben übernehmen sollen.

Falls die Depotstelle sich zurückziehen möchte, bemüht sich der Komplementär nach Kräften, innerhalb von zwei (2)

Monaten nach Inkrafttreten dieses Rücktritts einen Nachfolger zu finden und ernennt diesen anschließend anstelle der
ausscheidenden  Depotstelle.  Der  Komplementär  kann  die  Bestellung  der  Depotstelle  beenden,  darf  sie  jedoch  nicht
abberufen, bis ein Nachfolger gemäß dieser Bestimmung ernannt wurde, um an ihre Stelle zu treten.

Die Pflichten der Depotstelle erlöschen:
(i) im Falle eines freiwilligen Rückzugs der Depotstelle oder ihrer Abberufung durch die Gesellschaft; bis sie ersetzt

ist, muss die Depotstelle alle notwendigen Maßnahmen im Interesse der Gesellschafter weiterführen; oder

(ii) im Falle, dass die Depotstelle oder die Kommanditgesellschaft (a) Konkurs angemeldet haben, (b) eine Zahlungs-

einstellung erwirkt haben, (c) einen Vergleich mit Gläubigern eingegangen sind, (d) unter Zwangsverwaltung oder ein
ähnliches Verfahren gestellt wurden, oder (e) liquidiert wurden; oder

(iii) wenn die CSSF der Depotstelle oder der Gesellschaft die Zulassung entzieht.
(2) Unabhängiger Prüfer
Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation einschließlich der Bücher der Gesellschaft werden von

einem Buchprüfer („Réviseur d'Entreprises“) überwacht welcher die luxemburger gesetzlichen Anforderungen hinsicht-
lich Redlichkeit und professioneller Erfahrung erfüllen soll und welcher die Pflichten erfüllen soll, welche im SICAR-Gesetz
vorgeschrieben sind. Der Prüfer wird durch den Komplementär ausgewählt und hat seine Verpflichtungen zu erfüllen, bis
ein Nachfolger gewählt wurde.

§ 26 Freistellung
Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellten, Berater und Bevoll-

mächtigten der Gesellschafter frei gemäß den Bestimmungen des Prospekts.

§ 27 Änderungen der Satzung, Anwendbares Recht
(1) Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit abgeändert werden durch eine Gesellschafterversammlung unter Einhaltung

der Anforderungen hinsichtlich Quorum und Mehrheiten gemäß § 18, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung
der CSFF.

32616

L

U X E M B O U R G

(2) Auf diesen Vertrag findet das Recht des Großherzogtums Luxemburg Anwendung.

<i>Zeichnung und Zahlung

Gesellschafter

Gezeichnetes

Kapital

CMP German Opportunity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.000,-

CMP German Opportunity Investors Fund II (SCS) (SICAR): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 30.000,-
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,-

Der Nachweis für die Einzahlung wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Grün-

dung entstehen, betragen ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200,-).

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 Handelsgesellschaftengesetz in seiner jeweils geltenden

Fassung vorgesehenen Bestimmungen aufgehoben wurden.

<i>Versammlung der Gesellschafter

Die oben genannten Personen, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und sich als ordnungsgemäß einbe-

rufen betrachten, halten unmittelbar im Anschluss eine außerordentliche Gesellschafterversammlung.

Nachdem zunächst beglaubigt wurde, dass die Gesellschaft ordnungsgemäß gegründet wurde, fassen diese einstimmig

den folgenden Beschluss.

<i>Einziger Beschluss

Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in der 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, deren Namen, Nachnamen, Zivilstand und Wohnort dem Notar

bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die vorgenannten Personen diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: H. Witzke et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59343. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011008276/1312.
(110010005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Michel Albert Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 87.966.

<i>Extrait de résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28.01.2011

Les actionnaires de la société MICHEL ALBERT INVESTISSEMENTS S.A. réunis le 28.01.2011 au siège social, ont décidé

à l’unanimité ce qui suit:

1. Accepter la démission de Monsieur Nicolas BANNASCH de son mandat d’administrateur;

Fait à Luxembourg, le 28.01.2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011028369/14.
(110034434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32617

L

U X E M B O U R G

SBSM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 92.180.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 mai 2010

<i>Résolutions

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
1. L’assemblée générale décide de révoquer la société FIDUGEC SARL au poste de commissaire aux comptes et décide

de la remplacer par la société Jawer Consulting SA ainsi que son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg et
ce jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028419/14.
(110034431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

People Skill S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 128.889.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pirard L-P.

Référence de publication: 2011028381/10.
(110034268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Polychord S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 142.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 Janvier 2011.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011028383/11.
(110034138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Sami-Bau G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9091 Ettelbrück, 1A, rue Michel Weiler.

R.C.S. Luxembourg B 106.868.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011028417/10.
(110034226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Pol S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 51.887.

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32618

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011028391/12.
(110033999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Potosi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 118.547.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2011.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A.

SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

<i>Pour la société
POTOSI S.A.

Référence de publication: 2011028393/15.
(110033871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Pranceworth Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 102.309.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 février 2011 que:
1. Sont réélus, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014:
- Monsieur Patrick MOINET, administrateur de catégorie A,
- Monsieur Olivier LIEGEOIS, administrateur de catégorie A,
- Monsieur James William DUFFY, administrateur de catégorie B,
- Monsieur Maurice THOMAS GREIG, administrateur de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011028394/17.
(110034480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

S A S Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028406/9.
(110033944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Quattro Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 141.990.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2011, la dénomination de la

rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

32619

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011028398/12.
(110034447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Rootness S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 89.678.

Lors de l’Assemblée Ordinaire des actionnaires tenue le 30 décembre 2010, il a été résolu ce qui suit:
1. Réélection de M. Anders BERGGREN, M. Torben MADSEN et de M. Gilles WECKER comme administrateurs au

conseil d’administration de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale;

2. Réélection de MODERN TREUHAND S.A. comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à la prochaine

assemblée générale.

At the Ordinary Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on 30 

th

 December 2010, it has

been resolved the following:

1. To re-elect Mr. Anders BERGGREN, Mr. Torben MADSEN and Mr. Gilles WECKER as a directors of the company

until the next annual general meeting;

2. To re-elect MODERN TREUHAND S.A. as the statutory auditor of the company until the next annual general

meeting.

Référence de publication: 2011028404/18.
(110033969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Snera Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 121.361.

En date du 20 décembre 2010, Marie-Laurence Lambert, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la société Snera Lux S.à r . l , avec siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 121 361

Alter Domus, mandaté par le démissionaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011028410/13.
(110034470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Saint-James Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 95.439.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028415/9.
(110034459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.424.

Par résolution circulaire signée en date du 14 février 2011, l'associé unique a décidé de nommer Hamsa Shadaksharappa,

avec adresse professionnelle au 245, Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028411/12.
(110034379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32620

L

U X E M B O U R G

Spes Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.830.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’asseblee générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 16 février 2011

Il ressort des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 février 2011:
que FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 12, Bâtiment F, rue Guillaume Kroll, à L-1882

Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42 230 est nommé
Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée statutaire de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pierre-Siffrein GUILLET / Christian FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011028412/15.
(110034241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Savelec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 14, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.425.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

25 février 2011.

Référence de publication: 2011028418/10.
(110034415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Schmit &amp; Klein Invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 141.839.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF
<i>EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011028421/13.
(110034204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Silvretta Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.969.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration

Il résulte des résolutions circulaires prises par le Conseil d'Administration que:
Mademoiselle Caria Alves Silva, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, a été nom-

mée, avec effet au 26 Avril 2011, en qualité de représentant permanent de la société DMC S.à r.l., administrateur de
catégorie B de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 Février 2011.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011028426/15.
(110034191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32621

L

U X E M B O U R G

Syrius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.373.

<i>Extrait des résolutions prises par les gérants en date du 11 février 2011

Les gérants acceptent la démission de Monsieur Alan John TAYLOR, demeurant à 3, Broughton Court, La Verte Rue,

St Mary, Jersey JE3 3DA, Channel Island de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 9 février 2011.

Est nommée gérant de catégorie A, avec effet au 9 février 2011:
Madame Christine Veronica STOCKTON, née le 20 décembre 1953 à Romford (GB), demeurant 15, Esplanade, JE2

3 St. Helier, Jersey.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011028437/16.
(110033979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Triplane S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 79.481.

La société DMS &amp; Associés S.à r.l.
43, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B46477
Ici représenté par Monsieur Christophe Fender
Dénonce le contrat de domiciliation conclu le 30 novembre 2000 avec
La société Triplane S.A.
43, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B79481
Avec la date d’effet le 27 janvier 2011
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La société DMS &amp; Associés S.à r.l.
Monsieur Christophe Fender

Référence de publication: 2011028444/20.
(110034015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

TTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 116.259.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l’associé unique en date du 25 février 2011 que:
- Monsieur Jeffrey Blake Johnson, né le 4 décembre 1964 au Kentucky, USA, résidant professionnellement au 2500

Northwinds Parkway, Suite 500, Alpharetta, Georgia 30009 USA, a été nommé gérant B avec effet immédiat pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028445/15.
(110034395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32622

L

U X E M B O U R G

Um Gruew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1280 Luxembourg, 3, rue du Père Jacques Brocquart.

R.C.S. Luxembourg B 136.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011028446/10.
(110034400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Usines Roboto, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 13-15, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 11.621.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011028447/10.
(110034300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Unistar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 72, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.426.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du gérant unique en date du 01 février 2011:
Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 72 Avenue de la Faïencerie L – 1510 Luxembourg.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028449/12.
(110033956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

VoiceCom GmbH (S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 22A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 81.986.

Suite à des cessions de parts intervenues sous seing privée en date du 21 février 2011, le capital social de la société

VoiceCom GmbH est dés à présent souscrit comme suit:

Monsieur Emile GUTENKAUF, né le 16 juillet 1959, demeurant au 6, Brillwee L – 8274 Kehlen 400.- parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028451/11.
(110033896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

VAN GEET, DERICK &amp; Co, réviseurs d'entreprises, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 73.376.

Nous vous signalons que la société CVBA VEGEDE associée de la société susmentionnée a changé d'adresse.
La nouvelle adresse est:
CVBA VEGEDE
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
B-1090 Brussel (Jette)

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011028452/14.
(110034425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32623

L

U X E M B O U R G

Venoplas, Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

R.C.S. Luxembourg B 108.329.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028455/9.
(110034273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Veroninvest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 72.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011028459/10.
(110034304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Nivard S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 158.202.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1) La société à responsabilité limitée "A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée", ayant son

siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 127.330,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2010.
2) Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant

professionnellement à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2010.
Les  prédites  procurations,  après  avoir  été  signées  "ne  varietur"  par  le  mandataire  des  comparantes  et  le  notaire

instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, ici représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de dresser acte con-

stitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elle...t arrêté les statuts comme suit.

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", sous
la dénomination de "NIVARD S.A. SPF".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-
bourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

32624

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion

et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Par instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre

(a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des
actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les
certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les
titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du
marché monétaire, (d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e)
tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières pré-
cieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents
éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient
matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endos-
sables ou non-endossables et quelque soit le droit qui leur est applicable.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large, à condition que la société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle
détient, tout en restant dans les limites de la loi sur les SPF.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions quatre cent mille euros (€ 3.400.000.-), représenté par trente-quatre

mille (34.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l'article 3 de la loi sur les

SPF.

Les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sou...es conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. En cas

de vente de l'usufruit ou de la nue propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue propriété sera déterminée par la valeur
de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue propriété conformément aux
tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réserves expressément
par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues
par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux adminis-

32625

L

U X E M B O U R G

trateurs, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous

dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie
en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société,
de toute autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et

pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi qu'avec la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 15, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011 et par dérogation

à l'article 14, la première assemblée annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription

Les trente-quatre mille (34.000) actions ont été souscrites comme suit:

32626

L

U X E M B O U R G

1. La société "A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée",
préqualifiée, dix-sept mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
2. Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée, dix-sept mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
TOTAL: TRENTE-QUATRE MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence d'un million d'euros (€ 1.000.000.-), de

sorte que le montant d'un million d'euros (€ 1.000.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à trois mille deux cents euros (€
3.200.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes:

1) L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) la société à responsabilité limitée "A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée", préqualifiée.
b) Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée.
c) la société à responsabilité limitée "TAXIOMA s. à r.l.", ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 128.542.

Madame Maryse MOUTON, expert-comptable et réviseur d'entreprises, née à Aye (Belgique), le 25 mai 1966, de-

meurant professionnellement à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains est désignée représentante permanente de la société
"A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée" préqualifiée.

Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée, est désignée représentante permanente de la société "TAXIOMA s. à r.l."

préqualifiée.

2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Paul JANSSENS, employé privé, né à Lier (Belgique), le 23 février 1963, demeurant à L-5692 Elvange, 2, rue

des Prés.

3) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de 2015.

4) Le siège de la société est fixé à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 5 janvier 2011. Relation: CAP/2011/78. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bascharage, le 12 janvier 2011.

A. WEBER.

Référence de publication: 2011011238/184.
(110012107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Versale Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 65.203.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que les administrateurs de la Société ont changé d’adresse comme suit:
- Monsieur Gilles JACQUET a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Lu-

xembourg;

32627

L

U X E M B O U R G

- Lux Business Management S.à.r.l. a désormais son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011028460/16.
(110034143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Villa Romaine Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 83.003.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF
<i>EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011028462/13.
(110034206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

World Power Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.747.950,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.503.

Par résolution circulaire signée en date du 14 février 2011, l'associé unique a décidé de nommer Hamsa Shadaksharappa,

avec adresse professionnelle au 245, Park Avenue, 10167 New-York, Etats-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011028463/12.
(110034483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Wollbuttek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 31, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 19.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028466/10.
(110034416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

World Trade Polymers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.518.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WORLD TRADE POLYMERS S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011028468/11.
(110034194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32628

L

U X E M B O U R G

Ribeaumont Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Ribeaumont Holding S.A.).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 84.503.

L'an deux mille dix, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RIBEAUMONT HOLDING S.A., une

société anonyme holding ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, Boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 84.503, constituée suivant acte notarié du 13 novembre
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 396 du 12 mars 2002, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte notarié du 27 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 484 du 27 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric MANNIS, employé privé, demeurant professionnelle-

ment au 16, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Anthony GRACA, employé privé, demeurant professionnellement

au 16, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabrice SCOTT, employé privé, demeurant professionnellement au

16, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet de la Société afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

« Art. 2. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, au sens de la

loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société n'aura aucune activité commerciale.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit et émettre des obligations.
La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial

«SPF».»

2.- Transformation de la Société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de

gestion de patrimoine familial («SPF») conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

3.- Changement en conséquence de la dénomination de la société.
4.- Refonte complète des statuts.
5.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, au sens de la

loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société n'aura aucune activité commerciale.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit et émettre des obligations.
La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial

«SPF».»

32629

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer la société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,

en société de gestion de patrimoine familial («SPF») conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société et de modifier en conséquence l'article 1 

er

 pour lui

donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des Actions, une société anonyme

régie par la loi du 11 mai 2007 relative à la société de gestion de patrimoine familial («SPF») prenant la dénomination de
«Ribeaumont Holding SPF S.A.» (la Société).»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide, afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précède, de procéder à une

refonte complète des statuts. Ces derniers auront dès lors la teneur suivante:

«Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des Actions, une société anonyme

régie par la loi du 11 mai 2007 relative à la société de gestion de patrimoine familial («SPF») prenant la dénomination de
«Ribeaumont Holding SPF S.A.» (la Société).»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, au sens de la loi

du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

La Société n'aura aucune activité commerciale.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit et émettre des obligations.
La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial

«SPF».

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00), divisé en deux mille (2.000) actions sans

désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont détenues par les investisseurs éligibles au sens de la Loi.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi: a) une personne physique agissant dans le cadre de la

gestion de son patrimoine privé ou b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé
d'une ou de plusieurs personnes physiques ou c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou
b) du présent paragraphe. Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à
défaut, des dirigeants de la SPF.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

32630

L

U X E M B O U R G

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de

32631

L

U X E M B O U R G

quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille euros (1.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MANNIS, A. GRACA, F. SCOTT, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57975. Reçu: soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32632

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010914/216.
(110012468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Xenon Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.844.

Le Bilan arrêté au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011028470/10.
(110034284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

4U Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 111.606.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028475/11.
(110033862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Arjufra Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 152.288.

Il résulte d’un contrat d’apport que l’associé unique a apporté la totalité de ses parts sociales à Arjufra Holding (Cyprus)

Limited, une société de droit chypriote ayant son siège social au Julia House, 3 Th. Dervi Street, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus,
qui les détient en totalité avec effet au 26 mars 2010.

En conséquence, l'associé unique est le suivant:
Arjufra Holding (Cyprus) Limited avec 500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 22 février 2011.

Référence de publication: 2011028492/14.
(110034500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Artmarkt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 69.026.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 juin 2010

- Les mandats de Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant

au 19, rue des Champs à L-3912 Mondercange, de Monsieur Celso GOMES DOMINGUES, employé privé, né le 21 février
1978 à Luxembourg (L), demeurant au 219, rue Albert Unden et de Monsieur Alain VASSEUR, consultant, né le 24 avril
1958 à Dudelange (L), demeurant au 3, rue de Mamer à L-8277 Holzem en tant qu’administrateurs, ainsi que le mandat
de la société TRIPLE A CONSULTING, R.C.S. Luxembourg B 61417, établie au 2, Millegässel à L-2156 Luxembourg en
tant que Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de 2016.

Certifié sincère et conforme
ARTMARKT S.A.

Référence de publication: 2011028493/17.
(110034681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

32633

L

U X E M B O U R G

Astriger Services, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-5328 Medingen, 12, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 143.695.

L’associé unique d’Astriger Services LLC décide de transférer à compter du 01/01/2011 le siège social de ASTRIGER

SERVICES, succursale luxembourgeoise de Astriger Services LLC , du 11 avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG
(ancienne adresse) au 12 rue de la Chapelle L-5328 MEDIGEN (nouvelle adresse).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et associations.

Luxembourg, le 31/12/2010.

Référence de publication: 2011028495/12.
(110035154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

A. Rolf Larsen Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 27.713.

Im Jahre zweitausendzehn, am dritten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,
traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der „A. ROLF LARSEN HOLDING

S.A.“, Gesellschaft mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, die gegründet wurde gemäß notarieller
Urkunde vom 16. März 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 151 vom 4.
Juni 1988.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde vom 25. Mai 2000, veröffentlicht

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 492 vom 1. Juli 2000.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, mit beruflicher Anschrift

in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Ekaterina DUBLET, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2,

avenue Charles de Gaulle.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Alexia UHL, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg,

2, avenue Charles de Gaulle.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I.- Aus einer durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigten gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich

die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einbe-
rufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Aktionären vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1. Änderung des Holdingstatus der Gesellschaft nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 in eine Gesellschaft zur Verwaltung

von Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“) nach dem Gesetz vom 11. Mai 2007.

2. Anpassung von Artikel 4 der Satzungen wie folgt :

„ Art. 4. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz und die Verwaltung und Veräußerung

von Aktiva bestehend aus Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten sowie
von Bargeld und Guthaben jeglicher Art, die auf einem Konto geführt werden.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen halten, jedoch ohne in deren Geschäftsführung eingebunden zu sein.
Sie darf keine kommerzielle Tätigkeit ausüben.
Die Aktien der Gesellschaft können nur von natürlichen Personen, die im Rahmen der Verwaltung ihres privaten

Vermögens handeln, gehalten werden oder von Vermögensgemeinschaften jeglicher Form, die ausschließlich im Interesse
einer oder mehrerer natürlicher Personen handeln, oder von Vermittlern die für einzelne vorerwähnte Investoren han-
deln.

Die von der Gesellschaft ausgegebenen Wertpapiere können nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots sein und

dürfen nicht zur Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch immer im Rahmen
des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de
patrimoine familial“).“

32634

L

U X E M B O U R G

3. Änderung von Artikel 1 der Satzungen um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben :

„ Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen in der Form einer Aktiengesellschaft unter

der Bezeichnung „A. ROLF LARSEN HOLDING S.A.“

4. Anpassung von Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 und Artikel 17 Absatz 2 der Satzungen um sie an das Gesetz vom 25

August 2006 anzupassen, wie folgt:

„ Art. 7. Absatz 4. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Video-

oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben”.

„ Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.“

„ Art. 17. Absatz 2. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten,

einen derartigen Antrag stellen“.

5. Anpassung von Artikel 16 , Absatz 1 und Artikel 19, Absatz 1 der Satzungen um sie fortan folgenden Wortlaut zu

geben:

„ Art. 16. Absatz 1. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben

genannten Ort zusammen und zwar am ersten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 15.00 Uhr.“

„ Art. 19. Absatz 1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.“
6. Anpassung von Artikel 22 der Satzungen um sie an das Gesetz vom 11. Mai 2007 anzupassen, wie folgt:

„ Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen, und des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die
Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“). “

7. Abschaffung von Artikel 14 der Satzungen und nachfolgende Renumerierung von Artikeln der Satzungen.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt den Holdingstatus der Gesellschaft nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 in eine

Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“) nach dem Gesetz vom
11. Mai 2007 zu ändern und Artikel 4 der Satzungen wie folgt anzupassen:

„ Art. 4. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz und die Verwaltung und Veräußerung

von Aktiva bestehend aus Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 über Finanzsicherheiten sowie
von Bargeld und Guthaben jeglicher Art, die auf einem Konto geführt werden.

Die Gesellschaft darf Beteiligungen halten, jedoch ohne in deren Geschäftsführung eingebunden zu sein.
Sie darf keine kommerzielle Tätigkeit ausüben.
Die Aktien der Gesellschaft können nur von natürlichen Personen, die im Rahmen der Verwaltung ihres privaten

Vermögens handeln, gehalten werden oder von Vermögensgemeinschaften jeglicher Form, die ausschließlich im Interesse
einer oder mehrerer natürlicher Personen handeln, oder von Vermittlern die für einzelne vorerwähnte Investoren han-
deln.

Die von der Gesellschaft ausgegebenen Wertpapiere können nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots sein und

dürfen nicht zur Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern, dies jedoch immer im Rahmen
des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de
patrimoine familial“).

<i>Zweiter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt Artikel 1 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen in der Form einer Aktiengesellschaft unter

der Bezeichnung „A. ROLF LARSEN HOLDING S.A.“

<i>Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 und Artikel 17 Absatz 2 der Satzungen um sie an

das Gesetz vom 25 August 2006 wie folgt anzupassen:

„ Art. 7, Absatz 4. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Video-

oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben”.

„ Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.“

32635

L

U X E M B O U R G

„ Art. 17. Absatz 2. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen“.

<i>Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt Artikel 16 , Absatz 1 und Artikel 19, Absatz 1 wie folgt anzupassen:

„ Art. 16. Absatz 1. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben

genannten Ort zusammen und zwar am ersten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 15.00 Uhr.“

„ Art. 19, Absatz 1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.“

<i>Fünfter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt Artikel 22 der Satzungen um ihm an das Gesetz vom 11. Mai 2007 anzupassen,

wie folgt:

„ Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen, und des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die
Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen („société de gestion de patrimoine familial“). “

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 14 der Satzungen abzuschaffen und beschließt eine Neunumerierung von

nachfolgenden Artikeln vorzunehmen.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. LENTZ, E. DUBLET, A. UHL, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 08. Dezember 2010. Relation: EAC/2010/15409. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75.-EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011009015/123.
(110010620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Medinvest International (Invecom Management) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.357.

Il résulte d’une lettre datée du 24 janvier 2011 que Monsieur Luca Paveri Fontana a démissionné de sa fonction de

membre du conseil de surveillance.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028365/11.
(110034185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

APERAM Sourcing S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.760.

<i>Transfert de siège social

En date du 7 février 2011, le siège social de la société APERAM Sourcing S.C.A. a été transféré du 19 avenue de la

Liberté, L-2930 Luxembourg vers le 12C rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Son gérant, la société APERAM, société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B 155908, a été nommé en date du 25.01.2011.

Le membre du Conseil de Surveillance, la société AM HoldCo S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B152762, en date du 15 février 2011, a changé sa dénomination
en APERAM HoldCo S.à r.l. et a transféré son siège social du 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg vers le 12C
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

32636

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028514/18.
(110034954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Amber Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.646.

Les comptes annuels au 30.09.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AMBER HOLDING S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011028508/11.
(110035178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Ananas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 102.405.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 janvier 2011 que:
1. Sont réélus administrateur de la société, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui approu-

vera les comptes arrêtés au 31 décembre 2013:

Monsieur Patrick MOINET,
Monsieur Olivier LIEGEOIS,
Monsieur Luc GERONDAL.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 février 2011.

Référence de publication: 2011028510/17.
(110034931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Avolon Holding Corporation (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 120.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 152.746.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts en date du 27 décembre 2010 par lequel la société Oak Hill Capital Partners

III, L.P., ayant sont siège social au 87, Mary Street, bâtiment Walker House, KY1-9002 George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, immatriculée au Registre des Exempted Limited Partnerships Cayman Islands, sous le numéro WK-21633,
a cédé:

- 2.246 parts sociales de classe B1
- 2.246 parts sociales de classe B2
- 2.246 parts sociales de classe B3
- 2.246 parts sociales de classe B4
- 2.246 parts sociales de classe B5
- 2.246 parts sociales de classe B6
- 2.246 parts sociales de classe B7
- 2.246 parts sociales de classe B8
- 2.246 parts sociales de classe B9
- 2.246 parts sociales de classe B10,

32637

L

U X E M B O U R G

lui appartenant dans la Société, au profit de Avolon Holding Corporation (Luxembourg) III S.à r.l., une société de droit

luxembourgeois ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.858.

Il résulte de ce même contrat de cession de parts que la société Oak Hill Capital Management Partners III, L.P., ayant

sont siège social au 87, Mary Street, bâtiment Walker House, KY1-9002 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
immatriculée au Registre des Exempted Limited Partnerships Cayman Islands, sous le numéro WK-21632, a cédé:

- 194 parts sociales de classe B1
- 194 parts sociales de classe B2
- 194 parts sociales de classe B3
- 194 parts sociales de classe B4
- 194 parts sociales de classe B5
- 194 parts sociales de classe B6
- 194 parts sociales de classe B7
- 194 parts sociales de classe B8
- 194 parts sociales de classe B9
- 194 parts sociales de classe B10,
lui appartenant dans fa Société, au profit de Avolon Holding Corporation (Luxembourg) III S.à r.l., une société de droit

luxembourgeois ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.858.

En conséquence, suite à la précédente cession, la société Avolon Holding Corporation (Luxembourg) III S.à r.l. est à

présent détentrice des parts sociales suivantes:

- 2.440 parts sociales de classe B1
- 2.440 parts sociales de classe B2
- 2.440 parts sociales de classe B3
- 2.440 parts sociales de classe B4
- 2,440 parts sociales de classe B5
- 2.440 parts sociales de classe B6
- 2.440 parts sociales de classe B7
- 2.440 parts sociales de classe B8
- 2.440 parts sociales de classe B9
- 2.440 parts sociales de classe B10,
la société Oak Hill Capital Partners III, L.P. est à présent détentrice des parts sociales suivantes:
- 6.959 parts sociales de classe B1
- 6.959 parts sociales de classe B2
- 6.959 parts sociales de classe B3
- 6.959 parts sociales de classe B4
- 6.959 parts sociales de classe B5
- 6.959 parts sociales de classe B6
- 6.959 parts sociales de classe B7
- 6.959 parts sociales de classe B8
- 6.959 parts sociales de classe B9
- 6.959 parts sociales de classe B10,
et la société Oak Hill Capital Management Partners III, L.P. est à présent détentrice des parts sociales suivantes:
- 601 parts sociales de classe B1
- 601 parts sociales de classe B2
- 601 parts sociales de classe B3
- 601 parts sociales de classe B4
- 601 parts sociales de classe B5
- 601 parts sociales de classe B6
- 601 parts sociales de classe B7
- 601 parts sociales de classe B8
- 601 parts sociales de classe B9
- 601 parts sociales de classe B10.

32638

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011009031/79.
(110010863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

APERAM HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 152.762.

Les deux associés de la société APERAM HoldCo S.à r.l., sont:
- WiCo 1, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B157808,
- WiCo 2, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B157809.
Au 15 février 2011, les deux associés ont transféré leur siège social du 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg

vers le 12C rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028513/14.
(110034853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

APERAM Treasury S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.775.

En date du 7 février 2011, le siège social de la société APERAM Treasury S.C.A. a été transféré du 19 avenue de la

Liberté, L-2930 Luxembourg vers le 12C rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Son gérant, la société APERAM, société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B 155908, a été nommé en date du 25.01.2011.

Le membre du Conseil de Surveillance, la société AM HoldCo S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B152762, en date du 15 février 2011, a changé sa dénomination
en APERAM HoldCo S.à r.l. et a transféré son siège social du 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg vers le 12C
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028515/17.
(110034985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Aviva Investors Portefeuille II, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.503.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l´Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société qui a eu lieu le Vendredi 18

<i>Février 2011

L´Assemblée Générale procède à la nomination des Administrateurs, pour un nouveau mandat qui expirera à la pro-

chaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Au 18 Février 2011, le Conseil d’Administration se compose comme suit,
- M. Jean-Luc FRANÇOIS, Président et Administrateur
- M. Jean-François BOULIER, Administrateur
- M. Stéphane ROUGIER, Administrateur
L´Assemblée Générale a élu Ernst &amp; Young S.A. en tant que Réviseur d´Entreprises jusqu´à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 Février 2011.

Référence de publication: 2011028499/20.
(110034520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

32639

L

U X E M B O U R G

Elite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange.

R.C.S. Luxembourg B 153.791.

<i>Résolutions du 17 février 2011

Les associés de la société ELITE S.àr.l., Madame, Ouafae SABEK et Monsieur Alain VAN KASTEREN, ont pris les

décisions suivantes:

- Monsieur Alain Van Kasteren, demeurant à L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange, est nommé gérant

technique pour une durée indéterminé, en remplacement de Madame Sabek.

- Madame Ouafae Sabek, demeurant à L-1419 Luxembourg, 58, Montée de Dommeldange, est nommée gérante ad-

ministrative pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Van Kasteren.

- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants, dont obli-

gatoirement celle du gérant technique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2011.

G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2011028586/21.
(110034682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Arctic Lake S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 152.316.

Par la présente, le soussigné Claude Weber, Administrateur-délégué de MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEM-

BOURG S.A. (RC Luxembourg B 8801), ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, atteste avoir
dénoncé avec date d’effet au 15 février 2011 le contrat de domiciliation signé en date du 31 mars 2010 avec la société
ARCTIC LAKE S.à.r.l., (RC Luxembourg B 152316) ayant son siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Marsh Management Services Luxembourg SA.
Claude Weber
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011028516/13.
(110035012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Banco Popolare Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011028538/9.
(110034736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Audit Value International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 94.260.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.02.11.

Référence de publication: 2011028521/10.
(110034811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

32640


Document Outline

4U Consult S.à r.l.

Amber Holding S.A.

Ananas S.A.

APERAM HoldCo S.à r.l.

APERAM Sourcing S.C.A.

APERAM Treasury S.C.A.

Arctic Lake S.àr.l.

Arjufra Group Holding S.à r.l.

A. Rolf Larsen Holding S.A.

Artmarkt S.A.

Astriger Services

Audit Value International S.A.

Aviva Investors Portefeuille II

Avolon Holding Corporation (Luxembourg) II S.à r.l.

Banco Popolare Luxembourg S.A.

CMP German Opportunity Fund II (SCA) SICAR

Elite S.à r.l.

Medinvest International (Invecom Management) S.C.A.

Michel Albert Investissements S.A.

Milleknapp S.à.r.l.

Nivard S.A. SPF

Orfeo S.à r.l.

People Skill S.àr.l.

Pol S.A.

Polychord S.A.

Potosi S.A.

Pranceworth Ventures S.A.

Quattro Luxembourg S.à r.l.

Ribeaumont Holding S.A.

Ribeaumont Holding SPF S.A.

Rootness S.A.

Saint-James Finance

Sami-Bau G.m.b.H.

S A S Investments S.A.

Savelec S.A.

SBSM S.A.

Schmit &amp; Klein Invest SA

Silvretta Investment S.A.

Snera Lux S.à r.l.

Southdown Luxembourg Holdings S.à r.l.

Spes Invest S.A.

Syrius S.à r.l.

Triplane S.A.

TTC Holdings S.à r.l.

Um Gruew S.à r.l.

Unistar S.A.

Usines Roboto

VAN GEET, DERICK &amp; Co, réviseurs d'entreprises

Venoplas

Veroninvest Holding S.A.

Versale Investments S.A.

Villa Romaine Immobilière S.A.

VoiceCom GmbH (S.à r.l.)

Wollbuttek S.à r.l.

World Power Holdings Luxembourg S.à r.l.

World Trade Polymers S.A.

Xenon Investments S. à r.l.