logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 669

8 avril 2011

SOMMAIRE

All Car Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32071

AMP Capital Investors (European Infra-

structure No. 4) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

32106

Antrax S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32105

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.  . .

32066

Argentum Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32093

Association des Parents d'Eleves de Fet-

schenhof, Cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32108

BB Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32110

BCI Diamond II Luxco Holdings S.àr.l.  . . .

32108

Beaucette S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32110

Belfil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32069

Calatayud S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32112

Capita Fiduciary S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32107

Cap Mini S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32104

Car S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32112

Centerra Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

32111

Centrope Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

32078

Colways Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

32105

CVI GVF Luxembourg Eight S.à r.l.  . . . . . .

32069

CVI GVF Luxembourg Four S.à r.l.  . . . . . .

32069

CVI GVF Luxembourg Nine S.à r.l.  . . . . . .

32069

Dazzle Luxembourg N° 1 S.A. . . . . . . . . . . .

32109

Dazzle Luxembourg N° 2 S.A. . . . . . . . . . . .

32111

Delta Lloyd L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32110

DENIBO Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . .

32112

Deutsche Finanz A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32112

Diapason S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32068

EIM Holding Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

32111

EIM Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32111

Fédération Saint Hubert des Chasseurs du

Grand-Duché de Luxembourg asbl  . . . . .

32097

Fédération Saint Hubert des Chasseurs du

Grand-Duché de Luxembourg asbl  . . . . .

32099

Feldermaus A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32112

Ginevra International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

32110

Incoterm Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

32076

Incoterm Holding S.à r.l. SPF  . . . . . . . . . . .

32076

ING (L) II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32093

ING (L) Technix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32093

Investdeutschland S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .

32071

Malba S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32103

Mascagni S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32104

Multiwert Superfund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32075

Multiwert Superfund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32072

Multiwert Superfund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32076

Mustang ULM 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32107

Mustang ULM 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32107

NIKKO BANK (Luxembourg) S.A. . . . . . . .

32097

Perinvest (Lux) Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32109

Piramid Investment Solutions S.A. SPF  . .

32066

Silverstreet Private Equity Strategies Sicar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32072

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.  . . .

32097

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.  . . .

32103

Société de Promotion pour le Développe-

ment des Activités de Services S.P.F. S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32103

Tenke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32104

Tuscani S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32069

32065

L

U X E M B O U R G

Piramid Investment Solutions S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.944.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>22 avr. 2011 à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044499/1267/16.

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 2.050.

In the year two thousand ten, on the tenth of December.
In front of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

the sole shareholder of the public limited company [société anonyme] “ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.”, with

registered office at 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered in the Register of Commerce and Companies
of Luxembourg under number B2050, hereinafter referred to as “the Company”, originally incorporated under the name
Société Anonyme Luxembourgeoise d'Exploitations Minières pursuant to an instrument attested by the Notary Maître
François-Joseph Altwies on 8 December 1934, published in the Mémorial C, Register of Companies and Associations,
number 81, of 31 December 1934. The Articles of Association of the Company have been amended for the last time by
a deed of the undersigned notary of 23 September 2010, which deed has been published in the Mémorial, Register of
Companies and Associations on 6 November 2010, number 2385,

namely:
“AM Global Holding Bis “, a private limited liability company [société à responsabilité limitée] with registered office at

19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered in the Register of Commerce and Companies of Luxembourg,
under the number B 103018,

represented by Ms Ana-Paula DA SILVA, Paralegal, with professional address in Luxembourg,
pursuant to an instrument of proxy in unattested form, issued at Luxembourg on 9 December 2010,
which proxy, after being signed “ne varietur” by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will be annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting as the sole shareholder of the Company, agrees to waive the formal rules governing the

holding of an extraordinary general meeting, such as convening notices, the agenda, and the appointment of officers of
the meeting, acknowledging that it is fully appraised of the decisions to be taken.

Following discussion, it has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder noted, that on September 30, 2010, the loss of the Company exceeded three quarters of the corporate

subscribed capital and the shareholder, in accordance with Article 100 of the Law dated 10 August 1915, as amended,
on commercial companies, RESOLVED not to proceed to the dissolution of the Company, but instead to continue further
its activity in conformity with its corporate purposes

<i>Second resolution

The shareholder resolves to reduce the Company's corporate capital by an amount of one billion one hundred and

ninety-eight million three hundred and eighty thousand euro (EUR 1.198.380.000.-) so as to decrease it from its present
amount of one billion six hundred two million four hundred eighty thousand euro (EUR 1.602.480.000.-) to four hundred
and four million one hundred thousand euro (EUR 404.100.000.-) by absorption of losses in the amount of one billion
one hundred and ninety-eight million three hundred and eighty thousand euro (EUR 1.198.380.000.-)

32066

L

U X E M B O U R G

The proof of these existing losses has been given to the undersigned notary by presentation of an example of the

balance sheet of the company, as per 31 December 2009.

<i>Third resolution

As a consequence of such capital decrease, article 6 of the Company's Articles of Association is amended and shall

henceforth read as follows:

“ Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed in the sum of four hundred and four million one hundred

thousand euro (EUR 404.100.000.-) represented by ten thousand (10,000) shares with no specified nominal value, all paid
up in full.

The shares are and shall remain registered shares.”

<i>Fourth resolution

The shareholder resolves to accept the resignation of the director Mr. Bernard Fontana and to grant full and complete

discharge for the performance of his duties to the extent legally possible and further resolves to appoint the following
for a three-year mandate that will automatically expire on the date of the general meeting of shareholders to be held in
2013:

- Mr. Willie Smit, with professional address at Berkeley Square, W1J6DA London, United Kingdom, as a member of

the board of directors.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

the present deed are estimated at approximately at two thousand euro.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Le seul et unique actionnaire de la société anonyme «ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.», ayant son siège social

au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg,
sous le numéro B2050, ci-après dénommée la «Société», constituée originairement sous le nom de Société Anonyme
Luxembourgeoise d'Exploitations Minières suivant acte reçu par-devant notaire Maître François-Joseph Altwies en date
du 8 décembre 1934, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 81 du 31 décembre 1934. Les
statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 septembre
2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2385 du 6 novembre 2010;

à savoir:
«AM Global Holding Bis», société à responsabilité limitée avec siège social au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B103018, représentée aux fins
des présentes par Mademoiselle Ana-Paula DA SILVA, Paralegal, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 décembre 2010,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

La société comparante, agissant en sa qualité de seul et unique actionnaire de la Société convient de faire abstraction

des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations, ordre du jour et consti-
tution du bureau, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir.

Après discussion, elle prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique a pris note, qu'au 30 septembre 2010, la Société a réalisé des pertes excédant trois quarts du

capital social souscrit et l'Assemblée, en concordance avec l'article 100 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifié par
la suite, concernant les sociétés commerciales, a DECIDÉ de ne pas procéder à la dissolution de la Société mais par contre
de continuer ses activités en conformité avec son objet social.

32067

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un milliard cent quatre-vingt-dix

huit millions trois cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.198.380.000.-) afin de le ramener de son montant actuel d'un
milliard six cent deux millions quatre cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.602.480.000.-) à un montant de quatre cent
quatre millions cent mille euros (EUR 404.100.000.-) par l'absorption des pertes d'un montant d'un milliard cent quatre-
vingt-dix huit millions trois cent quatre-vingts mille euros (EUR 1.198.380.000.-).

La preuve de l'existence de ces pertes a été apportée au notaire soussigné par le bilan au 31 décembre 2009-

<i>Troisième résolution

Suite à la réduction de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura

désormais la teneur suivante:

“ Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre millions cent mille euros (EUR 404.100.000.-); il est

représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.“

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de l'administrateur M. Bernard Fontana et de lui accorder pleine

et entière décharge de l'accomplissement de ses fonctions dans la mesure légalement possible et décide de nommer la
personne suivante pour une période de trois (3) ans prenant automatiquement fin à la date de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2013:

- Monsieur Willie Smit, ayant pour adresse professionnelle le Berkeley Square, W1J6DA Londres, Royaume-Uni en

tant que membre du conseil d'administration.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à approximativement deux mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant

par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A.P. DA SILVA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15803. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011012000/126.
(110014542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2011.

Diapason S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 102.450.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>22 avr. 2011 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044500/1267/15.

32068

L

U X E M B O U R G

Tuscani S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 119.507.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>22 avr. 2011 à 16:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044501/1267/16.

Belfil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.819.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>19 avril 2011 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2010
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Ratification de la cooptation d'un administrateur
5. Décision à prendre quant à l'article 100 sur les sociétés commerciales
6. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044502/788/18.

CVI GVF Luxembourg Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.766.

CVI GVF Luxembourg Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.763.

CVI GVF Luxembourg Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.762.

Im Jahre zwei tausend und elf, am einunddreißigsten März.

Sind erschienen:

1) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts CVI GVF LUXEMBOURG EIGHT S.à r.l., mit

Sitz in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Lu-
xemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") unter Sektion B, Nummer 130.766, gegründet gemäß
Urkunde vom 24. Juli 2007 aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht
im Mémorial, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 2115 vom
27. September 2007. Die Satzung wurde bis zum heutigen Datum nicht abgeändert.

2) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts CVI GVF LUXEMBOURG FOUR S.à r.l., mit

Sitz in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Lu-

32069

L

U X E M B O U R G

xemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") unter Sektion B, Nummer 130.763, gegründet gemäß
Urkunde vom 24. Juli 2007 aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht
im Mémorial, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 2104 vom
26. September 2007. Die Satzung wurde bis zum heutigen Datum nicht abgeändert.

3) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts CVI GVF LUXEMBOURG NINE S.à r.l., mit Sitz

in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg
(„Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") unter Sektion B, Nummer 130.762, gegründet gemäß Urkunde
vom  24.  Juli  2007  aufgenommen  durch  Notar  Joseph  ELVINGER,  mit  dem  Amtssitz  in  Luxemburg,  veröffentlicht  im
Mémorial, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 2105 vom 26.
September 2007. Die Satzung wurde bis zum heutigen Datum nicht abgeändert.

Der Erschienene handelt aufgrund von Beschlüssen der drei vorgenannten Gesellschaften, welche Ihr durch Protokolle

der jeweiligen Geschäftsführungen vom 30. März 2011 erteilt wurden.

Die Erschienene ersucht zu beurkunden dass:
1. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts CVI GVF LUXEMBOURG EIGHT S.à r.l., mit

Sitz in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Lu-
xemburg  („Reigstre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg")  unter  Sektion  B,  Nummer  130.766,  mit  einem
Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500)
Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil, Eigentümerin ist von:

(a) allen Anteilen (100%) und aller Stimmrechte der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CVI GVF LUXEMBOURG

FOUR S.à r.l., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, eingetragen beim Handels-und Gesellschafts-
register von Luxemburg („Reigstre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") unter Sektion B, Nummer 130.763
mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil; und

(b) allen Anteilen (100%) und aller Stimmrechte an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts

CVI GVF LUXEMBOURG NEVE S.à r.l., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, eingetragen beim
Handels-und  Gesellschaftsregister  von  Luxemburg  („Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg")  unter
Sektion B, Nummer 130.762, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt
in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

Es wurden keine anderen Rechte oder Rechtstitel, welche Stimmrechte oder andere sonstige Rechte verleihen, von

den erwähnten Gesellschaften (hier noch als verschmelzende Gesellschaften bezeichnet) gewährt oder ausgestellt.

2. Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts CVI GVF LUXEMBOURG FOUR S.à r.l., und

CVI GVF LUXEMBOURG NINE S.à r.l. (beide Gesellschaften werden auch noch als aufgenommene Gesellschaften be-
zeichnet) beabsichtigen sich, gemäß Artikel 278 und 279 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten, mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts CVI GVF LUXEMBOURG EIGHT S.à r.l.,
(welche auch noch als aufnehmende Gesellschaft bezeichnet wird), durch Aufnahme zu verschmelzen.

3. Der Stichtag, ab dem die Geschäftshandlungen der aufgenommenen Gesellschaften unter dem Gesichtspunkt der

Rechnungslegung als für Rechnung der aufnehmenden Gesellschaft als vorgenommen gelten, wird auf den 01. Januar 2011
festgelegt.

4. Keinen besondere Vorteile werden den Geschäftsführern der verschmelzenden Gesellschaften gewährt.
5. Die Verschmelzung zwischen den Parteien wird einen Monat, nach der Offenlegung des Verschmelzungsplans im

Mémorial C, gemäß Artikel 9 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, in Kraft treten.

6. Jeder Anteilinhaber der aufnehmenden Gesellschaft hat einen Monat nach der Offenlegung dieses Verschmelzungs-

plans im Mémorial C das Recht, die im Artikel 267 Absatz (1) a.) b.) und c.) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
genannten Unterlagen einzusehen und eine vollständige kostenfreie Kopie auf Anfrage zu erhalten.

7. Ein oder mehrere Anteilinhaber der aufnehmenden Gesellschaft, welche(r) mindestens 5% der Aktien des gezeich-

neten Kapitals verfügen, haben das Recht, bis zum Tag nach der Hauptversammlung der aufgenommenen Gesellschaften
die Einberufung der Hauptversammlung der aufnehmenden Gesellschaft zu fordern, die über die Zustimmung zur Versch-
melzung  zu  beschließen  hat.  Die  Versammlung  muss  so  einberufen  werden,  dass  sie  im  Monat  der  Antragstellung
stattfindet.

8. Sollte weder eine Einberufung noch eine Ablehnung des Verschmelzungsplans durch die Anteilinhaber erfolgen, so

wird die Verschmelzung wie oben in Punkt 5 erwähnt gemäß Artikel 274 und insbesondere Absatz a) des Gesetzes über
die Handelsgesellschaften in Kraft treten.

9. Die verschmelzenden Gesellschaften werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften alle Steuererklärungen, welche

sich aus der endgültigen Einbringung der Einlagen ergeben, einreichen und diese nach deren Bescheiden begleichen.

10. Es wird vollständige Entlastung den Geschäftsführern der aufgenommenen Gesellschaften erteilt.
11. Die Geschäftsunterlagen der übertragenen Gesellschaft werden am Sitz der aufnehmenden Gesellschaft während

der vorgesehenen rechtlichen Frist aufbewahrt.

12. Formalitäten:
Die aufnehmende Gesellschaft:

32070

L

U X E M B O U R G

a. wird alle rechtlichen Formalitäten zur Veröffentlichung der Einlage, die bei der Verschmelzung entstehen, abwickeln.
b. wird alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Erklärungen einzureichen, sowie die Formalitäten zu erledigen,

damit die zu verschmelzenden Aktiva unter deren Namen erscheint.

c. wird alle notwendigen Vorkehrungen treffen damit die Übertragung aller zugeführten Sach- und Vermögenswerte,

sowie Rechte gegenüber Dritten, wirksam werden.

d. wird die Übertragung industrieller oder geistiger Eigentumsrechte, sowie anderer dinglicher Rechte an beweglichen

oder unbeweglichen Sachwerten oder Vermögen, falls vorhanden, gegenüber Dritten gemäß den entsprechenden ge-
setzlichen Bestimmungen vornehmen.

13. Übergabe der Wertpapiere: Nach Vollendung der Verschmelzung werden die aufgenommenen Gesellschaften der

aufnehmenden Gesellschaft alle originalen Gründungsurkunden und Änderungen übergeben, sowie alle Buchhaltungsun-
terlagen und sonstige buchhalterische Unterlagen, alle Eigentumsrechte oder Urkunden über Besitz von jeder Aktiva, alle
Belege über ausgeführten Transaktionen, alle Wertpapiere und Verträge (Darlehens-, Arbeits- und Treuhandverträge ),
Archive, alle Belege und andere Dokumente die im Bezug mit den aufgenommenen Rechten stehen, aushändigen.

14. Rechtskosten: Alle Rechts- und Honorarkosten, die bei der Verschmelzung anfallen, werden von der aufnehmenden

Gesellschaft übernommen.

15. Die aufnehmende Gesellschaft wird alle eventuellen Steuerschulden tilgen.
Dies sind die Bestimmungen des Verschmelzungsplans.

<i>Für CVI GVF LUXEMBOURG EIGHT S.à r.l. / Für CVI GW LUXEMBOURG FOUR S.à r.l. / Für CVI GVF LUXEMBOURG
NEVE S.à r.l.
Unterscrhiften

Référence de publication: 2011047659/102.
(110051154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Investdeutschland S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 35.810.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi <i>19 avr. 2011 à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044503/1267/15.

All Car Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 34.943.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>20 avr. 2011 à 10:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044506/1267/16.

32071

L

U X E M B O U R G

Multiwert Superfund, Fonds Commun de Placement.

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82 112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen

Multiwert Superfund; der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für
gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, als dessen Depotbank
beschlossen, das Sonderreglement des Teilfonds Multiwert Superfund - Comfort Invest zum 17. März 2011 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 07.02.2011.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Référence de publication: 2011025894/15.
(110031091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Silverstreet Private Equity Strategies Sicar, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 153.487.

In the year two thousand and eleven on the twenty-third day of March;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting of the partners (the “Meeting”) of “SILVERSTREET PRIVATE EQUITY

STRATEGIES SICAR”, a Luxembourg closed-ended Société d'Investissement en Capital à Risque in the form of a Société
en Commandite Simple, with its registered office at 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B.153487 (the “Partnership”), incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 2 June 2010, published in the Luxembourg Official Gazette,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1240 of 15 June 2010. The articles of incorporation of the
Partnership were amended for the last time by deed of the undersigned notary dated 13 January 2011, published in the
Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 227 of 4 February 2011.

The Meeting begins at 2.30 pm with Mrs. Sophie MARTINOT, private employee, residing professionally in Luxembourg,

being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs. Estelle MARIUCCI, private employee, residing professionally

in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. Tania ARAUJO, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman then states that:
I. The partners present or represented and the number of interests held by each of them are shown on an attendance

list signed by the members of the bureau, the partners present and the proxies of the partners represented. The said list
initialed “ne varietur” by the members of the bureau will be annexed to and be registered with this deed.

II. The Meeting was convened by a notice, containing the agenda, mailed to the partners by registered mail on 14 March

2011.

III. As appears from the said attendance list, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on

the items on the agenda.

IV. The agenda of the Meeting is as follows:
1. To replace the first paragraph of article 24 of the articles of incorporation of the Partnership with the following

paragraphs:

“The General Partner may, at its sole discretion, or at the request of Limited Partners who are not Defaulting Investors,

representing ten percent of the total Commitments, convene a general meeting of Investors which will vote on the
liquidation of the Partnership. These Limited Partners requesting the vote on the liquidation must send to the General
Partner, by registered mail with return receipt, by email or by fax, a document containing a description (the “Description”)
of their wish to liquidate the Partnership:

- the list of Limited Partners who are not Defaulting Investors signing the Description, together with their contact

information and the amount of their Commitments;

- the reasons for these Limited Partners' wish to liquidate the Partnership;
- the date that the planned liquidation would become effective if it is accepted by the Investors; and
- a proposed timeline allowing for the required regulatory approval for any such changes.

32072

L

U X E M B O U R G

The extraordinary general meeting must be held within thirty (30) Business Days from the date of receipt of the

Description. In addition to the convening notice, the General Partner may send to all of the Limited Partners, if it so
wishes, an opinion on the initiated process to liquidate the Partnership.

The resolution to liquidate the Partnership will need to be passed by a Qualified Majority Resolution at this extraor-

dinary general meeting.

The extraordinary general meetings of Limited Partners shall be held at the Partnership's registered office or at any

other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice to the meeting. Such meetings
of Limited Partners shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered mail to each Limited
Partner at least eight days prior to the meeting. The agenda shall be prepared by the General Partner.

Upon the passing of this Qualified Majority Resolution, the General Partner shall realise the assets of the Partnership

in the best interest of the Investors, and the Custodian shall distribute the net liquidation proceeds, after deduction of
liquidation charges and expenses, to the holders of Interests in the proportion of the respective rights of each Class, all
in accordance with the directions of the General Partner. The Commitment Period will end on the date on which the
Partnership will be put in liquidation and the terms of the Partnership, in respect of the post-Commitment period, will
continue to apply.”

2. To delete the last paragraph of article 24 of the articles of incorporation of the Partnership.
3. Miscellaneous.
The partners then passed the following resolutions:

<i>First resolution:

The partners resolved to replace the first paragraph of article 24 of the articles of incorporation of the Partnership

with the following paragraphs:

“The General Partner may, at its sole discretion, or at the request of Limited Partners who are not Defaulting Investors,

representing ten percent of the total Commitments, convene a general meeting of Investors which will vote on the
liquidation of the Partnership. These Limited Partners requesting the vote on the liquidation must send to the General
Partner, by registered mail with return receipt, by email or by fax, a document containing a description (the “Description”)
of their wish to liquidate the Partnership:

- the list of Limited Partners who are not Defaulting Investors signing the Description, together with their contact

information and the amount of their Commitments;

- the reasons for these Limited Partners' wish to liquidate the Partnership;
- the date that the planned liquidation would become effective if it is accepted by the Investors; and
- a proposed timeline allowing for the required regulatory approval for any such changes.
The extraordinary general meeting must be held within thirty (30) Business Days from the date of receipt of the

Description. In addition to the convening notice, the General Partner may send to all of the Limited Partners, if it so
wishes, an opinion on the initiated process to liquidate the Partnership.

The resolution to liquidate the Partnership will need to be passed by a Qualified Majority Resolution at this extraor-

dinary general meeting.

The extraordinary general meetings of Limited Partners shall be held at the Partnership's registered office or at any

other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice to the meeting. Such meetings
of Limited Partners shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered mail to each Limited
Partner at least eight days prior to the meeting. The agenda shall be prepared by the General Partner.

Upon the passing of this Qualified Majority Resolution,, the General Partner shall realise the assets of the Partnership

in the best interest of the Investors, and the Custodian shall distribute the net liquidation proceeds, after deduction of
liquidation charges and expenses, to the holders of Interests in the proportion of the respective rights of each Class, all
in accordance with the directions of the General Partner. The Commitment Period will end on the date on which the
Partnership will be put in liquidation and the terms of the Partnership, in respect of the post-Commitment period, will
continue to apply.”

<i>Second resolution:

The partners resolved to delete the last paragraph of article 24 of the articles of incorporation of the Partnership.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed at 03:00 pm.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

32073

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'“Assemblée”) de “SILVERSTREET PRIVATE EQUITY

STRATEGIES SICAR”, une Société d'Investissement en Capital à Risque luxembourgeoise de type fermé sous la forme
d'une  Société  en  Commandite  Simple,  avec  siège  social  au  20,  Boulevard  Emmanuel  Servais,  L-2535  Luxembourg  et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.153487 (la “Société”),
constituée suite à un acte du notaire instrumentant en date du 2 juin 2010, publié dans le Journal Officiel de Luxembourg,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1240 du 15 juin 2010. Les statuts de la Société ont été modifies
suite à un acte du notaire instrumentant en date du 13 janvier 2011, publié dans le Journal Officiel de Luxembourg,
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 227 du 4 février 2011.

L'Assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sophie MARTINOT, employée privée, résidant

professionnellement au Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire de l'Assemblée Madame Estelle MARIUCCI, employée privée, résidant pro-

fessionnellement au Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutatrice Madame Tania ARAUJO, employée privée, résidant professionnellement au Lu-

xembourg.

La Présidente expose ensuite que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts d'intérêts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau, les associés présents et les représentants des associés représentés. Ladite
liste signée “ne varietur” par les membres du bureau restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

II. L'Assemblée a été convoquée par l'envoi aux associés de lettres recommandées, contenant l'ordre du jour, en date

du 14 mars 2011.

III. Il appert de ladite liste de présence que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur les points à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est comme suit:
1. De remplacer le premier paragraphe de l'article 24 des statuts de la Société par les paragraphes suivants:
«L'Associé Commandité peut, à sa seule discrétion, ou à la demande des Associés Commanditaires qui ne sont pas

des Investisseurs Défaillants, représentant dix pour cent des Engagements totaux, convoquer une assemblée générale des
Investisseurs qui votera sur la liquidation de la Société. Ces Associés Commanditaires demandant le vote sur la liquidation
doivent envoyer à l'Associé Commandité, par courrier recommandé avec accusé de réception, par courrier électronique
ou par fax, un document contenant une description (la «Description») de leur volonté de liquider la Société.

- la liste des Associés Commanditaires qui ne sont pas des Investisseurs Défaillants ayant signé la Description, ainsi

que leurs coordonnées et le montant de leurs Engagements;

- les raisons de la volonté de ces Associés Commanditaires de liquider la Société;
- la date à laquelle cette liquidation planifiée deviendrait effective si elle est acceptée par la Investisseurs; et
- une proposition de ligne du temps permettant l'approbation réglementaire nécessaire en vue de tels changements.
L'assemblée générale extraordinaire doit être tenue dans les trente (30) Jours Ouvrables à partir de la date de réception

de la Description. En plus de la convocation, l'Associé Commandité peut envoyer à tous les Associés Commanditaires,
s'il le désire, une opinion sur l'initiation de la procédure de liquidation de la Société.

La décision de liquider la Société devra faire l'objet d'une Décision à Majorité Qualifiée à cette assemblée générale

extraordinaire.

Les assemblées générales extraordinaires des Associés Commanditaires seront tenues au siège social de la Société ou

à tout autre endroit au Grand Duché de Luxembourg tel que mentionné dans la convocation de l'assemblée. De telles
assemblées des Associés Commanditaires seront convoquées à l'aide d'une convocation comprenant l'ordre du jour
envoyé par courrier recommandé à chaque Associé Commanditaire au moins huit jours avant l'assemblée. L'ordre du
jour sera préparé par l'Associé Commandité.

A la suite de cette Décision à Majorité Qualifiée, l'Associé Commandité réalisera les avoirs de la Société dans le meilleur

intérêt des Investisseurs, et le Dépositaire distribuera le boni net de liquidation, après déduction des charges et dépenses
de liquidation, aux détenteurs de Parts d'Intérêts proportionnellement aux droits respectifs de chaque Classe, le tout
conformément aux directions de l'Associé Commandité. La Période d'Engagement prendra fin à la date à laquelle la Société
sera mise en liquidation et les termes de la Société, en rapport avec la période post-Engagement, continueront à s'appli-
quer.»

2. De supprimer le dernier paragraphe de l'article 24 des statuts de la Société.
3. Divers.
Les associés prennent ensuite les résolutions suivantes:

32074

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

Les associés décident de remplacer le premier paragraphe de l'article 24 des statuts de la Société par les paragraphes

suivants:

«L'Associé Commandité peut, à sa seule discrétion, ou à la demande des Associés Commanditaires qui ne sont pas

des Investisseurs Défaillants, représentant dix pour cent des Engagements totaux, convoquer une assemblée générale des
Investisseurs qui votera sur la liquidation de la Société. Ces Associés Commanditaires demandant le vote sur la liquidation
doivent envoyer à l'Associé Commandité, par courrier recommandé avec accusé de réception, par courrier électronique
ou par fax, un document contenant une description (la «Description») de leur volonté de liquider la Société.

- la liste des Associés Commanditaires qui ne sont pas des Investisseurs Défaillants ayant signé la Description, ainsi

que leurs coordonnées et le montant de leurs Engagements;

- les raisons de la volonté de ces Associés Commanditaires de liquider la Société;
- la date à laquelle cette liquidation planifiée deviendrait effective si elle est acceptée par la Investisseurs; et
- une proposition de ligne du temps permettant l'approbation réglementaire nécessaire en vue de tels changements.
L'assemblée générale extraordinaire doit être tenue dans les trente (30) Jours Ouvrables à partir de la date de réception

de la Description. En plus de la convocation, l'Associé Commandité peut envoyer à tous les Associés Commanditaires,
s'il le désire, une opinion sur l'initiation de la procédure de liquidation de la Société.

La décision de liquider la Société devra faire l'objet d'une Décision à Majorité Qualifiée à cette assemblée générale

extraordinaire.

Les assemblées générales extraordinaires des Associés Commanditaires seront tenues au siège social de la Société ou

à tout autre endroit au Grand Duché de Luxembourg tel que mentionné dans la convocation de l'assemblée. De telles
assemblées des Associés Commanditaires seront convoquées à l'aide d'une convocation comprenant l'ordre du jour
envoyé par courrier recommandé à chaque Associé Commanditaire au moins huit jours avant l'assemblée. L'ordre du
jour sera préparé par l'Associé Commandité.

A la suite de cette Décision à Majorité Qualifiée, l'Associé Commandité réalisera les avoirs de la Société dans le meilleur

intérêt des Investisseurs, et le Dépositaire distribuera le boni net de liquidation, après déduction des charges et dépenses
de liquidation, aux détenteurs de Parts d'Intérêts proportionnellement aux droits respectifs de chaque Classe, le tout
conformément aux directions de l'Associé Commandité. La Période d'Engagement prendra fin à la date à laquelle la Société
sera mise en liquidation et les termes de la Société, en rapport avec la période post-Engagement, continueront à s'appli-
quer.»

<i>Deuxième résolution:

Les associés décident de supprimer le dernier paragraphe de l'article 24 des statuts de la Société.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.00 heures.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-

parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. MARTINOT, E. MARIUCCI, T. ARAUJO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 mars 2011. LAC/2011/14253. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011046024/201.
(110051509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2011.

Multiwert Superfund, Fonds Commun de Placement.

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82 112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen

Multiwert Superfund; der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für
gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, als dessen Depotbank
beschlossen, das Sonderreglement des Teilfonds Multiwert Superfund - Absolute Return zum 17. März 2011 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32075

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 07.02.2011.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Référence de publication: 2011025895/15.
(110031092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Multiwert Superfund, Fonds Commun de Placement.

Die  Axxion  S.A.,  H.R.  Luxembourg  B  82  112,  hat  als  Verwaltungsgesellschaft  des  Organismus  für  gemeinsame

Anlagen ,,Multiwert Superfund"; der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, als dessen
Depotbank beschlossen, das Allgemeine Verwaltungsreglement des Fonds zum 17. März 2011 zu ändern.

Das Allgemeine Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 07.02.2011.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Référence de publication: 2011025896/15.
(110031093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

Incoterm Holding S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial,

(anc. Incoterm Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 81.477.

In the year two thousand and ten, on the seventeenth day of December.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

The company DIONEX INTERNATIONAL CORPORATION with its registered office at Tortola (B.V.I.), Road Town,

Wickhams Cay I, 3 

rd

 floor Omar Hodge bld,

here represented by Mr Cornelius BECHTEL, Company director, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the notary,
will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
- That the private limited liability company "INCOTERM HOLDING, S.à r.l., a private limited company (société à

responsabilité limitée), having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
R.C.S. Luxembourg section B and number 81477, incorporated by deed of the undersigned notary on April 5, 2001,
published in the Mémorial C number 959 of November 5, 2001. The articles has been amended by deed of undersigned
notary on the 6 

th

 of September 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2160

of the 18 

th

 of November 2006.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has

taken, through its mandatory, the following resolution:

<i>Resolution

The sole shareholder decides to amend the articles of the company so that, henceforth, the company will no more

have the statuts of a holding company as defined by the law of 31 July 1929 but have the status of a Private Wealth
Management Company ("SPF") as defined by the Law of 11 May 2007.

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to:
- change the name of the company into Incoterm Holding S.à r.l. SPF.
- change the wording of the purpose of the company, and subsequent amend articles 1,2,3 and 20 of the articles of

incorporation to give them the following wording:

Art. 1. There exists a Private Wealth Management Company ("SPF"), in the form of a private limited company (société

à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in force, namely the Companies Act of August 10, 1915 and
by the present articles of association.

32076

L

U X E M B O U R G

Art. 2. The company's name is Incoterm Holding S.à r.l. SPF.

Art. 3. The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal

of financial assets (within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of
any kind held in an account.

The company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role

in its subsidiary.

The company is not allowed to exercise any commercial activity.
The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management,

either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons,
or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on

the stock exchange.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the
limits of the Law of May 11, 2007 on creation of a Private Wealth Management Company ("SPF").

Art. 20. The law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on creation

of a Private Wealth Management Company ("SPF") shall apply in-so-far as these Articles of Incorporation do not provide
for the contrary.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société DIONEX INTERNATIONAL CORPORATION avec siège social à Tortola (B.V.I.), Road Town, Wickhams

Cay I, 3 

rd

 floor Omar Hodge bld,

ici représentée par Monsieur Cornelius BECHTEL, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le
mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivants:
- Que la société à responsabilité limitée INCOTERM HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
81477, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 avril 2001, publié au Mémorial C numéro
959 du 5 novembre 2001; dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6
septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2160 du 18 novembre 2006

- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a

pris, par son mandataire, la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de modifier le régime fiscal de la société, laquelle n'aura plus le statut de société holding tel

que défini par la loi du 31 juillet 1929 mais le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi
du 11 mai 2007.

Suite au à ce qui précède l'assemblée décide de:
- changer la dénomination de la société en "INCOTERM HOLDING, S.à r.l. SPF":
- modifier l'objet social, et

32077

L

U X E M B O U R G

- en conséquence de modifier les articles 1,2,3 et 20 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", sous forme d'une société à respon-

sabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de INCOTERM HOLDING, S.à r.l. SPF.

Art. 3. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial ("SPF") trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BECHTEL, J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2010. Relation GRE/2010/4700. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 24 février 2011.

Référence de publication: 2011027495/126.
(110033431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Centrope Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 157.352.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of March.
Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Eurovegas Holding Limited, having its registered office at 15 Esplanade, St Helier, JE1 1RB, registered with the Com-

panies Registry of Jersey under number 100012, here represented by Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party
and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party requested the notary to state that:

32078

L

U X E M B O U R G

I. Eurovegas Holding Limited owns TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) parts having a par value of ONE

EURO (EUR 1.-), representing the entire share capital of Centrope Holding S.àr.l., a Luxembourg private limited company,
société à responsabilité limitée, having its registered office at 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 157.352 (the “Company”).

II. The registered office and principal place of establishment of the Company have been transferred to Luxembourg

pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 7 

th

 , 2010 which has been published in the Mémorial C

n° 2791 on 20 December 2010.

III. It is contemplated to transfer the registered office of the Company from 57, avenue Grande Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg to 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB, Channel Islands and consequently change of the place of
registration of the Company, with effect from the date (the "Effective Date") on which a certificate of continuance in
respect to the Company is issued by the Jersey Financial Services Commission in its capacity as the Jersey Companies
Registrar in accordance with Article 1270 of the Companies (Jersey) Law 1991, as amended, (the "Jersey Law") provided
that the Company ceases to be a Luxembourg company subject to the fulfilment of all applicable provision of the laws of
Jersey also as of the Effective Date;

IV. Eurovegas Holding Limited has waived any and all convening requirements.
The general meeting of participants is therefore duly constituted and can validly resolve.
V. The general meeting of participants of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of participants unanimously resolves to approve the annual accounts of the Company as of 31

December 2010 and the interim balance sheet as of 15 February 2011.

<i>Second resolution

The general meeting of participants unanimously resolves to transfer the registered office of the Company from 57,

avenue Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg to 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB, Channel Islands and
consequently, to change the place of registration of the Company with effect from the Effective Date in compliance with
articles 2 third paragraph, 199 and 159 second paragraph of the Luxembourg law dated August 10, 1915 on commercial
companies, as amended, and to file any and all documents required under the Jersey Law to give full effect to this resolution,
including the filing of a certified copy of these resolutions with the Jersey Financial Services Commission which states the
Company's new registered office as being to 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB, Channel Islands upon its continuance
into Jersey.

In addition, the general meeting of participants unanimously resolves to change as of the Effective Date the corporate

form of the Company from a Luxembourg private limited liability company, société à responsabilité limitée, into a private
company incorporated in Jersey subject to the legal and regulatory provisions applicable to such corporate form under
the Jersey Law and subsequently to adopt the New Articles (as defined and laid down below) so as to make them being
in line with the laws of Jersey.

<i>Third resolution

The general meeting of participants unanimously resolves to accept the resignation of Paul HÖRETZEDER from his

position as manager of the Company. The resignation shall effect from the Effective Date.

The general meeting of participants unanimously resolves to accept the resignation of Sylvie PORTENSEIGNE from

her position as manager of the Company effect as of 9 March 2011.

In addition the general meeting of shareholders unanimously resolves to discharge Paul HÖRETZEDER and Sylvie

PORTENSEIGNE from their liability toward the Company as managers of the Company in respect of the performance
of their duties from the date of their appointment as managers until the date of their respective resignation.

The general meeting of shareholders unanimously resolves to appoint:
a) Paul HÖRETZEDER, born on 6 April 1975 in Wels, Austria, residing in Miller von Aichholzstrasse 38a, 4810 Gmun-

den, Austria; counsel;

b) Steven ROBINSON, born on 5 September 1974, residing professionally at Hawksford Trust Company Jersey Limited,

15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB; Director at Hawksford Trust Company Jersey Limited;

c) Michael POWELL, born on 30 September 1958, residing professionally at Hawksford Trust Company Jersey Limited,

15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB; Director at Hawksford Trust Company Jersey Limited; and

d) Stephen CARR, born on 19 July 1977, residing professionally at Hawksford Trust Company Jersey Limited, 15

Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB; Associate Director at Hawksford Trust Company Jersey Limited;

as new directors of the Company to take effect on the Effective Date.

<i>Fourth resolution

The general meeting of participants unanimously confirms that (i) the New Articles are consistent with requirements

of the laws of Jersey, (ii) the Company will, with effect from the Effective Date, cease to be a Luxembourg company, and

32079

L

U X E M B O U R G

(iii) that the Company will, subject to the applicable provisions of the Jersey Law as of the Effective Date, be subject to
the applicable laws of Jersey, and (iv) that neither the transfer of the registered office of the Company nor the change of
its place of incorporation and of its corporate form entails the dissolution and/or liquidation of the Company and the
creation of a new legal entity.

<i>Fifth resolution

The general meeting further unanimously resolves to appoint Paul HÖRETZEDER, Steve ROBINSON, Michael PO-

WELL, and Stephen CARR, each severally, with the broadest powers (including the power of substitution) to take any
action, including without limitation the execution and delivery of any deed, form, certificate, agreement or other document
and the compliance with all applicable filing and publication formalities under Luxembourg law and the laws of Jersey and
in connection with the recording of the transfer of the registered office and the change of the place of registration of the
Company at the Luxembourg Register of Commerce and Companies and the filing of any and all documents required
under the Jersey Law to give full effect to this resolution, including the filing of a certified copy of these resolutions with
the Jersey Financial Services Commission which states the Company's new registered office as being to 15 Esplanade, St
Helier, Jersey, JE1 1RB, Channel Islands upon its continuance into Jersey, which might be necessary or useful for the
registered office of the Company to be duly and validly transferred to Jersey.

<i>Sixth resolution

The general meeting of participants unanimously resolves that the books and documents in relation to the Company

shall be transferred to the new registered office of the Company in Jersey as soon as possible following the Effective Date.

<i>Seventh resolution

It was noted that the share capital of the Company from the Effective Date will remain unchanged and will be EUR

12,500 par value capital divided into 12,500 EUR 1.- limited liability shares.

NEW ARTICLES AND MEMORANDUM

(for the purposes of the Jersey Law)
COMPANIES (JERSEY) LAW 1991
COMPANY LIMITED BY SHARES
MEMORANDUM OF ASSOCIATION
of
CENTROPE HOLDINGS LIMITED
1. The name of the Company is Centrope Holdings Limited (the “Company”).
2. The Company shall have unrestricted corporate capacity.
3. The capital of the Company is EUR 12,500 par value capital divided into 12,500 EUR 1.- limited liability shares.
4. The Company is a private company.
5. The Company is a par value company.
6. The liability of each member arising from his holding of a share is limited to the amount (if any) unpaid on it.
COMPANIES (JERSEY) LAW 1991
COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

CENTROPE HOLDINGS LIMITED

1. Definitions and Interpretations.
1.1 In these Articles, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:
“Alternate Director” means any alternate director of the Company appointed in accordance with these Articles;
“Articles” means these articles of association as amended from time to time;
“Company” means the company incorporated under the Law in respect of which these Articles have been registered;
“Director” means any director of the Company appointed in accordance
with these Articles;
“Holder” means, in relation to Shares, the member whose name is entered in the register of members of the Company

as the holder of those Shares;

“Law” means the Companies (Jersey) Law 1991 including any statutory modification or re-enactment thereof for the

time being in force;

“Memorandum” means the memorandum of association of the Company as amended from time to time;
“Office” means the registered office of the Company;

32080

L

U X E M B O U R G

“Ordinary Resolution” means a resolution of the Company either in general meeting passed by a simple majority of

the votes cast at that meeting or in writing in accordance with Article 15;

“Seal” means the common seal or official seal of the Company;
“Secretary” means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary

of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary;

“Share” means a share in the capital of the Company; and
“Special Resolution” means a special resolution as defined in the Law.
1.2 In these Articles, save where the context otherwise requires:
(a) the word “person” includes a firm, a body corporate, an unincorporated association or an authority;
(b) the singular includes the plural and vice versa;
(c) where a word or phrase is given a particular meaning, other grammatical forms of that word or phrase have

corresponding meanings;

(d) a reference to an “Article” is a reference to an article of these Articles;
(e) a reference to writing includes typewriting, printing, telegram, facsimile or other modes of representing or repro-

ducing words in a visible form;

(f) headings are inserted for convenience and do not affect the interpretation of these Articles; and
(g) words or expressions defined in the Law shall have the same meaning where used in these Articles but excluding

any statutory modification thereof not in force when these Articles became binding on the Company.

1.3 The Standard Table prescribed pursuant to the Law shall not apply to the Company and is expressly excluded in

its entirety.

2. Share Capital.
2.1 Subject to the provisions of the Law, these Articles and any special rights attached to any existing Shares:
(a) any Share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by Ordinary Resolution determine;

and

(b) the Company may issue fractions of Shares and any such fractional Shares shall rank pari passu in all respects with

the other Shares of the same class issued by the Company, but shall rank pro rata with such other Shares in respect of
the rights attaching to the Shares of such class.

2.2 Subject to the provisions of these Articles, the unissued Shares shall be at the disposal of the Directors and they

may allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such times and generally on such terms
as they think fit.

2.3 Subject to the provisions of the Law, the Company may issue Shares which are to be redeemed, or are liable to

be redeemed, at the option of the Company or at the option of the Holder holding such redeemable Shares and on such
terms and in such manner as may be determined by Ordinary Resolution.

2.4 The Company may exercise the powers of paying commissions conferred by the Law. Subject to the provisions of

the Law, any such commission may be satisfied by the payment of cash or by the allotment of fully or partly paid Shares
or partly in one way and partly in the other.

2.5 Save as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any Share upon any trust and

(save as otherwise provided by these Articles or by law) the Company shall not be bound by or recognise (even when
having notice thereof) any interest in any Share save an absolute right of the Holder of such Share to the entirety thereof.

2.6 The Company shall not be required to enter the names of more than four joint Holders in respect of any Share

in the register of members of the Company.

3. Special Rights Attaching to Classes of Shares.
3.1 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares, the special rights attached to any

class may (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that class) be varied or abrogated, either
whilst the Company is a going concern or during or in contemplation of a winding-up:

(a) in the case of a par value company, with the consent in writing of the Holders of a majority in nominal value of the

issued Shares of that class; or

(b) with the sanction of an Ordinary Resolution passed at a separate meeting of the Holders of the issued Shares of

that class.

3.2 The provisions of these Articles relating to general meetings or to the proceedings thereat shall apply, mutatis

mutandis, to each separate meeting held pursuant to this Article save that in the case of a meeting of the Holders of a
class of par value Shares, the quorum shall be persons holding or representing by proxy not less than one-third in nominal
value of the issued Shares of that class but provided that if, at any adjourned meeting of such Holders, a quorum as above
defined is not present, those Holders who are present shall be a quorum.

32081

L

U X E M B O U R G

3.3 The special rights conferred upon the Holders of any Shares or class of Shares issued with preferred, deferred or

other special rights shall (unless otherwise expressly provided by the terms of issue of such Shares) be deemed not to
be varied by the creation or issue of further Shares or further classes of Shares ranking pari passu therewith.

4. Share Certificates.
4.1 Every Holder, upon becoming a Holder, shall be entitled without payment to one certificate for all the Shares of

each class held by him (and, upon transferring a part of his holding of Shares of any class, to a certificate for the balance
of such holding) or several certificates each for one or more of his Shares upon payment, for every certificate after the
first, of such reasonable sum as the Directors may determine.

4.2 Every certificate shall either be sealed with the Seal or signed by two Directors or a Director and the Secretary,

or by such persons as the Directors shall authorise from time to time, and shall specify the number, class and distinguishing
numbers (if any) of the Shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up thereon. The Company
shall not be bound to issue more than one certificate for Shares held jointly by several persons and delivery of a certificate
to one joint Holder shall be a sufficient delivery to all of them.

4.3 If a share certificate is defaced, worn out, lost or destroyed, it may be renewed on such terms (if any) as to evidence

and indemnity and payment of the expenses reasonably incurred by the Company in investigating evidence as the Directors
may determine, but otherwise free of charge and (in the case of defacement or wearing out) on delivery up of the old
certificate.

5. Lien.
5.1 The Company shall have a first and paramount lien on every Share (not being a fully paid Share) for all moneys

(whether presently payable or not) payable at a fixed time or called in respect of that Share. The Directors may at any
time declare any Share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Article. The Company's lien on a Share
shall extend to any amount payable in respect of it.

5.2 Without prejudice to the provisions of these Articles providing for the forfeiture or surrender of Shares, the

Company may sell in such manner as the Directors may determine any Shares on which the Company has a lien if a sum
in respect of which the lien exists is presently payable and is not paid within 14 days after notice has been given to the
Holder of such Shares or, where required by law, to the person entitled to it, demanding payment and stating that, if the
notice is not complied with, the Shares may be sold.

5.3 To give effect to a sale of Shares pursuant to this Article, the Directors may authorise some person to execute an

instrument of transfer in respect of the Shares.

5.4 A person any of whose Shares have been sold pursuant to this Article shall cease to be a Holder in respect of them

and shall deliver to the Company for cancellation the certificate for the Shares sold but shall remain liable to the Company
for all moneys which, at the date of sale, were presently payable by him to the Company in respect of those Shares with
interest at the rate at which interest was payable on those moneys before such sale or at such rate not exceeding ten
per cent per annum as the Directors may determine from the date of sale until payment provided that the Directors may
waive payment wholly or in part or enforce payment without any allowance for the value of the Shares at the time of
sale or for any consideration received on their disposal.

5.5 The net proceeds of the sale after payment of the costs shall be applied in payment of so much of the sum for

which the lien exists as is presently payable and any residue shall (upon delivery to the Company for cancellation of the
certificate or certificates for the Shares sold and subject to a like lien for any moneys not presently payable as existed
upon the Shares before the sale) be paid to the person entitled to the Shares at the date of the sale.

6. Calls on Shares and Forfeiture.
6.1 Subject to the terms of allotment, the Directors may make calls upon the Holders in respect of any consideration

agreed to be paid for such Shares that remains unpaid and each Holder shall (subject to receiving at least 14 days' notice
specifying when and where payment is to be made) pay to the Company as required by the notice the amount called on
such Shares. A call may be required to be paid by instalments. A call may, before receipt by the Company of any sum due
thereunder, be revoked in whole or part and payment of a call may be postponed in whole or part. A person upon whom
a call is made shall remain liable for calls made upon him notwithstanding the subsequent transfer of the Shares in respect
whereof the call was made.

6.2 A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call

was passed.

6.3 The joint Holders of a Share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
6.4 If a call remains unpaid after it has become due and payable, the person from whom it is due and payable shall pay

interest on the amount unpaid from the day upon which it became due and payable until it is paid at the rate fixed by the
terms of allotment of the Share or in the notice of the call or at such rate not exceeding ten per cent per annum as the
Directors may determine provided that the Directors may waive payment of the interest wholly or in part.

6.5 An amount payable in respect of a Share on allotment or at any fixed date shall be deemed to be a call and, if it is

not paid, the provisions of these Articles shall apply as if that amount had become due and payable by virtue of a call. The

32082

L

U X E M B O U R G

Company may accept from a Holder the whole or a part of the amount remaining unpaid on Shares held by him although
no part of that amount has been called up.

6.6 Subject to the terms of allotment, the Directors may make arrangements on the issue of Shares for a difference

between the Holders in the amounts and times of payment of calls on their Shares.

6.7 If a call remains unpaid after it has become due and payable, the Directors may give to the person from whom it

is due not less than 14 days' notice requiring payment of the amount unpaid together with any interest which may have
accrued. The notice shall name the place where payment is to be made and shall state that, if the notice is not complied
with, the Shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

6.8 If the notice referred to in Article 6.7 is not complied with, any Share in respect of which it was given may, at the

discretion of the Directors and before the payment required by the notice has been made, either:

(a) be forfeited by a resolution of the Directors and the forfeiture shall include all dividends or other moneys payable

in respect of the forfeited Shares and not paid before the forfeiture; or

(b) be accepted by the Company as surrendered by the Holder thereof in lieu of such forfeiture.
6.9 A forfeited or surrendered Share may be sold, re-allotted or otherwise disposed of on such terms and in such

manner as the Directors determine either to the person who was before the forfeiture the Holder or to any other person
and, at any time before sale, re-allotment or other disposition, the forfeiture or surrender may be cancelled on such
terms  as  the  Directors  think  fit.  Where,  for  the  purposes  of  its  disposal,  a  forfeited  or  surrendered  Share  is  to  be
transferred to any person, the Directors may authorise some person to execute an instrument of transfer in respect of
the Share.

6.10 A person any of whose Shares have been forfeited or surrendered shall cease to be a Holder in respect of them

and shall deliver to the Company for cancellation the certificate for the Shares forfeited or surrendered but shall remain
liable to the Company for all moneys which at the date of forfeiture or surrender were presently payable by him to the
Company in respect of those Shares with interest at the rate at which interest was payable on those moneys before such
forfeiture or surrender or at such rate not exceeding ten per cent per annum as the Directors may determine from the
date of forfeiture or surrender until payment provided that the Directors may waive payment wholly or in part or enforce
payment without any allowance for the value of the Shares at the time of forfeiture or surrender or for any consideration
received on their disposal.

6.11 A declaration under oath by a Director or the Secretary that a Share has been forfeited or surrendered on a

specified date shall be conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled to the Share
and the declaration shall (subject to the execution of an instrument of transfer if necessary) constitute a good title to the
Share and the person to whom the Share is disposed of shall not be bound to see to the application of the consideration,
if any, nor shall his title to the Share be affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the
forfeiture, surrender or disposal of the Share.

7. Transfer of Shares.
7.1 The instrument of transfer of a Share may be in any usual form or in any other form which the Directors may

approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the Shares are fully paid, by or on behalf of
the transferee.

7.2 The Directors may refuse to register the transfer of a Share (whether fully paid or not) to a person of whom they

do not approve and they may refuse to register the transfer of a Share on which the Company has a lien. They may also
refuse to register a transfer unless the instrument of transfer is:

(a) lodged at the Office or at such other place as the Directors may appoint and is accompanied by the certificates for

the Shares to which it relates and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the
transferor to make the transfer;

(b) in respect of only one class of Shares; and
(c) in favour of not more than four transferees.
7.3 If the Directors refuse to register a transfer of a Share, they shall, within two months after the date on which the

instrument of transfer was lodged with the Company, send to the transferor and the transferee notice of the refusal.

7.4 The registration of transfers of Shares or of transfers of any class of Shares may be suspended at such times and

for such periods (not exceeding 30 days in any year) as the Directors may determine.

7.5 No fee shall be charged for the registration of any instrument of transfer or, subject as otherwise herein provided,

any other document relating to or affecting the title to any Share.

7.6 The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered but any instrument of transfer

which the Directors refuse to register shall be returned to the person lodging it when notice of the refusal is given.

8. Transmission of Shares.
8.1 If a Holder dies, the survivor or survivors (where he was a joint Holder) and his personal representatives (where

he was a sole Holder or the only survivor of joint Holders) shall be the only persons recognised by the Company as
having any title to his interest provided that nothing herein contained shall release the estate of a deceased Holder from
any liability in respect of any Share which had been jointly held by him.

32083

L

U X E M B O U R G

8.2 A person becoming entitled to a Share in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder may,

upon such evidence being produced as the Directors may properly require, elect either to become the Holder of such
Share or to make such transfer thereof as the deceased, bankrupt or incapacitated Holder could have made. If he elects
to become the Holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to transfer the Share, he shall
execute an instrument of transfer of the Share to the transferee. All of the provisions of these Articles relating to the
transfer of Shares shall apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by
the Holder and the death, bankruptcy or incapacity of the Holder had not occurred.

8.3 A person becoming entitled to a Share in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder shall

have the rights to which he would be entitled if he were the Holder of such Share save that he shall not before being
registered as the Holder be entitled in respect of it to be sent any notice given pursuant to these Articles (unless specifically
provided for) or to attend or vote at any general meeting or at any separate meeting of the Holders of that class of Shares
in the Company.

9. Alteration of Share Capital.
9.1 Whenever, as a result of a consolidation of Shares, any Holders would become entitled to fractions of a Share, the

Directors may, in their absolute discretion, on behalf of those Holders, sell the Shares representing the fractions for the
best price reasonably obtainable to any person (including, subject to the provisions of the Law, the Company) and dis-
tribute the net proceeds of sale in due proportion among those Holders, and the Directors may authorise some person
to  execute  an  instrument  of  transfer  of  the  Shares  to,  or  in  accordance  with  the  directions  of,  the  purchaser.  The
transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the Shares be affected
by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the sale.

9.2 Subject to the provisions of the Law, the Company may convert existing non-redeemable Shares (whether issued

or not) into Shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed, at the option of the Company or at the
option of the Holder holding such redeemable Shares and on such terms and in such manner as may be determined by
Ordinary Resolution.

10. General Meetings.
10.1 All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.
10.2 The Directors may call general meetings and, on the requisition of Holders pursuant to the provisions of the Law,

shall forthwith proceed to call a general meeting for a date not later than two months after the receipt of the requisition.
If there are not sufficient Directors to call a general meeting, any Director or any Holder may call such a meeting.

11. Notice of General Meetings.
11.1 An annual general meeting or a general meeting called for the passing of a Special Resolution and all other meetings

shall be called by at least the minimum number of days' notice required by the Law. A general meeting may, however, be
called by shorter notice if it is so agreed:

(a) in the case of an annual general meeting, by all the Holders entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of any other meeting, by a majority in number of the Holders having a right to attend and vote at the

meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent of the total voting rights of the Holders who have
that right.

11.2 The notice shall specify the day, time and place of the meeting and the general nature of the business to be

transacted and, in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.

11.3 Subject to the provisions of these Articles and to any restrictions imposed on any Shares, the notice shall be given

to all Holders, to all persons recognised by the Directors as having become entitled to a Share following the death,
bankruptcy or incapacity of a Holder and to the Directors and auditor (if any).

11.4 The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person

entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at the meeting.

12. Proceedings at General Meetings.
12.1 No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. The quorum shall be:
(a) if all the issued Shares are held by the same Holder, one person being such Holder present in person or by proxy;

and

(b) otherwise, two persons entitled to vote upon the business to be transacted, each being a Holder present in person

or by proxy.

12.2 If such a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting or if, during a meeting,

such a quorum ceases to be present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same
time and place or such day, time and place as the chairman may determine and, if at such adjourned meeting, a quorum
is not present within five minutes from the time appointed for the holding of the meeting, those Holders present in person
or by proxy shall be a quorum.

12.3 The chairman, if any, of the board of Directors or, in his absence, some other Director nominated by the Directors

shall preside as chairman of the meeting but, if neither the chairman nor such other Director (if any) is present within 15

32084

L

U X E M B O U R G

minutes after the time appointed for holding the meeting and willing to act, the Directors present shall elect one of their
number to be chairman and, if there is only one Director present and willing to act, he shall be chairman.

12.4 If no Director is willing to act as chairman, or if no Director is present within 15 minutes after the time appointed

for holding the meeting, the Holders present and entitled to vote shall choose one of their number to be chairman.

12.5 A Director or a representative of the auditor (if any) shall, notwithstanding that he is not a Holder, be entitled

to attend and speak at any general meeting and at any separate meeting of the Holders of any class of Shares.

12.6 The chairman may, with the consent of a general meeting at which a quorum is present (and shall if so directed

by the meeting), adjourn the general meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted
at an adjourned general meeting other than business which might properly have been transacted at such meeting had the
adjournment not taken place. No notice of any adjourned meeting need be given save that, when a general meeting is
adjourned for 14 days or more, at least seven days' notice shall be given specifying the day, time and place of the adjourned
meeting and the general nature of the business to be transacted.

12.7 A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before or on the declaration

of the result of the show of hands, a poll is duly demanded. Subject to the provisions of the Law, a poll may be demanded:

(a) by the chairman; or
(b) by at least two Holders having the right to vote on the resolution; or
(c) by a Holder or Holders representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the Holders having the

right to vote on the resolution; or

(d) by a Holder or Holders holding Shares conferring a right to vote on the resolution being Shares on which an

aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all the Shares conferring that
right,

and a demand by a person as proxy for a Holder shall be the same as a demand by the Holder.
12.8 Unless a poll is duly demanded, a declaration by the chairman that a resolution has been carried or carried

unanimously, or by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority and an entry to that effect in the
minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes
recorded in favour of or against the resolution.

12.9 The demand for a poll may, before the poll is taken, be withdrawn but only with the consent of the chairman and

a demand so withdrawn shall not be taken to have invalidated the result on a show of hands declared before the demand
was made.

12.10 A poll shall be taken as the chairman directs and he may appoint scrutineers (who need not be Holders) and fix

a day, time and place for declaring the result of the poll. The result of the poll shall be deemed to be the resolution of
the meeting at which the poll was demanded.

12.11 In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman shall be entitled to a

casting vote in addition to any other vote he may have.

12.12 A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll

demanded on any other question shall be taken either forthwith or at such day, time and place as the chairman directs
not being more than 30 days after the poll is demanded. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a
meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll was demanded. If a poll is demanded
before the declaration of the result on a show of hands and the demand is duly withdrawn before the poll is taken, the
meeting shall continue as if the demand had not been made.

12.13 No notice need be given of a poll not taken forthwith if the day, time and place at which it is to be taken are

announced at the meeting at which it is demanded. In any other case at least seven days' notice shall be given specifying
the day, time and place at which the poll is to be taken.

13. Votes of Holders.
13.1 Subject to any rights or restrictions attached to any Shares, on a show of hands, every Holder who is present in

person shall have one vote and, on a poll, every Holder present in person or by proxy shall have one vote for every Share
of which he is the Holder (and, in the case of a fraction of a Share of which he is the Holder, an equivalent fraction of
one vote).

13.2 In the case of joint Holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be

accepted to the exclusion of the votes of the other joint Holders, and seniority shall be determined by the order in which
the names of the Holders stand in the register of members of the Company.

13.3 A Holder in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction (whether in Jersey or

elsewhere) in matters concerning mental disorder may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his receiver,
curator or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such receiver, curator or other person
may, on a poll, vote by proxy. Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of the person claiming to
exercise the right to vote shall be deposited at the Office, or at such other place within Jersey as is specified in accordance
with these Articles for the deposit of instruments of proxy, before the time appointed for holding the meeting or ad-
journed meeting at which the right to vote is to be exercised and, in default, the right to vote shall not be exercisable.

32085

L

U X E M B O U R G

13.4 No Holder shall vote at any general meeting or at any separate meeting of the Holders of any class of Shares,

either in person or by proxy, in respect of any Share held by him unless all moneys presently payable by him in respect
of that Share have been paid.

13.5 No objection shall be raised to the qualification of any person to vote save at the meeting or adjourned meeting

at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting shall be valid. Any objection
made in due time shall be referred to the chairman whose decision shall be final and conclusive.

13.6 On a poll, votes may be given either personally or by proxy. A Holder may appoint more than one proxy to

attend on the same occasion.

13.7 An instrument appointing a proxy shall be in writing in any usual form, or as approved by the Directors, and shall

be executed by or on behalf of the appointor.

13.8 The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed,

or a notarially certified copy of such power or authority, shall be deposited at the Office or at such other place as is
specified for that purpose in the notice of the meeting or in the instrument of proxy issued by the Company before the
time appointed for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to
vote or, in the case of a poll, before the time appointed for taking the poll and, in default, the instrument of proxy shall
not be treated as valid.

13.9 A vote given or a poll demanded by proxy or by a duly authorised representative of a body corporate shall be

valid notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice
of the determination was received by the Company at the Office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the vote is given or the
poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or adjourned meeting) the
time appointed for taking the poll.

14. Corporations Acting by Representatives.
14.1 Any corporation which is a Holder may, by resolution of its directors or other governing body, authorise such

person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting or at any meeting of any class of Holders, and
the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents
as that corporation could exercise if it were a natural person who is a Holder. A corporation present at any meeting by
such representative shall be deemed for the purposes of these Articles to be present in person.

15. Resolutions in Writing.
15.1 Anything that may, in accordance with the provisions of the Law, be done by a resolution in writing signed by or

on behalf of each Holder is authorised by these Articles without any restriction.

15.2 The Directors may determine the manner in which resolutions shall be put to Holders pursuant to the terms of

this Article and, without prejudice to the discretion of the Directors, provision may be made in the form of a resolution
in writing for each Holder to indicate how many of the votes which he would have been entitled to cast at a meeting to
consider the resolution he wishes to cast in favour of or against such resolution or to be treated as abstentions and the
result of any such resolution in writing need not be unanimous and shall be determined upon the same basis as on a poll.

16. Number of Directors.
16.1 Subject to the provisions of the Law, the Company in general meeting may from time to time fix the maximum

and/or minimum number of Directors and unless so fixed the number of Directors (other than Alternate Directors) shall
not be subject to any maximum and the minimum number shall be one.

17. Alternate Directors.
17.1 Any Director (other than an Alternate Director) may appoint any other Director, or any other person, to be an

Alternate Director and may remove from office an Alternate Director so appointed by him.

17.2 An Alternate Director shall be entitled to attend, participate in, be counted towards a quorum and vote at any

meeting of Directors and any meeting of committees of Directors of which his appointor is a member at which the
Director appointing him is not personally present, and generally to perform all the functions of his appointor as a Director
in his absence but shall not be entitled to receive any remuneration from the Company for his services as an Alternate
Director. It shall not be necessary to give notice of such a meeting to an Alternate Director.

17.3 An Alternate Director shall cease to be an Alternate Director if his appointor ceases to be a Director.
17.4 Any appointment or removal of an Alternate Director shall be by notice to the Company signed by the Director

making or revoking the appointment or in any other manner approved by the Directors.

17.5 Save as otherwise provided in these Articles, an Alternate Director shall be deemed for all purposes to be a

Director and shall alone be responsible for his own acts and defaults and he shall not be deemed to be the agent of the
Director appointing him.

32086

L

U X E M B O U R G

18. Powers of Directors.
18.1 Subject to the provisions of the Law, the Memorandum, these Articles and any directions given by Special Reso-

lution, the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all the powers of the Company
in any part of the world.

18.2 No alteration of the Memorandum or these Articles and no direction given by Special Resolution shall invalidate

any prior act of the Directors which would have been valid if that alteration had not been made or that direction had not
been given.

18.3 The powers given by this Article shall not be limited by any special power given to the Directors by these Articles

and a meeting of Directors at which a quorum is present may exercise all powers exercisable by the Directors.

18.4 The Directors may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for

such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his
powers.

19. Delegation of Directors' Powers.
19.1 The Directors may delegate any of their powers to any committee consisting of one or more Directors and (if

thought fit) one or more other persons, provided that a majority of the members of the committee shall be Directors.
No resolution of a committee shall be effective unless a majority of those present when it is passed are Directors. The
Directors may also delegate to any managing director of the Company or any other Director (whether holding any other
executive office or not) such of their powers as they consider desirable to be exercised by him. Any such delegation may
be made subject to any conditions that the Directors may impose, either collaterally with or to the exclusion of their
own powers, and may be revoked or altered. Subject to any such conditions, the proceedings of a committee shall be
governed by these Articles regulating the proceedings of Directors so far as they are capable of applying.

20. Appointment of Directors.
20.1 The first Directors shall be determined in writing by the subscribers to the Memorandum, or a majority of them.
20.2 The Directors shall have power at any time, and from time to time, without sanction of the Company in general

meeting, to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an additional Director.

20.3 The Company may by Ordinary Resolution appoint any person as a Director.

21. Disqualification, Removal and Resignation of Directors.
21.1 The office of a Director shall be vacated if:
(a) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Law or becomes prohibited by law from, or is disqualified

from, being a Director; or

(b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
(c) he resigns his office by notice to the Company; or
(d) the Company so resolves by Ordinary Resolution.
21.2 A Director may resign from office as a Director by giving notice in writing to that effect to the Company at the

Office, which notice shall be effective upon such date as may be specified in such notice, failing which upon delivery, to
the Office.

22. Remuneration of Directors.
22.1 The Directors shall be entitled to such remuneration as the Company may by Ordinary Resolution determine or

in accordance with such agreements relating to the provision of the services of the Directors as shall be entered into by
the Company from time to time and, unless such resolution or agreement provides otherwise, the remuneration shall
be deemed to accrue from day to day.

23. Directors' Expenses.
23.1 The Directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in connection with

their attendance at meetings of Directors or committees or general meetings or separate meetings of the Holders of any
class of Shares or of debentures of the Company or otherwise in connection with the discharge of their duties.

24. Directors' Appointments and Interests.
24.1 Subject to the provisions of the Law, the Directors may appoint one or more of their number to the office of

managing director of the Company or to any other executive office in the Company and may enter into an agreement
or arrangement with any Director for his employment by the Company or for the provision by him of any services outside
the scope of the ordinary duties of a Director. Any such appointment, agreement or arrangement may be made upon
such terms as the Directors determine and they may remunerate any such Director for his services as they think fit. Any
appointment of a Director to an executive office shall terminate if he ceases to be a Director but without prejudice to
any claim for damages for breach of any agreement relating to the provision of the services of such Director. The Directors
may also (without prejudice to any claim for damages for breach of any agreement between the Director and the Com-
pany) remove a Director from any executive office.

32087

L

U X E M B O U R G

24.2 Subject to the provisions of the Law, and provided that he has disclosed to the Directors the nature and extent

of any of his material interests, a Director notwithstanding his office:

(a) may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the

Company is otherwise interested;

(b) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or

otherwise interested in, any body corporate promoted by the Company or in which the Company is otherwise interested
or the interests of which may conflict with those of the Company;

(c) shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such

office or employment or from any such transaction or arrangement or from any interest in any such body corporate and
no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit; and

(d) may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company and he or his firm shall be entitled to

remuneration for professional services as though he were not a Director.

24.3 For the purposes of this Article:
(a) a general notice given by or on behalf of a Director to the Directors that such Director is to be regarded as having

an interest of the nature and extent specified in the notice in any transaction or arrangement with a specified person or
class of persons shall be deemed to be sufficient disclosure of his interest in any such transaction or arrangement; and

(b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect him to have knowledge

shall not be treated as an interest of his.

25. Directors' Gratuities and Pensions.
25.1 The Directors may resolve that the Company shall provide benefits, whether by the payment of gratuities or

pensions  or  by  insurance  or  otherwise,  for  any  Director  who  has  held  but  no  longer  holds  any  executive  office  or
employment with the Company or with any body corporate which is or has been a subsidiary of the Company or a
predecessor in business of the Company or of any such subsidiary, and for any member of his family (including a spouse
and a former spouse) or any person who is or who was dependent on him, and may (as well before as after he ceases to
hold such office or employment) contribute to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such
benefit.

26. Proceedings of Directors.
26.1 Subject to the provisions of these Articles, the Directors may regulate their proceedings as they think fit.
26.2 A Director may, and the Secretary at the request of a Director shall, call a meeting of the Directors.
26.3 Questions arising at a meeting of Directors shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality of

votes, the chairman shall have a second or casting vote. A person who has been appointed as an Alternate Director by
one or more Directors shall have one vote in respect of each such appointment, in addition to any vote that he may be
entitled to as a Director.

26.4 Whenever two or more persons hold the office of Director the quorum necessary for the transaction of the

business of the Directors shall be two or such greater number as may be fixed by the Company in general meeting. When
only one Director is in office, he may exercise alone all the powers and discretions for the time being exercisable by the
Directors. A person who is an Alternate Director shall be counted in the quorum, and any Director acting as an Alternate
Director shall, in the absence of the Director for whom he acts as Alternate Director, also be counted as one for each
of the Directors for whom he acts as Alternate Director.

26.5 Any Director enabled to participate in the proceedings of a meeting of the Directors by means of a communication

device (including a telephone) which allows all of the other Directors present at such meeting to hear at all times such
Director and such Director to hear at all times all other Directors present at such meeting (in each case whether in
person or by means of such type of communication device) shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when calculating a quorum.

26.6 The Directors may act notwithstanding any vacancies in their number but, if the number of Directors is less than

the number fixed as the quorum, the Directors or the sole continuing Director may act only for the purpose of filling
vacancies or of calling a general meeting to appoint Directors.

26.7 The Directors may appoint one of their number to be the chairman of the board of Directors and may at any

time remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the Director so appointed shall preside at every meeting
of Directors at which he is present. If there is no Director holding that office, or if the Director holding it is unwilling to
preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the Directors present may appoint
one of their number to be chairman of the meeting.

26.8 All acts done by a meeting of Directors, or by a committee duly authorised by the Directors, or by a person

acting as a Director or Alternate Director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect
in the appointment of any Director or Alternate Director or member of such committee or that any of them were
disqualified from holding office, or had vacated office, or were not entitled to vote, be as valid as if every such person had
been duly appointed and was qualified and had continued to be a Director or Alternate Director or member of such
committee and had been entitled to vote.

32088

L

U X E M B O U R G

26.9 A resolution in writing signed by all the Directors entitled to receive notice of a meeting of Directors or of a

committee duly authorised by the Directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of Directors
or (as the case may be) a committee duly authorised by the Directors duly convened and held and may consist of several
documents in the like form each signed by one or more Directors or, in the case of a committee, the members of such
committee provided that a resolution signed by an Alternate Director need not also be signed by his appointor and, if it
is signed by a Director who has appointed an Alternate Director, it need not be signed by the Alternate Director in that
capacity.

26.10 A Director may vote in respect of any transaction or arrangement or proposed transaction or arrangement in

which he has an interest which he has disclosed in accordance with these Articles and, if he does vote, his vote shall be
counted and he shall be counted towards a quorum at any meeting of the Directors at which any such transaction or
arrangement or proposed transaction or arrangement, shall come before the Directors for consideration.

26.11 Where proposals are under consideration concerning the appointment of two or more Directors to offices or

employment with the Company or any body corporate in which the Company is interested, the proposals may be divided
and considered in relation to each Director separately and each of the Directors concerned shall be entitled to vote and
be counted in the quorum in respect of each resolution save that concerning his own appointment.

27. Secretary.
27.1 Subject to the provisions of the Law, the Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such

remuneration and upon such conditions as they may think fit and any Secretary so appointed may be removed by them.

28. Minutes.
28.1 The Secretary shall cause minutes to be made in books kept for the purpose in accordance with the Law.

29. The Seal.
29.1 The Directors may at any time resolve that the Company shall have, or shall cease to have, a common seal.
29.2 A Seal shall only be used by the authority of the Directors or of a committee authorised by the Directors. The

Directors may determine who shall sign any instrument to which a Seal is affixed and, unless otherwise so determined,
it shall be signed by any two Directors or a Director and the Secretary.

29.3 Subject to the provisions of the Law, the Directors may resolve to have or cease to have:
(a) an official seal for use in any country territory or place outside Jersey, which shall be a copy of the common seal

of the Company. Any such official seal shall in addition bear either the name of the country, territory or place in which
it is to be used or the words “branch seal”; and

(b) an official seal for use only in connection with the sealing of securities issued by the Company and such official seal

shall be a copy of the common seal of the Company but shall in addition bear the word “securities”.

30. Dividends.
30.1 Subject to the provisions of the Law, the Company may by Ordinary Resolution declare dividends in accordance

with the respective rights of the Holders, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.

30.2 The Directors may pay interim dividends subject to and in accordance with the provisions of the Law. If different

classes of Shares have been issued, the Directors may pay interim dividends on Shares which confer deferred or non-
preferred rights with regard to dividend as well as on Shares which confer preferential rights with regard to dividend, but
no interim dividend shall be paid on Shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any
preferential dividend is in arrear. Subject to the provisions of the Law, the Directors may also pay at intervals settled by
them any dividend payable at a fixed rate. Provided that the Directors act in good faith, they shall not incur any liability
to the Holders of Shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim
dividend on any Shares having deferred or non-preferred rights.

30.3 Save as otherwise provided by the rights attached to Shares, all dividends shall be declared and paid according to

the amounts paid up on the Shares on which the dividend is paid. All dividends shall be apportioned and paid proportio-
nately to the amounts paid up on the Shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend
is paid but, if any Share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date that Share
shall rank for dividend accordingly.

30.4 A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct that it shall be

satisfied wholly or partly by the issue of Shares or by the distribution of assets and, where any difficulty arises in regard
to the distribution, the Directors may settle the difficulty and in particular may issue fractional certificates and fix the
value for distribution of any assets and may determine that cash shall be paid to any Holder upon the footing of the value
so fixed in order to adjust the rights of Holders and may vest any assets in trustees.

30.5 Any dividend or other moneys payable in respect of a Share may be paid by cheque sent by post to the registered

address of the Holder or the person recognised by the Directors as entitled to the Share or, if two or more persons are
the Holders or are recognised by the Directors as jointly entitled to the Share, to the registered address of the first
Holder named in the register of members of the Company or to such person or persons entitled and to such address as
the Directors shall in their absolute discretion determine. Every cheque shall be made payable to the order of the person

32089

L

U X E M B O U R G

or persons entitled or as the Directors shall in their absolute discretion determine to such other person as the person
or persons entitled may in writing direct and payment of the cheque shall be a good discharge to the Company. Any joint
Holder or other person jointly entitled to a Share as aforesaid may give receipts for any dividend or other moneys payable
in respect of such Share.

30.6 The Directors may deduct from any dividend or other moneys payable to any Holder or other person entitled

on or in respect of a Share all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or
otherwise in relation to any Shares held by such Holder or other person entitled.

30.7  No  dividend  or  other  moneys  payable  in  respect  of  a  Share  shall  bear  interest  against  the  Company  unless

otherwise provided by the rights attached to such Share.

30.8 Any dividend which has remained unclaimed for 10 years from the date when it became due for payment shall, if

the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company.

31. Accounts and Audits.
31.1 No Holder shall (as such) have any right of inspecting any accounting records or other book or document of the

Company save as conferred by the Law or authorised by the Directors or by Ordinary Resolution.

31.2 The Company may appoint an auditor to examine the accounts and report thereon in accordance with the Law.

32. Capitalisation of Profits.
32.1 With the authority of an Ordinary Resolution the Directors may:
(a) subject as hereinafter provided, resolve to capitalise any undivided profits of the Company not required for paying

any preferential dividend (whether or not they are available for distribution) or, in the case of a par value company any
sum standing to the credit of the Company's capital redemption reserve, or share premium account;

(b) appropriate the sum resolved to be capitalised to the Holders in proportion to the number or, in the case of a par

value company, nominal amounts of the Shares (whether or not fully paid) held by them respectively which would entitle
them to participate in a distribution of that sum if the Shares were fully paid and the sum were distributable and were
distributed by way of dividend and apply such sum on their behalf either in or towards paying up the amounts, if any, for
the time being unpaid on any Shares held by them respectively, or in paying up and allotting unissued Shares or debentures
of the Company credited as partly or fully paid to those Holders, or as they may direct, in those proportions, or partly
in one way and partly in the other provided that any profits which are not available for distribution and, in the case of a
par value company, the capital redemption reserve and the share premium account may, for the purposes of this Article,
only be applied in paying up unissued Shares to be allotted to Holders credited as fully paid up;

(c) make such provision by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they determine

in the case of Shares or debentures becoming distributable under this Article in fractions; and

(d) authorise any person to enter on behalf of all the Holders concerned into an agreement with the Company providing

for the allotment to them respectively, credited as fully paid, of any Shares or debentures to which they are entitled upon
such capitalisation, any agreement made under such authority being binding on all such Holders.

33. Notices.
33.1 Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing and may be given by

email or any other electronic method provided that a notice calling a meeting of the Directors need not be in writing.

33.2 The Company may give any notice to a Holder either personally, by sending it by post in a prepaid envelope

addressed to the Holder at his registered address, by leaving it at that address or by emailing the notice to the Holder's
electronic address last notified to the Company by the Holder. In the case of joint Holders of a Share, all notices shall be
given to the joint Holder whose name stands first in the register of members of the Company in respect of the joint
holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint Holders.

33.3 A Holder present, either in person or by proxy, at any general meeting or of the Holders of any class of Shares

shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the purposes for which it was called.

33.4 Every person who becomes entitled to a Share shall be bound by any notice in respect of that Share which, before

his name is entered in the register of members, has been duly given to a person from which he derives his title.

33.5 Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence

that the notice was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing
it was posted.

33.6 Electronic communication of a notice (properly addressed and dispatched to the Holder's electronic address last

notified in writing) is given or deemed to have been given at the time the electronic notice leaves the information system
of the Company or the information system any other person sending the notice on the Company's behalf (as the case
may be).

33.7 A notice may be given by the Company to the persons recognised by the Directors as being entitled to a Share

in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder by sending or delivering it, in any manner authorised
by these Articles for the giving of notice to a Holder, addressed to them by name, or by the title of representatives of
the deceased, or trustee of the bankrupt or curator of the Holder or by any like description at the address, if any, supplied

32090

L

U X E M B O U R G

for that purpose by such persons. Until such an address has been supplied, a notice may be given in any manner in which
it might have been given if the death, bankruptcy or incapacity had not occurred. If more than one person would be
entitled to receive a notice in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder, notice given to any one
of such persons shall be sufficient notice to all such persons.

34. Winding Up.
34.1 If the Company is wound up, the Company may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction

required by the Law, divide the whole or any part of the assets of the Company among the Holders in specie provided
that no Holder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

34.2 For the purposes of this Article, the liquidator or, where there is no liquidator, the Directors may, for that

purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the Holders or different classes
of Holders or vest the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Holders.

35. Indemnity.
35.1 In so far as the Law allows, every present or former officer of the Company shall be indemnified out of the assets

of the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been such an officer. The
Directors, may without sanction of the Company in general meeting, authorise the purchase or maintenance by the
Company for any officer or former officer of the Company of any such insurance as is permitted by the Law in respect
of any liability which would otherwise attach to such officer or former officer.

<i>Costs and Evaluation

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company

incurs or for which it is liable by reason of the transfer of its registered office to Jersey, amounts to approximately one
thousand nine hundred euro (€ 1,900.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us the notary, the present original deed.

Follows the French Translation of Above Text:

L'an deux mille onze, le quatorze mars.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A COMPARU:

Eurovegas Holding Limited, ayant son siège social au 15 Esplanade, St Hellier, JE1 1RB, inscrite auprès du Registre des

Sociétés der Jersey sous le numéro 100012 représentée par Marcus PETER, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg en
vertu d'une procuration, laquelle restera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. Eurovegas Holding Limited détient DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de

UN EURO (EUR 1,-) représentant l'intégralité du capital social de Centrope Holding S.àr.l., une société à responsabilité
limitée luxembourgeoise, dont le siège social est au 57, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
enregistrée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 157.352 (la “Société”).

II. Le siège social et le principal établissement de la Société ont été transférés au Luxembourg suivant acte du notaire

soussigné en date du 7 décembre 2010 publié au Mémorial C n° 2791 le 20 décembre 2010.

III. Il est proposé de transférer le siège social de la Société de 57, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-

xembourg  à  15  Esplanade,  St  Helier,  Jersey,  JE1  1RB,  Iles  de  la  Manche,  et  en  conséquence,  de  modifier  le  lieu
d'enregistrement de la Société, avec effet à compter de la date (la «Date d'Effet») à partir de laquelle un certificat de
maintien concernant la Société est émis par la Jersey Financial Services Commission en qualité de teneur du registre des
sociétés de Jersey conformément à l'article 127O de la loi de Jersey sur les sociétés de 1991, telle que modifiée (la «Loi
de Jersey») à la condition que la Société cesse d'être une société luxembourgeoise, sous réserve de la réalisation de toutes
les dispositions applicables de droit de Jersey à la Date d'Effet;

IV. Eurovegas Holding Limited renonce à toutes formalités de convocation.
L'assemblée générale est correctement constituée et peut valablement résoudre.
V. L'assemblée générale des associés de la Société a pris les résolutions suivantes:

32091

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité d'approuver les comptes de la Société au 31 décembre

2010 et le bilan intermédiaire au 15 février 2011.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de transférer le siège social de la Société de 57, avenue

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg à 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB, Îles de la Manche, et en
conséquence, de modifier le lieu d'enregistrement de la Société, avec effet à compter de la Date d'Effet, et conformément
aux articles 2 troisième alinéa, 199 et 159 deuxième alinéa de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée et de déposer tous les documents requis d'après la Loi de Jersey afin de donner plein
effet à cette résolution, y compris le dépôt d'une copie certifiée de ces résolutions à la Jersey Financial Services Com-
mission qui confirme qu'à partir de son maintien à Jersey, le nouveau siège social de la Société est situé à 15 Esplanade,
St Helier, Jersey, JE1 1RB, Iles de la Manche.

De plus, l'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de changer à compter de la Date d'Effet la forme

sociale de la Société de société à responsabilité de droit luxembourgeois, à private company enregistrée à Jersey et
soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables à cette forme de société d'après la Loi de Jersey, et en
conséquence d'adopter les Nouveaux Statuts (tel que définit et reproduit à la fin du présent acte) afin de les mettre en
conformité avec le droit de Jersey.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité d'accepter la démission de Paul HÖRETZEDER, de ses

fonctions de gérant de la Société. La démission prendra effet à compter de la Date d'Effet.

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité d'accepter la démission de Sylvie PORTENSEIGNE, de ses

fonctions de gérant de la Société avec effet au 9 mars 2011.

De plus l'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de décharger Paul HÖRETZEDER et Sylvie POR-

TENSEIGNE pour l'exécution de leurs fonctions de gérants depuis la date de leur désignation comme gérant jusqu'à et
y compris la date de leur démission.

L'assemblée générale des actionnaires résout à l'unanimité de désigner:
a) Paul HÖRETZEDER, né le 6 avril 1975 à Wels, Autriche, résidant à Miller von Aichholzstrasse 38a, 4810 Gmunden,

Autriche; conseiller;

b) Steven ROBINSON, né le 5 septembre 1974, résidant professionnellement Hawksford Trust Company Jersey Li-

mited, 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB; administrateur de Hawksford Trust Company Jersey Limited;

c) Michael POWELL, né le 30 septembre 1958, résidant professionnellement Hawksford Trust Company Jersey Limi-

ted, 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB; administrateur de Hawksford Trust Company Jersey Limited;

d) Stephen CARR, né le 19 juillet 1977, résidant professionnellement Hawksford Trust Company Jersey Limited, 15

Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1RB; administrateur associé de Hawksford Trust Company Jersey Limited;

comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de la Date d'Effet.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires confirme à l'unanimité que (i) les Nouveaux Statuts sont conformes aux pre-

scriptions du droit de Jersey, (ii) à partir de la Date d'Effet, la Société cessera d'être une société de droit luxembourgeois
et, (iii) sous réserve des dispositions de la Loi de Jersey, à partir de la Date d'Effet, la Société sera exclusivement soumise
aux lois de Jersey applicables, et (iv) ni le transfert du siège social de la Société, ni le changement de son lieu d'enregis-
trement, ni le changement de sa forme sociale n'ont pour effet la dissolution et/ou le liquidation de la Société et la création
d'une nouvelle entité juridique.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale résout à l'unanimité de désigner Paul HÖRETZEDER, Steve ROBINSON, Michael POWELL, et

Stephen CARR individuellement et avec les pouvoirs les plus étendus (y compris le pouvoir de substitution), de prendre
toute mesure, en ce compris notamment la signature et la délivrance de tout acte, formulaire, certificat, contrat ou autre
document et l'observation de toutes formalités de dépôt et de publicité requises d'après le droit luxembourgeois et le
droit de Jersey pour l'enregistrement du transfert du siège social et le transfert du lieu d'enregistrement de la Société
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et le dépôt de tout document requis d'après le droit
de Jersey, et nécessaire ou utile au transfert diligent et valide du siège social de la Société à Jersey, afin de donner plein
effet à ces résolutions, y compris le dépôt d'une copie certifiée de ces résolutions à la Jersey Financial Services Commission
qui confirme qu'à partir du maintien de la Société à Jersey, le nouveau siège social de la Société sera situé au 15 Esplanade,
St Helier, Jersey, JE1 1RB, Îles de la Manche.

32092

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale résout à l'unanimité que les livres et documents liés à la Société seront transférés à son nouveau

siège social aussitôt que possible après la Date d'Effet.

<i>Septième résolution

Il est noté qu'à la Date d'Effet le capital de la société reste inchangé et s'élève à EUR 12.500 de valeur divisé en 12.500

parts à responsabilité limitée de EUR 1,- chacune.

NOUVEAU STATUTS

Référence est faite à la version anglaise du présent acte

<i>Frais

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société et facturés en

raison du présent acte sont évalués à mille neuf cents euros (€ 1.900,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, ledit comparant a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: Peter, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 mars 2011. Relation: EAC/2011/3596. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011047987/816.
(110054129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

Argentum Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Argentum Fonds coordonné au 28. février 2011 a été déposé au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28. février 2011.

IPConcept Fund Management S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011040758/11.
(110044981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2011.

ING (L) Technix, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 53.127.

ING (L) II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 60.411.

L'an deux mille onze, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

I) ING (L) Technix, une société d'investissement à capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, section B, sous le numéro 53127 et ayant son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,

représentée par Monsieur Guillaume André, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxem-

bourg,

en vertu d'une décision du conseil d'administration de la prédite société prise en date du 2 mars 2011
ci-après la «société absorbée»,

32093

L

U X E M B O U R G

II) ING (L) II, une société d'investissement à capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, section B, sous le numéro 60411 et ayant son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,

représentée par Monsieur Guillaume André, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxem-

bourg,

en vertu d'une décision du conseil d'administration de la prédite société prise en date du 2 mars 2011
ci-après la «société absorbante».
Lesquelles sociétés comparantes, telles que représentées, ont demandé au notaire soussigné d'acter comme suit le

projet de fusion sur lequel se sont mis d'accord le Conseil d'Administration de ING (L) Technix et le Conseil d'Admi-
nistration de ING (L) II afin de réaliser la fusion entre les deux sociétés, lequel projet de fusion est conçu comme suit:

I. Désignation des sociétés qui fusionnent
ING (L) Technix est une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable (Partie

II de la loi du 20 décembre 2002), avec son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, constituée sous la
dénomination «BBL TECHNIX» suivant acte notarié, en date du 11 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 171 du 5 avril 1996. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire instrumentant en date du 12 février 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 298 du 5 mars 2007, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 53127.

ING (L) II est une société anonyme établie sous le régime d'une société d'investissement à capital variable (Partie II de

la loi du 20 décembre 2002), avec son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, constituée sous la dénomi-
nation de «ING (L) SELECTIS», suivant acte notarié en date du 21 août 1997, publié au Mémorial, Recueil C numéro 522
en date du 24 septembre 1997, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte
du notaire instrumentant du 13 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil C numéro 259 du 8 février 2011, inscrite
au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 60411.

ING (L) Technix et ING (L) II ont pour administration centrale ING Investment Management Luxembourg S.A., avec

siège social siège au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg et pour banque dépositaire et service financier Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. avec siège social siège au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

II. Fusion de ING (L) II avec ING (L) Technix
ING (L) II fusionnera avec ING (L) Technix par absorption de cette dernière. Lors de la prise d'effet de la fusion, tous

les actifs et les passifs de la société absorbée (tel qu'ils existeront à cette date) seront transférés de plein droit à la société
absorbante, la société absorbée cessera d'exister et la société absorbante émettra des nouvelles actions aux (alors anciens)
détenteurs d'actions de la société absorbée, conformément (i) à la loi Luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915 telle que modifiée, ainsi que (ii) aux modalités de la fusion prévues par le présent projet de fusion, le
rapport des conseils d'administration des sociétés, fusionnantes ((i) et (ii) constituant ensembles les «Conditions de la
Fusion»). Les compartiments de ING (L) II accueilleront les actifs et les passifs des compartiments de ING (L) Technix.

Au terme de l'opération de fusion ING (L) Technix cessera d'exister ipso jure et les actions en circulation de chacun

des compartiments de ING (L) Technix seront annulées.

Les classes d'action des compartiments de ING (L) II accueilleront les actifs et les passifs des classes d'action des

compartiments de ING (L) Technix.

III. Transfert des avoirs des compartiments de ING (L) Technix
Le transfert des avoirs s'opérera comme suit, conformément aux articles 257 et suivants de la loi Luxembourgeoise

du 10 août 1915 sur tes sociétés commerciales, telle que modifiée:

Détails des compartiments absorbés:

Détails des compartiments absorbants:

Nom SICAV

Nom compartiment

Nom SICAV

Nom compartiment

ING (L) TECHNIX

Dual Win 1

ING (L) II

Technix Dual Win 1

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0573989497 max 1,5%

Cap

LU0591960140

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Short Term 1

ING (L) II

Technix Short Term 1

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0447001586 max 1,5%

Cap

LU0591960223

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Short Term 2

ING (L) II

Technix Short Term 2

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0467768957 max 1,5%

Cap

LU0591960496

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Short Term 3

ING (L) II

Technix Short Term 3

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0545738477 max 1,5%

Cap

LU0591960579

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Booster 1

ING (L) II

Technix Special Booster 1

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

32094

L

U X E M B O U R G

Cap

LU0432693132 max 1,5%

Cap

LU0591960652

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Booster 2

ING (L) II

Technix Special Booster 2

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0496700955 max 1,5%

Cap

LU0591960736

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Callable 4

ING (L) II

Technix Special Callable 4

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0424977972 max 1,5%

Cap

LU0591960819

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Callable 6

ING (L) II

Technix Special Callable 6

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0457802014 max 1,5%

Cap

LU0591960900

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Callable 7

ING (L) II

Technix Special Callable 7

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0467768791 max 1,5%

Cap

LU0591961114

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Callable 8

ING (L) II

Technix Specil Callable 8

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0563851004 max 1,5%

Cap

LU0591961205

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Callable 9

ING (L) II

Technix Special Callable 9

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0578491937 max 1,5%

Cap

LU0591961387

max 1,5%

ING (L) TECHNIX

Special Callable Maximizer 1

ING (L) II

Technix Special Callable Maximizer

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Classe d'action

ISIN

Frais de gestion

Cap

LU0573989570 max 1,5%

Cap

LU0591961460

max 1,5%

Les objectifs et politiques d'investissement des compartiments absorbés de ING (L) Technix seront identiques par

rapport à ceux des compartiments absorbants de ING (L) II.

<i>Rapport d'échange

En contrepartie de la transmission universelle des avoirs de ING (L) Technix, ING (L) II émettra et attribuera aux

actionnaires du (des) compartiment(s) de ING (L) Technix un nombre d'actions au sein du (des) compartiment(s) cor-
respondant(s) de ING (L) II, proportionnel aux actifs nets apportés à ce (ces) compartiment(s) calculés au 17 juin 2011.

Le rapport d'échange entre les actions des compartiments de ING (L) Technix et des compartiments correspondants

de ING (L) II sera établi sur base des valeurs nettes d'inventaire des compartiments de ING (L) Technix et des compar-
timents de ING (L) II calculés au 17 juin 2011.

Une publication ultérieure renseignera dans les plus brefs délais les résultats de la fusion et notamment les rapports

d'échange déterminés sur base des valeurs nettes d'inventaire calculées au 17 juin 2011.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. est nommé comme expert indépendant afin d'établir un rapport élaboré pour ING

(L) Technix conformément à l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur
la proposition de fusion entre ING (L) Technix et ING (L) II.

Ernst &amp; Young S.A. est nommé comme expert indépendant afin d'établir un rapport élaboré pour ING (L) II confor-

mément à l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur la proposition de
fusion entre ING (L) Technix et ING (L) II.

<i>Modalités de remise des actions

Les actions au porteur inscrites dans les livres de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. seront, au jour de

la prise d'effet de la fusion, converties automatiquement en actions dans les compartiments relevant de ING (L) II.

Les actions au porteur physiques de ING (L) Technix détenues par des personnes qui ne sont pas inscrites dans les

livres de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. au jour de la prise d'effet de la fusion et qui ne sont pas déposées
auprès de la banque dépositaire Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. au jour de la prise d'effet de la fusion
pourront être échangées en actions dans les compartiments relevant de ING (L) II auprès de Dexia BIL.

<i>Suspension de la souscription, L'échange et Le rachat

Les nouvelles souscriptions, échanges et rachats dans les compartiments de la société absorbée seront acceptés jusqu'à

15h30 le 15 juin 2011.

Date à partir de laquelle les nouvelles actions donnent droit de participer aux bénéfices
Les actions des compartiments de ING (L) II nouvellement émises, suite à la fusion, bénéficieront des mêmes droits à

tous égards que les actions existantes et participeront à ce titre aux bénéfices à partir de la date effective de la fusion.

32095

L

U X E M B O U R G

<i>Droits spéciaux

Aucun actionnaire ni de ING (L) II ni de ING (L) Technix ne bénéficiera de droits spéciaux et aucun titre autre que

des actions ne sera émis.

<i>Date d'effet sur le plan comptable

Du point de vue comptable, la fusion sera considérée comme accomplie le 17 juin 2011, date à partir de laquelle les

opérations de ING (L) Technix seront accomplies pour compte de ING (L) II.

<i>Avantages particuliers

A l'exception d'une rémunération normale due aux experts indépendants et aux réviseurs d'entreprises des sociétés

participant à la fusion pour leurs prestations, aucun avantage particulier ne sera attribué ni aux experts indépendants ni
aux membres du conseil d'administration ni aux réviseurs d'entreprises des sociétés participant à la fusion.

IV. Convocation d'une assemblée générale extraordinaire délibérant et Approuvant le projet de fusion
Une assemblée générale extraordinaire de ING (L) Technix sera convoquée pour être tenue au moins un mois après

la publication de ce projet de fusion dans le Mémorial C afin de délibérer et d'approuver le projet de fusion. À moins
qu'un ou plusieurs actionnaires de ING (L) II, disposant d'au moins 5% des actions en circulation de ING (L) II ne le
requièrent jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de ING (L) Technix, la fusion sera réalisée sans décision
d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ING (L) II.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibérera valablement que si les conditions de quorum et de présence requises

par les articles 67-1 et 68 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont remplies.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ING

(L) Technix sera convoquée aux mêmes fins.

Tout actionnaire a, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée appelée à se prononcer sur le projet

de fusion, le droit de prendre connaissance ou d'obtenir sans frais et sur simple demande, au siège social de la société
absorbée, une copie des documents prévus par l'article 267(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée, à savoir:

a) Le projet de fusion;
b) Les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois dernières années pour ING (L) Technix et ING (L)

II;

c) Les rapports des conseils d'administration des sociétés qui fusionnent;
d) Le rapport d'examen du projet de fusion établi par le réviseur d'entreprises de chacune des sociétés qui fusionnent.
Tout actionnaire de ING (L) Technix qui ne serait pas d'accord avec le projet de fusion a le droit de demander à la

société absorbée ou à Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. le rachat de ses actions sans frais endéans 30 jours
calendriers avant la date effective de la fusion, à savoir le 17 juin 2011. Les actions d'un actionnaire de ING (L) Technix
inscrites dans les livres de Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ou déposés auprès de ING à la date effective
de la fusion qui ne demande pas le rachat sans frais de ses actions pendant cette période, par défaut, seront échangées
pour les actions du compartiment relevant de ING (L) II.

V. Répartition des frais inhérents à la fusion
Les frais sont estimés à sept mille euros(7.000.- EUR) et seront payables par la société de gestion de ING (L) Technix,

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Ce projet de fusion a été approuvé séparément par les conseils d'administration de ING (L) Technix et d'ING (L) II

par résolutions circulaires en date du 2 mars 2011 avec effet au 2 mars 2011.

Le notaire soussigné certifie la légalité du projet de fusion en application de l'article 271 de la loi 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, ès qualités qu'il agisse, connu du notaire par ses noms, prénoms usuels, état et

demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. ANDRE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2011. Relation: LAC/2011/14168. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2011.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2011045112/178.
(110050144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

32096

L

U X E M B O U R G

Fédération Saint Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg asbl, Association sans but lu-

cratif.

Siège social: L-9167 Mertzig, 15, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg F 110.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

<i>Pour La FEDERATION SAINT HUBERT DES CHASSEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Asbl
Par mandat
Laurent METZLER

Référence de publication: 2011047125/14.
(110052511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,

(anc. NIKKO BANK (Luxembourg) S.A.).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 11.809.

In the year two thousand and eleven, on the seventeenth of March,
before Maître Joëlle Baden, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.", a société

anonyme having its registered office at L-2557 Luxembourg, 9a, rue Robert Stümper, recorded with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under section B, number 11.809, incorporated by a notarial deed on the 14 

th

 of February

1974, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 56 of 18 

th

 of March 1974.

The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 26 November

2009, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 104 of 15 January 2010.

The meeting is opened at 11.30 a.m. with Mr Kamo Masashi, Deputy Managing Director at Nikko Bank (Luxembourg)

S.A., with professional address at 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, in the chair.

The chairman appoints as secretary Mr Jérôme Goepfert, Legal Adviser at Nikko Bank (Luxembourg) S.A., with pro-

fessional address at 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Cécile Schneider, Senior General Manager at Nikko Bank (Luxembourg) S.A.,

with professional address at 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Proposal to change the name of the company from Nikko Bank (Luxembourg) S.A. to SMBC Nikko Bank (Luxem-

bourg) S.A. with effect from April 1 

st

 , 2011.

2.- Miscellaneous.
II.- That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented share-
holders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The proxyholder of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been

initialled ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were

necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting decides to change with effect as of 1 April 2011 the name of the company from Nikko Bank

(Luxembourg) S.A. to SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A..

32097

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution:

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting decides to amend with effect as of 1 April 2011 the

nd

 sentence of the 1 

st

 article of the articles of incorporation of the company which will henceforth read as follows:

"The Company will exist under the name of "SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A."."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereupon, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the registered office of the company, at the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille onze, le dix-sept mars,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
se  réunit  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "NIKKO  BANK  (LUXEM-

BOURG) S.A.", ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 9a, rue Robert Stümper, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 11.809, constituée suivant acte notarié reçu le 14 février 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 56 du 18 mars 1974.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 26 novembre 2009,

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 104 du 15 janvier 2010.

L'assemblée est ouverte à 11.30 sous la présidence de Monsieur Kamo Masashi, Deputy Managing Director de Nikko

Bank (Luxembourg) S.A., demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Goepfert, juriste de Nikko Bank (Luxembourg) S.A., de-

meurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cécile Schneider, Senior General Manager de Nikko Bank (Luxem-

bourg) S.A., demeurant professionnellement au 9A, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Proposition de modifier la dénomination sociale de la société de Nikko Bank (Luxembourg) S.A. en SMBC Nikko

Bank (Luxembourg) S.A. avec effet au 1 

er

 avril 2011.

2) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société de Nikko Bank (Luxembourg) S.A. en

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A. avec effet au 1 

er

 avril 2011.

32098

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier avec effet au 1 

er

 avril 2011 la

ème

 phrase du 1 

er

 article des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

"La société existe sous la dénomination de "SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A."."

<i>Évaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: K. MASASHI, J. GOEPFERT, C. SCHNEIDER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2011. LAC/2011 / 12713. Reçu soixante quinze euros€ 75,-.

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011047168/112.
(110052452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

Fédération Saint Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg asbl, Association sans but lu-

cratif.

Siège social: L-9167 Mertzig, 15, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg F 110.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 décembre 2010, homologuée par jugement en

matière d'homologation de décisions d'associations sans but lucratif rendu le 31 mars 2011, les statuts ont été modifiés
comme suit:

FEDERATION SAINT HUBERT DES CHASSEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, A.s.b.l.
Association sans but lucratif
Organisation pour la Protection de la Nature agréée par arrêté ministériel du 3 octobre 2005
Siège social: Mertzig

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  L'Association est dénommée FEDERATION SAINT HUBERT DES CHASSEURS DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, Asbl, régie par les présents statuts et son règlement d'ordre intérieur qui sera arrêté par le Comité
Central.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9167 Mertzig, 15, rue de l'Ecole.

Titre II. Objet

Art. 4. L'Association a pour objet de promouvoir et de favoriser par tous les moyens légaux les intérêts de la chasse

et des chasseurs dans un esprit de saines conceptions cynégétiques, éthiques et respectueuses de la conservation de la
Nature. Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment
prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet. L'Association est confessionnellement et poli-
tiquement neutre.

Titre III. Associés

Art. 5. L'association est composée de membres effectifs, de membres sympathisants, de membres amis et de membres

d'honneur. Le nombre minimum des membres effectifs ne peut être inférieur à vingt.

Art. 6. Des membres:

Art. 6.1. Sont considérés comme membres effectifs les associés ayant payé leur cotisation et étant ou ayant été titulaires

d'un permis de chasse luxembourgeois valable.

32099

L

U X E M B O U R G

Art. 6.2. Sont considérées comme membres sympathisants les personnes physiques ou morales ayant payé leur coti-

sation et n'étant pas titulaires d'un permis de chasse luxembourgeois valable.

Art. 6.3. Sont considérées comme membres amis les personnes physiques ou morales qui soutiennent l'action et l'esprit

de l'Association moyennant une cotisation.

Art. 6.4. Peuvent être nommées membres d'honneur les personnes physiques ou morales qui, à un titre reconnu,

auront servi soit les intérêts de l'Association, soit ceux de la chasse.

Art. 7. La qualité de membre se perd:
1) par démission volontaire à adresser par écrit au conseil d'administration,
2) par le non-paiement de la cotisation dans les trois mois de son échéance,
3) par exclusion définitive ou temporaire pour infraction grave aux statuts, à la loi sur les associations, à la législation

sur la chasse ainsi qu'à l'éthique de la chasse, ou pour atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'Association, prononcée
à la majorité des deux tiers des délégués présents à l'Assemblée Générale sur proposition du Comité Central, le membre
concerné entendu préalablement en sa défense. La suspension d'un membre pourra être prononcée par le Comité Central
au vu de la gravité des agissements, en attendant la décision de la prochaine Assemblée Générale.

Art. 7bis. Une demande en réadmission pourra être présentée par le membre exclu en référence à l'article 7. 3) auprès

du Comité Central aux conditions et modalités à définir par le règlement d'ordre intérieur dont mention à l'article 1

er

 .

Titre IV. Cotisations

Art. 9. Les différentes cotisations annuelles, à fixer par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité Central, ne

peuvent être supérieures à cent Euros.

Une ristourne de l'ordre de 10% à valoir sur les cotisations réglées par les membres effectifs et sympathisants au jour

de l'Assemblée Générale de l'Association sera accordée aux sections définies au titre V ci-après en fonction du nombre
de leurs membres visés par les articles 6.1. et 6.2.

Titre V. Sections

Art. 10. L'association est organisée sous forme de sections constituées en associations libres dans lesquelles sont

inscrits ses membres effectifs et sympathisants. Elles ont pour objet de resserrer les liens d'amitié entre ses membres,
d'organiser des activités d'intérêt public en matière de chasse, d'émettre dans le cadre de l'objet social des avis, propo-
sitions et suggestions sur les questions intéressant le plan régional et national, et de les soumettre au Comité Central.

Le nombre de sections est limité à une par canton. Dans les localités ayant plus de dix mille habitants plusieurs sections

peuvent être créées sur avis favorable du Comité Central. Aucune nouvelle section ne peut être constituée avec moins
de 35 membres effectifs. Aucun membre ne peut être affilié à plusieurs sections. Les transferts des membres d'une section
vers une autre ne sont autorisés qu'au courant des mois de juin et juillet moyennant une demande écrite de l'intéressé
à adresser au secrétariat de l'Association.

Art 12. Tous les membres de la section sont admis à assister à l'Assemblée Générale. Seuls les membres effectifs sont

éligibles et ont le droit de vote.

Art. 13. L'Assemblée Générale a pour mission et pour compétence:
a) de prendre connaissance du rapport du comité sur l'activité de la section pendant l'année écoulée,
b) d'élire le comité et de désigner au moins deux vérificateurs de comptes,
c) de désigner le délégué au Comité Central et son suppléant qui devront être membres du comité de la section, ainsi

que les délégués à l'Assemblée Générale de l'Association.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. En cas d'égalité de voix, celle du président ou de son remplaçant

est prépondérante.

Art. 15. Le comité a le devoir de convoquer l'assemblée extraordinaire sur demande du Comité Central avec propo-

sition d'ordre du jour ou lorsque un cinquième des membres effectifs de la section en font la demande par écrit avec
indication de l'ordre du jour. Le comité devra convoquer dans un délai d'un mois.

Art. 16. Chaque section est dirigée et administrée par le comité composé de trois membres au moins et de quinze

membres au plus. Il est élu pour la durée d'un an par l'Assemblée Générale ordinaire. Le président dirige les travaux du
comité et de l'assemblée. Il est désigné par vote secret à la majorité absolue par la même Assemblée Générale parmi les
membres du comité. Si aucun candidat à la présidence n'obtient la majorité absolue, il sera procédé à un deuxième scrutin
où le président sera désigné à la majorité relative. Il est également loisible à l'Assemblée Générale locale d'élire son
président par acclamation. Tous les membres effectifs de la section sont éligibles. Pour le cas où aucune candidature pour
le poste de président n'est présentée, il appartiendra au comité d'en désigner un parmi les membres élus lors de sa
première réunion. Il élira de la même façon un secrétaire et un trésorier. Le comité élu a la faculté de s'adjoindre dans
l'accomplissement de sa tâche un ou plusieurs membres de la section.

32100

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Le comité se réunit au moins tous les deux mois. Le membre du comité absent à trois réunions consécutives

sans excuse peut être appelé à justifier son absence. A défaut de justification il peut être considéré comme démissionnaire.
En remplacement d'un membre du comité démissionnaire, décédé, rayé ou interdit pendant son mandat, le comité peut
par voie de cooptation désigner un membre de la section pour achever ce mandat.

Art. 17bis. En cas de dissolution d'une section, l'actif restant après liquidation et paiement des dettes, sera automati-

quement affecté à la FEDERATION SAINT HUBERT DES CHASSEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Asbl.

Titre VI. Conseil d'administration

Art. 18. L'Association est administrée par un conseil d'administration dénommé «Comité Central». Il est composé des

délégués des sections, à raison d'un délégué par section qui peut se faire remplacer par son suppléant ou, en cas d'em-
pêchement de ce dernier, par son président.

En outre, il comprend douze membres élus par l'Assemblée Générale qui constituent ensemble avec les 3 membres

désignés conformément aux dispositions de l'article 19 alinéa 5, le comité de gestion dénommé «Comité Directeur». A
l'exception des 3 membres ci-avant désignés, le Comité Directeur est renouvelé par au moins un tiers tous les ans. Les
douze membres sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 ans, et leur mandat est renouvelable. Les
membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés, quelque soit
le nombre de votants.

Les candidatures pour le Comité Directeur devront parvenir par envoi recommandé au président au plus tard dix

jours avant l'Assemblée Générale. Pour être éligible au Comité Directeur il faut être membre effectif et ne pas avoir été
exclu de l'Association au courant des 5 années précédant l'année de sa candidature.

D'autre part le Comité Central compte un président élu à la majorité relative par l'Assemblée Générale parmi les

douze membres élus du Comité Directeur et sur proposition de ce dernier. La durée de sa fonction sera égale à la durée
de son mandat au sein du Comité Directeur. En cas d'absence, il sera remplacé par un des vice-présidents sur décision
du Comité Directeur. Le Comité Central gère les affaires de l'Association et la représente dans tous les actes judiciaires
et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou
l'Assemblée Générale l'y autorisent, à un tiers. Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'Assemblée
Générale le compte de l'exercice écoulé.

Lors des votes au sein du Comité Central et en cas d'égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est

prépondérante.

Les membres du Comité Central ne sont responsables que du mandat qui leur est confié. Ils ne contractent en raison

de leur gestion aucune obligation personnelle ou solidaire relative aux engagements de l'Association.

Art .19. Le Comité Directeur assure la gestion journalière et exécute les décisions du Comité Central.
Le Comité Directeur désigne parmi ses douze membres élus 2 vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire

général adjoint ainsi qu'un trésorier général et un trésorier général adjoint.

Le Comité Directeur prend soin de tout ce qui a trait aux intérêts de l'Association. Il peut notamment passer des

contrats, placer tous fonds et opérer des retraits, faire encaisser toutes sommes et donner quittance. L'Association est
engagée par la signature conjointe du président, du secrétaire général et du trésorier général. En cas d'empêchement
d'une des personnes précitées, elle sera remplacée par un des vice-présidents.

Le Comité Central pourra s'adjoindre un juriste et un médecin-vétérinaire, ainsi qu'un représentant aux différentes

organisations internationales. Leur mandat, renouvelable d'année en année, devra être confirmé par l'Assemblée Générale.
Ils sont d'office membres du Comité Directeur avec droit de vote au Comité Directeur et au Comité Central.

Art. 20. Le Comité Directeur se réunit chaque fois que l'intérêt de l'Association l'exige. Ses décisions pour être valables

exigent la présence de la majorité de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres
présents. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 21. Le Comité Directeur pourra créer des groupes de travail ayant pour but l'étude et la réalisation de certains

objets déterminés. Chaque groupe de travail est présidé par un de ses membres. L'exécution des propositions faites par
les groupes de travail est soumise à l'approbation du Comité Central.

Titre VII. Assemblée Générale

Art. 22. L'Assemblée Générale se compose de tous les membres. Seuls les délégués des sections ont le droit de vote

sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après. Le mode de scrutin se trouve plus amplement exposé au règlement
d'ordre intérieur dont mention à l'article 1 

er

 .

L'Assemblée Générale est présidée par le président du Comité Central, ou en cas d'absence ou d'empêchement par

un des vice-présidents.

Art. 23. Les attributions de l'Assemblée Générale comportent le droit:
1) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l'Association en se conformant aux dispositions légales en

la matière, ainsi qu'aux présents statuts,

32101

L

U X E M B O U R G

2) d'élire les membres du Comité Directeur et de les révoquer, le tout sous réserve des dispositions de l'article 18

des présents statuts,

3) d'approuver annuellement les comptes présentés par le Comité Central,
4) de désigner ou de confirmer 3 réviseurs de caisse (voir note à la suite de l'article 26 ci-après),
5) de fixer les cotisations annuelles (voir article 9),
6) d'exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.

Art. 24. L'Assemblée Générale est convoquée chaque année dans le courant du mois de mai et se réunit au siège social

ou en tout autre endroit désigné par le Comité Central.

Une Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée dans les cas prévus par les statuts ou la loi et au cas où un

cinquième des membres effectifs en font la demande par écrit avec indication de l'ordre du jour. De même toute pro-
position signée par un vingtième des membres effectifs doit être portée à l'ordre du jour. Les convocations aux assemblées
doivent mentionner l'ordre du jour. Elles sont faites soit par avis inséré dans le périodique officiel de l'Association ou
dans un ou plusieurs quotidiens luxembourgeois, soit par avis postal, le tout au moins quatorze jours avant la date de
l'assemblée.

Chaque section est représentée au prorata de ses membres d'après le mode de répartition ci-après:
- jusqu'à 60 membres: 6 délégués
- jusqu'à 70 membres: 7 délégués
- jusqu'à 80 membres: 8 délégués
- jusqu'à 90 membres: 9 délégués
- jusqu'à 100 membres: 10 délégués
- au-dessus de 100 membres: 12 délégués
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des votants, le vote par procuration n'étant pas admis,

sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. Les votes ont lieu au scrutin secret, sauf
décision contraire à prendre par l'assemblée à la même majorité par vote à main levée.

Art. 25. Les décisions de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signé par le pré-

sident et le membre du Comité Directeur ayant fait fonction de secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où
tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date au recueil spécial du Mémorial.

Titre VIII. Exercice social - Comptes

Art. 26. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et clôture le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, dans le courant du mois de mai, le bilan et le compte de pertes et profits sont soumis par le Comité

Central à l'Assemblée Générale aux fins d'approbation du rapport et des comptes de l'exercice écoulé. Ce rapport devra
être signé par au moins 2 des réviseurs de caisse désignés par l'Assemblée Générale aux termes des dispositions de
l'article 23. 4) ci-avant.

Titre IX. Modification des statuts

Art. 27. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans les avis de convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres effectifs.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres effectifs présents ou

représentés.

Si les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion

peut être convoquée qui pourra délibérer quelque soit le nombre des membres effectifs présents, mais dans ce cas la
décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

En cas de modification apportée à l'objet de l'Association il sera procédé en conformité de l'article 8 al. 3 de la loi du

21 avril 1928.

Titre XI. Sections existantes

Art. 29. Les sections de la FEDERATION DES CHASSEURS LUXEMBOURGEOIS seront reprises par l'Association.
Celles actuellement constituées qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 10 des présents statuts de-

meurent constituées.

32102

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 4 avril 2011.

<i>Pour la Fédération Saint Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l.
Laurent METZLER
<i>Par mandat

Référence de publication: 2011047736/192.
(110052506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 11.809.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011047182/11.
(110052454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2011.

S.P.D.A.S., Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.P.F. S.A., Société

Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 15.683.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>21 avr. 2011 à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
Référence de publication: 2011044508/1267/16.

Malba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 157.829.

Il est porté à la connaissance de tiers que, par acte sous seing privé daté du 24 février 2011, la société Orangefield

Trust (Luxembourg) S.A., société anonyme, constituée et régie par les lois de Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 28 967, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, a cédé les 100 parts sociales d’une valeur nominale de 125,- EUR chacune qu’elle détenait dans la société
Malba S.à r.l., à la société Roseland S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois de Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 157 831, ayant son siège social au 40,
avenue Monterey.

En conséquence de quoi, la société Roseland S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 157 831, ayant son siège
social au 40, avenue Monterey est maintenant l’associé unique de la société Malba S.à r.l..

Luxembourg, le 24 février 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011028729/21.
(110034510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

32103

L

U X E M B O U R G

Mascagni S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 44.218.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MASCAGNI S.A., société de gestion de patrimoine familial, sont

priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, <i>19 avril 2011 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044514/750/16.

Tenke S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 14.674.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>18 avril 2011 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011044515/1267/15.

Cap Mini S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.165.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
"la mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société OTT&amp;Co S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au

38, Parc d’Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg,

"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "CAP MINI S.A.", ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 131.165,
a été constituée suivant acte reçu le 24 juillet 2007 par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Lu-
xembourg et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 2186, du 3 octobre 2007. Ses statuts
ont été modifiés selon acte dressé en date du 1 

er

 octobre 2007 par-devant Maître Henri HELLINCKX et publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 2622 du 16 novembre 2007.

32104

L

U X E M B O U R G

II.- Que le capital social de la société anonyme "CAP MINI S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à cinq millions trois

cent quarante-neuf mille huit cent euros (EUR 5.349.800), représenté par cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-
dix-huit (53.498) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, intégralement libérées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

"CAP MINI S.A.".

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec effet immédiat.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit des
actifs de la société en tant qu'actionnaire unique.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56972. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2011009884/48.
(110009938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Antrax S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 12.643.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ANTRAX S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, <i>20 avril 2011 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011045155/750/16.

Colways Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.495.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le trente décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société ZED TRADE LLC, ayant son siège social au 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958, County of Sussex,
ici représentée par Monsieur Stéphane SABELLA, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg,

En vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Panama, le 23 décembre 2010.

32105

L

U X E M B O U R G

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:

- La société anonyme ‘‘COLWAYS INVESTMENTS S.A.’’, R.C.S. Luxembourg numéro B 106495, fut constituée par

acte reçu par Maître AndréJean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars
2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 667 du 7 juillet 2005;

- La société a actuellement un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société ‘‘COLWAYS INVEST-

MENTS S.A.’’.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la société ‘‘COLWAYS

INVESTMENTS S.A.’’ avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société ‘‘COLWAYS INVESTMENTS S.A.’’ déclare que l’activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister

à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée.

- la comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels modifiés au 31/12/2009, sur base

des rapports de gestion et rapports de commissaire s’y rapportant et des annexes, ainsi qu'approuver le bilan de clôture
en date de ce jour;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu'à

ce jour;

- le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des

déclarations fiscales y afférentes;

- les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions nominatives qui a été immédia-

tement lacéré. Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société COLWAYS INVESTMENTS S.A.’’.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Sabella et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2011. Relation: LAC/2011/1452. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

<i>Le Receveur (signé): pd Conny SCHUMACHER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011009120/52.

(110010682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2011.

AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 138.617.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 18 février 2011 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 18 février 2011, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la
société, avec valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) seront désormais réparties comme suit:

32106

L

U X E M B O U R G

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

AMP Capital Investors (European Infrastructure N° 3) S.à r.l.
15, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 189

SITE (Euro) N° 2 S.à r.l.
15, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 811

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 000

Luxembourg, le 28 février 2011.

Référence de publication: 2011028509/23.
(110034754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

Mustang ULM 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.230.

Suite à un changement d'adresse de Mr Martin McGuire, Gérant de catégorie B de la Société, il y a lieu de modifier

les données de celui-ci comme suit: Mr Martin McGuire réside dorénavant au 155 Bishopsgate, 8 

th

 Floor, EC2M 3XJ

Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011027940/16.
(110032888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Mustang ULM 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 127.230.

Suite à un changement d'adresse de EAVF Mustang S.à r.l., Associé de la Société, il y a lieu de modifier les données de

celui-ci comme suit: EAVF Mustang S.à r.l. a dorénavant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2011027941/15.
(110032956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Capita Fiduciary S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 117.939.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 décembre 2010 que:
Est nommée, en tant que Réviseur d'Entreprises et jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2012, la société «KPMG

AUDIT», Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et enregistré
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.590, en remplacement de la société
«ERNST &amp; YOUNG».

32107

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 25 février 2011.

*.

Référence de publication: 2011028240/16.
(110034401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

BCI Diamond II Luxco Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.000.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2011, la dénomination de la

rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011028229/12.
(110034440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Association des Parents d'Eleves de Fetschenhof, Cents, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 167, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg F 5.058.

<i>Articles des statuts à modifier (modifications en italique)

Art. 1 

er

 .  L'association est dénommée: ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE FETSCHENHOF, CENTS.

Son siège est au Centre Sociétaire, 167, rue de Trèves, L-2630 LUXEMBOURG.

Art. 2. L'association se propose:
- de regrouper les parents ayant la charge des élèves de l'Ecole fondamentale de Cents,
- de favoriser le dialogue et les rapports entre les parents, le personnel enseignant, te comité d'école, le personnel du

Foyer scolaire, les élèves et les autorités scolaires,

- de proposer à la commune, aux autorités scolaires, au personnel enseignant et au comité d'école toutes suggestions

relativement à l'éducation des enfants, à l'administration et à l'organisation des activités scolaires et périscolaires, ainsi
qu'au développement du plan de réussite scolaire,

- d'aider et d'informer les parents dans leur rôle éducatif.

Art. 3. L'association qui est politiquement idéologiquement et confessionnellement indépendante et neutre, est con-

stituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Peuvent devenir membres actifs, les parents d'élèves ou les personnes ayant la garde d'un ou de plusieurs enfants

de l'Ecole fondamentale de Cents ainsi que toute personne concernée par la vie scolaire ou périscolaire.

Art. 8 bis. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social.

Art. 9. Les membres actifs payent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale sur pro-

position du conseil d'administration. Le montant maximum de la cotisation ne peut dépasser la somme de 50 €.

Art. 10. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 15 au plus, élus

par l'assemblée générale à la majorité simple des voix, parmi les membres actifs.

Leur mandat a une durée d'une année scolaire. Ils sont rééligibles à condition qu'ils aient la charge d'un enfant, élève

d'une classe de l'Ecole fondamentale de Cents.

Entre deux assemblées générales, le conseil d'administration peut coopter des membres à la majorité des voix; ces

membres cooptés n'ont pas le droit de vote.

Art. 11. Ne peuvent être membres du conseil d'administration, les membres du conseil communal et de la commission

scolaire. Les enseignants-parents des classes de l'Ecole fondamentale de Cents ne peuvent avoir plus de 2 représentants
au conseil d'administration. Les enseignants peuvent déléguer 1 représentant avec voix consultative au conseil d'admi-
nistration.

Art. 12. Le conseil d'administration élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président d'un

secrétaire et d'un trésorier. (le vice-président a été supprimé)

Art. 15. Les droits, obligations, pouvoirs et la responsabilité des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14

de la loi du 21 avril 1928.

32108

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Toute convocation à l'assemblée générale ordinaire est portée à la connaissance des membres au moins 15

jours avant la date fixée.

La convocation à l'assemblée générale extraordinaire doit leur parvenir au moins 5 jours francs avant la date fixée.
L'ordre du jour doit être joint à ces convocations.
Tout membre actif a droit au vote et peut se faire représenter par un autre membre actif porteur de sa procuration

écrite. Le nombre de mandats pouvant être détenus par une même personne est limité à deux.

Art. 19. Toute réunion de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant la signature du président et du

secrétaire, ou de leurs remplaçants. Les résolutions à l'assemblée générale sont consignées dans un registre spécial con-
servé au siège de l'association, où tous les associés pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre.

Art. 20 bis. Les ressources de l'association se composent des cotisations des membres actifs, de dons en espèces ou

en nature, de subventions d'organismes publics ou privés et de toute autre provenance légale.

Les ressources peuvent en outre résulter d'activités culturelles ou artistiques et d'autres manifestations publiques ou

privées auxquelles l'association participe ou qu'elle organise.

Référence de publication: 2011009531/52.
(110010009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Perinvest (Lux) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.860.

Suite à la démission de Madame Martine VERMEERSCH de son poste d'administrateur avec effet au 17 janvier 2011

et suite à la nomination d'un nouvel administrateur le 17 février 2011, le Conseil d'Administration se compose dès lors,
comme suit:

- Monsieur Ismael SASSI,
- Monsieur Malcolm JENNINGS,
- Monsieur Frédéric ADAM,
- Monsieur Riccardo MILLICH, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 Février 2011.

<i>Pour PERINVEST (LUX) SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Marc-André BECHET / Martine VERMEERSCH
<i>Sous-Directeur / Directeur

Référence de publication: 2011027952/20.
(110032782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2011.

Dazzle Luxembourg N° 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 113.836.

<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d’administration de la société le 1 

<i>er

<i> février 2011

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration constate la demission de Monsieur André Lutgen à partir du 1 

er

 janvier 2011 et nomme

Madame Isabelle Pairon, née le 28 septembre 1979 à Libramont, Belgique, avec adresse professionnelle au 10, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg en remplacement de l’administrateur démissionnaire jusqu’au 17 janvier 2012.

Pour extrait et traduction sincère et conforme
<i>L’agent domiciliataire

Référence de publication: 2011028260/14.
(110034034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

32109

L

U X E M B O U R G

Delta Lloyd L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.964.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 21 février 2011

Le Conseil d’Administration a approuvé la nomination de Monsieur Wim ANTOONS (résidant professionnellement

à B-1210 BRUXELLES, 23, avenue de l’Astronomie) en qualité de représentant permanent de la société DELTA LLOYD
BANK (ayant son siège social à B-1210 BRUXELLES, 23, avenue de l’Astronomie), en remplacement de Monsieur Geert
CEUPPENS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2011.

Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2011028267/16.
(110034402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

BB Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 85.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BB INVESTISSEMENT S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011028228/11.
(110034478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Beaucette S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 38.156.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2010.

Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311  Luxembourg,  est  nommée  représentant  permanent  pour  la  société  FMS  SERVICES  S.A  en  remplacement  de
Madame Rachel BACKES.

<i>Pour la société
BEAUCETTE S.A.

Référence de publication: 2011028231/13.
(110033868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Ginevra International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.069.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 février 2011

<i>Résolutions:

L'assemblée prend acte de et accepte les démissions de Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant

professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction d'administrateur et de
Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724
Luxembourg de sa fonction d'administrateur et Président du Conseil d'Administration.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec effet

immédiat, Monsieur Stefano De Meo, employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri
à L-1724 Luxembourg.

L'assemblée décide de nommer  comme  nouvel  administrateur, avec effet immédiat, Monsieur  Emmanuel  Briganti,

employé privé, demeurant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

32110

L

U X E M B O U R G

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 30 juin 2011.
L'assemblée constate que la société, Fiduciaire Mevea Sàrl, 4, rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg, qui agit en sa qualité

de commissaire aux comptes de la société, a été dissoute en date du 20 janvier 2011. La société Fiduciaire Mevea Lu-
xembourg  Sàrl,  45-47,  route  d'Arlon,  L  -1140  Luxembourg  (Rcs  Luxembourg  B  156.455)  reprend  le  mandat  de
commissaire aux comptes de la société qui viendra à échéance lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice
clos au 30 juin 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2011028662/30.
(110035067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2011.

EIM Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. EIM Holding Luxembourg S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 62.391.

<i>Extrait sincère et conforme des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration en date du 6 janvier 2011

«........
Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Arpad BUSSON, demeurant au 20 Gilston Road, London SW10 9SR,

United Kingdom, a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour,
conformément à l'article 6 des statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur et de Président, Monsieur Arpad BUSSON aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction

dans les Statuts de la Société.

..........»

Luxembourg, le 6 janvier 2011.

<i>Pour EIM HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2011028280/18.
(110033872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Dazzle Luxembourg N° 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 113.835.

<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d’administration de la société le 1 

<i>er

<i> février 2011

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration constate la demission de Monsieur André Lutgen à partir du 1 

er

 janvier 2011 et nomme

Madame Isabelle Pairon, née le 28 septembre 1979 à Libramont, Belgique, avec adresse professionnelle au 10, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg en remplacement de l’administrateur démissionnaire jusqu’au 17 janvier 2012.

Pour extrait et traduction sincère et conforme
<i>L’agent domiciliataire

Référence de publication: 2011028261/14.
(110034035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Centerra Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 116.497.

Les comptes annuels au 10 Novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32111

L

U X E M B O U R G

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011028234/11.
(110034452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2011.

Feldermaus A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 114.624.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036438/10.
(100200588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Deutsche Finanz A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 108.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036420/10.
(100200583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

DENIBO Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull.

R.C.S. Luxembourg B 121.694.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DENIBO Participations Sàrl
Signature

Référence de publication: 2011036419/11.
(100201131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Car S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 64.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036405/10.
(100200741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Calatayud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 103.101.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011036402/10.
(100200579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

32112


Document Outline

All Car Services S.A.

AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) S.à r.l.

Antrax S.A. - SPF

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

Argentum Fonds

Association des Parents d'Eleves de Fetschenhof, Cents

BB Investissement S.A.

BCI Diamond II Luxco Holdings S.àr.l.

Beaucette S.A.

Belfil S.A.

Calatayud S.A.

Capita Fiduciary S.A.

Cap Mini S.A.

Car S.A

Centerra Luxembourg S.à.r.l.

Centrope Holding S.à r.l.

Colways Investments S.A.

CVI GVF Luxembourg Eight S.à r.l.

CVI GVF Luxembourg Four S.à r.l.

CVI GVF Luxembourg Nine S.à r.l.

Dazzle Luxembourg N° 1 S.A.

Dazzle Luxembourg N° 2 S.A.

Delta Lloyd L

DENIBO Participations S.à r.l.

Deutsche Finanz A.G.

Diapason S.A.

EIM Holding Luxembourg S.A.

EIM Luxembourg S.A.

Fédération Saint Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg asbl

Fédération Saint Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg asbl

Feldermaus A.G.

Ginevra International S.A.

Incoterm Holding S.à r.l.

Incoterm Holding S.à r.l. SPF

ING (L) II

ING (L) Technix

Investdeutschland S.A., SPF

Malba S.à r.l.

Mascagni S.A.

Multiwert Superfund

Multiwert Superfund

Multiwert Superfund

Mustang ULM 1

Mustang ULM 1

NIKKO BANK (Luxembourg) S.A.

Perinvest (Lux) Sicav

Piramid Investment Solutions S.A. SPF

Silverstreet Private Equity Strategies Sicar

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.

SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.

Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.P.F. S.A.

Tenke S.A.

Tuscani S.A.