logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 531

22 mars 2011

SOMMAIRE

5M Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25463

Accero S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25460

Antica Roma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25461

Aurelia Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25464

Bear S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25461

Chaussures Lopes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

25471

Comptoir Luxembourgeois du Bois S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25463

Crebim S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25462

Defat Tanguy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25476

Ezpellor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25471

Family Affair S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25462

FGA (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

25476

Fidji Luxco (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25471

Fidji Luxco (BC) Commandite  . . . . . . . . . .

25471

Fidji Luxembourg (BC)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

25475

Fidji Luxembourg (BC2)  . . . . . . . . . . . . . . . .

25476

Finagouti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25478

Financière de l'Europe Occidentale S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25473

Financière du Stuff S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

25482

Foncière de l'Est S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25478

Fosbele Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

25469

Futureoil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25479

Gambini Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

25478

Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l.,

SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25482

GI-Gasification International (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25483

Grossfeld Immobilière  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25483

Grupo Imoveis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25483

Hanseatic Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

25486

Health Care Investments Holding S.A.  . . .

25487

Helvetia Communication Participations

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25483

Helvetia Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

25484

Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l. . . . .

25484

Hopen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25487

HOPI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25487

ICH Property Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

25460

Immobilien Progress Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25488

Innovative Solutions and Advisory Services

for European Business S.A.  . . . . . . . . . . . .

25482

Invista European Real Estate Finance S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25469

I&P International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25488

Kinvope Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25479

Le Cordon Bleu Investments Holding

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25466

Lux Home Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . .

25481

Master International Holding S.A.  . . . . . . .

25465

Metalpoint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25484

NeXgen Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25473

Next Generation Absolute Return II  . . . . .

25442

Patron Aachen Leasing S. à r. l. . . . . . . . . . .

25467

Patron Aachen Prime Holdings S.à r.l.  . . .

25473

Patron Dieter II S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

25478

Praedia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25487

P&S Machines de Construction S.à r.l.  . . .

25480

R & C Ambiances S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

25474

Sonik S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25467

The Jupiter Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . .

25488

Tomitrois S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25470

Wandpark S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25464

25441

L

U X E M B O U R G

Next Generation Absolute Return II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 159.523.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Decision Analytics Advisory Partners AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered

office at Weinbergstrasse 10, CH-8807 Freienbach, Switzerland, registered with the commercial register of the canton
of Schwyz, Switzerland under number CH-130.3.014.027-7,

here represented by Nicolas Papavoine, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given on 10

March 2011.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as representative of the shareholder, has requested the officiating notary

to enact the following articles of incorporation of a company, which it declares to establish as follows:

1. Art. 1. Name.
1.1 There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares

hereafter created, an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) in the form of
a public limited liability company (société anonyme) under the name "Next Generation Absolute Return II" (the Company).

1.2 Any reference to shareholders of the Company (Shareholders) in the articles of incorporation of the Company

(the Articles) shall be a reference to 1 (one) Shareholder as long as the Company shall have 1 (one) Shareholder.

2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the Grand Duchy of Luxembourg, in the municipality of

Mamer. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the
Company (the Board). It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution
of the general meeting of Shareholders of the Company (the General Meeting) deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.

2.2 The Board shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem

fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political, economic or social or military developments or events

have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances.
Such temporary measure shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

4. Art. 4. Object of the Company.
4.1 The exclusive purpose of the Company is to invest the assets of the Company in transferable securities and other

assets permitted by law in accordance with the principle of risk diversification, within the limits of the investment policies
and restrictions determined by the Board pursuant to article 19 hereof, and with the objective of paying out to Share-
holders the profits resulting from the management of the assets of the Company, either through distributions or through
accumulation of income in the Company.

4.2 The Company may take any measures and execute any transactions that it considers expedient with regard to the

fulfilment and implementation of the object of the Company to the full extent permitted by Part I of the act dated 20
December 2002 concerning undertakings for collective investment as well as subsequent amendments and laws in relation
thereto (the 2002 Act).

5. Art. 5. Share capital, Share classes.
5.1 The capital of the Company will at all times be equal to the total net assets of the Company and will be represented

by fully paid-up shares of no par value.

5.2 The minimum capital, as provided by law, is fixed at EUR 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand

euro) to be reached within a period of six months as from the authorisation of the Company by the Luxembourg super-
visory authority. Upon the decision of the Board, the shares issued in accordance with these Articles may be of more
than one share class. The proceeds from the issue of shares of a share class, less a sales commission (sales charge) (if

25442

L

U X E M B O U R G

any), are invested in transferable securities of all types and other legally permissible assets in accordance with the invest-
ment policy as set forth by the Board and taking into account investment restrictions imposed by law.

5.3 The initial capital is EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) divided into 31 (thirty-one) shares of no par value.
5.4 The Company has an umbrella structure, each compartment corresponding to a distinct part of the assets and

liabilities of the Company (a Sub-fund) as defined in article 133 of the 2002 Act, and that is formed for one or more share
classes of the type described in these Articles. Each Sub-fund will be invested in accordance with the investment objective
and policy applicable to that Sub-fund. The investment objective, policy, as well as the risk profile and other specific
features of each Sub-fund are set forth in the prospectus of the Company (the Prospectus). Each Sub-fund may have its
own funding, share classes, investment policy, capital gains, expenses and losses, distribution policy or other specific
features.

5.5 Within a Sub-fund, the Board may, at any time, decide to issue one or more share classes the assets of which will

be commonly invested but subject to different fee structures, distribution, marketing targets, currency or other specific
features, including special rights as regards the appointment of directors in accordance with article 13 of these Articles.
A separate net asset value per share, which may differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for
each share class.

5.6 The Company may create additional share classes whose features may differ from the existing share classes and

additional Sub-funds whose investment objectives may differ from those of the Sub-funds then existing. Upon creation of
new Sub-funds or share classes, the Prospectus will be updated, if necessary.

5.7 The Company is one single legal entity. However, the rights of the Shareholders and creditors relating to a Sub-

fund or arising from the setting-up, operation and liquidation of a Sub-fund are limited to the assets of that Sub-fund. The
assets of a Sub-fund are exclusively dedicated to the satisfaction of the rights of the Shareholder relating to that Sub-fund
and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the setting-up, operation and liquidation
of that Sub-fund, and there shall be no cross liability between Sub-funds, in derogation of article 2093 of the Luxembourg
Civil Code.

5.8 The Board may create each Sub-fund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the Board may,

at the expiration of the initial period of time, extend the duration of that Sub-fund one or more times. At the expiration
of the duration of a Sub-fund, the Company shall redeem all the shares in the share class(es) of shares of that Sub-fund,
in  accordance  with  article  8  of  these  Articles,  irrespective  of  the  provisions  of  article  23  of  these  Articles.  At  each
extension of the duration of a Sub-fund, the registered Shareholders will be duly notified in writing, by a notice sent to
their address as recorded in the Company's register of Shareholders. The Company will inform the bearer Shareholders
by a notice published in newspapers to be determined by the Board, if these investors and their addresses are not known
to the Company. The Prospectus shall indicate the duration of each Sub-fund and, if applicable, any extension of its
duration.

5.9 For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each share class will, if

not already denominated in euro, be converted into euro. The capital of the Company equals the total of the net assets
of all the share classes.

6. Art. 6. Shares.
6.1 The Board determines whether the Company issues shares in bearer and/or in registered form. If bearer share

certificates are issued, they will be issued in such denominations as the Board prescribes, and they may be imprinted with
a notice that they may not be transferred to any Restricted Person (as defined in article 10 below) or entity established
by or for a Restricted Person. The applicability of the regulations of article 10 does not, however, depend on whether
certificates are imprinted with such a notice.

6.2 All registered shares issued by the Company are entered in the register of Shareholders, which is kept by the

Company or by one or more persons designated by the Company. This register contains the names of the owners of
registered shares, their permanent residence or elected domicile as indicated to the Company, and the number of re-
gistered shares held by them.

6.3 The entry of the Shareholder's name in the register of Shareholders evidences the Shareholder's right of ownership

to such registered shares. The Company decides whether a certificate for such entry is delivered to the Shareholder or
whether the Shareholder receives a written confirmation of its shareholding.

6.4 If bearer shares are issued, registered shares may be converted into bearer shares and bearer shares may be

converted into registered shares at the request of the Shareholder. An exchange of registered shares into bearer shares
will be effected by cancellation of the registered share certificates, if any, after confirming that the transferee is not a
Restricted Person and by issuance of one or more bearer share certificates to replace the cancelled registered share
certificates. An entry will be made in the register of Shareholders to evidence such cancellation. An exchange of bearer
shares into registered shares will be effected by cancellation of the bearer share certificates, and, if applicable, by issuance
of registered share certificates in lieu thereof. An entry will be made in the register of Shareholders to evidence such
issuance. At the discretion of the Board, the costs of any such exchange may be charged to the Shareholder requesting
it.

25443

L

U X E M B O U R G

6.5 Before shares are issued in bearer form and before registered shares are converted into bearer shares, the Com-

pany may require evidence, satisfactory to the Board, that such issuance or exchange will not result in such shares being
held by a Restricted Person.

6.6 The share certificates will be signed by two members of the Board. The signatures may be handwritten, printed

or in the form of a facsimile. One of these signatures may be made by a person duly authorised to do so by the Board;
in this case, it must be handwritten. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may
determine.

6.7 If bearer shares are issued, the transfer of bearer shares will be effected by delivery of the corresponding share

certificates. The transfer of registered shares is effected:

(a) if share certificates have been issued, by delivery of the certificate or certificates representing these shares to the

Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and

(b) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be entered in the register of

Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act on their behalf. Any transfer of registered shares will be entered in the register of Shareholders. This entry will be
signed by one or more members of the Board or by one or more other persons duly authorised to do so by the Board.

6.8 Shareholders entitled to receive registered shares must provide the Company with an address to which all notices

and announcements may be sent. This address will also be entered into the register of Shareholders.

6.9 In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may have a notice to this effect entered

into the register of Shareholders. The Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company,
or at such other address as may be determined by the Company from time to time, until another address is provided to
the Company by that Shareholder. A Shareholder may, at any time, change the address entered in the register of Share-
holders by means of a written notification to the registered office of the Company or to such other address as may be
determined by the Company from time to time.

6.10 Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
6.11 If a Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, damaged

or destroyed, then, at the Shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and
guarantees as the Company may determine, including but not restricted to a bond issued by an insurance company. With
the issuance of the new share certificate, which will be marked as a duplicate, the original share certificate being replaced
shall become void.

6.12 The Company may, at its discretion, charge the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable

expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the
cancellation of the original share certificate, to the Shareholder.

6.13 The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership

of a share or shares is disputed, all persons claiming a right to those shares will appoint one owner to represent those
shares towards the Company. The failure to appoint such an attorney results in the suspension of the exercise of all rights
attached to such shares.

6.14 The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares do not carry voting rights, except

where their number is so that they represent a whole share, but are entitled to participate in the net assets attributable
to the relevant share class on a pro rata basis. Certificates for bearer shares will only be issued for whole shares.

7. Art. 7. Issue of shares.
7.1 The Board is authorised, without limitation, to issue an unlimited number of fully paid up shares at any time without

reserving a preferential right to subscribe for the shares to be issued for the existing Shareholders.

7.2 The Board may impose restrictions on the frequency at which shares of a certain share class are issued; the Board

may, in particular, decide that shares of a particular share class will only be issued during one or more offering periods
or at such other intervals as provided for in the Prospectus.

7.3 Shares in Sub-funds will be issued at the subscription price. The subscription price for shares of a particular share

class of a Sub-fund corresponds to the net asset value per share of the respective share class (see articles 11 and 12, the
Net Asset Value) plus any sales charge, if applicable. Additional fees may be incurred if distributors and paying agents are
involved in a transaction. The relevant subscription price may be rounded up or down to the nearest unit of the currency
in which it is to be paid, as determined by the Board.

7.4 A process determined by the Board and described in the Prospectus shall govern the chronology of the issue of

shares in a Sub-fund.

7.5 The subscription price is payable within a period determined by the Board, which may not exceed 5 (five) business

days from the relevant valuation day, determined as every such day on which the Net Asset Value per share for a given
share class or Sub-fund is calculated (the Valuation Day).

7.6 The Board may confer the authority upon any of its members, any managing director, officer or other duly au-

thorised representative to accept subscription applications, to receive payments for newly issued shares and to deliver
these shares.

25444

L

U X E M B O U R G

7.7 The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of assets, in accordance with

Luxembourg law, in particular in accordance with the obligation to deliver a valuation report from the auditor (réviseur
d'entreprises agréé) of the Company, and provided that such assets are in accordance with the investment objectives and
policies of the relevant Sub-fund.

7.8 Applications for subscription are irrevocable, except -for the duration of such suspension -when the calculation of

the Net Asset Value has been suspended in accordance with article 12 of these Articles.

8. Art. 8. Redemption of shares.
8.1 Any Shareholder may request redemption of all or part of his shares from the Company, pursuant to the conditions

and procedures set forth by the Board in the Prospectus and within the limits provided by law and these Articles.

8.2 Subject to the provisions of article 12 of these Articles, the redemption price per share will be paid within a period

determined by the Board which may not exceed 5 (five) business days from the relevant Valuation Day, as determined
in accordance with the current policy of the Board, provided that any share certificates issued and any other transfer
documents have been received by the Company.

8.3 The redemption price per share for shares of a particular share class of a Subfund corresponds to the Net Asset

Value per share of the respective share class less any redemption fee, if applicable. Additional fees may be incurred if
distributors and paying agents are involved in a transaction. The relevant redemption price may be rounded up or down
to the nearest unit of the currency in which it is to be paid, as determined by the Board.

8.4 A process determined by the Board and described in the Prospectus shall govern the chronology of the redemption

of shares in a Sub-fund.

8.5 If as a result of a redemption application, the number or the value of the shares held by any Shareholder in any

share class falls below the minimum number or value that is then determined by the Board in the Prospectus, the Company
may decide to treat such an application as an application for redemption of all of that Shareholder's shares in the given
share class.

8.6 If, in addition, on a Valuation Day or at some time during a Valuation Day, redemption applications as defined in

this article and conversion applications as defined in article 9 of these Articles exceed a certain level set by the Board in
relation to the shares of a given share class, the Board may resolve to reduce proportionally part or all of the redemption
and conversion applications for a certain time period and in the manner deemed necessary by the Board, in the best
interest of the Company. The portion of the non-proceeded redemptions will then be proceeded by priority on the
Valuation Day following this period, these redemption and conversion applications will be given priority and dealt with
ahead of other applications (but subject always to the foregoing limit).

8.7 The Company may satisfy payment of the redemption price owed to any Shareholder, subject to such Shareholder's

agreement, in specie by allocating assets to the Shareholder from the portfolio set up in connection with the share class
(es) equal in value to the value of the shares to be redeemed (calculated in the manner described in article 11) as of the
Valuation Day or the time of valuation when the redemption price is calculated if the Company determines that such a
transaction would not be detrimental to the best interests of the remaining Shareholders of the relevant Sub-fund. The
nature and type of assets to be transferred in such case will be determined on a fair and reasonable basis and without
prejudicing the interests of the other Shareholders in the given share class or classes, as the case may be. The valuation
used will be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers are borne by
the transferee.

8.8 All redeemed shares may be cancelled.
8.9 All applications for redemption of shares are irrevocable, except - in each case for the duration of the suspension

- in accordance with article 12 of these Articles, when the calculation of the Net Asset Value has been suspended or
when redemption has been suspended as provided for in this article.

9. Art. 9. Conversion of shares.
9.1 A Shareholder may convert shares of a particular share class of a Sub-fund held in whole or in part into shares of

the corresponding share class of another Sub-fund; conversions from shares of one share class of a Sub-fund to shares
of another share class of either the same or a different Sub-fund are also permitted, except otherwise decided by the
Board.

9.2 The Board may make the conversion of shares dependent upon additional conditions.
9.3 A conversion application will be considered as an application to redeem the shares held by the Shareholder and

as  an  application  for  the  simultaneous  acquisition  (issue)  of  the  shares  to  be  acquired.  The  conversion  ratio  will  be
calculated on the basis of the Net Asset Value per share of the respective share class; a conversion fee may be incurred.
Additional fees may be incurred if distributors and paying agents are involved in a transaction. The prices of the conversion
may be rounded up or down to the nearest unit of the currency in which they are to be paid, as determined by the Board.
The Board may determine that balances of less than a reasonable amount to be set by the Board, resulting from conver-
sions will not be paid out to Shareholders.

9.4 As a rule, both the redemption and the acquisition parts of the conversion application should be calculated on the

basis of the values prevailing on one and the same Valuation Day. If there are different order acceptance deadlines for

25445

L

U X E M B O U R G

the Sub-funds in question, the calculation may deviate from this, in particular depending on the sales channel. In particular
either:

(a) the sales part may be calculated in accordance with the general rules on the redemption of shares (which may be

older than the general rules on the issue of shares), while the purchase part would be calculated in accordance with the
general (newer) rules on the issue of shares; or

(b) the sales part is not calculated until a time later in relation to the general rules on share redemption together with

the purchase part calculated in accordance with the newer (in relation to the sales part) rules on the issue of shares.

9.5 Conversions may only be effected if, at the time, both the redemption of the shares to be converted and the issue

of the shares to be acquired are simultaneously possible; there will be no partial execution of the application unless the
possibility of issuing the shares to be acquired ceases after the shares to be converted have been redeemed.

9.6 All applications for the conversion of shares are irrevocable, except -in each case for the duration of the suspension

-in accordance with article 12 of these Articles, when the calculation of the Net Asset Value of the shares to be redeemed
has been suspended or when redemption of the shares to be redeemed has been suspended as provided for in article 8.
If the calculation of the Net Asset Value of the shares to be acquired is suspended after the shares to be converted have
already been redeemed, only the acquisition part of the conversion application can be revoked during this suspension.

9.7 If, in addition, on a Valuation Day or at some time during a Valuation Day redemption applications as defined in

article 8 of these Articles and conversion applications as defined in this article exceed a certain level set by the Board in
relation to the shares issued in the share class, the Board may resolve to reduce proportionally part or all of the re-
demption and conversion applications for a certain period of time and in the manner deemed necessary by the Board, in
the best interest of the Company. The portion of the non-proceeded redemptions will then be proceeded by priority on
the Valuation Day following this period, these redemption and conversion applications will be given priority and dealt
with ahead of other applications (but subject always to the foregoing limit).

9.8 If as a result of a conversion application, the number or the value of the shares held by any Shareholder in any

share class falls below the minimum number or value that is then -if the rights provided for in this sentence are to be
applicable determined by the Board in the Prospectus, the Company may decide to treat the purchase part of the con-
version application as a request for redemption for all of the Shareholder's shares in the given share class; the acquisition
part of the conversion application remains unaffected by any additional redemption of shares.

9.9 Shares that are converted to shares of another share class will be cancelled.

10. Art. 10. Restrictions on ownership of shares.
10.1 The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any individual or legal entity,
(a) if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company;
(b) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg law or other law; or
(c) if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that

it would not have otherwise incurred (such individual or legal entities are to be determined by the Board and are defined
herein as Restricted Persons).

10.2 For such purposes the Company may:
(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares, where such registration or transfer would

result in legal or beneficial ownership of such shares by a Restricted Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders or who seeks to register

the transfer of shares in the register of Shareholders to furnish the Company with any information, supported by affidavit,
which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's
shares rests with a Restricted Person, or whether such registration will result in beneficial ownership of such shares by
a Restricted Person; and

(c) decline to accept the vote of any Restricted Person at the General Meeting; and
(d) instruct a Shareholder to sell his shares and to demonstrate to the Company that this sale was made within 10

(ten) business days of the sending of the relevant notice if the Company determines that a Restricted Person is the sole
beneficial owner or is the beneficial owner together with other persons.

If the investor does not comply with the notice, the Company may, in accordance with the procedure described below,

compulsorily redeem all shares held by such a Shareholder or have this redemption carried out:

(1) The Company provides a second notice (Purchase Notice) to the investor or the owner of the shares to be

redeemed, in accordance with the entry in the register of Shareholders; this Purchase Notice designates the shares to
be redeemed, the procedure under which the redemption price is calculated and the name of the acquirer.

Such Purchase Notice will be sent by registered mail to the last known address or to the address listed in the Company's

books. This Purchase Notice obliges the investor in question to send the share certificate or share certificates that
represent the shares to the Company in accordance with the information in the Purchase Notice.

Immediately upon close of business on the date designated in the Purchase Notice, the Shareholder's ownership of

the shares which are designated in the Purchase Notice ends. For registered shares, the name of the Shareholder is

25446

L

U X E M B O U R G

deleted from the register of Shareholders; for bearer shares, the certificate or certificates that represent the shares are
cancelled.

(2) The price at which these shares are acquired (Sales Price) corresponds to an amount determined on the basis of

the share value of the corresponding share class on a Valuation Day, or at some time during a Valuation Day, as determined
by the Board, less any redemption fees incurred, if applicable. The purchase price is, less any redemption fees incurred,
if applicable, the lesser of the share value calculated before the date of the purchase notification and the share value
calculated on the day immediately following submission of the share certificate(s).

(3) The purchase price will be made available to the previous owner of these shares in the currency determined by

the Board for the payment of the redemption price of the corresponding share class and deposited by the Company at
a bank in Luxembourg or elsewhere (corresponding to the information in the purchase notification) after the final de-
termination of the purchase price following the return of the share certificate(s) as designated in the purchase notification
and their corresponding coupons that are not yet due. After the purchase notification has been provided and in accordance
with the procedure outlined above, the previous owner no longer has any claim related to all or any of these shares and
the previous owner also has no further claim against the Company or the Company's assets in connection with these
shares, with the exception of the right to receive payment of the purchase price without interest from the named bank
after actual delivery of the share certificate(s). All income from redemptions to which Shareholders are entitled in ac-
cordance with the provisions of this paragraph may no longer be claimed and is forfeited as regards the respective share
class(es) unless such income is claimed within a period of five years after the date indicated in the purchase notification.
The Board is authorised to take all necessary steps to return these amounts and to authorise the implementation of
corresponding measures for the Company.

(4) The exercise of the powers by the Company in accordance with this article may in no way be called into question

or declared invalid on the grounds that the ownership of shares was not sufficiently proven or that the actual ownership
of shares did not correspond to the assumptions made by the Company on the date of the Purchase Notice, provided
that the Company exercised the above-named powers in good faith.

10.3 Restricted Persons as defined in these Articles are neither persons who subscribe shares for the duration of their

shareholding in connection with the formation of the Company nor securities dealers who subscribe shares in the Com-
pany for distribution.

11. Art. 11. Calculation of net asset value per share.
11.1 The Company, each Sub-fund and each share class in a Sub-fund have a Net Asset Value determined in accordance

with these Articles. The reference currency of the Company is the euro. The Net Asset Value of each Sub-fund shall be
calculated in the reference currency of the Sub-fund or share class, as it is stipulated in the relevant special section of the
Prospectus, and shall be determined by the administrative agent on each Valuation Day as stipulated in the relevant special
section of the Prospectus, by calculating the aggregate of:

(a) the value of all assets of the Company which are allocated to the relevant Sub-fund in accordance with the provisions

of these Articles; less

(b) all the liabilities of the Company which are allocated to the relevant Sub-fund in accordance with the provisions of

these Articles, and all fees attributable to the relevant Sub-fund, which fees have accrued but are unpaid on the relevant
Valuation Day.

11.2 The Net Asset Value per share shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-fund and shall be

calculated by the administrative agent as at the Valuation Day of the relevant Sub-fund by dividing the Net Asset Value
of the relevant Sub-fund by the number of shares which are in issue on such Valuation Day in the relevant Sub-fund
(including shares in relation to which a Shareholder has requested redemption on such Valuation Day).

11.3 If the Sub-fund has more than one share class in issue, the administrative agent shall calculate the Net Asset Value

for each share class by dividing the portion of the Net Asset Value of the relevant Sub-fund attributable to a particular
share class by the number of shares of such share class in the relevant Sub-fund which are in issue on such Valuation Day
(including shares in relation to which a Shareholder has requested redemption on such Valuation Day).

11.4 The Net Asset Value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the currency in which the Net

Asset Value of the relevant shares are calculated.

11.5 The assets of the Company shall be deemed to include:
(a) all cash on hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not yet

collected);

(c) all securities, shares, bonds, debentures, swaps, options or subscription rights and any other investments and

securities belonging to the Company;

(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided

that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such
as trading ex-dividend or ex-rights;

(e) all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company except to the extent that such interest

is comprised in the principal thereof;

25447

L

U X E M B O U R G

(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(g) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.
11.6 The assets of the Company will be valued as follows:
(a) the value of any cash in hand or on deposit, notes and bills payable on demand and accounts receivable (including

reimbursements of fees and expenses payable by any undertaking for collective investment (UCI) in which the Company
may invest), prepaid expenses and cash dividends declared and interest accrued but not yet collected, shall be deemed
the nominal value of these assets unless it is improbable that it can be paid and collected in full; in which case, the value
will be arrived at after deducting such amounts as the Board may consider appropriate to reflect the true value of these
assets;

(b) securities and money market instruments listed on an official stock exchange or dealt on any other regulated market

will be valued at their last available price in Luxembourg on the Valuation Day and, if the security or money market
instrument is traded on several markets, on the basis of the last known price on the main market of this security. If the
last known price is not representative, valuation will be based on the fair value at which it is expected it can be sold, as
determined with prudence and in good faith by the Board;

(c) unlisted securities and securities or money market instruments not traded on a stock exchange or any other

regulated market as well as listed securities and securities or money market instruments listed on a regulated market for
which no price is available, or securities or money market instruments whose quoted price is, in the opinion of the Board,
not representative of actual market value, will be valued at their last known price in Luxembourg or, in the absence of
such price, on the basis of their probable realisation value, as determined with prudence and in good faith by the Board;

(d) securities or money market instruments denominated in a currency other than the relevant Sub-fund's valuation

currency will be converted at the average exchange rate of the currency concerned applicable on the Valuation Day;

(e) the valuation of investments reaching maturity within a maximum period of 90 days may include straight-line daily

amortisation of the difference between the principal 91 days before maturity and the value at maturity;

(f) the liquidation value of futures, spot, forward or options contracts that are not traded on stock exchanges or other

regulated markets will be equal to their net liquidation value determined in accordance with the policies established by
the Board on a basis consistently applied to each type of contract. The liquidation value of futures, spot, forward or
options contracts traded on stock exchanges or other regulated markets will be based on the latest available price for
these contracts on the stock exchanges and regulated markets on which these options, spot, forward or futures contracts
are traded by the Company; provided that if an options or futures contract cannot be liquidated on the date on which
the net assets are valued, the basis for determining the liquidation value of said contract shall be determined by the Board
in a fair and reasonable manner;

(g) swaps are valued at their fair value based on the last known closing price of the underlying security;
(h) UCIs are valued on the basis of their last available net asset value in Luxembourg. As indicated below, this net asset

value may be adjusted by applying a recognised index so as to reflect market changes since the last valuation;

(i) liquid assets and money market instruments are valued at their nominal value plus accrued interest, or on the basis

of amortised costs;

(j) any other securities and assets are valued in accordance with the procedures put in place by the Board and with

the help of specialist valuers, as the case may be, who will be instructed by the Board to carry out the said valuations.

11.7 In the context of Sub-funds which invest in other UCIs, valuation of their assets may be complex in some cir-

cumstances and the administrative agents of such UCIs may be late or delay communicating the relevant net asset values.
Consequently, the administrative agent, under the responsibility of the Board, may estimate the assets of the relevant
Sub-funds as of the Valuation Day considering, among other things, the last valuation of these assets, market changes and
any other information received from the relevant UCIs. In this case, the Net Asset Value estimated for the Sub-funds
concerned may be different from the value that would have been calculated on the said Valuation Day using the official
net asset values calculated by the administrative agents of the UCIs in which the Sub-fund invested. Nevertheless, the
Net Asset Value calculated using this method shall be considered as final and applicable despite any future divergence.

11.8 For the purpose of determining the value of the Company's assets, the administrative agent, having due regards

to the standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the Net Asset Value, completely and
exclusively rely, unless there is manifest error or negligence on its part, upon the valuations provided either (i) by the
Board, (ii) by various pricing sources available on the market such as pricing agencies (i.e., Bloomberg, Reuters, etc.) or
administrators of underlying UCIs, (iii) by prime brokers and brokers, or (iv) by (a) specialist(s) duly authorised to that
effect by the Board. In particular, for the valuation of any assets for which market quotations or fair market values are
not publicly available (including but not limited to non listed structured or credit-related instruments and other illiquid
assets), the administrative agent will exclusively rely on valuations provided either by the Board or by third party pricing
sources appointed by the Board under its responsibility or other official pricing sources like UCIs' administrators and
others like Telekurs, Bloomberg, Reuters and will not check the correctness and accuracy of the valuations so provided.
If the Board gives instructions to the administrative agent to use a specific pricing source, the Board undertakes to make
its own prior due diligence on such agent as far as its competence, reputation, professionalism are concerned so as to

25448

L

U X E M B O U R G

ensure that the prices which will be given to the administrative agent are reliable and the administrative agent will not,
and shall not be required to, carry out any additional due diligence or testing on any such pricing source.

11.9 If one or more sources of quotation is not able to provide relevant valuations to the administrative agent, the

latter is authorised to not calculate the Net Asset Value and, consequently, not to determine subscription, redemption
and conversion prices. The administrative agent shall immediately inform the Board if such a situation arises. If necessary,
the Board may decide to suspend the calculation of the Net Asset Value in accordance with the procedures described in
the Prospectus.

11.10 The liabilities of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) all administrative expenses due or accrued including but not limited to the costs of its constitution and registration

with regulatory authorities, as well as legal, audit, management, custodial, paying agency and corporate and central ad-
ministration agency fees and expenses, the costs of legal publications, prospectuses, financial reports and other documents
made available to Shareholders, translation expenses and generally any other expenses arising from the administration of
the Company;

(c) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and
which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;

(d) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves

authorised and approved by the Board; and

(e) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.
11.11 The allocation of assets and liabilities of the Company between Sub-funds (and within each Sub-fund between

the different share classes) shall be effected so that:

(a) the subscription price received by the Company on the issue of shares, and reductions in the value of the Company

as a consequence of the redemption of shares, shall be attributed to the Sub-fund (and within that Sub-fund, the share
class) to which the relevant shares belong;

(b) assets acquired by the Company upon the investment of the subscription proceeds and income and capital appre-

ciation in relation to such investments which relate to a specific Sub-fund (and within a Sub-fund, to a specific share class)
shall be attributed to such Sub-fund (or share class in the Sub-fund);

(c) assets disposed of by the Company as a consequence of the redemption of shares and liabilities, expenses and

capital depreciation relating to investments made by the Company and other operations of the Company, which relate
to a specific Sub-fund (and within a Sub-fund, to a specific share class) shall be attributed to such Sub-fund (or share class
in the Sub-fund);

(d) where the use of foreign exchange transactions, instruments or financial techniques relates to a specific Sub-fund

(and within a Sub-fund, to a specific share class) the consequences of their use shall be attributed to such Sub-fund (or
share class in the Sub-fund);

(e) where assets, income, capital appreciations, liabilities, expenses, capital depreciations or the use of foreign exchange

transactions, instruments or techniques relate to more than one Sub-fund (or within a Sub-fund, to more than one share
class), they shall be attributed to such Sub-funds (or share classes, as the case may be) in proportion to the extent to
which they are attributable to each such Sub-fund (or each such share class);

(f) where assets, income, capital appreciations, liabilities, expenses, capital depreciations or the use of foreign exchange

transactions, instruments or techniques cannot be attributed to a particular Sub-fund they shall be divided equally between
all Sub-funds or, in so far as is justified by the amounts, shall be attributed in proportion to the relative Net Asset Value
of the Sub-funds (or share classes in the Sub-fund) if the Company, in its sole discretion, determines that this is the most
appropriate method of attribution;

(g) upon payment of dividends to the Shareholders of a Sub-fund (and within a Sub-fund, to a specific share class) the

net assets of this Sub-fund (or share class in the Sub-fund) are reduced by the amount of such dividend.

11.12 For the purpose of valuation under this article:
(a) shares of the relevant Sub-fund in respect of which the Board has issued a redemption notice or in respect of which

a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account on the relevant Valuation
Day, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(b) all investments, cash balances and other assets of any Sub-fund expressed in currencies other than the currency of

denomination in which the Net Asset Value of the relevant Sub-fund is calculated, shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of shares;

(c) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Day, to the extent practicable; and

(d) where the Board is of the view that any conversion or redemption which is to be effected will have the result of

requiring significant sales of assets in order to provide the required liquidity, the value may, at the discretion of the Board
be effected at the actual bid prices of the underlying assets and not the last available prices. Similarly, should any sub-

25449

L

U X E M B O U R G

scription or conversion of shares result in a significant purchase of assets in the Company, the valuation may be done at
the actual offer price of the underlying assets and not the last available price.

12. Art. 12. Frequency and temporary suspension of the calculation of share value and of the issue, redemption and

conversion of shares.

12.1 The Net Asset Value of shares issued by the Company shall be determined with respect to the shares relating to

each Sub-fund by the Company as set forth in the Prospectus, but no instance less than twice monthly, as the Board may
decide.

12.2 The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net Asset Value of shares

of any Sub-fund or share class, the issue of the shares of such Sub-fund or share class to subscribers and the redemption
of the shares of such Sub-fund or share class from its Shareholders as well as conversions of shares of any share class in
a Sub-fund:

(a) when one or more stock exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the

assets of the Sub-fund or of the relevant share class, or when one or more foreign exchange markets in the currency in
which a substantial portion of the assets of the Sub-fund or of the relevant share class are denominated, are closed
otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted or suspended;

(b) when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility

and the control of the Board, disposal of the assets of the Sub-fund or of the relevant share class is not reasonably or
normally practicable without being seriously detrimental to the interests of the Shareholders;

(c) in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the

Sub-fund or of the relevant share class or if, for any reason beyond the responsibility of the Board, the value of any asset
of the Sub-fund or of the relevant share class may not be determined as rapidly and accurately as required;

(d) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf

of the Company are rendered impracticable or if purchases and sales of the Sub-fund's assets cannot be effected at normal
rates of exchange; and

(e) when the Board so decides, provided that all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant laws

and regulations are applied (i) upon publication of a notice convening a General Meeting of Shareholders of the Company
or of a Sub-fund for the purpose of deciding on the liquidation, dissolution, the merger or absorption of the Company
or the relevant Sub-fund and (ii) when the Board is empowered to decide on this matter, upon their decision to liquidate,
dissolve, merge or absorb the relevant Sub-fund.

12.3 Any such suspension may be notified by the Company in such manner as it may deem appropriate to the persons

likely  to  be  affected  thereby.  The  Company  shall  notify  Shareholders  requesting  redemption  of  their  shares  of  such
suspension.

13. Art. 13. Board of directors.
13.1 The Company shall be managed by a Board of at least 7 (seven) members. The directors of the Company, either

Shareholders or not, are appointed for a term which may not exceed 6 (six) years by a General Meeting and shall be
eligible for re-appointment. The Board will be elected by the Shareholders at the General Meeting at which the number
of directors, their remuneration and term of office will also be determined.

13.2 The Board will issue, in at least one Sub-fund, a class S1 share (the Class S1 Share(s)) and a class S2 share (the

Class S2 Share(s)) (and together the Class S Shares). The holders of Class S1 and Class S2 Shares will be entitled to
propose to the General Meeting a list containing the names of candidates for the position of director of the Company
out of each which a certain number of directors must be chosen.

13.3 The Board must be composed at all times of three (3) directors (including the chairman of the Board) appointed

out of the list proposed by the holder(s) of Class S1 Share(s) and four (4) directors appointed out of the list proposed
by the holder(s) of Class S2 Share(s).

13.4 The directors chosen out of the list proposed by the holder(s) of Class S1 Share(s) are referred to as Class S1

Directors, the directors chosen out of the list proposed by the holder(s) of Class S2 Share(s) are referred to as Class S2
Directors (and together the Class S Directors).

13.5 Each list of candidates proposed by the holders of Class S Shares shall indicate a number of candidates equal to

at least twice the number of directors to be appointed as Class S1 Director and Class S2 Director.

13.6 When a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate

a permanent representative in order to accomplish this task in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability as if he was performing this
task for his own account and on his own behalf, without prejudice to the joint liability of him and the Legal Entity. The
Legal Entity cannot revoke the Representative unless it simultaneously appoints a new permanent representative.

13.7 Members of the Board are selected by a majority vote of the shares present or represented at the relevant General

Meeting. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a
blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

25450

L

U X E M B O U R G

13.8 Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the

General  Meeting,  provided  however  that  if  a  Class  S  Director  is  removed,  the  remaining  directors  must  call  for  an
extraordinary General Meeting without delay in order for a new Class S Director to be appointed in his/her place in
accordance with the requirements of this article 13. The new Class S Director appointed by the General Meeting will be
chosen from the candidates on the list presented by the relevant Class S Share(s).

13.9 In the event of a vacancy in the office of a member of the Board, the remaining directors may temporarily fill such

vacancy; the Shareholders will take a final decision regarding such nomination at their next General Meeting. For the
avoidance of doubt, a vacancy in the office of a Class S Director must be filled with a new Class S Director out of a list
proposed by the relevant holder(s) of Class S1 or Class S2 Share(s).

14. Art. 14. Board meetings.
14.1 The Board will elect a chairman out of the Class S1 Directors. It may further choose a secretary, either director

or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board. The Board shall meet upon call by
the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

14.2 The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board. In his absence, the General

Meeting or, as the case may be, the Board will appoint another Class S1 Director as chairman pro tempore by vote of
the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

14.3 Meetings of the Board are convened by the chairman or by any other two members of the Board.
14.4 The directors will be convened separately to each meeting of the Board. Written notice of any meeting of the

Board will be given to all directors at least 24 hours prior to the date set for such meeting, except in emergencies, in
which case the notice of meeting may be waived. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex,
telefax or other similar means of communication. No separate invitation is necessary for meetings whose date and location
have been determined by a prior resolution of the Board.

14.5 The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
14.6 The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
14.7 Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or telegram or telex

another director as his proxy.

14.8 A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors

are present at the meeting.

14.9 Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in
Luxembourg.

14.10 The Board can validly debate and take decisions only if the majority of its members (and at least one Class S1

Director and one Class S2 Director) is present or duly represented.

14.11 All resolutions of the Board shall require a majority of the directors present or represented at the Board meeting

and at least the positive votes of a Class S1 Director and a Class S2 Director, in which the quorum requirements set
forth in the present article are met. In case of a tied vote the chairman will have a casting vote.

14.12 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall

consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an
electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date
of the last signature.

14.13 The decisions of the Board will be recorded in minutes to be kept at the registered office of the Company and

signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

14.14 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by any two other directors.

14.15 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal
interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director
who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

14.16 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual general meeting of the Shareholders of the Company (the Annual General Meeting).

25451

L

U X E M B O U R G

14.17 The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary

course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

14.18 If, due to a conflict of interest, a quorum of the Board cannot be reached and only 2 (two) directors are in

opposition to vote, resolutions shall be passed by application of the article 14.2 and the article 14.10.

15. Art. 15. Powers of the board of directors.
15.1 The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the

Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in article 19 of these Articles, to the extent
that such powers are not expressly reserved by law or by these Articles to the General Meeting.

15.2 All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the General Meeting lie in the competence of

the Board.

16. Art. 16. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of a Class

S1 Director and a Class S2 Director or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been
delegated by the Board, but only within the limits of such power.

17. Art. 17. Delegation of powers.
17.1 The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers

to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to members of the Board or physical persons or
corporate entities which need not be members of the Board, acting under the supervision of the Board. The Board may
also delegate certain of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such persons (whether a
member of the Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are members
of the Board and that no meeting of the committee shall be necessary for the purpose of exercising any of its powers,
authorities or discretions unless a majority of those persons present are members of the Board.

17.2 The Board may also confer special powers of attorney.

18. Art. 18. Indemnification.
18.1 The Company may indemnify any director or officer, and his or her heirs, executors and administrators against

expenses reasonably incurred by him or her in connection with any action, suit proceeding to which he or she may be
made a party by reason of his or her being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he or she is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as which he or she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or wilful misconduct.

18.2 In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by

the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he or she may be entitled.

19. Art. 19. Investment policies and Restrictions.
19.1 The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Com-

pany's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the General Meeting may be exercised
by the Board.

19.2 The Board has, in particular, the power to determine the corporate policy. The course of conduct of the mana-

gement and business affairs of the Company shall fall under such investment restrictions as may be imposed by the 2002
Act or be laid down in the laws and regulations of those countries where the shares are offered for sale to the public or
as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board and as shall be described in any prospectus relating to
the offer of shares.

19.3 In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the Company to comply

with the following general investment restrictions.

19.4 The management of the assets of the Sub-funds will be undertaken within the following investment restrictions.

A Sub-fund may be subject to different or additional investment restrictions set out in the relevant special section of the
Prospectus.

Eligible investments
19.5 The Company's investments may consist solely of:
(a) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in an European

Union (EU) Member State;

(b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in an EU Member State;
(c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt in

on another market in any country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;

(d) new issues of transferable securities and money market instruments, provided that:
(i) the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on any stock

exchange or another regulated market referred to in subparagraphs (a), (b) and (c);

25452

L

U X E M B O U R G

(ii) such admission is secured within a year of issue;
(e) units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and/or other UCIs within the

meaning of the first and second indent of Article 1 (2) of the UCITS directive, whether situated in an EU Member State
or not, provided that no more than 10% of the net assets of the UCITS or other UCI whose acquisition is contemplated,
can, according to their fund rules or constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other
UCIs;

(f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing

in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in an EU Member State or, if the
registered office of the credit institution is situated in a non-EU Member State, provided that it is subject to prudential
rules considered by the Luxembourg supervisory authority as equivalent to those laid down in EU law;

(g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market re-

ferred to in subparagraphs (a), (b) and (c); and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (each an OTC
Derivative), provided that:

(i) the underlying consists of instruments covered by this article 19.5, financial indices, interest rates, foreign exchange

rates or currencies, in which a Sub-fund may invest according to its investment objectives as stated in the Prospectus;

(ii) the counterparties to OTC Derivative transactions are first class institutions;
(iii) the OTC Derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or

closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company's initiative;

(h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market if the issue or issuer of such instruments

is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:

(i) issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of an EU Member State, the European

Central Bank, the EU or the European Investment Bank, a non-EU Member State or, in the case of a federal State, by one
of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more EU Member States
belong, or

(ii) issued by an undertaking, any securities of which are listed on a stock exchange or dealt in on regulated markets

referred to in subparagraphs (a), (b) or (c), or

(iii) issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by

EU law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the Luxembourg
supervisory authority to be at least as stringent as those laid down by EU law, or

(iv) issued by other bodies belonging to the categories approved by the Luxembourg supervisory authority provided

that investments in such instruments are subject to investor protection rules equivalent to that laid down in the first, the
second or the third indent and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR
10 million and which (i) represents and publishes its annual accounts in accordance with Directive 78/660/EEC, (ii) is an
entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing
of the group or (iii) is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking
liquidity line.

19.6 However, each Sub-fund may:
(i) invest up to 10% of its net assets in transferable securities and money market instruments other than those referred

to under article 19.5 above; and

(ii) hold liquid assets on an ancillary basis.
Risk diversification
19.7 In accordance with the principle of risk diversification, the Company is not permitted to invest more than 10%

of the net assets of a Sub-fund in transferable securities or money market instruments of one and the same issuer. The
total value of the transferable securities and money market instruments in each issuer in which more than 5% of the net
assets are invested, must not exceed 40% of the value of the net assets of the respective Sub-fund. This limitation does
not apply to deposits and OTC Derivative transactions made with financial institutions subject to prudential supervision.

19.8 The Company is not permitted to invest more than 20% of the net assets of a Sub-fund in deposits made with

the same body.

19.9 The risk exposure to a counterparty of a Sub-fund in an OTC Derivative transaction may not exceed:
(i) 10% of its net assets when the counterparty is a credit institution referred to in article 19.5 (f); or
(ii) 5% of its net assets, in other cases.
19.10 Notwithstanding the individual limits laid down in articles 19.7, 19.8 and 19.9, a Sub-fund may not combine:
(i) investments in transferable securities or money market instruments issued by,
(ii) deposits made with, and/or
(iii) exposures arising from OTC Derivative transactions undertaken with a single body,
in excess of 20% of its net assets.

25453

L

U X E M B O U R G

19.11 The 10% limit set forth in article 19.7 can be raised to a maximum of 25% in case of certain bonds issued by

credit institutions which have their registered office in an EU Member State and are subject by law, in that particular
country, to specific public supervision designed to ensure the protection of bondholders. In particular the funds which
originate from the issue of these bonds are to be invested, in accordance with the law, in assets which sufficiently cover
the financial obligations resulting from the issue throughout the entire life of the bonds and which are allocated prefe-
rentially to the payment of principal and interest in the event of the issuer's failure. Furthermore, if investments by a Sub-
fund in such bonds with one and the same issuer represent more than 5% of the net assets, the total value of these
investments may not exceed 80% of the net assets of the corresponding Sub-fund.

19.12 The 10% limit set forth in article 19.7 can be raised to a maximum of 35% for transferable securities and money

market instruments that are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another Organisation
for Economic Cooperation and Development (OECD) Member State, or by public international organisations of which
one or more EU Member States are members.

19.13 Transferable securities and money market instruments which fall under the special ruling given in articles 19.11

and 19.12 are not counted when calculating the 40% risk diversification ceiling mentioned in article 19.7.

19.14 The limits provided for in articles 19.7 to 19.12 may not be combined, and thus investments in transferable

securities or money market instruments issued by the same body or in deposits or derivative instruments with this body
shall under no circumstances exceed in total 35% of the net assets of a Sub-fund.

19.15 Companies which are included in the same group for the purposes of consolidated accounts, as defined in

accordance with Directive 83/349/EEC or in accordance with recognised international accounting rules, are regarded as
a single body for the purpose of calculating the limits contained in this section "Risk diversification".

19.16 A Sub-fund may invest, on a cumulative basis, up to 20% of its net assets in transferable securities and money

market instruments of the same group.

Exceptions which can be made
19.17 Without prejudice to the limits laid down in the section “Investment Prohibitions” below, the limits laid down

in articles 19.7 to 19.16 are raised to a maximum of 20% for investment in shares and/or bonds issued by the same body
if, according to the relevant special section of the Prospectus, the investment objective and policy of that Sub-fund is to
replicate the composition of a certain stock or debt securities index which is recognised by the Luxembourg supervisory
authority, on the following basis:

(i) its composition is sufficiently diversified,
(ii) the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers,
(iii) it is published in an appropriate manner.
The above 20% limit may be raised to a maximum of 35%, but only in respect of a single body, where that proves to

be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable securities or
money market instruments are highly dominant.

19.18 The Company is authorised, in accordance with the principle of risk diversification, to invest up to 100% of the

net assets of a Sub-fund in transferable securities and money market instruments from various offerings that are issued
or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international
organisations in which one or more EU Member States are members. These securities must be divided into at least six
different issues, with securities from one and the same issue not exceeding 30% of the total net assets of a Sub-fund.

Investment in UCITS and/or other UCIs
19.19 A Sub-fund may acquire the units of UCITS and/or other UCIs referred to in article 19.5(e), provided that no

more than 20% of its net assets are invested in units of a single UCITS or other UCI. If a UCITS or other UCI has multiple
compartments (within the meaning of article 133 of the 2002 Act) and the assets of a compartment may only be used to
satisfy the rights of the investors relating to that compartment and the rights of those creditors whose claims have arisen
in connection with the setting-up, operation and liquidation of that compartment, each compartment is considered as a
separate issuer for the purposes of applying the above limit.

19.20 Investments made in units of UCIs other than UCITS may not exceed, in aggregate, 30% of the net assets of the

Sub-fund.

19.21 When a Sub-fund has acquired units of UCITS and/or other UCIs, the assets of the respective UCITS or other

UCIs do not have to be combined for the purposes of the limits laid down in articles 19.7 to 19.16.

19.22 When a Sub-fund invests in the units of UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation,

by the same management company or by any other company with which the management company is linked by common
management or control, or by a substantial direct or indirect holding, (regarded as more than 10% of the voting rights
or share capital), that management company or other company may not charge subscription, conversion or redemption
fees on account of the Sub-fund's investment in the units of such UCITS and/or other UCIs.

19.23 If a Sub-fund invests a substantial proportion of its assets in other UCITS and/or other UCIs, the maximum level

of the management fees that may be charged both to the Sub-fund itself and to the other UCITS and/or other UCIs in
which it intends to invest, shall be disclosed in the relevant special section of the Prospectus.

25454

L

U X E M B O U R G

19.24 In the annual report of the Company it shall be indicated for each Sub-fund the maximum proportion of mana-

gement fees charged both to the Sub-fund and to the UCITS and/or other UCIs in which the Sub-fund invests.

Tolerances and multiple compartment issuers
19.25 If, because of reasons beyond the control of the Company or the exercising of subscription rights, the limits

mentioned in this article 19 are exceeded, the Company must have as a priority objective in its sale transactions to reduce
these positions within the prescribed limits, taking into account the best interests of the Shareholders.

19.26 Provided that they continue to observe the principles of risk diversification, newly established Sub-funds may

deviate from the limits mentioned under articles 19.7 to 19.24 above for a period of six months following the date of
their initial launch.

19.27 If an issuer of eligible investment is a legal entity with multiple compartments and the assets of a compartment

may only be used to satisfy the rights of the investors relating to that compartment and the rights of those creditors
whose claims have arisen in connection with the setting-up, operation and liquidation of that compartment, each com-
partment is considered as a separate issuer for the purposes of applying the limits set forth under articles 19.7 to 19.17
and 19.19 to 19.24.

Investment prohibitions
The Company is prohibited from:
19.28 acquiring equities with voting rights that would enable the Company to exert a significant influence on the

management of the issuer in question;

19.29 acquiring more than
(i) 10% of the non-voting equities of one and the same issuer,
(ii) 10% of the debt securities issued by one and the same issuer,
(iii) 10% of the money market instruments issued by one and the same issuer, or
(iv) 25% of the units of one and the same UCITS and/or other UCI.
The limits laid down in paragraphs (ii), (iii) and (iv) may be disregarded at the time of acquisition if at that time the

gross amount of the debt securities or of the money market instruments, or the net amount of the securities in issue,
cannot be calculated.

Transferable securities and money market instruments which, in accordance with article 48, paragraph 3 of the 2002

Act are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another Member State of the OECD or
which are issued by public international organisations of which one or more EU Member States are members are exempted
from the above limits.

19.30 selling transferable securities, money market instruments and other eligible investments mentioned under sub-

paragraphs e), g) and h) of article 19.5 short;

19.31 acquiring precious metals or related certificates;
19.32 investing in real estate and purchasing or selling commodities or commodities contracts;
19.33 borrowing on behalf of a particular Sub-fund, unless:
(i) the borrowing is in the form of a back-to-back loan for the purchase of foreign currency;
(ii) the loan is only temporary and does not exceed 10% of the net assets of the Sub-fund in question;
19.34 granting credits or acting as guarantor for third parties. This limitation does not refer to the purchase of trans-

ferable securities, money market instruments and other eligible investments mentioned under sub-paragraphs (e), (g) and
(h) of article 19.5 that are not fully paid up.

Risk management and limits with regard to derivative instruments
19.35 The Company must employ (i) a risk-management process which enables it to monitor and measure at any time

the risk of the positions and their contribution to the overall risk profile of the portfolio and (ii) a process for accurate
and independent assessment of the value of OTC Derivatives.

19.36 Unless otherwise provided for in respect of a specific Sub-fund in the Prospectus, each Sub-fund shall ensure

that its global exposure relating to derivative instruments does not exceed the total net value of its portfolio.

19.37 The exposure is calculated taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk,

future market movements and the time available to liquidate the positions. This shall also apply to the following articles.

19.38 A Sub-fund may invest, as a part of its investment policy, in financial derivative instruments provided that the

exposure to the underlying assets does not exceed in aggregate the investment limits laid down in articles 19.7 to 19.16.
Under no circumstances shall these operations cause a Sub-fund to diverge from its investment objectives as laid down
in the Prospectus and the relevant special section of the Prospectus.

19.39 When a transferable security or money market instrument embeds a derivative, the latter must be taken into

account when complying with the requirements of this article 19.

19.40 Co-management and pooling
The Board may, in the best interest of the Company and as described in more detail in the Prospectus, decide that all

or part of the assets of the Company or of a Sub-fund will be jointly managed on a separate basis with other assets of

25455

L

U X E M B O U R G

other Shareholders, including other UCI and/or their sub-fund or that all or part of the assets of two or more Sub-funds
will be managed jointly on a separate basis or in a pool.

19.41 Indirect investments
Investments of any Sub-fund may be directly or indirectly made through whollyowned subsidiaries of the Company, in

accordance with the respective decision made by the Board and as described in detail in the Prospectus. References to
assets and investments in these Articles correspond either to investments made directly or to assets held directly for the
Company or to such investments or assets that are made or held indirectly for the Company by the above-mentioned
subsidiary.

19.42 Techniques and instruments
The Company is authorised, as determined by the Board and in accordance with applicable laws and regulations, to

use techniques and instruments that deal with securities and money-market instruments and other assets permitted by
law, provided that that such techniques and instruments are used for hedging or efficient portfolio management purposes.

20. Art. 20. Auditor.
20.1 The accounting data reported in the annual report of the Company will be examined by an auditor (réviseur

d'entreprises agréé) appointed by the General Meeting and remunerated by the Company.

20.2 The auditor fulfils all duties prescribed by the 2002 Act.

21. Art. 21. General meeting of shareholders of the Company.
21.1 The General Meeting represents, when properly constituted, the entire body of Shareholders of the Company.

Its resolutions are binding upon all the Shareholders, regardless of the share class held by them. It has the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

21.2 The Annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in the Grand Duchy of Luxem-

bourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered
office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Wednesday in the month of April of each
year at 11.00 a.m., Luxembourg time. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the Annual General
Meeting shall be held on the next following business day.

21.3 The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional

circumstances so require.

21.4 Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective

convening notices of the meeting.

21.5 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

21.6 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General

Meetings, unless otherwise provided herein.

21.7 The Board may convene a General Meeting. It shall be obliged to convene it so that it is held within a period of

one month, if Shareholders representing onetenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda.
One or more Shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or
more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days
before the relevant General Meeting.

21.8 Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and be made in accordance with the

requirements of the act of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the 1915 Act).

21.9 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will

be  passed  by  a  simple  majority  of  those  present  or  represented  and  voting.  Votes  relating  to  shares  for  which  the
shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into
account to calculate the majority.

21.10 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted in a General Meeting where at least one half of

the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may
be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied,
a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at
fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg
newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant
General Meeting. Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from voting,
cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

25456

L

U X E M B O U R G

21.11 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a Shareholder

as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under
Luxembourg law) is affixed.

21.12 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

21.13 The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General

Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant
Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set
forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda.
In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours
before the relevant General Meeting.

21.14 The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders in order to attend any

meeting of Shareholders.

21.15 The business transacted at any meeting of the Shareholders will be limited to the matters on the agenda and

transactions related to these matters.

21.16 Each share of any share class is entitled to one vote, in accordance with Luxembourg law and these Articles. A

Shareholder may act at any meeting of Shareholders through a written proxy to another person, who need not be a
Shareholder and who may be a member of the Board.

22. Art. 22. General meetings of shareholders in a sub-fund or in a share class.
22.1 The Shareholders of the share classes issued in a Sub-fund may hold, at any time, General Meetings to decide on

any matters which relate exclusively to that Sub-fund.

22.2 In addition, the Shareholders of any share class may hold, at any time, General Meetings for any matters which

are specific to that share class.

22.3 The provisions of article 21 of these Articles apply to such General Meetings, unless the context otherwise

requires.

22.4 Each share is entitled to one vote in accordance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act

either in person or through a written proxy to another person who need not be a Shareholder and may be a director.

22.5 Unless otherwise provided for by law or in these Articles, the resolutions of the General Meeting of Shareholders

of a Sub-fund or of a share class are passed by a simple majority vote of the Shareholders present or represented.

23. Art. 23. Liquidation or merger of sub-funds or share classes.
23.1 In the event that for any reason the value of the total net assets in any Subfund or the value of the net assets of

any share class within a Sub-fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the Board to be the
minimum level for such Sub-fund, or such share class, to be operated in an economically efficient manner or in case of a
substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the
Board may decide to redeem all the shares of the relevant share class or classes at the Net Asset Value per share (taking
into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Day at which
such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to Shareholders of the relevant share class or classes
prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the
redemption operations: registered holders shall be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of,
or to keep equal treatment between the Shareholders, the Shareholders of the Sub-fund or of the share class concerned
may continue to request redemption of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of
investments and realisation expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

23.2 Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, the General Meeting of any one

or all share classes issued in any Sub-fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board,
to redeem all the shares of the relevant share class or classes and refund to the Shareholders the Net Asset Value of
their  shares  (taking  into  account  actual  realisation  prices  of  investments  and  realisation  expenses)  calculated  on  the
Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such General Meeting
of Shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or duly represented and voting
at such meeting.

23.3 Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be

deposited with a bank or credit institution as defined by the act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
(the Custodian). The Custodian will keep the assets for a period of six months thereafter; after such period, the assets
will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

23.4 All redeemed shares may be cancelled.
23.5 Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this article, the Board may decide to allocate

the assets of any Sub-fund to those of another existing Sub-fund within the Company or to another Luxembourg UCITS
or to another sub-fund within such other Luxembourg UCITS (the New Sub-fund) and to repatriate the shares of the
share class or classes concerned as shares of another share class (following a split or consolidation, if necessary, and the

25457

L

U X E M B O U R G

payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to Shareholders). Such decision will be published in
the same manner as described in the first paragraph of this article one month before its effectiveness (and, in addition,
the publication will contain information in relation to the New Sub-fund), in order to enable Shareholders to request
redemption of their shares, free of charge, during such period.

23.6 Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a contribution of the assets and

of the liabilities attributable to any Sub-fund to another Sub-fund within the Company may in any other circumstances be
decided upon by a General Meeting of the Shareholders of the share class or classes issued in the Sub-fund concerned
for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an merger by resolution taken by
simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

23.7 Furthermore, in other circumstances than those described in the first paragraph of this article, a contribution of

the assets and of the liabilities attributable to any Sub-fund to another Luxembourg UCITS or to another sub-fund within
such other Luxembourg UCITS shall require a resolution of the Shareholders of the share class or classes issued in the
Sub-fund concerned taken with a 50% quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the
shares present or represented and voting, except when such an merger is to be implemented with a Luxembourg un-
dertaking for collective investment under the form of a common fund (fonds commun de placement) or a foreign based
undertaking for collective investment, in which case resolutions shall be binding only on such Shareholders who have
voted in favour of such merger.

23.8 For the interest of the Shareholders of the relevant Sub-fund or in the event that a change in the economic or

political situation relating to a Sub-fund so justifies, the Board may proceed to the reorganisation of such Sub-fund by
means of a division into two or more Sub-funds. Such decision will be published in the same manner as described in the
first  paragraph  of  this  article.  Information  concerning  the  New  Sub-fund(s)  created  will  be  provided  to  the  relevant
Shareholders. Such publication will be made one month prior to the effectiveness of the reorganisation in order to permit
Shareholders to request redemption of their Shares free of charge during such one month prior period.

24. Art. 24. Financial year. The financial year of the Company commences on 1 

st

 January each year and terminates on

31 

st

 December of the same year.

25. Art. 25. Dividends.
25.1 The General Meeting determines, upon proposal from the Board and within the limits provided by law, how the

income from the Sub-fund will be distributed with regard to each existing share class, and may declare, or authorise the
Board to declare, dividends.

25.2 For any share class entitled to dividends, the Board may decide to pay interim dividends in accordance with legal

provisions.

25.3 Payments of dividends to owners of registered shares will be made to such Shareholders at their addresses in the

register of Shareholders. Payments of dividends to holders of bearer shares will be made upon presentation of the dividend
coupon to the agent or agents more specifically designated by the Company.

25.4 Dividends may be paid in such a currency and at such a time and place as the Board determines from time to

time.

25.5 The Board may decide to distribute bonus stock instead of cash dividends under terms and conditions set forth

by the Board.

25.6 Any dividend that has not been claimed within five years of its declaration will be forfeited and repatriated to the

share class(es) issued in the respective Sub-fund.

25.7 No interest will be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

26. Art. 26. Custodian.
26.1 To the extent required by law, the Company will enter into a custodian agreement with the Custodian.
26.2 The Custodian will fulfil its obligations in accordance with the 2002 Act.
26.3 If the Custodian indicates its intention to terminate the custodial relationship, the Board will make every effort

to find a successor custodian within two months of the effective date of the notice of termination of the custodian
agreement. The Board may terminate the agreement with the Custodian but may not relieve the Custodian of its duties
until a successor custodian has been appointed.

27. Art. 27. Liquidation of the Company.
27.1 The Company may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting, subject to the quorum and

majority requirements referred to in article 28 of these Articles.

27.2 If the assets of the Company fall below two-thirds of the legal minimum capital, the question of the dissolution

of the Company will be referred to the General Meeting by the Board. The General Meeting, for which no quorum will
be required, will decide by simple majority of the votes of the shares represented at the General Meeting.

27.3 The question of dissolution of the Company will further be referred to the General Meeting whenever the share

capital falls below one-fourth of the legal minimum capital; in such event, the General Meeting will be held without any

25458

L

U X E M B O U R G

voting quorum requirements and the dissolution may be decided by Shareholders holding one-quarter of the votes of the
shares represented at the meeting.

27.4 The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from the date on which the net

assets of the Company have fallen below two-thirds or one-quarter of the legal minimum, as the case may be.

27.5 If the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators appointed in accor-

dance with the provisions of the 2002 Act.

27.6 The decision to dissolve the Company will be published in the Mémorial and two newspapers with adequate

circulation, one of which must be a Luxembourg newspaper.

27.7 The liquidator(s) will manage each Sub-fund's assets in the best interests of the Shareholders and allocate the

proceeds  of  the  liquidation,  after  deduction  of  liquidation  costs,  amongst  the  Shareholders  of  the  relevant  Sub-fund
according to their respective prorata.

27.8 Any amounts unclaimed by the Shareholders at the closing of the liquidation of the Company will be deposited

with the Caisse de Consignation in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed
beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.

28. Art. 28. Amendments to the articles. These Articles may be amended by a General Meeting of Shareholders subject

to the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Act.

29. Art. 29. Definitions. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing

persons or Shareholders also include corporations, partnerships, associations and any other organised group of persons,
whether incorporated or not.

30. Art. 30. Applicable law. All matters not governed by these Articles will be determined in accordance with the 1915

Act and the 2002 Act. In case of conflict between the 1915 Act and the 2002 Act, the 2002 Act shall prevail.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2011.
The first annual General Meeting will be held in 2012.

<i>Subscription

The Articles having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to 31 (thirty-one)

shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by the Shareholder by payment in cash, so that the sum of EUR 31,000 (thirty-

one thousand euro) paid by the Shareholder is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having
been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26, 26-3 and 26-5 of the 1915 Act

have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that
these Articles comply with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,000.-(three thousand euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. the number of directors is set at 7 (seven);
2. the following persons are appointed as Class S1 directors:
- Mr Fred Sage, Managing Partner, Decision Analytics Advisory Partners AG, Chairman, whose professional address is

at Weinbergstrasse 10, CH-8807 Freienbach, Switzerland, born on 20 February 1958 in Long Beach, United States of
America;

- Mr Hendrik Leber, Non-Executive Director, Decision Analytics Advisory Partners AG, whose professional address

is at Acatis Investment GmbH, MainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt, Germany, born on 22 February 1957
in Essen, Germany;

- Mr Robert Friedman, General Partner, Blacksmith Partners LP, whose private address is at 1, Blacksmith Lane, Pound

Ridge, NY 10576, New York, United States of America, born on 15 May 1950 in New York, United States of America;

the following persons are appointed as Class S2 directors:
- Mr Gianluigi Sagramoso, Managing Director and Chief Executive Officer, Lemanik S.A., whose professional address

is at Via Cantonale 19, CH-6900 Lugano, Switzerland, born on 5 November 1958 in Milan, Italy;

- Mr Philippe Meloni, Managing Director, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., whose professional address

is at 41, op Bierg, L-8217 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, born on 7 November 1971 in Boussu, Belgium;

25459

L

U X E M B O U R G

- Mr Jean-Philippe Claessens, Senior Vice-President, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., whose professional

address is at 41, op Bierg, L-8217 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, born on 22 April 1968 in Liège, Belgium; and

- Mr Maxime Maréchal, Risk Manager, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., whose professional address is at

41, op Bierg, L-8217 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, born on 20 October 1984 in Liège, Belgium.

3. that there be appointed Deloitte S.A., with registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, as external auditor of the Company;

4. that the terms of office of the members of the Board and of the independent auditor will expire after the annual

general meeting of shareholders approving the accounts for the year ended on 2011; and

5. that the address of the registered office of the Company is at 41, op Bierg, L8217 Mamer, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, name, civil

status and residence, the said person appearing signed the present deed together with the notary.

Signé: N. PAPAVOINE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mars 2011. Relation: LAC/2011/12080. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2011.

Référence de publication: 2011039237/1051.
(110043609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2011.

Accero S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.957,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.527.

Il est à noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Thomas Malone, gérant A de la société est dorénavant située

au 17040, suite 300, Pilkington Road, OR 97035 Lake Oswego, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

<i>Pour ACCERO S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011004085/14.
(110004655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

ICH Property Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 109.931.

<i>Extrait du conseil d'administration du 01/02/11

1. CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est transféré du 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 23, rue

Jean Jaurès L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1 

er

 février 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2011019604/13.
(110023941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25460

L

U X E M B O U R G

Antica Roma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 156.324.

<i>Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Les assoicés, à l'unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Le siège social de la société est transféré de L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen à:
L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker
Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch/Alzette, le 10 janvier 2011.

<i>Les associés

Référence de publication: 2011004114/15.
(110004648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Bear S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 54.632.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix.
Le trois décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée MOM Participations s.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I 

er

 , R.C.S. Luxembourg numéro 45054, propriétaire de sept cent cinquante (750) parts sociales de

la société BEAR S.à r.l., ci-après désignée;

2.- Monsieur Alain UNGEHEUER, commerçant, né à Luxembourg, le 12 janvier 1961, demeurant à L-5760 Hassel, 22,

route de Luxembourg, propriétaire de sept cent cinquante (750) parts sociales de la société BEAR S.à r.l., ci-après désignée.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur André PIPPIG, comptable, demeurant professionnellement à

L-2210 Luxembourg 54, boulevard Napoléon 1 

er

 ,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations signées "ne varietur" par le man-

dataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être forma1isées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:
I.- Que la société à responsabilité limitée BEAR S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I 

er

 , R.C.S. Luxembourg numéro B 54632, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 15 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 352 du 23 juillet 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant
actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 17 février 1998, publié au Mémorial C numéro 387 du 28 mai 1998;
- en date du 20 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 423 du 17 avril 2003.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée BEAR S.à r.l., pré-désignée, s'élève actuellement à EUR

37.184,03.- (trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents), représenté par 1.500 (mille cinq cents) parts
sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III.- Que les comparants sont les seuls associés de la prédite société BEAR S.à r.l..
IV.- Que les comparants ont décidé de dissoudre et de liquider la société BEAR S.à r.l. qui a interrompu ses activités.
V.- Que les comparants se désignent comme liquidateurs de la société et auront pleins pouvoirs d'établir, de signer,

d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

VI.- Que les comparants en leur qualité de liquidateurs de la société déclarent de manière irrévocable reprendre tout

le passif présent et futur de la société dissoute.

VII.- Que les comparants déclarent qu'ils reprennent tout l'actif de la société et qu'ils s'engageront à régler tout le

passif de la société indiqué au point VI.

VIII.- Que la liquidation de la société BEAR S.à r.l. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement

close.

25461

L

U X E M B O U R G

IX.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société dissoute pour l'exécution de son mandat.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société

dissoute.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: André PIPPIG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2010. Relation GRE/2010/4351. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004142/56.
(110004762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Crebim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.555.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 4 janvier 2011

1) Est nommé administrateur, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin

2010, qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 4 janvier 2011.
2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2011,

qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011004203/22.
(110004640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Family Affair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.856.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'associé unique en date du 23 mars 2010 que:
- La Société ITPS (Luxembourg) S.A. enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le

numéro B 71431 dont le siège social est établi au 43, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg est nommée gérant
de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 3 février 2011.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011019541/15.
(110023085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25462

L

U X E M B O U R G

Comptoir Luxembourgeois du Bois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 24, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.605.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix.
Le trois décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Marc KRANTZ, indépendant, né à Fauvillers (Belgique), le 25 juin 1955, demeurant à B-6637 Fauvillers,

Wisembach 28 (Belgique).

Lequel comparant déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DU BOIS S.à r.l., ayant son siège social à

L-8832 Rombach-Martelange, 24, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg numéro B 98605, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 janvier 2004, publié au Mémorial C
numéro 226 du 25 février 2004 (la "Société").

2) Que le capital de la Société est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.

3) Que le comparant est l'associé unique de la Société.
4) Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter

et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que le comparant déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.
7) Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société

indiqué au point 6).

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des parts sociales de la société dissoute.
11) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-8832 Rombach-Martelange, 24, route d'Arlon.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marc KRANTZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2010. Relation GRE/2010/4363 Reçu soixante-quinze euros 75,00€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME

Junglinster, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004198/45.
(110004756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

5M Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 70.264.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 4 janvier 2011

1) Est nommé administrateur, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l'année 2011.:

25463

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 4 janvier 2011.
2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2014.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011004564/22.
(110004646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Aurelia Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.735.

<i>Extrait des Résolutions des Associés prises en date du 6 janvier 2011

Les Associés de Aurelia Capital (la "Société") ont décidé comme suit:
De modifier l'adresse de Madame Georgia Phanou-Christodoulou, gérante de la société au 26, Averof Street, CY-1105

Nicosia, Chypre.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Kossi Agbekponou
<i>Gérant

Référence de publication: 2011005310/14.
(110004819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Wandpark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 116.350.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom, METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WIGRE S.A., société anonyme, une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 71.604,

ici représentée par son administrateur Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
CONSIDERANT QUE:
1) la société WANDPARK S.A., société anonyme, une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 67, Boulevard de la Pétrusse, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 116.350, a été constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 11 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1363 en date du
14 juillet 2006 (la "Société");

2) le capital social de la Société s'élève à € 32.000.- (trente-deux mille Euros), représenté par 3.200 (trois mille deux

cents) actions d'une valeur nominale de € 10.- (dix Euros) chacune, intégralement libérées;

3) WIGRE S.A. est l'actionnaire unique de la Société.
Ceci ayant été acté, WIGRE S.A., en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, représenté comme décrit ci-dessus,

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

25464

L

U X E M B O U R G

<i>Première Résolution

L'actionnaire unique de la Société décide de modifier l'article 20 des statuts de la Société, qui devra désormais être lu

comme suit:

Art. 20. "En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommées par l'assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux actionnaires au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.".

<i>Seconde Résolution

L'actionnaire unique de la Société décide de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la

mettre en liquidation, et en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes intérimaires de la Société au 30
septembre 2010, déclare:

1) que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
2) que l'activité de la Société a cessé;
3) que l'actionnaire unique est donc investi de tout l'actif de la Société et qu'il s'engage à régler tout et n'importe quel

passif éventuel de la Société dissoute;

4) que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
5) que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société;
6) que les certificats d'actions au porteur, représentant 100% du capital social, sont annulés après signature du présent

acte;

7) que tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège

de la Société.

<i>Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée générale,

est estimé à mille euros (EUR 1.000.-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite à la personne comparante, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Albert WILDGEN, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59634. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): p.d. Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions C.

Luxembourg-Bonnevoie, le 6 janvier 2011.

Tom METZLER.

Référence de publication: 2011004844/63.
(110004615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Master International Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 73.636.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Stefan BECKER, demeurant à A-5071 Wals-Siezenheim, Austrasse 24,
ici représenté par Monsieur Robert WEIRIG, demeurant à L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange,
en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le27 décembre 2010,
laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant

restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

25465

L

U X E M B O U R G

- qu'il est l'actionnaire unique de «Master International Holding SA» (la «Société»), ayant son siège social à L-1636

Luxembourg, 10, Rue Willy Goergen, constituée pardevant Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à Luxembourg
le 22 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 223 du 23 mars 2000;

- que le capital de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix mille euros (190.000 EUR) représenté par mille deux cent

quarante (1.240) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées;

- que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre et de liquider la Société celle-ci ayant cessé toute activité et d'agir en

tant que liquidateur de la Société;

- qu'en agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société qu'en tant qu'actionnaire unique, il déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés et/ou que tous les actifs deviendront la propriété de l'actionnaire unique;

- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été pris en charge par l'actionnaire et/ou que tous les

passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société, pour

l'exercice de leurs mandats;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1636 Luxembourg,

10, Rue Willy Goergen.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'action-

naire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. WEIRIG; P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/196. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004377/45.

(110004639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Le Cordon Bleu Investments Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.775.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2010

L'Assemblée décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société.

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée

de cinq ans à l'adresse suivante: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Fides (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011004789/16.

(110004822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

25466

L

U X E M B O U R G

Patron Aachen Leasing S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 134.388.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 26 Janvier 2011

<i>Première résolution

L’Associé Unique accepte la démission de M. Michael Vandeloise de son poste de gérant de la société avec effet

immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique nomme Mr. Robert Brimeyer, né le 3 Mai 1972 à Luxembourg, Luxembourg, résidant profession-

nellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2011019727/18.
(110023626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Sonik S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 157.879.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am siebzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

die Gesellschaft deutschen Rechts IMMOBILIEN GASPER &amp; STEIN GmbH, gegründet gemäß Urkunde von Notar

Jürgen PHILIPPI, mit Amtssitz in Dillingen/Saar (D) am 6. Dezember 2005, mit Sitz in D-66663 Merzig, Poststrasse 41,
eingetragen im Zentralen Handelsregister beim Amtsgericht Saarbrücken unter HR 15760,

hier vertreten durch den Geschäftsführer Herr Udo STEIN, Dipl. Sachverständiger, wohnhaft in D-66663 Merzig, Zum

Reisberg 32,

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorgenannte Partei hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezü-

gliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Erbringung von Bürodienstleistungen, wie die Erstellung von WEG und

NK -Abrechnungen, Erstellung von Verkaufsexposes, die Aufbereitung von Verkehrswertgutachten.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „SONIK S. à r. l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Stadtbredimus.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500,- EUR) eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125,- EUR).

Alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft deutschen Rechts IMMOBILIEN GASPER &amp;

STEIN GmbH, vorgenannt.

25467

L

U X E M B O U R G

Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500,-

EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes

über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-

santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitest gehenden

Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesell-

schafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.

Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-

kapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Wenn, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn

von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

eintausend Euro (1.000,- EUR).

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

25468

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Herr Udo STEIN, geboren am 14. Mai 1978 in Völklingen (D), Dipl. Sachverständiger, wohnhaft in D-66663 Merzig,

Zum Reisberg 32.

Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäfts-

führers.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. STEIN, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 21 décembre 2010. Relation: REM/2010/1686. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

Remich, den 30. Dezember 2010.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2011004686/103.
(110003619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Invista European Real Estate Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.462.

EXTRAIT

Monsieur Michael CHIDIAC, gérant de la Société, est domicilié professionnellement à L-2163 Luxembourg, 22, Avenue

Monterey.

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Pour extrait conforme
INVISTA EUROPEAN REAL ESTATE FINANCE S.à r.l.
Anne de Moel et Marta Kozinska
<i>Gérantes

Référence de publication: 2011005342/16.
(110004804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Fosbele Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 117.635.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 4 février 2011

M. Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né le 3 septembre 1971 à Bassano del Grappa (Italie), demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme adminis-
trateur de la société en remplacement de M. Vincent TUCCI, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat
d’administrateur qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2012.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FOSBELE INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011019555/17.
(110023143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25469

L

U X E M B O U R G

Tomitrois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 95.241.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le trente décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Michele TRULLI, demeurant 3, rue Louis Aureglia, MC-98000 Monaco,
ici représenté par Mademoiselle Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre

d'Aspelt, L-1142 Luxembourg,

en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 25 novembre 2010 à Monaco,
laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant

restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, est devenue Actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital

social de la société anonyme "TOMITROIS S.A." avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11b, Boulevard Joseph II, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 95241 ,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet

2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 960 du 18 septembre 2003.

L'Actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social de la société, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
- qu'il est propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- qu'il a pleine connaissance des statuts de la Société et en connaît parfaitement la situation financière.
Ensuite le comparant en sa qualité d'Actionnaire unique a déclaré dissoudre par les présentes la Société avec effet

immédiat et déclare que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, tel qu'il résulte de la situation financière
établie par la société anonyme FIDALPHA S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 9, Avenue Guillaume (RCS
Luxembourg B 114321).

Qu'en qualité d'Actionnaire unique il se trouve investi de tout l'actif et s'engage expressément à prendre à sa charge

tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout payement à
sa personne.

Partant la dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
Le comparant donne décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux

Comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1840 Luxembourg, 11b,

Boulevard Joseph II.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à l'ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société "TOMITROIS S.A."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date d'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. MATERA; P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/178. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Référence de publication: 2011004517/50.
(110004645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

25470

L

U X E M B O U R G

Ezpellor, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 142.608.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 octobre 2010

Il est décidé de nommer en tant qu’administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013:

- Monsieur Marc THILL, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

- Madame Virginie CLAUSEN, administrateur de sociétés, née le 5 décembre 1971 à Caen, France, demeurant au 15

Vineyard Hill Road, Wimbledon Park SW19-7JL, Royaume-Uni.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 février 2011.

Référence de publication: 2011019526/16.
(110023643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 111.801.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2011, la dénomination de la

rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019534/12.
(110023227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Fidji Luxco (BC) Commandite, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 111.800.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2011, la dénomination de la

rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019535/12.
(110023228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Chaussures Lopes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 36, rue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.915.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Antonio SAMPAIO LOPES, indépendant, demeurant à L-9240 Diekich, 1, Grand-rue, né le 8 août 1969 à

Felgueiras au Portugal (matr: 1969 08 08 350).

Lequel comparant a arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "CHAUSSURES LOPES S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune d'Ettelbruck; il pourra être transféré en tout autre lieu

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

25471

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un ou de plusieurs magasins de chaussures, la vente d'articles de ma-

roquinerie et accessoires.

Elle pourra notamment conclure des contrats de franchisage et pourra effectuer toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui
peuvent en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de

désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,00 €), divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq (125,00 €) euros chacune.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés, représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Antonio SAMPAIO LOPES, prénommé.
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cent euros (800,00 €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, le comparant susnommé, représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est constitué en as-

semblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixée à L- 9047 Ettelbruck, 36, rue Prince Henri.
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Antonio SAMPAIO LOPES, prénommé.
3. La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. SAMPAIO LOPES, P. PROBST.

25472

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2010. DIE/2010/12601. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 6 janvier 2011.

P. PROBST

Référence de publication: 2011007042/71.
(110004522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

NeXgen Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 138.783.

<i>Résolution circulaire du conseil d’administration en date du 01/01/ 2011

Il résulte du Conseil d'Administration tenu en date du 1 

er

 janvier 2011 que:

- les gérants de la société ont décidé de transférer le siège social de la Société NEXGEN PARTNERS S.A.R.L. au 3A,

Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2011019687/14.
(110023926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Patron Aachen Prime Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.929.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 26 Janvier 2011

<i>Première résolution

L’Associé Unique accepte la démission de M. Michael Vandeloise de son poste de gérant de la société avec effet

immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique nomme Mr. Robert Brimeyer, né le 3 Mai 1972 à Luxembourg, Luxembourg, résidant profession-

nellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2011019728/18.
(110023627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Financière de l'Europe Occidentale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.124.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 31 décembre 2010 a décidé, conformément à l'article 4 des statuts de la Société, de

transférer le siège social de la Société de L-2340 Luxembourg, 34B Rue Philippe II à L-1940 Luxembourg, 296-298 Route
de Longwy à compter du 1 

er

 janvier 2011.

Puis l'Assemblée Générale qui s'est tenue à l'issue de ce Conseil d'Administration a:
- pris acte de la démission de la société anonyme «TRIPLE A CONSULTING» de ses fonctions de commissaire aux

comptes de la Société avec effet rétroactif à la date du dernier rapport de commissaire émis sur les comptes annuels au
31.12.2009;

- a nommé en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société, la société à responsabilité limitée SWL S.àr.l.,

ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 85782, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

25473

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011019549/20.
(110023493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

R &amp; C Ambiances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.

R.C.S. Luxembourg B 157.899.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt-sept décembre
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

ont comparu:

1. Monsieur Mario Alexandre RIBEIRO DE OLIVEIRA, installateur chauffage-sanitaire, né le 22 février 1983 à Oleiros

au Portugal, demeurant à B-6791 Athus, 149, rue de Rodange;

2. Monsieur Pedro Alexandre DA CRUZ GONÇALVES, installateur chauffage-sanitaire, né le 21 juillet 1984 à Valpacos

au Portugal, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, boulevard JF Kennedy.

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de

constituer:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "R &amp; C AMBIANCES S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Bascharage; il pourra être transféré en tout autre

lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet les installations et réparations de chauffages et sanitaires.
La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles, mobilières ou immobi-

lières, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter
la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de

désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000.- €) divisé en cent (100) parts

sociales de trois cent cinquante euros chacune (350.-€)

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses co-associés, représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

25474

L

U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

Monsieur RIBEIRO DE OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Monsieur DA CRUZ GONÇALVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-

CINQ MILLE EUROS (EUR 35.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration des comparants

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille deux cent cinquante

euros (1.250.- €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants susnommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont constitués en

assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixée à L- 4736 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.
2. Sont nommés gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur RIBEIRO DE OLIVEIRA, prénommé, est nommé au poste de gérant technique;
- Monsieur DA CRUZ GONÇALVES, prénommé, est nommé au poste de gérant administratif.
3. La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. A. RIBEIRO DE OLIVEIRA, P. A. DA CRUZ GONÇALVES, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 28 décembre 2010. DIE/2010/12659. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.-

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 6 janvier 2011.

Pierre PROBST
<i>Le notaire

Référence de publication: 2011004821/88.
(110004193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Fidji Luxembourg (BC), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 110.918.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2011, la dénomination de la

rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

25475

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019536/12.
(110023229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Fidji Luxembourg (BC2), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 115.238.

Suite à une décision de la Commune de Schuttrange et avec effet à partir du 1 

er

 janvier 2011, la dénomination de la

rue où se trouve notre siège social a changé.

La dénomination nouvelle est 9 A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011019537/12.
(110023230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

FGA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.096.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 07 février 2011

Démission de Colette REUTER au poste de commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme
Aniel Gallo
<i>Le bureau

Référence de publication: 2011019547/12.
(110023519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Defat Tanguy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 157.913.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Tanguy DEFAT, transporteur, né à Virton le 26 janvier 1977, demeurant à B-6860 Mellier, 108, rue des

Orlais.

Lequel comparant a arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "DEFAT TANGUY S.à r.l.".

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Rambrouch; il pourra être transféré en tout autre

lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'affrètement et le transport national et international de marchandises par la route, le

service de transport de colis, de courriers et de marchandises pour compte de tiers.

La société a en plus pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant

de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir
par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière, tous titres et valeurs
mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

25476

L

U X E M B O U R G

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de

désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500,00 €) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq (125,00 €) euros chacune.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés, représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2011.

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Tanguy DEFAT, prénommé.
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cent euros (800,00 €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, le comparant susnommé, représentant l'intégralité du capital social de la société, s'est constitué en as-

semblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixé à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Tanguy DEFAT, prénommé.
La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec le notaire le présent acte

Signé: T. DEFAT, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2010. DIE/2010/12587. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 6 janvier 2011.

P. PROBST.

Référence de publication: 2011007048/76.
(110004500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

25477

L

U X E M B O U R G

Patron Dieter II S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.583.

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 26 Janvier 2011

<i>Première résolution

L’Associé Unique accepte la démission de M. Michael Vandeloise de son poste de gérant de la société avec effet

immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique nomme Mr. Robert Brimeyer, né le 3 Mai 1972 à Luxembourg, Luxembourg, résidant profession-

nellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2011019729/18.
(110023628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Finagouti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 123.443.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des résolutions des actionnaires de la société FINAGOUTI S.A. prises en date du 19 janvier 2011 que la

liquidation de la société a été clôturée et que la société a cessé d'exister.

Les documents légaux et comptables de la société seront conservés pendant une période de 5 ans à L-1258 Luxem-

bourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/01/11.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011019548/16.
(110023699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Gambini Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 145.053.

Il résulte d’une lettre datée du 09 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019565/11.
(110023042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Foncière de l'Est S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 58.225.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 31 décembre 2010 a décidé, conformément à l'article 4 des statuts de la Société, de

transférer le siège social de la Société de L-2340 Luxembourg, 34B Rue Philippe 11 à L-1940 Luxembourg, 296-298 Route
de Longwy à compter du 1 

er

 janvier 2011.

Puis l'Assemblée Générale qui s'est tenue à l'issue de ce Conseil d'Administration a:

25478

L

U X E M B O U R G

- pris acte de la démission de la société anonyme «TRIPLE A CONSULTING» de ses fonctions de commissaire aux

comptes de la Société avec effet rétroactif à la date du dernier rapport de commissaire émis sur les comptes annuels au
31.12.2009;

- a nommé en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société, la société à responsabilité limitée SWL S.àr.l.,

ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 85782, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2011019554/20.
(110023494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Futureoil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 143.849.

Par décision du conseil d'administration tenu le 1 

er

 Février 2011 au siège social de la Société, il a été décidé:

- D'accepter, avec effet immédiat, la démission de:
Madame Elisiana PEDONE, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg

de sa fonction d'administrateur,

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat
Monsieur Andrea CASTALDO résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxem-

bourg,

son mandat ayant pour échéance l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne dé Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011019557/20.
(110023462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Kinvope Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 27.385.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2010 documenté par Maître Joëlle

BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2010, LAC / 2010/59889.

Que:
- la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée,
-  que  les  livres  et  documents  sociaux  seront  conservés  pour  une  durée  de  cinq  ans  au  L-2320  Luxembourg,  67,

boulevard de la Pétrusse.

Luxembourg, le 28 janvier 2011.

Pour extrait conforme
Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011019986/19.
(110023732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25479

L

U X E M B O U R G

P&amp;S Machines de Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierschestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 157.906.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

Sind erschienen:

1. Herr Patrick SCHWEITZER, Angestellter, geboren in Moresnet (Belgien), am 3. August 1970, wohnhaft in B-4728

Kelmis, Promenadenstrasse 11;

2.  Herr  Rainer  PFAFFEN,  Angestellter,  geboren  in  Aachen  (Deutschland)  am  20.  April  1968,  wohnhaft  in  B-4711

Lontzen, Johberg 52.

Welche Komparenten erklären, zwischen ihnen und denjenigen, die später Teilhaber werden könnten, eine Gesell-

schaft  mit  beschränkter  Haftung  luxemburgischen  Rechts  zu  gründen,  die  den  Bestimmungen  des  Gesetzes  über  die
Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „P&amp;S Machines de Construction S.à r.l.".

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Vermietung von Baumaschinen, Werkzeugen und Baugeräten.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder

unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könn-
ten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird,
vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Heinerscheid.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Großherzogtums verlegt werden.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in hundert

(100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR).

Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern sowie an Drittpersonen frei übertragbar.
Im Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen

und von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer derer Mandate werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder

mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, egal wie viele Anteile er besitzt. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich ordentlich bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit, Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

25480

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn

dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2011.

<i>Abschätzung, Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf € 800.- abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR) wurden wie folgt gezeichnet:

- Herr Patrick SCHWEITZER, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Herr Rainer PFAFFEN, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR) wurden vollständig und in bar eingezahlt, so

dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Teilhaber folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird:
Herr Angelo SCHWEITZER, geboren am 7. September 1977 in Eupen (B), wohnhaft in B-4710 Lontzen, Mühlenweg

18.

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SCHWEITZER, R. PAFFEN, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2010. DIE/2010/12284. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, den 22. Dezember 2010.

P. PROBST

Référence de publication: 2011007052/91.
(110004377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Lux Home Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue John Fitzgerald Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.950.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 10 janvier 2011

Le Conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Jean-Michel LARRE, demeurant professionnellement à

L-7327 Steinsel, 35, rue John Fitzgerald Kennedy, en qualité d’administrateur-délégué. Il sera chargé de la gestion jour-
nalière de la société, avec pouvoir d’engager celle-ci par sa signature individuelle. Son mandat expirera lors de l’assemblée
générale ordinaire de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011019655/13.
(110023159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25481

L

U X E M B O U R G

Innovative Solutions and Advisory Services for European Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 130.226.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 26 janvier 2011

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 26 janvier 2011, que les

résolutions suivantes ont été adoptées:

- L’assemblée décide de renouveler le mandat de Madame Véronique De Meester au poste d’administrateur de la

société et ce, jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en 2016.

- L’assemblée décide de renouveler le mandat de Fidus Gestion S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212

Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes de la société et ce, jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en
2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011019600/20.
(110023414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.803.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1 

<i>er

<i> avril 2010

- Les mandats d'Administrateurs de Madame Chantai GASPAR, employée privée, demeurant professionnellement au

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Madame Françoise DUMONT, employée privée, demeurant profession-
nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2016;

- Madame Catherine PISVIN, employé privée, demeurant au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée

nouvel Administrateur en remplacement de Madame Nicole THIRION, qui ne souhaite plus se présenter au suffrage. Le
mandat de Madame Catherine PISVIN viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016;

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 12, rue

Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, est reconduit pour une période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 1 

er

 avril 2010.

FINANCIERE DU STUFF S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011020229/22.
(110024416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2011.

Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 127.050.

Au Conseil de Gérance et à Messieurs les Associés de la Société
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma décision de démissionner avec effet au 17 décembre 2010, de mon

mandat de gérant de la société GENESTA NORDIC BALTIC REAL ESTATE SARL, SICAR.

Mark BUTLER.

Référence de publication: 2011019559/12.
(110023037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25482

L

U X E M B O U R G

Grupo Imoveis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 154.724.

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 04 février 2011:
Madame Valérie WESQUY , née le 06 mars 1968 à Mont St Martin (France) ,employée privée, demeurant profession-

nellement  3  rue  Belle  Vue  L  –  1227  Luxembourg  a  été  nommée  administrateur  de  la  société  en  remplacement  de
Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019562/15.
(110023043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

GI-Gasification International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.436.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 novembre 2010

Conformément aux dispositions de l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Luis Miguel DIAS DA SILVA SANTOS.
Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2015.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Certifié sincère et conforme
GI-GASIFICATION INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Administrateur Cat A / Administrateur Cat B

Référence de publication: 2011019568/16.
(110023070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Helvetia Communication Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 97.687.

Il résulte d’une lettre datée du 06 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019589/11.
(110023090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Grossfeld Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 85.508.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 1 

er

 décembre 2010 a:

- pris acte de la démission de Monsieur Daniel GEERTS de ses fonctions d'administrateur de la société à compter du

30 novembre 2010;

- coopté Monsieur Laurent JACQUEMART, né le 25 juin 1975 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement

à B-1000 Bruxelles (Belgique), Tour &amp; taxis, Avenue du Port 86c Boite 316, en qualité d'administrateur de la société, en
remplacement de Monsieur Daniel GEERTS, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2012, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

25483

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/01/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011019571/17.
(110023495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 150.479.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par l’actionnaire en date du 1 

<i>er

<i> août 2010

L’actionnaire a décidé:
- D’accepter la démission de Annick Magermans à la fonction de gérante de classe B du Conseil de Gérance avec effet

au 1 

er

 août 2010.

- De nommer Bertrand De Fays, né le 12 juillet 1981 à Woluwe-Saint-Lambert, Belgique, demeurant professionnelle-

ment au 16 Avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, Luxembourg à la fonction de gérant de classe B du Conseil de Gérance
avec effet au 1 

er

 août 2010 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 février 2011.

Référence de publication: 2011019584/16.
(110023937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Metalpoint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 86.677.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour. METALPOINT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011019917/21.
(110023024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Helvetia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 112.271.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten, on the twenty-fourth Day of December.
Before the undersigned Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Mr Stephane BERDUGO, employee, residing at 10B, Chemin de la Chevillarde CH-1208 Genève,
Here represented by Mrs Babsi Sinnes, employee, professionally residing at Hesperange, by virtue of a proxy given on

December 7 

th

 , 2010.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

25484

L

U X E M B O U R G

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "HELVETIA INVESTMENTS S.A.", having its principal office at 67, rue Ermesinde L-1469 Lu-

xembourg,  has  been  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  André  Jean-Joseph  SCHWACHTGEN,  notary  then
residing in Luxembourg, on November 24 

th

 2005 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number

424 of February 27 

th

 2006;

- that the share capital of the corporation "HELVETIA INVESTMENTS S.A." is fixed at thirty-one thousand euro (EUR

31,000.-) represented by three thousand and one hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each,
fully paid;

- that Mr Stéphane BERDUGO, prenamed, has become sole owner of the shares of "HELVETIA INVESTMENTS S.A.";
- that Mr Stéphane BERDUGO declares to have full knowledge of the articles of association and the financial situation

of the Corporation and approves the financial statements of the Corporation as of the date of dissolution of the Cor-
poration;

- that Mr Stéphane BERDUGO declares explicitly to proceed with the dissolution and liquidation of the Corporation

as the business activity of the Corporation has ceased;

- that Mr Stéphane BERDUGO, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "HELVETIA INVESTMENTS

S.A.", declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that she is irrevocably assuming

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of "HELVETIA INVESTMENTS S.A." is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and Statutory Auditor of the company for the exercise of their mandates

except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the previous

registered office of the Company.

<i>Declaration of the affiant

The affiant, through its proxyholder, declares on behalf of the beneficial owners that the assets of the Company to be

liquidated do not serve to any activities constituting an infraction under article 506-1 of the Criminal Code or article 8-1
of the law of February 19, 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction (money
laundering) or an act of terrorism as defined in article 135-1 of the Criminal Code (financing of terrorism), and that the
Company has never been involved in such activities.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at 890,- EUR.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Marc Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

- Monsieur Stéphane BERDUGO, employé, résidant au 10B, Chemin de la Chevillarde CH-1208 Genève,
Ici représenté par Madame Babsi SINNES, employée, résidant professionnellement à Hesperange, en vertu d'une pro-

curation donnée le 7 décembre 2010.

Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société HELVETIA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, a

été constituée suivant acte reçu par le notaire André Jean-Joseph SCHWATCHGEN, alors de résidence à Luxembourg,
en date du 24 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 424 du 27 février 2006;

25485

L

U X E M B O U R G

- que le capital social de la société HELVETIA INVESTMENTS S.A., précitée, s'élève actuellement à trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune, entièrement libérées;

- que Monsieur Stéphane BERDUGO, prénommé, est devenu seul propriétaire des actions dont s'agit;
- que Monsieur Stéphane BERDUGO déclare avoir pleine connaissance des statuts et de la situation financière de la

Société et approuve les états financiers de la Société au jour de la dissolution de la Société;

- que Monsieur Stéphane BERDUGO déclare explicitement dissoudre et liquider la société HELVETIA INVESTMENTS

S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur Stéphane BERDUGO, prénommé, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société HELVETIA

INVESTMENTS S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société HELVETIA INVESTMENTS S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'ancien siège social

de la Société.

<i>Déclaration du comparant

Le comparant, par son mandataire, déclare au nom et pour compte des bénéficiaires économiques que les actifs de la

Société à liquider ne serviront pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou à des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme)
et que la Société à liquider ne s'est pas livrée à de telles activités.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à 890,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: Sinnes, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59153. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Sandt.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 6 janvier 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011004639/109.
(110003596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Hanseatic Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.000,00.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 8, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 82.746.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 7 février 2011 que:
- La démission de Taco Th. van der Mast, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 7 février 2011.

Référence de publication: 2011019586/12.
(110023046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

25486

L

U X E M B O U R G

Health Care Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 41.845.

<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d’administration de la société le 1 

<i>er

<i> février 2011

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration constate la demission de Monsieur André Lutgen à partir du 1 

er

 janvier 2011 et nomme

Madame Isabelle Pairon, née le 28 septembre 1979 à Libramont, Belgique, avec adresse professionnelle au 10, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg en remplacement de l’administrateur démissionnaire jusque l’assemblée générale annuelle
ordinaire des actionnaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait et traduction sincère et conforme
<i>L’agent domiciliataire

Référence de publication: 2011019587/15.
(110023893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Hopen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 106.700.

Il résulte d’une lettre datée du 09 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019592/11.
(110023091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Praedia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 70.375.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: PRAEDIA HOLDING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011019919/21.
(110023083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

HOPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.629.

Il résulte d’une lettre datée du 09 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

25487

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019593/11.

(110023092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

I&amp;P International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 115.681.

Il résulte d’une lettre datée du 09 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019596/11.

(110023266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

Immobilien Progress Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 116.861.

Il résulte d’une lettre datée du 09 août 2010 que mademoiselle Annalisa CIAMPOLI a démissionné de son poste

d’administrateur.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 07 février 2011.

Référence de publication: 2011019606/11.

(110023184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2011.

The Jupiter Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 110.737.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 14 janvier 2011 a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L'assemblée a ré-rélu Messieurs Garth Lorimer Turner (résidant au 1, Victoria Street BER-H1111 Hamilton aux

Bermudes), Patrick Zurstrassen (résidant au 19 rue de Bitbourg, L-l273 Luxembourg) et Maître Jacques Elvinger (résidant
2, Place Winston Churchill à L-1340 Luxembourg), aux fonctions d'Administrateurs pour une période d'un an se terminant
à l'assemblée générale annuelle de 2012.

2. L'assemblée a élu Mr. Adrian Creedy (résidant au 1, Grosvenor Place, SW1X7JJ London, Royaume Unis) à la fonction

d'Administrateur pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2012.

3. L'assemblée a ré-élu Ernst &amp; Young à la fonction de Réviseur d'Entreprise pour une période d'un an se terminant à

l'assemblée générale annuelle de 2012.

<i>Pour THE JUPITER GLOBAL FUND
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011019924/21.

(110022999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

25488


Document Outline

5M Europe S.A.

Accero S. à r.l.

Antica Roma S.à r.l.

Aurelia Capital

Bear S.à r.l.

Chaussures Lopes S.à r.l.

Comptoir Luxembourgeois du Bois S.à r.l.

Crebim S.A.

Defat Tanguy S.à r.l.

Ezpellor

Family Affair S.à r.l.

FGA (Luxembourg) S.A.

Fidji Luxco (BC)

Fidji Luxco (BC) Commandite

Fidji Luxembourg (BC)

Fidji Luxembourg (BC2)

Finagouti S.A.

Financière de l'Europe Occidentale S.A.

Financière du Stuff S.A.

Foncière de l'Est S.A.

Fosbele Investments S.A.

Futureoil S.A.

Gambini Investment S.A.

Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR

GI-Gasification International (Luxembourg) S.A.

Grossfeld Immobilière

Grupo Imoveis S.A.

Hanseatic Europe S.à r.l.

Health Care Investments Holding S.A.

Helvetia Communication Participations S.A.

Helvetia Investments S.A.

Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l.

Hopen S.A.

HOPI S.A.

ICH Property Holding S.A.

Immobilien Progress Management S.A.

Innovative Solutions and Advisory Services for European Business S.A.

Invista European Real Estate Finance S.à r.l.

I&amp;P International S.A.

Kinvope Holding S.A.

Le Cordon Bleu Investments Holding S.à.r.l.

Lux Home Distribution S.A.

Master International Holding S.A.

Metalpoint S.A.

NeXgen Partners

Next Generation Absolute Return II

Patron Aachen Leasing S. à r. l.

Patron Aachen Prime Holdings S.à r.l.

Patron Dieter II S. à r. l.

Praedia Holding S.A.

P&amp;S Machines de Construction S.à r.l.

R &amp; C Ambiances S.à r.l.

Sonik S. à r. l.

The Jupiter Global Fund

Tomitrois S.A.

Wandpark S.A.