logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 408

2 mars 2011

SOMMAIRE

3W Power Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

19584

Advans S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19568

Aktiva S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19569

Alternative Leaders S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

19569

Aratus Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19570

Armatix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19571

Assets & Buildings Investments I S.A.  . . . .

19569

Atlantico Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19571

Audiovision International S.A. . . . . . . . . . . .

19572

Autòs Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19571

Avon Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19572

BML Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19573

Cantac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19574

Capitaine Private S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . .

19575

Carbolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19576

C.A.S. Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19573

Cedar Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19573

Cemex Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . .

19560

Centrix Beteiligungen AG  . . . . . . . . . . . . . .

19574

Champs de Mars S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19576

Chimindu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19576

Cidron Liberty Systems S.à r.l . . . . . . . . . . .

19557

Clima Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19577

CMS Management Services S.A. . . . . . . . . .

19577

Com3 Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19580

Comex Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19578

Cominsider S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19578

Compagnie d'Investissement Espagnole

Morlie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19579

Conecon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19580

Conso Services International S.A.  . . . . . . .

19563

Cosmétique Groupe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

19581

Couquelet International S.A.  . . . . . . . . . . . .

19582

DB PEP V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19538

EUROMOVERS International EWIV  . . . . .

19584

Financial & Building Corporation S.A. . . . .

19575

Financière Naturam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

19570

FIS Global Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19579

GL Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19582

I.B.C. Györ Luxemburg 2 S.A.  . . . . . . . . . . .

19583

I.B.C. Györ Luxemburg S.A.  . . . . . . . . . . . .

19582

Imison International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

19581

I-TEK S.E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19583

KEV Germany Spittelmarkt 1 S.à r.l. . . . . .

19570

Kompass Wohnen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

19575

LSF4 Mega Investments II S.àr.l. . . . . . . . . .

19577

LSF-KEB Capital Investments S.à r.l.  . . . .

19567

Lux-Ideal S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19580

Luxsyspur S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19580

Matterhorn Capital Data Centre Group S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19579

Medalux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19583

Medalux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19584

Medalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19584

Medalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19583

NGP Quatro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19568

Regard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19578

WCC Romania S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19567

Weather Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19567

Weather Finance II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

19566

WE invest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19567

19537

L

U X E M B O U R G

DB PEP V, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 159.072.

STATUTES

In the year two thousand eleven, on the sixteenth day of February.
Before the undersigned notary, Maître Jean-Joseph Wagner, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“DB Private Equity GmbH”, a company incorporated and existing under the laws of Germany, with registered offices

in Zeppelinstraße 4-8, 50667 Cologne, Germany

represented here by Mr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, professionally residing in L-1011 Luxembourg, as per a private

power of attorney issued in Cologne (Germany) on 14 February 2011.

The power of attorney issued, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to this document and these will be registered together.

The appearing party, represented as stated hereabove, request the notary to state the following articles of incorpo-

ration of a public limited company (société anonyme), which it hereby declares to organise:

Articles of Incorporation

Art. 1. Name. The Company is a public limited company (société anonyme) in the form of an investment company

with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé or "SICAV - FIS") and is named "DB PEP V" (the "Company").

Art. 2. Registered office. The registered office is located in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg. By a simple

resolution of the Board of Directors, it is possible to establish branches and representative offices at a different location
in the Grand Duchy as well as abroad.

Provided that the Board of Directors determines that extraordinary political or warlike events have occurred or are

imminent that could interfere with the Company’s usual business activities at the Company’s registered office or that
could interfere with the communication with persons abroad, then the registered office may be temporarily transferred
abroad until the situation has normalised completely. Such provisional measures shall have no effect on the Company’s
nationality. The Company will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company shall commence upon the notary's certification of these Articles of Incorporation. The

term of the Company is not limited.

Art. 4. Corporate Object. The exclusive purpose of the Company is to invest its assets in participations as shareholder

or partner, in subordinate receivables and/or participation rights from private equity funds and Investee Companies, (in
particular in the form of buy-out, growth capital, special situation and secondary funds), whose investment strategy focuses
on equity capital financing of companies with the aim of diversifying investment risks and to have their shareholders profit
from the investment results. In the process, the investment objectives and investment limits of the Company and the Sub-
Funds shall be observed respectively as they are set out in the Offering Memorandum published by the Company. The
investments concerned may be made either directly or via subsidiaries.

The Company may execute any measures and transactions it deems useful to fulfil and execute this corporate object,

namely in the broadest sense in accordance with the law of February 13 

th

 2007 on specialised investment funds (herei-

nafter referred to as the "Law of 2007").

Art. 5. Corporate Capital. The Company's capital shall be represented by shares of no nominal value and shall at any

time be equal to the net asset value, as determined in accordance with the following Article 11. The Company's capital
shall be denominated in euro. The initial capital of the Company is EUR 40,000.- (forty thousand Euros), divided into 4
(four) shares of no nominal value. The minimum corporate capital of EUR 1,250,000.- (one million two hundred fifty
thousand Euros) must be reached within twelve months after the date on which the Company has been authorised as a
specialised investment fund under Luxembourg law. Thereafter, the minimum capital must at all times be at least EUR
1,250,000.- (one million two hundred fifty thousand Euros).

The Board of Directors may at any time resolve that the shares of the Company are to belong to different compart-

ments to be established (the "Sub-Funds"), which in turn may be denominated in different currencies. The Board of
Directors may also decide that within a Sub-Fund several share classes are to be issued with different features, such as a
specific distribution or reinvestment policy, a specific fee structure or other specific features as decided by the Board of
Directors and set out in the Company's Offering Memorandum. Each Sub-Fund's term shall be set by the Board of
Directors in accordance with the regulations of the Offering Memorandum.

The capital inflows from the issue of shares shall be invested as per the provisions of the Company’s Offering Memo-

randum in Investee Companies and other legally permissible assets, in accordance with the investment policy set out by

19538

L

U X E M B O U R G

the Board of Directors and in observance of the investment limits provided for by law or adopted by the Board of
Directors.

Art. 6. Changes to the Company's capital. The Company's capital shall at all times be equal to the entirety of the shares

issued. The total amounts paid in respect of the shares shall correspond to the Company's net assets (hereinafter referred
to as the "Total Net Asset Value"). The Company's capital may increase or decrease following the issue of additional
shares by the Company or the redemption of shares by the Company.

Art. 7. Registered shares and share certificates. Shares of the Company are only issued as registered shares.
A shareholders' register shall be kept at the Company’s registered office for such registered shares. This register shall

contain the name of each shareholder, the shareholder’s place of business, the number of shares held and, if applicable,
the date of transfer of each share. The entries in the shareholders’ register shall be signed by one or more persons
specified by the Board of Directors.

Share  certificates  for  registered  shares  will  only  be  issued  at  the  request  and  at  the  expense  of  the  shareholder

concerned. However, confirmation of entry in the shareholders’ register will always be sent to the shareholder. Requested
share certificates will be issued within one month after subscription, provided that all payments on the subscribed shares
have been received in full. Share certificates will be signed by two directors or any person that has been appointed for
this purpose by the Board of Directors.

In order to ensure that (1) the Company's shareholders satisfy the requirements of the Law of 2007 at all times, (2)

the number of well-informed investors as defined by the Law of 2007 does not exceed 100 (one hundred) per Sub-Fund,
and (3) natural persons do not invest directly, share transfers shall be subject to the prior consent of the Board of
Directors. The purchaser may only be a well-informed investor as defined by article 2 of the law specified above. Company
shares shall be held by well-informed investors and the purchaser shall assume fully the remaining obligations with respect
to the Company.

Notwithstanding the preceding provisions, shares held as part of the restricted assets (gebundenes Vermögen) of an

insurance company, a German pension fund, a German benefit plan or any other investor, the capital investments of which
are subject to the German Insurance Supervision Act (Versicherungsaufsichtsgesetz) or which are held by investment
companies on behalf of mutual investment funds (Sondervermögen), regardless of the transfer restrictions applicable to
other investors, may be transferred and shall not require the consent of the Board of Directors, insofar as (i) the transferee
is an insurance, a social insurance agency, a pension fund, an investment company, a foundation or a credit institution or
(ii) the transferee is another institutional investor which either has an adequate credit (investment grade) rating or suf-
ficient appropriate securities and (iii) the transfer does not result in non-eligible persons holding shares or cause the total
number of shareholders to exceed 100 (one hundred). “Transfer” shall refer in particular to the sale, exchange, transfer
and assignment of shares. Upon the transfer, the transferee shall assume all obligations and commitments and the sole
liability in relation to the shares transferred; any (subsidiary) liability for such obligations and commitments on the part
of the previous investor is excluded following disposal of the shares (no joint and several liability of vendor and purchaser).
All such obligations shall pass to the purchaser, thereby releasing the vendor.

To the extent to which and as long as shares are held as part of the guarantee assets (Sicherungsvermögen) of an

insurance company, disposal of such shares is permitted only with the prior written approval of the trustee (Treuhänder)
for the guarantee assets or the trustee’s representative, if the insurance company has appointed a trustee as defined by
section 70 of the German Insurance Supervision Act.

If a shareholder of the Company subscribes for shares in the Company on behalf of a third party and not for its own

account, such third party must also be a well-informed investor as defined by article 2 of the Law of 2007 (with the
exception that natural persons may not invest directly).

Transfers of registered shares shall be carried out by means of a written transfer declaration which shall be entered

in the shareholders’ register; the declaration shall be dated and shall be signed by the purchaser, the seller or by other
representatives authorised for this purpose and the share certificate must be returned, where one has been issued. The
Company may also accept other original documents that provide adequate proof of the transfer.

Each holder of registered shares must inform the Company of its address for the purpose of entry in the shareholders’

register. If such address differs from its administrative address, it may also provide a postal address. All notifications and
announcements by the Company to holders of registered shares may be sent to such address with legally binding effect.
The shareholder may apply to the Company in writing at any time to change its address in the register.

If a shareholder does not provide an address, the Company may allow a note to this effect to be entered in the

shareholders’ register. In such cases the address of the shareholder shall be the registered office of the Company until
the shareholder notifies the Company of a different address.

Shares shall only be issued after the subscription has been accepted and the payment of at least 5 (five) percent per

share required as per article 28 (3) of the Law of 2007 has been received.

The Company shall only recognise a single shareholder per share. In the case of joint ownership or of a usufruct, the

Company may suspend the rights relating to the share ownership until the point in time at which a person is specified
who will represent the joint owners or the beneficiaries and the usufructuaries vis-à-vis the Company.

19539

L

U X E M B O U R G

The Company may issue fractional shares up to the third decimal place. Fractional shares do not provide a voting right,

but do entitle the owner to participate in the distributions of the Company on a pro-rata basis.

Art. 8. Loss or destruction of share certificates. If a shareholder can prove to the Company with convincing evidence

that a share certificate belonging to the shareholder was lost or destroyed, the Company will issue a replacement certi-
ficate at the request of the shareholder. This issue shall be subject to the conditions set forth by the Company, including
a compensation, inspecting or demanding documents, which must be signed to the Company's satisfaction by a bank, a
stock broker or another party. The original certificate shall become completely invalid following the issue of a new share
certificate, which shall indicate that it is a duplicate.

Mutilated or damaged share certificates may be exchanged by the Company for new share certificates. The mutilated

or damaged share certificates are to be given back to the Company, which will then immediately declare them invalid.

The Company shall be authorised at its sole discretion to require shareholders to provide appropriate compensation

for such costs arising from the issue and registration of a new share certificate or from cancelling and destroying the
original share certificate.

Art. 9. Restriction of property rights to shares. Shares in the Company may only be held by well-informed investors

(with the exception that natural persons may not invest directly). Furthermore, the Company may, at its sole discretion,
restrict or forbid their shares from being owned by certain well-informed investors if it believes that such ownership:

- contravenes the interests of the other shareholders or the Company; or
- may result in a violation of the laws in the Grand Duchy of Luxembourg or another country; or
- may subject the Company to taxation in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg; or
- negatively impacts the interests of the Company in another manner.
For this purpose, the Company may:
a) refuse to issue shares or to transcribe them in the shareholders' register if it is apparent that this issue or trans-

cription would result in share ownership being transferred to another person who is not eligible to own shares of the
Company,

b) carry out a forced redemption of such shares if it is apparent to the Company that these shares are owned by a

person who is not allowed to own shares of the Company, either individually or together with other persons,

c) carry out a forced redemption of such shares if it is apparent to the Company that these shares are owned by one

or more persons to such as extent as to result in the Company being subject to the application of tax laws or other laws
of countries other than Luxembourg.

In cases b) and c) the following procedure shall be applied:
i. The Company shall send the shareholder concerned a notification (hereinafter referred to as the "Redemption

Notification"). The Redemption Notification shall indicate the shares to be redeemed, the Redemption Price to be paid
and the location where this price is to be paid. The Redemption Notification may be sent as a registered letter to the
shareholder at his designated postal address or at the address entered in the shareholders' register. The shareholder
concerned shall be obligated to return to the Company without delay the certificate(s) that represent(s) the shares listed
in the Redemption Notification. Upon the end of business hours on the day specified in the Redemption Notification, the
shareholder shall cease being the owner of the shares listed in the Redemption Notification. The share certificates that
represent the relevant shares shall be annulled.

ii. The price at which the shares specified in the Redemption Notification are redeemed (hereinafter referred to as

the "Redemption Price") shall correspond to the net asset value of the shares issued on the Valuation Day, on which the
redemption is to be carried out.

iii. The Redemption Price shall be deposited for the benefit of the owner of these shares by the Company at a bank

based in Luxembourg or elsewhere, which was specified in the Redemption Notification. This bank shall pay the Re-
demption Price to the shareholder concerned upon surrender of any issued share certificates that represent the shares
listed in the Redemption Notification. Following the Redemption Price being deposited as per these conditions, individuals
interested in the shares specified in the Redemption Notification may make no claim to these shares or take any legal
steps against the Company. The right of the shareholder identifying himself as a legitimate owner of the shares to receive
payment of the deposited Redemption Price upon return of any issued share certificate(s), as explained above, shall be
excluded from this rule.

iv. Under the condition that the Company is of good faith, it may exercise the powers granted in this article even if it

cannot be clearly proven who is in possession of the shares.

d) at shareholders’ meetings revoke the voting rights of persons who are not permitted to own shares of the Company.

Art. 10. Issue, redemption and conversion of shares. The total of the commitments entered into by investors within

the subscription periods according to the subscription agreements shall constitute the individual SubFund’s maximum
committed capital; the total of the maximum committed capital of the Sub-Funds shall constitute the Company’s maximum
committed capital to which the shareholders have committed themselves ("Total Subscriptions"). The Board of Directors
of the Company is entitled to issue new shares at any time to well-informed investors, as defined in article 2 of the Law
of 2007 (with the exception that natural persons may not invest directly), up to the level of the committed capital required.

19540

L

U X E M B O U R G

Subscriptions shall be accepted at the Company's registered office or at the registered offices of institutions named by
the Company.

In order for the new subscription of shares to be valid, they must be paid for in full. Newly issued shares shall have

the same rights as the shares in circulation on the date of the share issue.

Payment of the amount for the shares to be issued respectively shall be payable upon written request by the Board of

Directors within the period specified in the written request.

If a shareholder fails to pay for a share tranche on the due date when capital is called, the shareholder shall be deemed

to be in default from the due date without any need for a formal reminder. Without prejudice to other statutory legal
consequences, the shareholder in default will be liable for annual default interest of 8 percentage points above the three
month EURIBOR interest rate (Euro Interbank Offered Rate) on the due date (per www.reuters.com).

If, after a written demand for payment has been issued following a default, a shareholder fails to pay the overdue

amount plus accrued interest on arrears within a period of four weeks, the Board of Directors is entitled, at its own
discretion, to exercise one or more of the following rights against the defaulting shareholder (cumulatively). Existing
statutory or other contractual claims by the Sub-Fund are only affected to the extent that they are explicitly excluded as
a result of the following rights being exercised.

(i) The Company’s Board of Directors may, by written declaration and in accordance with the procedure described

in article 9, redeem all of the shareholder’s shares for the benefit of the Sub-Fund. In the case of the redemption, the
defaulting shareholder will lose all shareholder rights, in particular voting rights, as well as the right to participate in future
capital contributions or distributions.

In such cases, the Sub-Fund shall owe the defaulting shareholder compensation, the total amount of which shall be

determined as follows:

The shareholder shall receive a total of 50% of the capital payments made by the shareholder to date, less the sum of

distributions already made, capped at 50% of the pro rata net asset value of its shares on the date of redemption.

The claims of the defaulting shareholder shall also be reduced by interest on arrears accruing and any resulting expenses

arising for the Sub-Fund, such as bridge financing costs, costs for legal advice or damages arising as a result of the Sub-
Fund’s defaulting towards investment programs or direct investments.

The compensation determined shall be payable in instalments. The individual instalments shall be due for payment on

the dates on which the Sub-Fund makes distributions to the remaining shareholders. The maximum amount of each
individual instalment shall be the amount which the defaulting shareholder would have received if no redemption had
been made. The individual instalments shall not be interest-bearing. No claim to the provision of collateral shall exist.

(ii) The Company is also entitled to sell the shares of the shareholder in default, in part or fully, to third party well-

informed investors as defined by article 2 of the Law of 2007 at a market price to be determined by the Board of Directors,
whereby additional discounts on the purchase price of up to 15% of the market price established shall be allowed.

The market price shall be determined at the discretion of the Board of Directors. In this vein, the Board must take

into account discounts applied to the sale of shares in closed funds which are known to it from the market.

However, for the purpose of determining the market price the Board of Directors is not required to conduct studies

of the market or obtain offers from third parties.

For the purpose of executing a sale in case of default, the shareholder hereby authorises the Company to make all

necessary declarations and to take all required actions (including the granting of the relevant subauthorisations) to achieve
an effective sale and an effective transfer of the defaulting shareholder’s shares to a third party. The achieved purchase
price must initially be used to settle the defaulting shareholder’s liabilities towards the Company.

(iii) Ultimately, the Board of Directors is entitled to withdraw the right to accept shares as part of its commitment

from the defaulting shareholder, and to take all other measures which ensure that the defaulting shareholder is not in a
better position that it would have been in had it taken over its shares and honoured its capital commitments on time.

(iv) The Board of Directors may declare that the Shareholder’s voting rights shall remain in abeyance throughout the

period of default.

(v) In place of preceding measures (i) and (ii) but if required in addition to (iii) and (iv), the Company may redeem 25%

of the defaulting shareholder’s shares without providing any consideration.

The Board of Directors reserves the right to reject in whole or in part any subscription application or to suspend the

issue of shares without prior notification at any time. The Board of Directors may limit the frequency of the issue of
shares. Following the initial issue within the subscription periods set out in the Offering Memorandum, shares shall be
issued at the price of EUR 10,000 (ten thousand).

A shareholder's shares shall not be redeemed in whole or in part at the unilateral request of the shareholder.
However, the Board of Directors of the Company may decide to redeem shares or fractional shares of the Company

as a way of distributing paid in or otherwise liquid capital to shareholders. The redemption price shall generally correspond
with the proportionate net asset value of the shares on the valuation day on which redemptions are carried out. The
decision to repurchase shall be binding for all shareholders and shall be valid pro rata to their share in the capital of the
Company. The Board of Directors shall notify the registered shareholders by mail of the decision to redeem and inform
the shareholders of the number of shares and the calculation of the redemption price. The shares of the capital repur-

19541

L

U X E M B O U R G

chased by the Company shall be annulled in the Company’s books. The redemption price will be paid out in Luxembourg
no later than twenty bank business days after the last redemption price calculation day.

Art. 11. Net asset value. If investments by the Company or its Sub-Funds as per article 4 of these Articles of Incor-

poration and the provisions of the Offering Memorandum are made through subsidiaries, the Company's accounts shall
directly recognise the value of the assets held by the subsidiaries, less the subsidiaries’ liabilities. In this case, the value of
the investments in subsidiaries shall not be taken into consideration when calculating the net asset value. The assets held
by the subsidiaries shall be valued in accordance with the following rules.

Each day on which the net asset value of the shares is calculated is referred to hereinafter as a "Valuation Day".
The net asset value per share is expressed in the respective SubFund's currency and is determined for each of the

Company’s shares by dividing the assets of each Sub-Fund, i.e. the total of the assets minus the liabilities, by the number
of the shares of this Sub-Fund in circulation on the Valuation Day. The net asset value per share shall be rounded to the
second decimal place.

In the event dividends are paid or shares are issued and repurchased, the net assets of each individual Sub-Fund shall

be adjusted as follows:

- If a dividend is paid per share, the net asset value of the Sub-Fund is decreased by the amount of the dividend

distribution;

- If shares are issued or repurchased, the net assets of the Sub-Fund are increased or decreased by the amount received

or distributed.

The assets of each Sub-Fund may include:
- shares of companies;
- all liquid assets, including interest accrued thereon;
- shares and other securities held by the Sub-Fund;
- all outstanding receivables including interest receivables on accounts and securities accounts and income from se-

curities sold but not yet delivered;

- all assets held by the Sub-Fund or acquired on its behalf;
- all other assets including expenses paid in advance.
The assets of each Sub-Fund shall be valued in accordance with the following rules:
- Shares in Investee Companies shall initially be valued immediately based on their acquisition costs incl. initial acquisition

expenses and subsequently based on the last available quarterly and annual reports for the Investee Companies prepared
regularly on the basis of the guidelines of the relevant national and international venture capital or private equity asso-
ciations.

- This proportionate net asset value determined on the basis of the last available reports shall be adjusted for subsequent

payment flows such as calls for capital, distributions and results notifications of the Investee Companies (in case of a
reporting date which precedes the valuation date of the Sub-Fund). Furthermore, additional information provided by the
manager of the Investee Company regarding events and developments of the Investee Company itself or at the level of
an underlying company holding will be included in the assessment, insofar as such information has a material influence on
the valuation of the share in the Investee Company.

- Other private equity investments shall be valued on the basis of the "International Private Equity and Venture Capital

Valuation Guidelines" issued by the Association Française des Investisseurs en Capital, the British Venture Capital Asso-
ciation and the European Venture Capital Association (EVCA).

- The value of cash or bank balances, deposit certificates and outstanding claims, prepaid expenses, cash dividends and

declared or accrued interest not yet received or other money market instruments corresponds to the full sum, unless
this can most probably not be paid or received in full. In such cases, the value will be defined by applying an appropriate
discount in order to obtain the real value. If reasons for such a value reduction no longer exist, a corresponding appre-
ciation must be made.

- Shares in money market funds will be valued at the last known redemption price.
If specific circumstances render the valuation based on the above rules impossible or inaccurate, the respective Sub-

Fund shall be entitled to apply other generally recognized or verifiable valuation criteria in order to obtain an appropriate
valuation of the net assets.

The value of shares in Investee Companies and of other assets not denominated in the individual Sub-Fund currency

shall be converted to the individual Sub-Fund currency at the exchange rate on the valuation date.

The net asset value of the individual Sub-Fund may be obtained on each bank business day at the Company’s registered

office.

The liabilities of the respective Sub-Fund may include:
- all loans and claims against the Sub-Fund;
- costs incurred and payable by the Sub-Fund (including costs for the central administration agent, lawyers, the In-

vestment Adviser and costs of the Depositary);

19542

L

U X E M B O U R G

- all known current and future liabilities, including payment obligations from contractual liabilities due and Sub-Fund

dividends determined but not yet paid;

- Sub-Fund provisions approved and accepted by the Board of Directors; and
- all other liabilities of the Sub-Fund.
The individual costs charged to the Sub-Funds are described in detail in the Offering Memorandum.

Art. 12. Suspension of the calculation of net asset value. The Board of Directors is entitled to temporarily suspend

the calculation of the net asset value of the shares of a Sub-Fund under the following circumstances:

- if, owing to events outside the responsibility or control of the Company, normal disposition over the net assets of

a Sub-Fund is impossible without seriously harming the interests of the shareholders;

- if, owing to a breakdown of communications or for any other reason, the value of a significant part of the net assets

of a Sub-Fund cannot be determined;

- if restrictions on foreign exchange or capital transactions prevent the processing of transactions for a Sub-Fund’s

account;

- if a general meeting has been convened for the purpose of liquidating the Company or a Sub-Fund.
Suspension of calculation of the net asset value shall be notified to shareholders by mail at the addresses entered in

the shareholders’ register.

Art. 13. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three

directors, who need not be shareholders of the Company. Directors shall be elected for a maximum term of six years.
The Board of Directors shall be elected by the shareholders in the context of the general meeting; the general meeting
shall also decide on the number of directors, their remuneration and the duration of their term in office.

The directors shall be elected by the majority of the votes from the shareholders present and represented at the

general meeting concerned.

Each director may at any time be removed or replaced by resolution of the general meeting and without specifying a

reason.

Upon the loss of a sitting director, the remaining directors may temporarily fill the missing position by co-opting an

additional director; at the next general meeting, the shareholders shall make a final decision regarding the appointment.

Art. 14. The powers of the Board of Directors. The Board of Directors shall have comprehensive power to execute

all decisions and administrative actions within the context of the Company's corporate object and in accordance with the
Company’s investment policy, as set forth in the Offering Memorandum.

All  powers  not  expressly  reserved  by  law  or  by  these  Articles  of  Incorporation  for  the  general  meeting  may  be

performed by the Board of Directors.

Art. 15. Transferring powers. The Board of Directors may transfer its powers in conjunction with the of day-to-day

management of the Company (including the authorisation to act as authorised signatory for the Company) and its powers
to execute acts within the context of the management policy and of the Company's corporate object to one or several
natural or legal persons, whereby these natural or legal persons need not be directors and have the powers determined
by the Board of Directors, and can further delegate these powers, subject to the approval of the Board of Directors.

The Company may, as detailed in the Company's Offering Memorandum, conclude an investment advisory agreement

with one or more company (companies) ("Investment Adviser") regarding the Company or the individual Sub-Funds,
which should make recommendations to and advise the Company with regard to the investment policy of the Company
or the individual Sub-Funds.

The Board of Directors may also transfer individual powers of attorney by notarial acts or private deeds.

Art. 16. Board of Directors meeting. The Board of Directors shall appoint a chairman from its members. He may

appoint a secretary, who need not be a director and who takes and preserves the minutes of the Board of Directors
meetings and general meetings. The Board of Directors shall meet following an invitation by the chairman of the Board
of Directors or two directors at the location indicated in the invitation.

The chairman of the Board of Directors shall preside over the Board of Directors meetings and general meetings. In

his absence, the shareholders or the directors may mandate a different director, or in the case of the general meeting, a
different person, to preside over the respective meeting.

The directors shall be invited in writing to each Board of Directors meeting at least 14 (fourteen) days prior to the

corresponding date, except in the cases of emergency, for which the nature of the emergency shall be noted in the
invitation. This invitation may be waived unanimously in writing, by fax or similar means of communication. An invitation
is not required for meetings held at times and places that were previously decided in a Board of Directors resolution.

Each director may be represented by a different director or a different person at each Board of Directors meeting via

power of attorney conveyed in writing, where applicable, by fax or a similar means of communication. One single director
may represent several of his colleagues.

19543

L

U X E M B O U R G

Each director may participate in a Board of Directors meeting via teleconference or similar means of communication

that enable all participants in the meeting to hear each other; this participation shall be equal to participating in the meeting
personally.

The Board of Directors may only act upon Board of Directors meetings properly convened. The directors may not

bind the Company by individual signatures, except in the case of a resolution by the Board of Directors providing express,
corresponding authorisation.

The Board of Directors may only pass valid resolutions or take actions if at least the majority of the directors are

present or represented.

The minutes for the Board of Directors resolutions shall be taken and these minutes shall be signed by the chairman

who presided over the Board of Directors meeting. Excerpts from these minutes, which are to be created for evidentiary
purposes in legal or other proceedings, shall be legally signed by the chairman who presided over the Board of Directors
meeting or two directors.

Resolutions shall be passed by a majority of the directors present and represented. In the event of a tied vote, the

chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.

Written circular resolutions that are approved and signed by all the directors shall be equivalent to resolutions passed

at Board of Directors meetings. Each director may approve such resolutions in writing, by telegram, telex, fax or similar
means of communication. This approval is to be confirmed in writing and the entirety of the documents shall form the
record for proof of the resolutions passed.

Art. 17. Signatory power. The Company shall be legally bound to third parties by the joint signatures of two directors

or by the single or joint signatures of persons who were authorized for this purpose by the Board of Directors.

Art. 18. Remuneration of the Board of Directors. Remuneration of directors shall be determined by the general

meeting. This remuneration shall also comprise expenses and other costs that arise for the directors in pursuit of their
business, including any costs for measures related to legal proceedings, unless such measures are the result of wilful
misconduct or gross negligence on the part of the director concerned.

Art. 19. General meeting. The general meeting represents all the Company’s shareholders. Its resolutions shall be

binding for all shareholders. It shall have the comprehensive power to order, execute or approve actions in conjunction
with the Company’s business.

The general meeting shall meet upon invitation by the Board of Directors.
It may also meet upon request by shareholders who represent at least one tenth of the Company’s assets.
In accordance with provisions set forth by Luxembourg law, the annual general meeting shall be held at a place to be

specified in the invitation in Luxembourg on the last Wednesday of the month of June at 4 p.m.

If this date is a public holiday or bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the last

preceding bank business day.

Other general meetings may be held at such locations and at such times as specified in the respective invitation.
The shareholders shall meet upon invitation of the Board of Directors; this invitation shall include the agenda and must

be sent to each holder of registered shares to the address entered in the shareholders' register at least eight days prior
to the general meeting. The notification to the owners of registered shares need not be proven at the meeting. The
agenda shall be prepared by the Board of Directors, except in cases where the meeting is convened upon written request
by the shareholders, in which case the Board of Directors may prepare an additional agenda.

Since all shares are issued as registered shares and no publications are carried out, the invitation to the shareholders

may only be sent by registered mail.

Provided all shareholders are present or represented and consider themselves to be properly convened and to have

been informed of the agenda, the general meeting may take place without a written invitation.

The Board of Directors may set all other conditions that the shareholders must meet to participate in a general meeting.
At the general meeting, only those items shall be addressed that are contained on the agenda (the agenda shall contain

all legally required items).

Each share shall represent one vote. A shareholder may be represented at any general meeting by giving a written

power of attorney to another person who need not be a shareholder and may be a director.

Unless otherwise provided for by law or in these Articles of Incorporation, the resolutions at the general meeting shall

be passed by a simple majority of the votes of shareholders present or represented.

Art. 20. General meetings of shareholders of a Sub-Fund or a share class. The shareholders of a share class or a Sub-

Fund may hold a general meeting at any time in order to decide on procedures pertaining exclusively to that share class
or that Sub-Fund. The relevant provisions of article 19 shall apply correspondingly to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in accordance with the provisions of Luxembourg law and these Articles of Incor-

poration. Shareholders may act either in person or by another person having a related power of attorney and who need
not be a shareholder and may be a director.

19544

L

U X E M B O U R G

Unless otherwise provided for by law or in these Articles of Incorporation, the resolutions at the general meeting of

shareholders of a share class or a Sub-Fund shall be passed by a simple majority of the votes of shareholders present or
represented.

The general meeting of shareholders of a Sub-Fund may instruct the Board of Directors to terminate the investment

advisory agreement concluded between the Company and the Investment Adviser for the respective Sub-Fund. Any such
resolution by the general meeting shall only be valid if over half the share capital of the Sub-Fund was present when the
resolution was passed and the resolution was carried by over two-thirds of the votes cast. The Board of Directors of
the Company must comply with a valid resolution to terminate the investment advisory agreement.

Art. 21. Advisory Committee. An Advisory Committee may be installed for each Sub-Fund in accordance with the

rules set out in the Offering Memorandum published by the Company.

Art. 22. Depositary. As part of its legal obligations, the Company shall enter into a depositary bank agreement with a

bank as defined by the Law of April 5 

th

 1993 on the financial sector (hereinafter referred to as the "Depositary").

The Depositary shall fulfil the obligations and assume the responsibility as provided for by the applicable legal provisions.
Both the Depositary and the Company are entitled to terminate the depositary bank agreement at any time in accor-

dance with the depositary bank agreement. In this case, the Board of Directors shall make every effort to appoint another
bank as Depositary within two months with the approval of the supervisory authority responsible. Until a new bank has
been appointed Depositary, the previous Depositary shall continue to fulfil its duties as Depositary to the fullest extent
in order to protect the interests of the shareholders.

Art. 23. Auditor. The accounting data in the Company's annual report (which shall include, among other things, a

balance sheet or an asset statement, a financial accounting divided into income and expenses for the respective business
year as well as a report on the business activities in the past business year) shall be audited by an independent auditor
(réviseur d'entreprises agréé), who shall be appointed by the general meeting and paid by the Company.

The auditor shall fulfil all obligations as defined by the applicable legal provisions.

Art. 24. Business year. The Company's financial year begins on 1 January of each year and ends on 31 

st

 December of

the same year. The first business year shall end on 31 

st

 December 2011.

The Company’s annual financial statements shall be prepared in the respective currency of the Company’s capital, i.e.

in euro.

Art. 25. Distributions. The application of the annual returns shall be determined by the Company’s general meeting

on the recommendation of the Board of Directors.

The distribution of net income from investments may occur independently of realised or unrealised capital losses or

gains. The Company shall distribute free liquidity as soon as possible after the collection thereof.

When determining the amount to be distributed, a suitable liquidity reserve shall be ensured to meet the costs and

expenses of the Company and/or the Sub-Funds.

The Board of Directors may elect to pay out interim distributions in accordance with the law. A resolution regarding

the interim distributions does not require a resolution of the general meeting. Distributions may occur both during the
business year as well as at the end of the year while applying the surplus realised in the respective period. The amount
of the unrealised changes to the returns of the period is irrelevant in this case.

Distributions to the holders of registered shares shall be paid to the bank accounts entered in the shareholders’

register.

Distributions shall be paid in euro on a date and at a place determined by the Board of Directors at the appropriate

time.

Art. 26. Dissolution of the Company. The Company may be dissolved at any time by resolution of the general meeting.

This resolution shall only be valid if at least 75% of the shares in issue are represented at the general meeting and at least
75% of the shares with voting rights represented at such general meeting vote in favour of this resolution.

Provided the corporate capital falls below two-thirds of the minimum corporate capital as per article 5 of these Articles

of Incorporation, the Board of Directors shall submit the question of dissolving the Company to the general meeting.
The general meeting, which may be held without a quorum requirement, shall decide by simple majority of the shares
represented at the general meeting.

Furthermore, the question of dissolving the Company shall also be submitted to the general meeting, provided the

corporate capital falls below one-quarter of the minimum corporate capital as per article 5 of these Articles of Incorpo-
ration. In this case, the general meeting shall decide without a quorum requirement and the decision to dissolve the
Company may be made by shareholders holding a quarter of the shares with voting rights represented at the general
meeting.

The meeting must be convened in a timely manner such that it can be held within forty days of determining that the

corporate capital has fallen below two-thirds or one-quarter of the legal minimum respectively.

19545

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Dissolution of Sub-Funds. The general meeting of a Sub-Fund may elect to dissolve the respective Sub-Fund

or one or more share class(es); in this case, the shares concerned are cancelled and the shareholders concerned are
refunded the net asset value of the shares from the respective Sub-Fund or share class(es).

The general meeting of the Sub-Fund is entitled to pass such a resolution:
- if there is an essential change in the social, political or economic situation in the countries where investments for the

respective Sub-Fund are made or where the shares of this Sub-Fund are offered for sale, or

- insofar as the value of the assets of the respective Sub-Fund falls to such an extent that it is no longer possible to

guarantee the economically efficient management of this Sub-Fund, or

- as part of rationalisation measures.
The Company must inform the relevant shareholders about the decision of the general meeting of a Sub-Fund to

dissolve such Sub-Fund.

Any proceeds of liquidation not claimed by the shareholders after conclusion of the liquidation shall remain deposited

at the Depositary for a period of 6 (six) months and shall then be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg,
where they will be forfeited after 30 (thirty) years.

Art. 28. Liquidation. The liquidation of the Company in the event of a dissolution as per article 25 of these Articles of

Incorporation shall be executed by one or more liquidators; these may be natural or legal persons and shall be appointed
by the general meeting, which shall also decide on their powers and remuneration.

Any proceeds of liquidation not claimed by the shareholders after conclusion of the liquidation shall remain deposited

at the Depositary for a period of 9 (nine) months from the time when the respective liquidation was decided and shall
then be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg, where they will be forfeited after 30 (thirty) years.

Art. 29. Amendments to these Articles of Incorporation. The Articles of Incorporation may be amended by a general

meeting, which is subject to the quorum and majority requirements as per the Law of August 10 

th

 1915 on Commercial

Companies, including subsequent amendments and addenda.

Art. 30. Conflicts of interest. Contracts and other transactions between the Company and any other company or

enterprise shall not be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or employees of the
Company is personally interested in this other company or enterprise or is a director, shareholder, manager or employee
there. Each director and each manager of the Company, who is employed as a director, manager or simple employee in
a company or enterprise with which the Company concludes contracts or enters into other business relationships, shall
not be prevented from advising, voting or acting in connection with such a contract or such a business relationship by
this connection to this other company or enterprise.

If a director or a manager of the Company has a personal interest in connection with a business transaction of the

Company, this director or this manager shall inform the Board of Directors of this personal interest and shall refrain
from advising or voting in connection with this business transaction. This business transaction and the director's or
manager's personal interest shall be reported to the next general meeting.

Art. 31. Applicable law and jurisdiction. All issues that are not regulated by these Articles of Incorporation shall be

regulated by the provisions of the Law of August 10 

th

 1915 on Commercial Companies and by the Law of 2007 including

any subsequent changes or amendments to the respective laws.

<i>Subscription of the initial capital

The initial capital shall be subscribed as follows:
“DB Private Equity GmbH”, aforementioned, shall subscribe for 4 (four) shares at the equivalent of EUR 40,000.- (forty

thousand Euros).

Thus, the initial capital is EUR 40,000.- (forty thousand Euros) in total. The payment of the entire initial capital has

been properly proven to the undersigning notary.

<i>Declaration

The undersigned notary hereby declares that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of

August 10 

th

 1915 on Commercial Companies are met and hereby certifies this fact expressly.

<i>Founding general meeting of the Company

The aforementioned founding shareholder, who represents the entire subscribed initial capital, has promptly held a

general meeting, to which it hereby avows it was legally invited, and has passed these resolutions:

I. The following persons are hereby appointed as directors:
- Mr Ekkehart Kessel, Sal. Oppenheim PEP International S.à r.l., born on January 22 

nd

 1942 in Aachen, Germany,

professionally domiciled at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Luxembourg;

- Mr Andreas Schmidt, DB Private Equity GmbH, born on October 17 

th

 1974 in Siegen, Germany, professionally

domiciled at Zeppelinstrasse 4-8, D50667 Cologne, Germany; and

19546

L

U X E M B O U R G

-  Mr  Andrew  Reid,  born  on  16  May  1972  in  Glasgow,  Scotland,  professionally  domiciled  at  2,  boulevard  Konrad

Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxembourg.

Mr Ekkehart Kessel is hereby named chairman of the Board of Directors.
The mandates of the directors shall end with the ordinary general meeting in 2015.
II. The Company's registered office shall be at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

III. The first ordinary general meeting shall take place on June 27 

th

 2012.

IV. The following company is hereby appointed as auditor:
“KPMG Audit”, a société à responsabilité limitée, with registered office at 9, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Lu-

xembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 103.590).

The mandate of the auditor shall end with the ordinary general meeting in 2012.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing persons, in
case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
And  after  presenting  and  explaining  everything  in  the  preceding  to  the  appearing  parties,  who  are  known  to  the

undersigned notary by name, civil status and residence, these parties have signed this document with the notary.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahre zweitausendelf, am sechzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

„DB Private Equity GmbH“, eine Gesellschaft gegründet und bestehend unter deutschem Recht, mit Sitz in Zeppelin-

straße 4-8, D-50667 Köln, Deutschland,

hier  vertreten  durch  Herrn  Tobias  Lochen,  Rechtsanwalt,  beruflich  ansässig  in  L-1011  Luxemburg,  gemäß  privat-

schriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Köln (Deutscland), am 14. Februar 2011.

Die erteilte Vollmacht, nachdem sie „ne varietur“ durch den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei und dem

amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleibt diesem Dokument beigefügt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründet, wie folgt zu

beurkunden:

Satzung

Art. 1. Name. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft

mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds («société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé» oder «SICAV - FIS») und führt den Namen „DB PEP V“ (die «Gesellschaft»).

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfa-

chen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Groß-
herzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse statt-

gefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen
Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszu-
gehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben. Die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung dieser Satzung. Die Laufzeit der Gesellschaft

ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Anlage ihres Vermögens in

gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen, nachrangigen Forderungen und/oder Genussrechten von Private Equity-Fonds und
Beteiligungsgesellschaften,  (insbesondere  in  Form  von  Buy-out-,  Growth  Capital-,  Special-Situation-  und  Secondary-
Fonds), deren Anlagestrategie im Schwerpunkt auf Eigenkapitalfinanzierung von Unternehmen ausgerichtet ist, mit dem
Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse ihres Vermögens zugutekommen zu lassen.
Dabei sind die Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft bzw. der Teilfonds, wie sie in dem von der Gesellschaft
herausgegebenen Emissionsdokument beschrieben werden, zu berücksichtigen. Die betreffenden Anlagen können ent-
weder direkt oder über Tochtergesellschaften vorgenommen werden.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Aus-

führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom
13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (im folgenden “Gesetz von 2007“ genannt).

19547

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu

jeder Zeit dem Nettoinventarwert gemäß nachfolgendem Artikel 11 entsprechen. Das Gesellschaftskapital wird in Euro
ausgedrückt. Das Gründungskapital beträgt 40.000,- EUR (vierzigtausend Euro) und ist in 4 (vier) Aktien ohne Nennwert
eingeteilt. Das Mindestgesellschaftskapital von mindestens 1.250.000,- EUR (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro)
muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxem-
burger Recht erreicht werden. Das Gesellschaftskapital muss sich danach zu jedem Zeitpunkt auf mindestens 1.250.000,-
EUR (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) belaufen.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Gesellschaft verschiedenen zu errichtenden Teil-

fonds  (die  “Teilfonds“)  zugehörig  sind,  welche  wiederum  in  unterschiedlichen  Währungen  notiert  sein  können.  Der
Verwaltungsrat kann außerdem bestimmen, dass innerhalb eines Teilfonds mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen
Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische
Gebührenstruktur oder andere spezifischen Merkmale wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdo-
kument der Gesellschaft beschrieben. Die Laufzeit eines jedenTeilfonds wird vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung
mit den Regelungen des Emissionsdokuments festgelegt.

Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Emissionsdokuments der Ge-

sellschaft in Beteiligungsgesellschaften und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, entsprechend der
durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich festgelegten oder durch den
Verwaltungsrat aufgestellten Anlagegrenzen.

Art. 6. Veränderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit der

ausgegebenen Aktien. Die Summe der auf die Aktien eingezahlten Beträge entspricht dem Nettovermögen der Gesell-
schaft  (im  folgenden  “Gesamtnettovermögen“  genannt).  Das  Gesellschaftskapital  kann  sich  infolge  der  Ausgabe  von
weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

Art. 7. Namensaktien und Aktienzertifikate. Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich als Namensaktien ausge-

geben.

Für diese Namensaktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält

den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum
der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat
bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Aktienzertifikate zu Namensaktien werden lediglich auf Antrag und Kosten des betreffenden Aktionärs ausgestellt. Es

wird dem Aktionär jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister zugestellt. Beantragte Aktienzer-
tifikate werden binnen eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten
Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einer vom Verwal-
tungsrat zu diesem Zweck beauftragten Person unterzeichnet.

Um zu gewährleisten, dass die Aktionäre der Gesellschaft zu jeder Zeit 1) den Anforderungen des Gesetzes von 2007

entsprechen, 2) die Anzahl der sachkundigen Investoren im Sinne des Gesetzes von 2007 pro Teilfonds 100 (einhundert)
nicht übersteigt und 3) natürliche Personen nicht direkt beteiligtsind, benötigen Übertragungen von Aktien die vorherige
Zustimmung des Verwaltungsrats. Der Käufer kann nur ein sachkundiger Investor im Sinne von Artikel 2 des genannten
Gesetzes sein. Die Aktien der Gesellschaft werden von sachkundigen Investoren gehalten und der Käufer übernimmt voll
und ganz die restlichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft.

Abweichend hiervon sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Vermögen eines Versicherungsunternehmens,

eines deutschen Pensionsfonds, eines deutschen Versorgungswerks oder eines anderen Anlegers, der bei seiner Kapital-
anlage den Vorschriften des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes unterliegt, gehalten werden oder die von Kapital-
anlagegesellschaften auf Rechnung von Sondervermögen gehalten werden, ungeachtet der für andere Investoren geltenden
Übertragungsbeschränkungen zulässig und bedürfen keiner Genehmigung des Verwaltungsrates, sofern (i) der Übertra-
gungsempfänger  eine  Versicherung,  ein  Sozialversicherungsträger,  eine  Pensionseinrichtung,  eine  Kapitalanlagegesell-
schaft, eine Stiftung oder ein Kreditinstitut ist oder (ii) der Übertragungsempfänger ein anderer institutioneller Investor
ist, der entweder über ausreichende Bonität (Investmentgrade-Rating) oder ausreichende geeignete Sicherheiten verfügt
und (iii) die Übertragung nicht zur Folge hat, dass nichterwerbsberechtigte Personen Aktien halten und die Zahl der
Aktionäre insgesamt 100 (einhundert) nicht übersteigt. Als "Übertragung" gelten insbesondere der Verkauf, der Tausch,
die Übertragung und die Abtretung von Aktien. Mit der Übertragung übernimmt der Übertragungsempfänger sämtliche
Verbindlichkeiten und Verpflichtungen sowie die alleinige Haftung in Bezug auf diese Aktien; eine (subsidiäre) Haftung für
diese Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten durch den bisherigen Investor ist nach Verfügung über die Aktien ausge-
schlossen (keine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und Erwerber). Derartige Verpflichtungen gehen mit
schuldbefreiender Wirkung für den Veräußerer auf den Erwerber über.

Soweit und solange Aktien als Teil des Sicherungsvermögens eines Versicherungsunternehmens gehalten werden, darf

über diese Aktien nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen oder seines
Stellvertreters verfügt werden, soweit das Versicherungsunternehmen einen Treuhänder im Sinne des § 70 des deutschen
Versicherungsaufsichtsgesetzes bestellt hat.

19548

L

U X E M B O U R G

Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so

muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Investor im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 (eine Direktanlage
durch natürliche Personen ist ausgeschlossen) sein.

Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister

eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen
unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft
kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.

Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Gesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsregister mit-

teilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle
Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Namensaktien können rechtsverbindlich
an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderung
seiner Adresse im Register beantragen.

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das

Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein,
bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die gemäß Artikel 28 (3) des Gesetzes von

2007 notwendige Einzahlung von mindestens 5 (fünf) Prozent pro Aktie eingegangen ist.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder

eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeit-
punkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und
Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht,

berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis.

Art. 8. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten . Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeug-

ender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört
worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der
Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkunden-
forderung,  die  durch  eine  Bank,  einen  Börsenmakler  oder  eine  andere  Partei  zur  Zufriedenheit  der  Gesellschaft
unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein
Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausge-

tauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und
werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten

zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und
Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

Art. 9. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern vorbe-

halten  (eine  Direktanlage  durch  natürliche  Personen  ist  ausgeschlossen).  Des  Weiteren  kann  die  Gesellschaft  nach
eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie
der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktieninhaber oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird;

oder

- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern, wenn es offenkundig ist, dass

diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge haben würde, den Aktienbesitz auf eine andere Person zu übertragen, die
nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,

b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist,

Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem

solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als
Luxemburg auf die Gesellschaft zur Folge hat.

In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:
i. Die Gesellschaft wird dem betreffenden Aktionär, eine Benachrichtigung (im folgenden "Rückkaufsbenachrichtigung“

genannt) zusenden. Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden Rückkaufs-
preis  und  den  Ort,  wo  dieser  Preis  zu  bezahlen  ist,  an.  Die  Rückkaufsbenachrichtigung  kann  dem  Aktionär  durch

19549

L

U X E M B O U R G

Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden.
Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die
die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrich-
tigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Eigentümer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten
Aktien. Die Aktienzertifikate, die die entsprechenden Aktien verkörpern, werden annulliert.

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden

“Rückkaufspreis“ genannt), entspricht grundsätzlich dem Nettoinventarwert der ausgegeben Aktien am Bewertungstag,
an dem der Rückkauf vollzogen werden soll.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo

ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufs-
preis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegeben Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbe-
nachrichtigung  aufgeführten  Aktien  verkörpern,  auszahlen.  Nach  Hinterlegung  des  Rückkaufspreises  gemäß  diesen
Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine
Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon aus-
genommen  ist  das  Recht  des  sich  als  rechtmäßiger  Besitzer  der  Aktien  ausweisenden  Aktionärs,  den  hinterlegten
Rückkaufspreis gegen Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt
zu bekommen.

iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen

Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimm-

recht aberkennen.

Art. 10. Ausgabe, Rückkauf und Umtausch von Aktien. Die Summe der von den Investoren innerhalb der Zeichnungs-

perioden in den Zeichnungsvereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen ergibt das maximale Zeichnungskapital des
jeweiligen Teilfonds, die Summe der maximalen Zeichnungskapitalien der Teilfonds ergibt das maximale Zeichnungskapital
der Gesellschaft, zu deren Einzahlung sich die Aktionäre der Teilfonds verpflichtet haben (“Zeichnungsvolumen“). Der
Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zu diesem verpflichteten Zeichnungskapital zu jeder Zeit neue Aktien
an sachkundige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 (eine Direktanlage durch natürliche Personen
ist ausgeschlossen) auszugeben. Zeichnungen werden am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz der von der Gesellschaft
benannten Institutionen entgegengenommen.

Zur Gültigkeit der Neuzeichnung der Aktien ist erforderlich, dass diese voll eingezahlt sind. Neu ausgegebene Aktien

haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage der Aktienausgabe in Umlauf waren.

Die Zahlung des für die jeweils auszugebenden Aktien zu entrichtenden Betrages wird durch schriftliche Aufforderung

des Verwaltungsrates innerhalb der im Aufforderungsschreiben genannten Frist zur Zahlung fällig.

Leistet ein Aktionär im Falle eines Kapitalabrufs die Zahlung einer Aktientranche nicht bei Fälligkeit, kommt er ohne

das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der
säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von p. a. 8 Prozentpunkten über dem Dreimonats-
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) am Fälligkeitstag (lt. www.reuters.com).

Leistet ein säumiger Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzugs abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht

innerhalb einer Frist von vier Wochen die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, ist der Ver-
waltungsrat berechtigt, in seinem freien Ermessen eines oder mehrere (kumulativ) der nachfolgenden Rechte gegenüber
dem säumigen Aktionär wahrzunehmen. Bestehende gesetzliche oder andere vertragliche Ansprüche des Teilfonds wer-
den davon nur insoweit berührt, wie sie aus der Ausübung der nachfolgenden Rechte unmittelbar ausgeschlossen werden.

(i) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann sämtliche Aktien des säumigen Aktionärs durch schriftliche Erklärung

gemäß dem in Artikel 9 beschriebenen Verfahren zugunsten des Teilfonds zurückkaufen. Im Falle des Rückkaufs verliert
der säumige Aktionär sämtliche Aktionärsrechte, insbesondere Stimmrechte, sowie das Recht, an künftigen Kapitalein-
zahlungen oder Ausschüttungen zu partizipieren.

In diesem Falle schuldet der Teilfonds dem säumigen Aktionär einen Rückkaufpreis, dessen Gesamthöhe sich wie folgt

ermittelt:

Der säumige Aktionär erhält insgesamt 50% der von ihm geleisteten Kapitaleinzahlungen, gemindert um bereits erfolgte

Ausschüttungen, maximal jedoch 50% des anteiligen Nettoinventarwerts seiner Aktien zum Zeitpunkt des Rückkaufs.

Der Rückkaufpreis reduziert sich außerdem um aufgelaufene Verzugszinsen und einen etwaigen Verzugsschaden des

Teilfonds, z. B. aus Zwischenfinanzierungskosten, Rechtsberatungskosten oder Schäden aus dem Verzug des Teilfonds
gegenüber Beteiligungsprogrammen oder Direktbeteiligungen.

Der ermittelte Rückkaufpreis ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu

denen der Teilfonds Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt. Jede Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen
Betrag, den der säumige Aktionär erhalten hätte, wenn seine Aktien nicht zurückgekauft worden wären. Die einzelnen
Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

19550

L

U X E M B O U R G

(ii) Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Aktien des säumigen Aktionärs teilweise oder vollständig an Dritte sach-

kundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 zu einem vom Verwaltungsrat bestimmten Marktpreis zu
veräußern, wobei zusätzliche Kaufpreisabschläge von bis zu 15% vom ermittelten Marktpreis zulässig sind.

Die Bestimmung des Marktpreises liegt im Ermessen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat dabei insbesondere

die ihm aus dem Markt bekannten Abschläge beim Verkauf von Aktien an geschlossenen Fonds zu berücksichtigen. Der
Verwaltungsrat ist jedoch nicht verpflichtet, zur Bestimmung des Marktpreises Untersuchungen des Marktes vorzuneh-
men oder Angebote Dritter einzuholen.

Zur Durchführung des Verkaufs im Falle des Verzugs bevollmächtigt der Aktionär die Gesellschaft, alle erforderlichen

Erklärungen abgeben und Handlungen vornehmen zu dürfen (einschließlich der Erteilung entsprechender Untervollmach-
ten), um einen wirksamen Verkauf und einewirksame Übertragung der Aktien des säumigen Aktionärs auf einen Dritten
zu bewirken. Der erzielte Kaufpreis ist zunächst vollständig für die Begleichung der Verbindlichkeiten des säumigen Ak-
tionärs gegenüber der Gesellschaft zu verwenden.

(iii) Der Verwaltungsrat ist schließlich berechtigt, dem säumigen Aktionär das Recht zur Übernahme von Aktien im

Rahmen seiner Zeichnungsverpflichtung zu entziehen und alle weiteren Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass
der säumige Aktionär nicht besser steht, als er stünde, wenn er seine Aktienübernahme- und Kapitaleinlageverpflichtungen
bei Fälligkeit erfüllt hätte.

(iv) Der Verwaltungsrat kann erklären, dass das Stimmrecht der Aktionäre für die Dauer des Verzugs ruhen soll.
(v) Anstelle der vorstehenden Maßnahmen (i) und (ii) aber ggf. zusätzlich zu den Maßnahmen (iii) und (iv) kann die

Gesellschaft 25% der Aktien des säumigen Aktionärs ohne Gegenleistung einziehen.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder je-

derzeit  ohne  vorherige  Mitteilung  die  Ausgabe  von  Aktien  auszusetzen.  Der  Verwaltungsrat  kann  die  Häufigkeit  der
Aktienausgabe limitieren. Nach der Erstemission im Rahmen der im Emissionsdokument beschriebenen Zeichnungspe-
rioden erfolgt die Ausgabe von Aktien zum Preis von 10.000 (zehntausend) Euro.

Die Rücknahme aller oder eines Teils der Aktien eines Aktionärs auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vor-

gesehen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurück-

zukaufen, um eingezahltes und frei gewordenes Kapital an alle Aktionäre zurückzuführen. Der Rücknahmepreis entspricht
grundsätzlich dem anteiligen Nettoinventarwert der Aktien am Bewertungstag, an dem die Rücknahmen vollzogen wer-
den. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil
am Kapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird den registrierten Aktionären die Entscheidung zum Rückkauf per
Post mitteilen und die Aktionäre über Anzahl der Aktien sowie die Berechnung des Rücknahmepreises informieren. Die
von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rück-
nahmepreis wird in Luxemburg spätestens 20 Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahme-
preises ausbezahlt.

Art. 11. Nettoinventarwert. Sollte eine Anlagetätigkeit der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds gemäß Artikel 4 dieser

Satzung und den Bestimmungen des Emissionsdokuments in seiner jeweils gültigen Fassung über Tochtergesellschaften
erfolgen, wird in der Buchhaltung der Gesellschaft unmittelbar auf den Wert der von den Tochtergesellschaften gehaltenen
Vermögenswerte, abzüglich der Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften, abgestellt. In diesem Fall wird der Wert der
Beteiligungen an den Tochtergesellschaften bei der Berechnung des Nettoinventarwerts nicht berücksichtigt. Die Be-
wertung  der  von  den  Tochtergesellschaften  gehaltenen  Vermögenswerte erfolgt  nach den nachstehend  ausgeführten
Regelungen.

Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien berechnet wird, wird im Weiteren als "Bewertungstag" bezeich-

net.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wird in der jeweiligen Teilfondswährung ausgedrückt und wird für jede Aktie der

Gesellschaft dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen jedes Teilfonds, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbind-
lichkeiten,  durch  die  Zahl  der  am  Bewertungstag  im  Umlauf  befindlichen  Aktien  dieses  Teilfonds  geteilt  wird.  Der
Nettoinventarwert der Aktie wird auf die zweite Dezimalzahl gerundet.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Aktienausgaben und -rückkäufen wird das Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds

wie folgt angepasst:

- falls eine Dividende je Aktie ausgezahlt wird, verringert sich der Nettoinventarwert des Teilfonds um den Betrag der

Dividendenausschüttung;

- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen des Teilfonds

um den erhaltenen oder ausgezahlten Betrag.

Die Aktiva jedes Teilfonds können beinhalten:
- Gesellschaftsanteile;
- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- durch den Teilfonds gehaltene Anteile und sonstige Wertpapiere;

19551

L

U X E M B O U R G

- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften,

aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;

- alle Vermögenswerte, die von dem Teilfonds gehalten werden oder zu seinen Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.
Die Aktiva jedes Teilfonds werden nach folgenden Regeln bewertet:
- Anteile an Beteiligungsgesellschaften werden unmittelbar zu Beginn mit ihren Anschaffungskosten (inkl. Anschaf-

fungsnebenkosten)  und  nachfolgend  anhand  der  letztverfügbaren  Quartals-  und  Jahresberichte  der  Beteiligungsgesell-
schaften bewertet, die regelmäßig auf Basis von Bestimmungen der jeweiligen nationalen und internationalen Venture-
Capital- bzw. Private-Equity-Verbände erstellt werden.

- Dieser aus den letztverfügbaren Berichten ermittelbare anteilige Nettoinventarwert ist - bei einem dem Bewer-

tungstag des Teilfonds vorangehenden Berichtsstichtag - um anschließende Zahlungsflüsse wie Kapitalabrufe, Ausschüt-
tungen und Ergebnismitteilungen der Beteiligungsgesellschaften anzupassen. Darüber hinaus werden weitere Informatio-
nen des Managers der Beteiligungsgesellschaft über Ereignisse und Entwicklungen auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft
selbst oder dieser zugrunde liegenden Unternehmensbeteiligungen in die Beurteilung mit einbezogen, sofern sie einen
wesentlichen Einfluss auf die Bewertung des Anteils der Beteiligungsgesellschaft haben.

- Andere Private Equity Investments werden auf Basis der "International Private Equity and Venture Capital Valuation

Guidelines" bewertet, die durch die die "Association Française des Investisseurs en Capital", die "British Venture Capital
Association" und die "European Venture Capital Association" (EVCA) entwickelt worden sind.

- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, voraus-

bezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen oder sonstigen
Geldmarktinstrumenten entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt
oder erhalten werden kann. In diesen Fällen wird der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt,
um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Bestehen die Gründe für eine Wertminderung nicht mehr, ist eine entsprechende
Zuschreibung zu realisieren.

- Anteile an Geldmarktfonds werden zum letzten bekannten Rücknahmepreis bewertet.
Erweist sich aufgrund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurch-

führbar oder ungenau, ist der jeweilige Teilfonds berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungs-
kriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens sicherzustellen.

Der Wert der Anteile an Beteiligungsgesellschaften sowie andere Vermögenswerte, die nicht in der jeweiligen Teil-

fondswährung ausgedrückt sind, werden zum Fremdwährungskurs am Tag der Bewertung in die jeweilige Teilfondswäh-
rung umgerechnet.

Der Nettoinventarwert des jeweiligen Teilfonds kann an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft erhalten wer-

den.

Die Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds können umfassen:
- sämtliche Kredite und Forderungen gegen einen Teilfonds;
- angefallene und vom Teilfonds zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die Zentrale Verwaltungsstelle, Rechts-

und Anlageberatungskosten, Kosten für die Depotbank);

- sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus

fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden eines Teilfonds;

- vom Verwaltungsrat genehmigte und angenommene Rückstellungen des Teilfonds; und
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten des Teilfonds.
Die einzelnen den Teilfonds zu belastenden Kosten sind im Emissionsdokument näher beschrieben.

Art. 12. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des

Nettoinventarwerts der Aktien eines Teilfonds in den folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen,

eine normale Verfügung über das Nettovermögen eines Teilfonds unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre
schwerwiegend zu beeinträchtigen;

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem anderen Grund der Wert eines

beträchtlichen Teils des Nettovermögens eines Teilfonds nicht bestimmt werden kann;

- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung eines Teilfonds

verhindern;

- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft oder einen Teilfonds zu liqui-

dieren.

Die Aussetzung der Berechnung der Nettoinventarwerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister

eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Art. 13. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitglie-

dern besteht, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer

19552

L

U X E M B O U R G

von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der Generalversammlung
gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die
Dauer ihrer Amtszeit.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der Stimmen der auf der betreffenden Generalversammlung

anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Gene-

ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitglieds werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats die

fehlende Stelle zeitweilig durch Kooptation eines weiteren Verwaltungsratsmitglieds ausfüllen; die Aktionäre werden bei
der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-

und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks und im Einklang mit der Anlagepolitik der Gesellschaft,
wie sie im Emissionsdokument dargestellt ist, vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-

halten sind, können durch den Verwaltungsrat wahrgenommen werden.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen

Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu
handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschafts-
zweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder
des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden, und diese
Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen im Emissionsdokument der Gesellschaft beschrieben, einen Anlageberatungs-

vertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) ("Anlageberater") in Bezug auf die Gesellschaft oder auf die einzelnen
Teilfonds abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik der Gesellschaft oder der einzelnen Teilfonds der Ge-
sellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en).

Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

Art. 16. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er

kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der die Protokolle der Verwal-
tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwe-

senheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder,
im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens 14 (vierzehn) Tage vor dem

entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, bei denen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt
wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet
werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die
zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung mittels schriftlicher, gegebenenfalls durch

Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel übermittelter Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder
eine andere Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenz-

schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungs-

ratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen
entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der  Verwaltungsrat  kann  nur  dann  gültige  Beschlüsse  fassen  oder  Handlungen  vornehmen,  wenn  wenigstens  die

Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-

sitzung  unterzeichnet.  Auszüge  aus  diesen  Protokollen,  welche  zu  Beweiszwecken  in  gerichtlichen  oder  sonstigen
Verfahren  erstellt  werden,  sind  vom  Vorsitzenden  der  Verwaltungsratssitzung  oder  zwei  Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-

zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche

19553

L

U X E M B O U R G

Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird
schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Un-

terschrift  zweier  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  oder  durch  die  gemeinschaftliche  oder  einzelne  Unterschrift  von
Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 18. Vergütung des Verwaltungsrats. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der General-

versammlung  festgelegt.  Sie  umfassen  auch  Auslagen  und  sonstige  Kosten,  welche  den  Verwaltungsratsmitgliedern  in
Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn,
solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 19. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.

Ihre  Beschlüsse  binden  alle  Aktionäre.  Sie  hat  die  umfassende  Befugnis,  Handlungen  im  Zusammenhang  mit  der  Ge-
schäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,

zusammentreten.

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg

an einem in der Einladung angegebenen Ort am letzten Mittwoch des Monats Juni um 16.00 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung

am letzten vorangegangenen Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der

entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage

vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse
versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht
nachgewiesen  werden.  Die  Tagesordnung  wird  vom  Verwaltungsrat  vorbereitet,  außer  in  den  Fällen,  in  welchen  die
Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche
Tagesordnung vorbereiten kann.

Da sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die Einladung

an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die

Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind

(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).

Jede Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche

Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann,
vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-

neralversammlung durch die einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 20. Generalversammlungen der Aktionäre eines Teilfonds oder einer Aktienklasse. Die Aktionäre einer Aktien-

klasse oder eines Teilfonds können zu jeder Zeit eine Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden,
welche ausschließlich diese Aktienklasse beziehungsweise ausschließlich diesen Teilfonds betreffen. Die relevanten Be-
stimmungen in Artikel 19 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung.

Aktionäre können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär
sein muss, aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalver-

sammlung der Aktionäre einer Aktienklasse oder eines Teilfonds mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Die  Generalversammlung  der  Aktionäre  eines  Teilfonds  kann  den  Verwaltungsrat  der  Gesellschaft  anweisen,  den

Anlageberatungsvertrag, den die Gesellschaft für den jeweiligen Teilfonds mit dem Anlageberater abschließt, zu kündigen.
Ein solcher Beschluss der Generalversammlung ist nur wirksam, sofern bei der Beschlussfassung mehr als die Hälfte des
Aktienkapitals  des  Teilfonds  anwesend  war  und  der  positive  Beschluss  von  mehr  als  zwei  Dritteln  der  abgegebenen
Stimmen getragen wurde. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verpflichtet, einer gültigen Beschlussfassung zur Kün-
digung des Anlageberatungsvertrages Folge zu leisten.

19554

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Advisory Committee. Für jeden Teilfonds kann im Einklang mit den im Emissionsdokument der Gesellschaft

enthaltenen Regelungen ein Advisory Committee eingesetzt werden.

Art. 22. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer

Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit

dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um in-
nerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu
bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Akti-
onäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

Art. 23. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft (welcher u.a. eine Bilanz oder eine

Vermögensübersicht, eine nach Erträgen und Aufwendungen für das jeweilige Geschäftsjahr gegliederte Rechnungslegung
sowie einen Bericht über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr enthält) werden durch einen unabhängigen
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der
Gesellschaft bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. De-

zember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2011.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Euro,

aufgestellt.

Art. 25. Ausschüttungen. Die Verwendung des jährlichen Ergebnisses wird von der Generalversammlung auf Vorschlag

des Verwaltungsrates festgelegt.

Die Ausschüttung von Netto-Erträgen aus den Anlagen kann unabhängig von realisierten oder unrealisierten Kapital-

verlusten oder gewinnen erfolgen. Die Gesellschaft schüttet freie Liquidität so bald als möglich nach deren Vereinnahmung
aus. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der
Kosten und Ausgaben der Gesellschaft bzw. der Teilfonds zu achten.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Der

Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Generalversammlung. Ausschüttungen
dürfen sowohl unterjährig als auch zum Jahresende unter Verwendung des in der entsprechenden Periode realisierten
Überschusses erfolgen. Die Höhe der unrealisierten Veränderungen im Ergebnis der Periode ist hierbei unbeachtlich.

Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Namensaktien erfolgt an die im Aktionärsregister hinterlegte

Bankverbindung.

Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausgezahlt, wie dies der Verwaltungsrat zu

gegebener Zeit bestimmt.

Art. 26. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung

aufgelöst werden. Ein solcher Beschluss kann nur wirksam gefasst werden, wenn mindestens 75% der ausgegebenen Aktien
der Gesellschaft auf der Generalversammlung vertreten sind und die Generalversammlung der Auflösung mit mindestens
75% der auf dieser Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien zustimmen.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung

fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversamm-
lung, welche ohne Quorumserfordernis abgehalten werden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der General-
versammlung vertretenen Aktien entscheiden.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesell-

schaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt. In diesem Falle
wird die Generalversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre ent-
schieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der

Tatsache, dass das Gesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums gefallen ist,
abgehalten werden kann.

Art. 27. Auflösung von Teilfonds. Die Generalversammlung eines Teilfonds kann beschließen, den betreffenden Teil-

fonds  oder  eine  oder  mehrere  Aktienklassen  aufzulösen,  indem  die  betroffenen  Aktien  entwertet  werden  und  den
betroffenen Aktionären der Nettoinventarwert der Aktien dieses Teilfonds oder dieser Aktienklassen ausgezahlt wird.

Die Generalversammlung des Teilfonds ist befugt, einen solchen Beschluss zu fassen
- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen

Anlagen für den jeweiligen Teilfonds getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Teilfonds vertrieben werden, oder

19555

L

U X E M B O U R G

- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente Ver-

waltung dieses Teilfonds nicht mehr gewährleistet werden kann, oder

- im Rahmen einer Rationalisierung.
Die Gesellschaft hat die betroffenen Aktionäre über die durch die Generalversammlung des Teilfonds beschlossene

Auflösung dieses Teilfonds zu informieren.

Der Liquidationserlös, der von den Aktionären nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wird, bleibt bei der

Depotbank für einen Zeitraum von 6 (sechs) Monaten deponiert und wird anschließend bei der Caisse des Consignations
in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 (dreißig) Jahren verfällt.

Art. 28. Liquidierung. Die Liquidierung der Gesellschaft im Falle einer Auflösung gemäß Artikel 25 dieser Satzung wird

durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können
und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.

Der Liquidationserlös, der von den Aktionären nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wird, bleibt bei der

Depotbank für einen Zeitraum von 9 (neun) Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die jeweilige Liquidation beschlossen
wurde, deponiert und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 (dreißig)
Jahren verfällt.

Art. 29. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorums- und

Mehrheitserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgen-
der Änderungen und Ergänzungen unterliegt, geändert werden.

Art. 30. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft

oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches
Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied  und  jeder  leitende  Angestellte  der  Gesellschaft,  welche  als  Verwaltungsratsmitglied,  leitender
Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung tätig ist, mit welcher die Gesellschaft
Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Ge-
sellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen
Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern  ein  Verwaltungsratsmitglied oder  ein  leitender  Angestellter der  Gesellschaft im  Zusammenhang mit einem

Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende
Angestellte dem Verwaltungsrat dieses persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall
nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche
Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.

Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007einschließlich nachfolgender
Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

<i>Zeichnung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
„DB Private Equity GmbH“, vorgenannt, zeichnet 4 (vier) Aktien zum Gegenwert von 40.000,- EUR (vierzigtausend

Euro).

Damit  beträgt  das  Gründungskapital  insgesamt  40.000,-  EUR  (vierzigtausend  Euro).  Die  Einzahlung  des  gesamten

Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in den Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Gründungsversammlung der Gesellschaft

Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unver-

züglich eine Generalversammlung, zu der er sich als rechtens einberufen bekennt, abgehalten und folgende Beschlüsse
gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Ekkehart Kessel, Sal. Oppenheim PEP International S.à r.l., geboren am 22. Januar 1942 in Aachen, Deutschland,

beruflich ansässig in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Luxemburg;

- Herr Andreas Schmidt, DB Private Equity GmbH, geboren am 17. Oktober 1974 in Siegen, Deutschland, beruflich

ansässig in Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln (Deutschland); und

- Herr Andrew Reid, geboren am 16. Mai 1972 in Glasgow, Schottland, beruflich ansässig in 2, boulevard Konrad

Adenauer, L-1115 Luxemburg, Luxemburg.

19556

L

U X E M B O U R G

Herr Ekkehart Kessel wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.
II. Sitz der Gesellschaft ist 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Luxemburg.
III. Die erste ordentliche Generalversammlung wird am 27. Juni des Jahres 2012 stattfinden.
IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
„KPMG Audit“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, allée Scheffer, 2520 Luxemburg, Luxemburg

(R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 103.590).

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der

vorstehend genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deut-
schen Fassung; auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar nach

Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. LOCHEN, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 18. Februar 2011. Relation: EAC/2011/2295. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,-

EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2011027383/1094.
(110033647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Cidron Liberty Systems S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.198.

In the year two thousand and ten, on the seventeenth day of December.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared

Cidron Liberty Systems Limited, a private company with registered office at 26 Esplanade, St Helier, JE23QA, Jersey

Channel Islands, represented by Mr Raymond THILL, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 16 December,
2010, which proxy, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "Cidron Liberty Systems S.à r.l.",a"société à

responsabilité limitée" (limited liability company), having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade Register B 153.198, incorporated by notarial deed enacted on May 12, 2010
published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1420 dated on July 10, 2010 (the "Com-
pany").

The Sole Shareholder declared and requested the notary to state that:
I.- The Sole Shareholder holds all the six hundred and fifty (650) shares in issue in the Company, so that decisions can

validly be taken on the items of the agenda.

II.- The decisions to be resolved upon by the Sole Shareholder are the following:
1. Conversion of the share capital of the Company from Euro (EUR) into Norwegian Crowns (NOK) according to

the exchange rate applicable on May 12, 2010 with retroactive effect as at May 12, 2010.

2. Conversion of all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) into Norwegian Crowns (NOK) with

retroactive effect as at May 12, 2010.

3. Increase of the issued share capital after conversion into Norwegian Crowns by an amount of one thousand Nor-

wegian Crowns (NOK 1,000) so as to raise it to two hundred fifty four thousand Norwegian Crowns (NOK 254,000)
by the issue of one (1) new ordinary share with a par value of one thousand Norwegian Crowns (NOK 1,000), by
contribution in cash;

4. Amendment of the article 8 of the Company’s articles of association in order to reflect the above.
5. Miscellaneous.
Thereafter the following resolutions were passed by the Sole Shareholder of the Company:

19557

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolved to convert the corporate capital of the Company from Euro (EUR) into Norwegian

Crowns (NOK), with retroactive effect as at May 12, 2010 so that the capital of thirty-two thousand five hundred Euro
(EUR 32,500) divided into six hundred fifty (650) shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50) each is converted,
by applying the exchange rate of the European Central Bank as at May 12, 2010, being one Euro (EUR 1) equals seven
point seven eight six five Norwegian Crowns (NOK 7.7865), into two hundred fifty-three thousand Norwegian Crowns
(NOK 253,000) of corporate capital and sixty-one point twenty-five Norwegian Crowns (NOK 61.25) of Share premium.
The nominal value of the shares is converted from fifty Euro (EUR 50) into one thousand Norwegian Crowns (NOK
1,000).

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolved to convert all accounts in the books of the Company from Euro (EUR) into Norwegian

Crowns (NOK) with retroactive effect as at May 12, 2010.

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder decided to increase the corporate capital by the amount of one thousand Norwegian Crowns

(NOK 1,000) so as to raise it from its present amount of two hundred fifty-three thousand Norwegian Crowns (NOK
253,000) to two hundred fifty-four thousand Norwegian Crowns (NOK 254,000) by the issue of one (1) new ordinary
share with a par value of one thousand Norwegian Crowns (NOK 1,000), having the same rights and obligations than the
existing ordinary shares.

<i>Fourth resolution:

The Sole Shareholder accepted the subscription of one (1) new ordinary share to be issued, with a par value of one

thousand Norwegian Crowns (NOK 1,000), by a contribution in cash of an aggregate amount of one billion three hundred
and thirty million Norwegian Crowns (NOK 1,330,000,000).

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened the aforenamed company "Cidron Liberty Systems Limited", here represented as stated here-

above, which declared to subscribe to one (1) new ordinary share and to have it fully paid up by a contribution in cash
of an aggregate amount of one billion three hundred and thirty million Norwegian Crowns (NOK 1,330,000,000) so that
from now on the company has at its free and entire disposal the amount of one billion three hundred and thirty million
Norwegian Crowns (NOK 1,330,000,000), as was certified to the undersigned notary.

The total value of the payment amounting to one billion three hundred and thirty million Norwegian Crowns (NOK

1,330,000,000) is allocated as follows:

- one thousand Norwegian Crowns (NOK 1,000) to the share capital;
- twenty-five thousand four hundred Norwegian Crowns (NOK 25,400) to the legal reserve; and
-  one  billion  three  hundred  twenty-nine  million  nine  hundred  seventy-three  thousand  six  hundred  (NOK

1,329,973,600) to the share premium.

<i>Fifth resolution:

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend article 8 of the articles of incorporation,

which shall have the following wording:

"The Company's capital is set at two hundred fifty-four thousand Norwegian Crowns (NOK 254,000), represented

by ninety-eight (98) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), thirty-nine (39) class A preferred shares (the "Class A
Preferred Shares"), thirty-nine (39) class B preferred shares (the "Class B Preferred Shares"), thirty-nine (39) class C
preferred shares (the "Class C Preferred Shares"), thirty nine (39) class D preferred shares (the "Class D Preferred
Shares", and together with the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares, (the
"Preferred Shares"), being a total of two hundred fifty-four (254) shares of a nominal value of one thousand Norwegian
Crowns (NOK 1,000) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraor-
dinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles."

<i>Costs and Expenses:

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, he signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

19558

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le dix-sept décembre.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

Comparaît

Cidron Liberty Systems Limited, une société de droit privé avec siège social au 26, Esplanade, St Helier, JE2 3QA,

Jersey Channel Islands, représentée par Monsieur Raymond THILL, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé délivrée en date du 16, ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie présente à l’assemblée générale extraordinaire est l’associé unique (l’"Associé Unique") de la société à res-

ponsabilité limitée "Cidron Liberty Systems S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L1882 Luxembourg,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 153 198, constituée suivant acte
reçu le 12 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1420 du 10 juillet 2010
(la "Société").

L’Associé Unique prie le notaire d'acter que:
I.- L’Associé Unique détient les 650 (six cent cinquante) parts sociales émises par la Société, de sorte que les décisions

peuvent valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II.- Les décisions à prendre par l’Associé Unique sont les suivantes:
1. Conversion du capital social de la Société de l’Euro (EUR) en Couronnes Norvégiennes (NOK) selon le taux de

change applicable au 12 mai 2010 et avec effet rétroactif au 12 mai 2010.

2. Conversion de tous les comptes dans les livres de la Société de l’Euro (EUR) en Couronnes Norvégiennes (NOK)

avec effet rétroactif au 12 mai 2010.

3. Augmentation du capital social après conversion en Couronnes Norvégiennes à concurrence d'un montant de mille

Couronnes Norvégiennes (NOK 1 000) pour le porter à deux cent cinquante-quatre mille Couronnes Norvégiennes
(NOK 254 000) par l'émission d’une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de mille Couronnes Norvégiennes
(NOK 1 000), par apport en numéraire.

4. Modification de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter les points ci-dessus.
5. Divers.
Les résolutions suivantes ont été prises par l’Associé Unique de la Société:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de convertir le capital social de la Société de l’Euro (EUR) en Couronnes Norvégiennes

(NOK) avec effet rétroactif au 12 mai 2010 de sorte que le capital de trente-deux mille cinq cents euro (EUR 32 500)
divisé en six cent cinquante (650) parts sociales avec une valeur nominale de cinquante euro (EUR 50) soit converti par
application du taux de change de la Banque Centrale Européenne au 12 mai 2010 fixant un euro (EUR 1) équivalent sept
virgule sept huit six cinq (NOK 7,7865), et donc soit égal à deux cent cinquante-trois mille Couronnes Norvégiennes
(NOK 253 000) de capital social et soixante et un virgule vingt-cinq couronnes norvégiennes (NOK 61,25) de prime
d’émission. La valeur nominale des actions est convertie de cinquante euro (EUR 50) à mille Couronnes Norvégiennes
(NOK 1 000).

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de convertir tous les comptes dans les livres de la Société de l’Euro (EUR) en Couronnes

Norvégiennes (NOK) avec effet rétroactif au 12 mai 2010.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de mille Couronnes Norvégiennes (NOK 1.000)

pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-trois mille Couronnes Norvégiennes (NOK 253.000) à
deux cent cinquante-quatre mille Couronnes Norvégiennes (NOK 254.000) par l'émission d’une (1) nouvelle part sociale
d'une valeur nominale de mille Couronnes Norvégiennes (NOK 1.000), avec les mêmes droits et obligations que ceux
existants pour les parts sociales existantes ordinaires.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique accepte la souscription d’une (1) nouvelle part sociale ordinaire émise, avec une valeur nominale de

mille Couronnes Norvégiennes (NOK 1.000), par apport en numéraire d’un montant total d’un milliard trois cent trente
millions de Couronnes Norvégiennes (NOK 1.330.000.000).

<i>Intervention - Souscription - Libération

A ce sujet "Cidron Liberty Systems Limited", prénommée, représentée comme indiqué ci-desus;

19559

L

U X E M B O U R G

a déclaré souscrire à une (1) part sociale ordinaire nouvelle, et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la

Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme d’un milliard trois cent trente millions de Couronnes
Norvégiennes (NOK 1.330.000.000) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

La valeur totale du paiement d’un montant d’un milliard trois cent trente millions de Couronnes Norvégiennes (NOK

1.330.000.000) est allouée de la manière suivante:

- mille Couronnes Norvégiennes (NOK 1.000) au capital social;
- vingt-cinq mille quatre cents Couronnes Norvégiennes (NOK 25.400) à la réserve légale; et
- un milliard trois cent vingt-neuf millions neuf cent septante-trois mille six cents Couronnes Norvégiennes (NOK

1.329.973.600) à la prime d’émission.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier

l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 8. Le capital de la Société est de deux cent cinquante-quatre mille Couronnes Norvégiennes (NOK 254.000),

représenté par quatre-vingtdix-huit parts sociales ordinaires (98) (les «Parts Sociales Ordinaires»), trente-neuf (39) parts
sociales  préférentielles  de  classe  A  (les  «Parts  Sociales  Préférentielles  de  Classe  A»),  trente-neuf  (39)  parts  sociales
préférentielles de classe B (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe B»), trente-neuf (39) parts sociales préférentielles
de classe C (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe C»), trente-neuf (39) parts sociales préférentielles de classe D
(les «Parts Sociales Préférentielles de Classe D»), et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classe A, les Parts
Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, les «Parts Sociales Préférentielles»),
forment un total de deux cent cinquante-quatre (254) parts sociales d'une valeur nominale de mille Couronnes Norvé-
giennes (NOK 1 000) chacune. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élève à environ sept mille euros (EUR 7.000,-)

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59074. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur (signé): p.d. Tom BENNING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002342/176.
(110002145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Cemex Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 43-49, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 106.559.

In the year two thousand ten, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The company CEMEX HUNGARY KFT, a company organised and existing under the laws of Hungary, with its regis-

tered office at 6-12 Kapàs u, 3 

rd

 -4 

th

 floor, H-1027 Budapest, Hungary, registered with the Trade Registry of Hungary

under number 01-09-698135,

duly represented by Maître Nathalie HOULLÉ, avocat à la Cour, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal dated 7 December 2010.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

19560

L

U X E M B O U R G

The forementioned CEMEX HUNGARY KFT is the sole member of the limited liability company CEMEX LUXEM-

BOURG HOLDING S.à r.l., having its registered office at L-2763 Luxembourg, 43-49, rue Ste Zithe, registered with the
Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 106.559 (the “Company”), incorporated pursuant to a
deed received by the notary Tom METZLER, residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 2 

nd

 March 2005, published in the

Memorial C, Recueil des Sociétés et Association number 668 dated 7 July 2005, page 32052, which articles of incorporation
have been amended several time and for the last time by a deed received by the notary Carlo WERSANDT, residing in
Luxembourg, on 9 December 2010, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of the Company, has requested

the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The Company has received on this date from its sole member a contribution for the amount of EUR 607,990,264.99

(six hundred seven million nine hundred ninety thousand two hundred sixty four Euros and ninety nine cents), equivalent
to USD 805,343,905.- (eight hundred five million three hundred forty three thousand nine hundred five US Dollars),
according to the official exchange rate of EUR 1.- for USD 1.3246, as published by Reuters (ASK) for 9 December 2010
at 4 p.m. New York Time) (the “Contribution”).

The sole member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 607,990,200 (six

hundred seven million nine hundred ninety thousand two hundred Euros). Therefore, the corporate capital is increased
from its present amount of EUR 810,304,100.- (eight hundred ten million three hundred four thousand one hundred
Euros), represented by 8,103,041 (eight million one hundred three thousand forty one) corporate units with a nominal
value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, to the amount of EUR 1,418,294,300.- (one billion four hundred eighteen
million two hundred ninety four thousand three hundred Euros) represented by 14,182,943 (fourteen million one hundred
eighty two thousand nine hundred forty three) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros)
each.

The sole member resolves to allocate the remaining amount of the Contribution, i.e. EUR 64.99 (sixty four Euros and

ninety nine cents) to the Company's share premium account.

<i>Second resolution

The sole member resolves to issue 6,079,902 (six million seventy nine thousand nine hundred two) new corporate

units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros), having the same rights and obligations as the existing
corporate units and to allocate EUR 64.99 (sixty four Euros and ninety nine cents) to the Company's share premium
account.

<i>Subscription and Payment

There now appears Maître Nathalie HOULLÉ, previously named, acting in her capacity as duly appointed proxy of the

sole member, by virtue of the prementionned proxy.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the sole member for 6,079,902 (six million

seventy nine thousand nine hundred two) newly issued corporate units of the Company with a nominal value of EUR
100.- (one hundred Euros) each, with the payment in cash for an aggregate amount of EUR 607,990,200.- (six hundred
seven million nine hundred ninety thousand two hundred Euros).

Thereupon, the sole member formally resolves to accept the said payment in cash and subscription and to issue, allot

6,079,902 (six million seventy nine thousand nine hundred two) new fully paid-up corporate units of the Company to the
sole member and to credit the share premium account of the Company by an amount of EUR 64.99 (sixty four Euros
and ninety nine cents).

<i>Third resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company

has henceforth the following wording:

“The corporate capital is set at EUR 1,418,294,300.- (one billion four hundred eighteen million two hundred ninety

four thousand three hundred Euros) represented by 14,182,943 (fourteen million one hundred eighty two thousand nine
hundred forty three) corporate units with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euros) each, all fully paid in.”

<i>Fourth resolution

The sole member of the Company resolves to grant any one manager of the Company single signature power, to carry

out any required steps relating to the above capital increase, including the authorization (i) to amend the Company's
member(s) register, and (ii) more generally, to carry out any action in relation to the above resolutions.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately six thousand eight hundred euros (EUR 6,800)).

19561

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le treize décembre.
Par-devant nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

La société CEMEX HUNGARY KFT, une société constituée et existant selon les lois Hongroises, ayant son siège social

à 6-12 Kapàs u, 3 

rd

 -4 

th

 floor, H1027 Budapest, Hongrie, immatriculée au Registre de Commerce de Hongrie sous le

numéro 01-09-698135,

dûment représentée par Maître Nathalie HOULLÉ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 7 décembre 2010.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société CEMEX HUNGARY KFT pré-mentionnée, est l'associé unique de la société à responsabilité limitée CEMEX

LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 43-49, rue Ste Zithe, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.559 (la "Société"), constituée
en vertu d'un acte reçu par le notaire Maître Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
2 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 668 en date du 7 juillet 2005, page 32052.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire
Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 2010, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associé unique de la Société, a demandé

au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La Société a été créditée en date de ce jour par son associé unique d'un montant de EUR 607.990.264,99 (six cent

sept millions neuf cent quatre vingt dix mille deux cent soixante quatre Euros et quatre vingt dix neuf cents) correspondant
au montant de USD 805.343.905.- (huit cent cinq millions trois cent quarante trois mille neuf cent cinq dollars des Etats
Unis), conformément au taux de change officiel de EUR 1.- pour USD 1,3246, tel que publié par Reuters (ASK) au 9
décembre 2010 à 16 heures, heure de New York (l' «Apport»).

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 607.990.200 (six cent sept

millions neuf cent quatre vingt dix mille deux cents Euros). Par conséquent le capital social est augmenté de son montant
actuel de EUR 810.304.100.- (huit cent dix millions trois cent quatre mille cent Euros), représenté par 8.103.041 (huit
millions cent trois mille quarante et une) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune,
pour le porter au montant de EUR 1.418.294.300.- (un milliard quatre cent dix huit millions deux cent quatre vingt
quatorze mille trois cents Euros) représenté par 14.182.943 (quatorze millions cent quatre vingt deux mille neuf cent
quarante trois) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune.

L'associé unique décide d'allouer le montant restant de l'Apport soit EUR 64,99 (soixante quatre Euros et quatre vingt

dix neuf cents) au compte prime d'émission de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre 6.079.902 (six millions soixante dix neuf mille neuf cent deux) nouvelles parts sociales

ayant une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros), et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes et d'allouer le montant de EUR 64,99 (soixante quatre Euros et quatre vingt dix neuf cents) au compte prime
d'émission de la Société.

<i>Souscription et Paiement

Puis, a comparu, Maître Nathalie HOULLÉ, prénommée ci-avant, agissant en sa qualité de mandataire dûment désignée

de l'associé unique, en vertu de la procuration pré-mentionnée.

La partie comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de l'associé unique pour 6.079.902 (six millions

soixante dix neuf mille neuf cent deux) parts sociales de la Société nouvellement émises ayant une valeur nominal de EUR
100,- (cent euros) chacune, par le paiement en numéraire d'un montant total de EUR 607.990.200 (six cent sept millions
neuf cent quatre vingt dix mille deux cents Euros).

19562

L

U X E M B O U R G

Ainsi, l'associé unique décide formellement d'accepter ledit paiement en numéraire et la souscription, et d'émettre,

d'allouer 6.079.902 (six millions soixante dix neuf mille neuf cent deux) nouvelles parts sociales entièrement libérées de
la Société à l'associé unique et de créditer le compte prime d'émission de la Société d'un montant de EUR 64,99 (soixante
quatre Euros et quatre vingt dix neuf cents).

<i>Troisième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société

a désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à EUR 1.418.294.300.- (un milliard quatre cent dix huit millions deux cent quatre vingt quatorze

mille trois cents Euros), représenté par 14.182.943 (quatorze millions cent quatre vingt deux mille neuf cent quarante
trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

L'associé unique de la Société décide de donner pouvoir à tout gérant de la Société, avec pouvoir de signature indivi-

duelle, d'effectuer toute action nécessaire en relation avec l'augmentation de capital social ci-dessus, incluant l'autorisation

(i) de mettre à jour le registre d'actionnaire(s) de la Société, et (ii) plus généralement d'effectuer toutes actions en

relation avec les résolutions ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à six mille huit cents euros (EUR 6.800.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'Anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,

dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, à la date d'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès-qualités qu'elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. HOULLÉ, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56453. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Référence de publication: 2011002355/155.
(110002293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Conso Services International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 157.823.

STATUTS

L’an deux mille dix, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Madame Annie FRERE, administrateur de sociétés, demeurant au 13, rue du Cortil Bailly, B-1380 Lasne,
ici représentée par Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 07 décembre 2010.
2.- Monsieur Allen WHITE, consultant, demeurant au 13, rue du Cortil Bailly, B-1380 Lasne,
ici représenté par Madame Christel DETREMBLEUR, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 07 décembre 2010.
3.- la société «SHON INVEST S.A..», société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B132.467,

ici représentée par Madame Christel DETREMBLEUR, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 15 décembre 2010.
Les procurations signées "ne varietur" par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

19563

L

U X E M B O U R G

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «CONSO SERVICES INTER-

NATIONAL S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, le développement et la distribution de logiciels ainsi

que la vente, les prestations d’installation, de paramétrage, la formation et l’assistance technique relative à ces logiciels.
L’organisation et la dispense de toutes formations notamment pour les professionnels appartenant aux professions éco-
nomiques.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions, d’une

valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

La cession, l’aliénation ou le nantissement d’une participation majoritaire détenue par la Société requérera une auto-

risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des actions émises.

Le Conseil d’Administration doit désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

19564

L

U X E M B O U R G

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l’autorisation préalable délivrée

par le Ministère des Classes Moyennes, la société devra toujours être engagée soit par la signature conjointe d’un admi-
nistrateur et de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée, soit par la signature individuelle du délégué
à la gestion journalière ou de l’administrateur unique pour autant que ce signataire individuel soit détenteur de l’autori-
sation de commerce.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2011
2.- La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit:

1.- Madame Annie FRERE , prédésignée, cent cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.- Monsieur Allen WHITE, prédésigné, cent cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.- La société «SHON INVEST S.A.», prédésignée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: TROIS CENT DIX ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

19565

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes, représentées comme il est précisé ci-avant, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateur est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1) Madame Annie FRERE, administrateur de sociétés, demeurant au 13, rue du Cortil Bailly, B-1380 Lasne.
2) Monsieur Allen WHITE, consultant, demeurant au 13, rue du Cortil Bailly, B-1380 Lasne.
3) la société «SHON INVEST S.A.», société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (RCS Luxembourg B132.467), Madame Cornélia METTLEN, née le 29
janvier 1963 à Saint-Vith (Belgique), demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, agira en tant
que représentant permanent.

Madame Annie FRERE, prénommée, est nommée Président du Conseil d’Administration et administrateur délégué.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
«HRT Révision S.A.», ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2016.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DETREMBLEUR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2010. Relation: EAC/2010/16336. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011002363/163.
(110002406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

Weather Finance II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 144.734.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession d'actions conclu entre les associés WIND Telecommunicazioni S.p.A ayant son siège

social au via Cesare Giulio Viola, 48, I-00148 Rome (cédant) et Weather Finance I S.àr.l., ayant son siège au 12, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (acquéreur) en présence de la Société que 80 (quatre vingt) actions ont été vendues
et transférées du cédant à l'acquéreur avec effet au 30 décembre 2010.

Par suite du contrat de cession susmentionné, Weather Finance I S.à r.l. est l'associé unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

19566

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

<i>Pour WEATHER FINANCE II S.A R.L.
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011011730/19.
(110013233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

WCC Romania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.185.

Par résolutions signées en date du 10 décembre 2010, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Stéphane Bourg avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant

de classe A avec effet au 31 décembre 2010 et pour une durée indéterminée

2. Acceptation de la démission de Noëlla Antoine, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de

son mandat de gérant de classe A, avec effet au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011733/15.
(110012985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

LSF-KEB Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 90.485.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015735/10.
(110018703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

WE invest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 139.423.

Je soussigné, Monsieur Paul GRANGIER, démissionne de mon mandat de commissaire au comptes rétroactivement

au 1 

er

 janvier 2010, de la société WE invest SA, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 139423.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 19 janvier 2011.

Paul GRANGIER.

Référence de publication: 2011011734/12.
(110012967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Weather Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1883 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 98.414.

Veuillez noter que le siège social de I l'associé WIND TELECOM S.p.A. a été transféré au 66, Via Dei Due Macelli,

I-00187 Rome et que le numéro d'immatriculation est le suivant: 08526731008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

19567

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

<i>Pour Weather Capital S.à r.l.
S.G.G S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011011735/15.
(110013231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

NGP Quatro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 1.132.200,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.513.

<i>Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011.

En date du 10 janvier 2011 les associés de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Paul Lamberts, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Hille-Paul SCHUT, salarié, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage au Pays-Bas, demeurant profes-

sionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de classe B de la Société pour une
durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérants de classe A:

- John PERRY
- Thomas VERHAGEN
- Natural Gas Partners IX, L.P.

<i>Gérants de classe B:

- Richard BREKELMANS
- Hille-Paul SCHUT
- Johan DEJANS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011011919/27.
(110013074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Advans S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 110.428.

L'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement le 17 janvier 2011 a décidé de:
- nommer en tant qu'administrateur
Monsieur François LAGIER
31, boulevard Voltaire, F-75011 Paris
pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013

<i>Pour Advans S.A., SICAR
Société anonyme qualifiying as a société d'investissement en capital à risque (SICAR)
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2011011811/17.
(110013130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19568

L

U X E M B O U R G

Aktiva S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 12, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 145.758.

<i>Auszug des Protokolls der Verwaltungsratsitzung vom 21. Dezember 2010

„Gemäss der Ermächtigung durch die Generalversammlung beschliesst der Verwaltungsrat einstimmig Frau Nadine

PROVOST, wohnhaft in D-54662 Beilingen, Buchenweg 6, zur Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen. Ihr Mandat
endet mit ihrem Mandat als Verwaltungsratsmitglied im Jahr 2014.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder eines

Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet."

Grevenmacher, den 21. Dezember 2010.

FÜR GLEICHLAUTENDEN AUSZUG
Ferdinand STEFFEN / Jürgen STEINMETZ / Nadine PROVOST

Référence de publication: 2011011814/16.
(110013093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Assets &amp; Buildings Investments I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 135.150.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: ASSETS &amp; BUILDINGS INVESTMENTS I S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011820/21.
(110013213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Alternative Leaders S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 82.731.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social d'Alternative Leaders S.A. à

<i>Luxembourg, le 16 juin 2010:

L'assemblée décide de ratifier la démission de Maître Delandmeter en tant qu'administrateur d'Alternative Leaders

SA. avec effet au 16 avril 2010.

Le 23 novembre 2010.

ALTERNATIVE LEADERS SA
8-10 Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2011011815/16.
(110013188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19569

L

U X E M B O U R G

Aratus Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 148.306.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAU MANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: ARATUS INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011816/22.
(110013113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

KEV Germany Spittelmarkt 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 136.835.

Par résolutions signées en date du 14 janvier 2011, l'associé unique a accepté la démission de Mr. Keith NOTMAN,

avec adresse au 33, Castle Street, EH2 3DN Edinburgh, Royaume Uni, de son mandat de gérant avec effet au 31 décembre
2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011011903/16.
(110013133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Financière Naturam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 59.520.

<i>Cette version des comptes annuels au 31.12.2008 rectifiés remplace la version déposée en date du 30 avril 2010 n° LO

<i>90061439.04

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
50 Ave J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2011011880/15.
(110013090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19570

L

U X E M B O U R G

Armatix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 138.725.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 283, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,
Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.
Concernant l'Administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au

69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: ARMATIX S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011818/22.
(110013120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Autòs Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 87.540.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptés:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rué de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: AUTOS PROPERTIES S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011823/21.
(110013237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Atlantico Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 125.378.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,

19571

L

U X E M B O U R G

est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: ATLANTICO INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011821/22.
(110013222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Audiovision International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 16.817.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que dorénavant l'adresse professionnelle des administrateurs

et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011822/22.
(110013225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Avon Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 49.192.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: AVON HOLDING S.A.
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011824/21.
(110013241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19572

L

U X E M B O U R G

BML Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 152.402.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2010

<i>Résolution n°1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur de Mademoiselle Assia DERGUIANI, née le 17 novembre 1982 à Hayange (France) et demeurant à
F-57290 Fameck, 4, avenue François Mitterrand.

<i>Résolution n°2

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue
du Général Henry.

<i>Résolution n°3

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d'administrateur de Monsieur Michel Jean CLAUS, né le 31 mars 1945 à Genk (Belgique) et demeurant à B-1390 Grez-
Doiceau, 20, Les Gottes.

<i>Résolution n°4

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d'administrateur de Monsieur Claude Philippe FORET, né le 03 mars 1953 à Liège (Belgique) et demeurant à B-4430 Ans,
181, rue Walthère Jamar.

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2010.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2011011828/28.
(110013166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

C.A.S. Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 68.168.

Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CAS Services S.A. en fonction au 7 Janvier 2011 a été déposée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CAS Services S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011011830/12.
(110013682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Cedar Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 132.173.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

19573

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CEDAR INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011831/21.
(110013277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Centrix Beteiligungen AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 101.602.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CENTRIX BETEILIGUNGEN AG
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011840/21.
(110013386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Cantac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 134.138.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, la 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CANTAC S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011837/22.
(110013248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19574

L

U X E M B O U R G

Capitaine Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 154.376.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CAPITAINE PRIVATE S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011838/22.
(110013252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Kompass Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 145.663.

<i>Extrait des résolutions des associés

En date du 5 janvier 2011 les associés de la Société ont décidé de renommer KPMG AUDIT, ayant pour adresse 9,

Allée Scheffer, en tant que réviseur d'entreprise agréé pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication aux Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

Richard BREKELMANS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011011902/15.
(110013107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Financial &amp; Building Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 83.560.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

"Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions,

déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à anonyme FINANCIAL &amp; BUILDING

CORPORATION SA (B 83.560), préqualifiée;

ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;
met les frais à la charge du Trésor."

Lionel GUETH-WOLF
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011011878/17.
(110013726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19575

L

U X E M B O U R G

Carbolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 82.947.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CARBOLUX S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011839/22.
(110013271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Champs de Mars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 135.987.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CHAMPS DE MARS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011842/22.
(110013392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Chimindu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 33.895.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,

19576

L

U X E M B O U R G

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CHIMINDU S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011845/22.
(110013397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Clima Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 146.845.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CLIMA INVESTMENT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011846/22.
(110013415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

LSF4 Mega Investments II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 125.868.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Référence de publication: 2011015737/10.
(110018648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

CMS Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 81.525.

Une liste des fondés de pouvoirs de la Société CMS Management Services S.A. en fonction au 7 Janvier 2011 a été

déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CMS Management Services S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011011847/12.
(110013663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19577

L

U X E M B O U R G

Comex Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 30.567.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,
Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.
Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69,

route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: COMEX FINANCE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011848/22.
(110013423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Regard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.080.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009,

tenue en date du 27 juillet 2010 que:

Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412 F, Route d'Esch,

L-1471 Luxembourg.

De ce fait, l'adresse professionnelle des Administrateurs est modifiée de la façon suivante:
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412 F, Route

d'Esch, L-1471 Luxembourg.

- Monsieur Thierry JACOB, né le 07 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412 F, Route

d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011011929/20.
(110013414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Cominsider S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 61.138.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

19578

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: COMINSIDER S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011849/22.
(110013425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Compagnie d'Investissement Espagnole Morlie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 35.704.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,
Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,
Madame Marie BOURLOND, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT ESPAGNOLE MORLIE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011850/21.
(110013402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Matterhorn Capital Data Centre Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 155.492.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2011015748/11.
(110018322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

FIS Global Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 156.771.

<i>Extrait des résolutions de l’associée unique prises en date du 16 décembre 2010

1. M. Cédric CARNOYE a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. M. David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de type B pour
une durée indéterminée.

19579

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FIS Global Holdings
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010172146/16.
(100199824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Lux-Ideal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6689 Mertert, Zone Industrielle Fausermillen.

R.C.S. Luxembourg B 54.564.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011015740/10.
(110019159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Com3 Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 126.854.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: COM3 CONSULTING S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011852/22.
(110013417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Luxsyspur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 1B, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 131.987.

Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011015744/10.
(110019016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Conecon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 127.558.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société,

19580

L

U X E M B O U R G

LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: CONECON S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011853/21.
(110013428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Imison International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.118.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue le 29

décembre 2010 à Luxembourg que la clôture de la liquidation a été prononcée et qu'il faut procéder à la RADIATION
de l'inscription prise sous la section

B n° 82.118, au nom de la Société IMISON INTERNATIONAL S.A.,
avec siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Capital social: EUR 607.000,-
Les livres et documents sociaux de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans à l'adresse du siège social

de la société.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2011012463/20.
(110013127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Cosmétique Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 83.693.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: COSMETIQUE GROUPE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011855/22.
(110013431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

19581

L

U X E M B O U R G

Couquelet International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 7.038.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy BAUMANN, Administrateur de la société,
Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.
Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69,

route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: COUQUELET INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Caroline Felten / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011856/22.
(110013433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

GL Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 143.347.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: GL GROUP S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011011884/22.
(110013452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

I.B.C. Györ Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 137.238.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAU MANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,

19582

L

U X E M B O U R G

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: I.B.C. GYÖR LUXEMBURG S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011011889/22.
(110013461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Medalux S.A., Société Anonyme,

(anc. Medalux Holding S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 32.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011015755/10.
(110018447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

I.B.C. Györ Luxemburg 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 139.185.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: I.B.C. GYÖR LUXEMBURG 2 S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011011890/22.
(110013466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

I-TEK S.E., Société Européenne.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 99.569.

Par décision du Conseil d'administration du 6 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs ainsi que leurs représentants permanents et du commissaire aux
comptes:

KOFFOUR S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy BAUMANN,
LANNAGE S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Madame Marie BOURLOND,
VALON S.A., société anonyme, Administrateur de la société représentée par Monsieur Guy KETTMANN,
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société,
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 6 décembre 2010.

19583

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: I-TEK S.E.
Société européenne
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Cindy Szabo

Référence de publication: 2011011892/22.
(110013471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Medalux S.A., Société Anonyme,

(anc. Medalux Holding S.A.).

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 32.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011015756/10.
(110018448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

EUROMOVERS International EWIV, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg D 57.

AUSZUG

Aus einer Mitgliederversammlung der europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung EUROMOVERS Interna-

tional EWIV, mit Sitz in L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer D57, aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach, am 07.
Dezember 2010, einregistriert in Echternach, am 09. Dezember 2010, Relation: ECH/2010/1858, geht hervor dass:

1) die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation mit Wirkung vom heutigen Tage an beschlossen

wurde,

2) Herrn Nico ROESGEN, Geschäftsführer, wohnhaft in L-3390 Peppange, 102, rue de Crauthem, zum Liquidator

ernannt wurde.

Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse sowie sie in Artikel 144 und folgende des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehen sind.

Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Handlungen tätigen, ohne dass es einer Genehmigung durch die Versammlung

der Gesellschafter bedarf.

Echternach, den 27. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010172131/21.
(100199946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

3W Power Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.423.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2011016280/12.
(110018454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

19584


Document Outline

3W Power Holdings S.A.

Advans S.A., SICAR

Aktiva S.A.

Alternative Leaders S.A.

Aratus Investment S.A.

Armatix S.A.

Assets &amp; Buildings Investments I S.A.

Atlantico Invest S.A.

Audiovision International S.A.

Autòs Properties S.A.

Avon Holding S.A.

BML Invest S.A.

Cantac S.A.

Capitaine Private S.A. SPF

Carbolux S.A.

C.A.S. Services S.A.

Cedar Investments S.A.

Cemex Luxembourg Holdings S.à r.l.

Centrix Beteiligungen AG

Champs de Mars S.A.

Chimindu S.A.

Cidron Liberty Systems S.à r.l

Clima Investment S.A.

CMS Management Services S.A.

Com3 Consulting S.A.

Comex Finance S.A.

Cominsider S.A.

Compagnie d'Investissement Espagnole Morlie S.A.

Conecon S.A.

Conso Services International S.A.

Cosmétique Groupe S.A.

Couquelet International S.A.

DB PEP V

EUROMOVERS International EWIV

Financial &amp; Building Corporation S.A.

Financière Naturam S.A.

FIS Global Holdings

GL Group S.A.

I.B.C. Györ Luxemburg 2 S.A.

I.B.C. Györ Luxemburg S.A.

Imison International S.A.

I-TEK S.E.

KEV Germany Spittelmarkt 1 S.à r.l.

Kompass Wohnen S.à r.l.

LSF4 Mega Investments II S.àr.l.

LSF-KEB Capital Investments S.à r.l.

Lux-Ideal S.à.r.l.

Luxsyspur S.à r.l.

Matterhorn Capital Data Centre Group S.à r.l.

Medalux Holding S.A.

Medalux Holding S.A.

Medalux S.A.

Medalux S.A.

NGP Quatro S.à r.l.

Regard S.A.

WCC Romania S.à r.l.

Weather Capital S.à r.l.

Weather Finance II S.à r.l.

WE invest SA