This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 404
2 mars 2011
SOMMAIRE
Agalux Investment Company S.A. . . . . . . .
19346
Ageasfinlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19388
Alkern Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19390
Allied Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
19390
A & M Industries S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19388
Andbanc Asset Management Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19387
Anglesite Sea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19392
Anglo-Dutch Investment Group S.à r.l. . .
19391
ArcIndustrial France Developments I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19391
Babcock Luxembourg Investments II S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19377
Beyton Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
19392
Britanny Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19347
Cephalon Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
19390
Cipio Partners Fund VI S.C.S., SICAR . . . .
19381
Conengineering Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
19370
Convert Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
19349
Crossroads Property Investors S.A. . . . . . .
19378
Drayton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19351
Duaruz Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
19389
Eco-Building-Concept AG . . . . . . . . . . . . . . .
19374
Editions Letzeburger Journal S.A. . . . . . . .
19350
Eucalyptus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19346
Financial Mathematics S.A. . . . . . . . . . . . . .
19349
G3 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19378
Gartmore Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19349
Gima S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19391
Global Advantage Funds . . . . . . . . . . . . . . . .
19348
Global Crossing PEC Luxembourg I S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19376
Gottex Shelf Company 7 . . . . . . . . . . . . . . . .
19389
Gottex Shelf Company 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
19389
Immo-Style S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19348
Inland Navigation Luxembourg S.A. . . . . .
19346
Kingsgate Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
19380
Lambrusco Participations S.A. . . . . . . . . . .
19382
Lane & Space Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
19387
Les Bierts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19375
LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für
immobilienwirtschaftliche Funktions- und
Kostenoptimierung S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
19351
Macquarie-FSS Infrastructure Funds S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19384
Minerva Patents S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19383
Morgan Stanley Alzette S.à r.l. . . . . . . . . . .
19369
Morgan Stanley Derivative Products (Lu-
xembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19370
Nouvelle GAZEAUTHERME S.à r.l. . . . . .
19370
Palca Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19375
Pictet Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19355
Promovis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19384
Quint:Essence Concept . . . . . . . . . . . . . . . . .
19350
Revedaflo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19376
Société Luxembourgeoise d'Investisse-
ments et de Placements S.A. . . . . . . . . . . .
19377
TAXIS Caçao S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19384
Tyche S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19374
Universal Credit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19392
Valbonne I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19354
Vontobel Exchange Traded Structured
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19383
Working Capital Providers S.A. . . . . . . . . .
19383
xinex s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19387
xinex s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19387
19345
L
U X E M B O U R G
Inland Navigation Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 78.719.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von Inland Navigation Luxembourg S.A., welche am <i>18. März 2011i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz
mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars;
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2009;
3. Beschlussfassung über die Gewinn und Verlustwendungen;
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars;
5. Mandatsverlängerung;
6. Verschiedenes.
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2011024523/18.
Eucalyptus, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 54.769.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu exceptionnellement le <i>17 mars 2011i> à 10h30 au siège social de la société avec l'ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Statutaire ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.
2. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle
du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.
3. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2009 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice clôturé au
31 décembre 2009.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 23 Val Fleuri à Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011027762/565/22.
Agalux Investment Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 111.001.
Le règlement de gestion de FORTIS INSURANCE BELGIUM ALTERNATIVE FUND (anciennement FBA ALTERNA-
TIVE FUND) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2011.
<i>Pour AGALUX INVESTMENT COMPANY SA
i>BGL BNP Paribas
Signatures
Référence de publication: 2011026889/14.
(110032043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.
19346
L
U X E M B O U R G
Britanny Investment, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 22.404.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mars 2011i> à 14.30 heures au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg avec l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Adaptation de l'objet social de la société suite à l'abrogation de la loi modifiée du 31 juillet 1929 et modification
subséquente de l'article 4 des statuts comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à
la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août
1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
2. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de USD en EUR au taux
de conversion convenu entre parties de 1 USD = 0,74537865 EUR, de sorte que le capital social s'établit à EUR
360.017,89.
3. Réduction du capital social pour le porter à EUR 357.420 moyennant réduction du pair comptable des 4.830 actions
existantes, le montant de la réduction étant affecté, dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi modifiée sur les
sociétés commerciales, à un compte de réserve spécial dont il ne pourra être disposé que pour compenser des
pertes subies ou pour augmenter le capital social.
4. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 74 par action.
5. Instauration d'un capital autorisé d'un montant de EUR 740.000, et modification subséquente de l'article 5 des
statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 357.420 (trois cent cinquante-sept mille quatre cent vingt euros),
représenté par 4.830 (quatre mille huit cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 74 (soixante-quatorze
euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 740.000 (sept cent quarante mille euros),
qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 74 (soixante-quatorze euros)
chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de 5 ans prenant fin le 2016, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces,
en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sou-
scrit, il fera adapter le présent article.»
6. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter du 4
e
jeudi du mois de juillet au 4
e
jeudi
du mois de juin, et modification subséquente de l'article 15 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le 4
e
jeudi du mois de juin à 15.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»
19347
L
U X E M B O U R G
7. Modification des articles 7 (4
e
alinéa), 11 et 16 des statuts afin de les adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006
modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pour leur donner dorénavant la
teneur suivante:
Art. 7, 4
e
alinéa: «Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax,
conférence vidéo ou téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.»
Art. 11: «Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.»
Art. 16: «Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.»
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011029536/534/70.
Immo-Style S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 87.477.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du mardi <i>22 mars 2011i> à 10.00 heures au siège de la société 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, dans les bureaux
de la Fiduciaire Jean-Marc FABER, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé
au 31 décembre 2010;
b. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 2010;
c. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
d. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
e. Nominations;
f. Divers.
Le Commissaire aux Comptes.
Référence de publication: 2011029535/780/19.
Global Advantage Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 42.433.
We are pleased to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of Global Advantage Funds (the "Meeting"), which will be held on <i>25 March 2011i> at 11.00 a.m. at the
offices of State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Chairman's Statement and of the report of the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit & Loss Account as of 31 December 2010, and allocation of results.
3. Discharge to be granted to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties during
the financial year ended 31 December 2010.
4. Re-election of the following persons as Directors of the Company until the next Annual General Meeting to be
held in 2012:
- Mr. Michael Keppler,
- Mr. Benoit Fally,
- Mr. Rüdiger Zeppenfeld,
- Ms. Susanne van Dootingh.
5. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.àr.l. as Independent Auditor of the Company to hold office until the next
Annual General Meeting to be held in 2012.
6. Any others business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any Meeting by proxy.
19348
L
U X E M B O U R G
A proxy form may be obtained at the registered office's address and has to be returned by fax no later than 48 hours
before the meeting to the attention of Mrs. Candice Mayembo at the fax number +352 46 40 10 413 and by mail to the
registered office's address.
<i>By order of the Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2011029539/755/31.
Convert Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 30, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 123.305.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 mars 2011i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2141 Luxembourg et qui aura pour ordre
du jour:
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2010
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011029537/560/17.
Financial Mathematics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 114.827.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>21 mars 2011i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2011029538/833/18.
Gartmore Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 77.949.
Notice is hereby given that an
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company will be held at 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg on Thursday, <i>10i>
<i>March 2011i> at 11.00 a.m. (Luxembourg time). The purpose of such Meeting is the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review and approval of the Audited Annual Report and Accounts for the year ended 30
th
September 2010
2. Allocation of net results.
3. Discharge of liabilities to the Directors for the exercise of their mandate.
4. Re-election of Leslie Aitkenhead to the Board of Directors
5. Re-election of Ulrich Hocker to the Board of Directors
19349
L
U X E M B O U R G
6. Re-election of Victoria Huerta to the Board of Directors
7. Re-election of Claude Niedner to the Board of Directors
8. Re-election of Nigel Parker to the Board of Directors.
9. Approval of the remuneration of £20,000 net, per Director, per annum for Ulrich Hocker and Claude Niedner.
10. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as the Statutory Auditor of the Company.
11. Any other business.
13 December 2010.
<i>on behalf of the Board of Directorsi> .
Notes :
All shareholders are entitled to attend or be represented at the above Meeting. A shareholder is entitled to appoint
one or more proxies to attend and vote in his place. A proxy holder is not required to be a shareholder. To be valid,
Forms of Proxy must be lodged at Victor Buck Services S.A. - Client Services (Ref. JD11/00002), Ivy Building, Parc d'ac-
tivités, L-8308 Capellen, Luxembourg not less than 48 hours before the time appointed for the Meeting.
The Audited Annual Report and Accounts of the Company may be obtained from the registered office of Gartmore
SICAV at the offices of the representatives and distributors and electronically at www.gartmore.com.
Référence de publication: 2011025173/41/30.
Editions Letzeburger Journal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 5.056.
Les actionnaires sont invités à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra vendredi, <i>le 11 mars 2011i> , à 11 heures au siège social à Luxembourg, 51, rue de Strasbourg (2
e
étage).
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2010
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2010 et du compte des profits et pertes de l'exercice 2010
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 16 des
statuts.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011015235/2136/19.
Quint:Essence Concept, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.867.
Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Quint:Essence Concept SICAV (die "Gesellschaft") am <i>11. März 2011i> um 11.00 Uhr am Hauptsitz
der Gesellschaft stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlegung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend
das am 30. September 2010 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 30.
September 2010 beendeten Geschäftsjahres;
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend das
am 30. September 2010 beendete Geschäftsjahr;
4. Ernennung des Wirtschaftsprüfers;
5. Verlängerung der Verwaltungsratsmandate;
6. Verschiedenes.
19350
L
U X E M B O U R G
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum
festgelegt ist, und dass Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung mit einer einfachen Stimmenmehrheit der
anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.
Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt, welche bei der
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. bis spätestens zum 08. März 2011 hinterlegt wurden. Der Beleg betreffend den
Aktienbesitz und die Hinterlegung der Aktien muss erbracht werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2011025175/755/27.
Drayton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 41.520.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mars 2011i> à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2011025174/795/15.
LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung
S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 103.059.
Im Jahre zweitausend und elf, am einunddreissigtsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Großherzogtum Lu-
xemburg), sind die Aktionäre der LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Funktions- und
Kostenoptimierung S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4A, rue Henri M. Schnadt eingetragen im luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B
103.059 (nachfolgend „LUXEMBURGER TEAM S.A." oder die „übertragende Kapitalgesellschaft"), gegründet gemäß Ur-
kunde des Notars Alex WEBER mit dem damaligen Amtssitz in Bascharage, Großherzogtum Luxemburg, am 26. August
2004, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 1201 vom 24. November 2004, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wurde um 10.30 Uhr eröffnet.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Marco FRITSCH, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Er beruft zur Schriftführerin Frau Nadine GAUPP, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg;
und zur Stimmenzählerin Frau Josiane ADAMS, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest und erklärt:
I.- Die Tagesordnung der Generalversammlung umfasst folgende Punkte:
1. Genehmigung des gemeinsamen Verschmelzungsplans zwischen der übernehmenden Gesellschaft,
LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung mbH, eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet und bestehend nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland mit
Sitz in D-50670 Köln, Friesenstrasse 50, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtgerichts
Köln unter der Nr. HRB 57828 (nachfolgend „LUXEMBURGER TEAM GmbH oder die übernehmende Gesellschaft“);
und der übertragenden Kapitalgesellschaft LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Funk-
tions- und Kostenoptimierung S.A., eine Aktiengesellschaft errichtet und bestehend nach den Gesetzen Luxemburgs mit
Sitz in, 4A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) Luxemburg unter der Nummer B 103.059.
2. Bestätigung, dass die Übertragung der gesamten aktiven und passiven Vermögenswerte von der LUXEMBURGER
TEAM, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung S.A. auf die LUXEMBURGER TEAM,
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter
19351
L
U X E M B O U R G
Haftung zur Buchwerten nach den Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels-
und Gesellschaftsregister sowie über die Buchhaltung und die Jahresabschlüsse der Unternehmen unter Anpassung an die
deutschen Rechnungslegungsvorschriften erfolgen soll.
3. Feststellung, dass die Verschmelzung wirksam erfolgt ist.
4. Verzicht auf die Verschmelzungsprüfung gemäß Artikel 266 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (nachfolgend „LGHG“).
5. Verzicht auf das Anfechtungs- und Klagerecht gegen den Verschmelzungsbeschluss und auf das Klagerecht auf Scha-
denersatz gegen die Verwaltungsratsmitglieder der LUXEMBURGER TEAM S.A.
II.- Die Namen, Vornamen beziehungsweise Bezeichnung der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, derer Bevoll-
mächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl ihrer Aktien wurden in eine Anwesenheitsliste eingetragen; diese
Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Vors-
tand der Versammlung und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt
um mit derselben verwahrt zu werden.
III.- Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Bevollmächtigten, den Vorstand der Versammlung
und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, wurden ebenfalls der vorliegenden Urkunde beigefügt.
IV.- Das gesamte Aktienkapital ist in der beurkundeten Versammlung vertreten und alle anwesenden oder vertretenen
Aktionäre, erklären, dass sie rechtzeitig über die Tagesordnung der Versammlung informiert und benachrichtigt wurden,
und verzichten somit auf alle Frist- und Formvorschriften, sowie Informationsrechte.
V.- Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtswirksam über alle Punkte der
Tagesordnung beschließen.
VI.- Gemäß Artikel 267 LGHG standen der Versammlung folgende Dokumente zur Verfügung:
A - Gemeinsamer Verschmelzungsplan zwischen der
1) LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung S.A., eine
Aktiengesellschaft errichtet und bestehend nach den Gesetzen Luxemburgs mit Sitz in, 4A, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) Lu-
xemburg unter der Nummer B 103.059,
und der
(2) LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung mbH, eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet und bestehend nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland mit
Sitz in D-50670 Köln, Friesenstrasse 50, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtgerichts
Köln unter der Nr. HRB 57828;
B - Verschmelzungsbericht des Verwaltungsrats der LUXEMBURGER TEAM GmbH und der Geschäftsführer der
LUXEMBURGER TEAM S.A. (der "Gemeinsame Verschmelzungsbericht");
C - Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte der LUXEMBURGER TEAM S.A. und der LUXEMBURGER TEAM GmbH
der letzten drei Jahre und der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2010 der LUXEMBURGER TEAM S.A., welche den Ak-
tionären der LUXEMBURGER TEAM S.A. seit dem 7. Oktober 2010 am Sitz der LUXEMBURGER TEAM S.A. zur
Einsichtnahme zur Verfügung standen;
VI.- Gemäß Artikel 262 des LGHG wurde der Gemeinsame Verschmelzungsplan in Luxemburg durch ein privats-
chriftliches Dokument am 24. September 2010 erstellt, welches von den Mitgliedern des Verwaltungsrates der LUXEM-
BURGER TEAM S.A. und den Geschäftsführern der LUXEMBURGER TEAM GmbH unterzeichnet wurde. Der
gemeinsame Verschmelzungsplan wurde am 1. Oktober 2010 beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister
hinterlegt und im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Num-
mer 2101 am 7. Oktober 2010, veröffentlicht. Weiter wurde der Gemeinsame Verschmelzungsplan in der Bundesrepublik
Deutschland beim Handelsregister des Amtsgerichts Köln durch Eingabe des Notars Dr. Marc HERMANNS mit Amtssitz
in Hohenstaufenring 66-70, D-50674 Köln Bundesrepublik Deutschland am 23. Dezember 2010 hinterlegt und es liegt
ein Auszug des Gemeinsamen Registerportals der Länder vor, dass die Bekanntmachung des Verschmelzungsplans gemäß
§ 122d des Umwandlungsgesetzes mit den vorgesehenen Inhalten am 29.Dezember 2010 um 12.00 Uhr erfolgt ist.
Eine beglaubigte Abschrift des durch den Notar Dr. Marc HERMANNS beim Handelsgericht Köln eingereichten
Verschmelzungsplans und der veröffentlichte Auszug des Registerportals wird vorliegender Urkunde beigefügt um mit
derselben verwahrt zu werden. Somit ist zum heutigen Datum die Voraussetzung der einzuhaltenden einmonatigen Frist
vor dem Verschmelzungsbeschluss, sowohl nach dem deutschem Umwandlungsgesetz als auch nach dem luxemburgischen
Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung erfüllt.
VII.- Der Verwaltungsrat der LUXEMBURGER TEAM S.A. hat am 24. September 2010 dem Gemeinsamen Versch-
melzungsbericht zugestimmt und diesen am selben Datum unterzeichnet und die Geschäftsführer der LUXEMBURGER
TEAM GmbH haben den Gemeinsamen Verschmelzungsbericht ebenfalls am 24. September 2010 unterzeichnet.
Eine Kopie des Gemeinsamen Verschmelzungsberichts bleibt vorliegender Urkunde beigefügt um mit derselben ver-
wahrt zu werden.
Die Generalversammlung der Aktionäre der LUXEMBURGER TEAM S.A. fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
19352
L
U X E M B O U R G
<i>Erster Beschlußi>
Die Generalversammlung der Aktionäre bestätigt den gemeinschaftlich von den Vertretungsorganen der LUXEM-
BURGER TEAM S.A. und der LUXEMBURGER TEAM GmbH aufgestellten Gemeinsamen Verschmelzungsbericht zur
Kenntnis genommen zu haben und bestätigt, dass ihr dieser zusammen mit allen für die Verschmelzung relevanten Do-
kumenten einen Monat vor dem heutigen Tage zugänglich gemacht wurde.
Die Generalversammlung beschließt den Gemeinsamen Verschmelzungsplan, wie er im Amtsblatt des Großherzogtums
Luxemburg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2101 vom 7. Oktober 2010 veröffentlicht wurde,
vollständig und ohne Ausnahmen und Vorbehalte zu genehmigen und die Verschmelzung der LUXEMBURGER TEAM S.A.
mit der LUXEMBURGER TEAM GmbH durchzuführen.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Generalversammlung bestätigt, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte der LUXEMBURGER TEAM S.A.
in ihrer Gesamtheit an die LUXEMBURGER TEAM GmbH wie im Verschmelzungsplan vorgesehen, zu deren Buchwert
unter Anpassung an die deutschen Rechnungslegungsvorschriften und mit buchhalterischer Wirkung zum 1. Juli 2010,
0.00 Uhr übertragen werden sollen.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Generalversammlung der Aktionäre bestätigt weiterhin, dass die Wirksamkeit der Verschmelzung zwischen den
verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber Dritten gemäß den Artikeln 273ter und 274 des LGHG vom 10. August
1915 in der gegenwärtigen Fassung mit der Veröffentlichung dieser Urkunde im Amtsblatt des Großherzogtums Luxem-
burg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erfolgen wird. Ab dem Zeitpunkt der oben genannten Veröffent-
lichung ist die LUXEMBURGER TEAM S.A. ohne Abwicklung aufgelöst und ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen ist
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die LUXEMBURGER TEAM GmbH übertragen worden.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Aktionäre verzichten ausdrücklich auf eine Prüfung des Verschmelzungsplans im Sinne von § 122f UmwG und
Artikel 266 LGHG.
Es wurden somit keine Sachverständigen mit der Prüfung des Verschmelzungsplans beauftragt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Aktionäre verzichten ausdrücklich auf das in Artikel 276 LGHG vorgesehene Anfechtungs- und Klagerecht gegen
den Verschmelzungsbeschluss und auf das in Artikel 275 vorgesehene Klage- und Schadenersatzrecht gegen die Verwal-
tungsratsmitglieder der übertragenen Kapitalgesellschaft für Fehler in der Vorbereitung oder Umsetzung der Verschmel-
zung.
<i>Bestätigungi>
Der amtierende Notar bestätigt , dass nach luxemburgischem Recht die LUXEMBURGER TEAM S.A. betreffenden
Vorraussetzungen für ihre Verschmelzung mit der LUXEMBURGER TEAM GmbH vorliegen. Der amtierende Notar
bestätigt hiermit das Bestehen und die Rechtmäßigkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung insbesondere auch des
Verschmelzungsplans nach luxemburgischem Recht, sowie die Erfüllung aller Formalitäten und Erstellung der notwendigen
Schriftstücke und Dokumente welche im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung, der luxembur-
gischen Gesellschaft LUXEMBURGER TEAM S.A. obliegen.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf ein tausend fünf hundert Euro geschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft und bearbeitet ist, wird die Versammlung um 11.30 Uhr beendet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der Urkunde wurde dieselbe von den Erschienenen, die dem unterzeichneten Notar, nach Nach-
namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, zusammen mit dem Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: M. FRITSCH, N. GAUPP, J. ADAMS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 1
er
février 2011. Relation: ECH/2011/173. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 3. Februar 2011.
Référence de publication: 2011017695/144.
(110020831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2011.
19353
L
U X E M B O U R G
Valbonne I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.582.
L'an deux mille onze, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Valbonne I, une société d’investissement à capital
variable, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank
Baden en date du 30 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 92, en date du 30 janvier 2003.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nancy Kerff, employée de banque, avec adresse professionnelle
à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Madame Stéphanie Kuchly, employée de banque, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Aurélie Frey, employée de banque, avec adresse professionnelle à Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des
avis contenant l’ordre du jour envoyés aux actionnaires nominatifs par lettre recommandée le 7 janvier 2011.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pa-
reillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III.- Qu'il appert de la liste de présence que les 13.000 (treize mille) actions en circulation sont toutes représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Approbation de la dissolution du Fonds et mise en liquidation.
2. Détermination de la date de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires appelée à se prononcer
sur les rapports du Liquidateur et du Réviseur d’entreprises, à donner décharge au Liquidateur et aux Administrateurs
et à clôturer la liquidation de la Société.
3. Nomination de Michèle Berger, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4. Divers.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix présentes ou représentées
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que l’assemblée de clôture de liquidation aura lieu à la date à laquelle les rapports du liquidateur
et du réviseur seront disponibles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme Michèle Berger, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que liquidateur en relation avec
la liquidation volontaire de la Société.
L’assemblée décide en outre de conférer au liquidateur les pouvoirs comme suit:
L’assemblée décide d’attribuer au liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la «Loi»).
Le liquidateur est autorisé à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux
articles 145 et suivants de la Loi, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément
à l’article 148 de la Loi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
19354
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. KERFF, S. KUCHLY, A. FREY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4240. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 février 2011.
Référence de publication: 2011024865/65.
(110030242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.
Pictet Select, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.927.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eleventh of February.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Pictet & Cie (Europe) S.A., with registered office at 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, represented by Mrs Nancy
KERFF, employee, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given on the 10
th
of February 2011.
The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in its capacity, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a
"société anonyme" named "Pictet Select" and qualifying as a "société d'investissement à capital variable" ("SICAV") which
it intends to incorporate in Luxembourg:
"Title I. Denomination, Duration, Object, Registered office
Art. 1. Name. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares of the company
hereafter issued, a company in the form of a société anonyme (public limited company) qualifying as a société d'investis-
sement à capital variable (investment company with variable capital) under the name of Pictet Select (the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved by a resolution
of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").
Art. 3. Object. The Company’s sole purpose is to invest the funds at its disposal in transferable securities, money
market instruments and other liquid financial assets authorised by Part I of the Law of 20 December 2002 governing
undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2002”), and as from the first of July 2011 by Part I of the
Law of 17 December 2010 (the “Law of 2010”), in order to spread the investment risks and enable its shareholders to
benefit from earnings generated through the management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transactions that it deems necessary to accomplish and develop
its purpose in the broadest sense, pursuant to the Law of 2002, and as from the 1
st
of July 2011, pursuant to the Law of
2010.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, in the
Grand Duchy of Luxembourg.
Subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
resolution of the board of directors of the Company (the "Board").
The Board is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Luxembourg and,
if and to the extent it is allowed by applicable laws and regulations, to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office also may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means
of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for any amend-
ment to the Articles of Incorporation.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economical, social or military events have occurred
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.
19355
L
U X E M B O U R G
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time
be equal to the net assets of the Company as defined in Article 12 hereof.
The initial subscribed capital is EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 310 (three hundred and ten) fully
paid up shares which will be entirely redeemed at their initial value of EUR 31,000,- (thirty-one thousand euro) by the
launch date of the first sub-fund.
The minimum capital of the Company shall be the minimum capital required by Luxembourg law and must be reached
within six (6) months after the date on which the Company has been authorised as an investment fund under the Law of
2002.
The Board may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more compartments or sub-funds, (each
such compartment or sub-fund, a "Sub-Fund"). The Company constitutes a single legal entity but the assets of each Sub-
Fund shall be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the corresponding Sub-Fund and the assets of a
specific Sub-Fund are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Sub-Fund.
The shares to be issued in a Sub-Fund may, as the Board shall determine, be of one or more different classes (each
such class, a "Class"), the features, terms and conditions of which shall be established by the Board.
The Board may create each Sub-Fund for an unlimited or a limited period of time.
The proceeds from the issuance of shares of any Class within a Sub-Fund shall be invested pursuant to Article 17
hereof in securities of any kind or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or
monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities or assets or with such other specific features, as
the Board shall from time to time determine in respect of the relevant Sub-Fund.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class shall, if not
expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes.
The general meeting of shareholders of a Sub-Fund or Class, deciding with simple majority, or the Board, may con-
solidate ("reverse split") or split the shares of such Sub-Fund or Class.
Art. 6. Issue of shares. The Board is authorized without limitation to issue fully paid shares at any time, in accordance
with the procedures and subject to the terms and conditions determined by the Board and disclosed in the prospectus,
without reserving to the existing shareholders preferential or pre-emptive rights to subscription of the shares to be
issued.
Investors shall have either to commit to subscribe to shares or may directly subscribe to shares, as determined by the
Board and disclosed in the prospectus.
In case the Board decides that investors have to commit to subscribe shares, investors will be required to execute a
subscription agreement and indicate therein their total committed capital (the "Commitment" or "Commitments"), subject
to any minimum Commitment as may be decided by the Board.
The procedures relating to Commitments and drawdown of the Commitments will be disclosed in the prospectus and
the subscription agreement.
If at any time an investor or shareholder fails to honour its Commitment through the full payment of the subscription
price within the timeframe decided by the Board (a "Defaulting Investor" and/or (as the case may be), "Defaulting Sha-
reholder") and referred to in the prospectus, the Board has the authority, in addition to legal remedies, to charge interest
on the resulting unpaid amount at a rate disclosed in the prospectus. If the unpaid amount, plus interest thereon, is not
paid within a certain period determined in the prospectus, the Board shall have the right, at its discretion, to take one or
several of the following measures:
- impose damages corresponding to a certain percentage of the amount committed by the Defaulting Investor, as
disclosed in the prospectus;
- set off any distributions to the Defaulting Shareholder until any amounts owing to the Company have been paid in
full;
- redeem the shares of the Defaulting Investor as described in Article 9 below of its shareholding in the Company
payable at the time fixed by the Board in its discretion in the best interest of the shareholders;
- reduce or terminate the Defaulting Investor’s committed capital;
- exercise any other remedy available under applicable law, and
- admit new Investors in order to replace the Defaulting Investor.
Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the prospectus, the issue price shall be based on to the Net
Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof plus a subscription
charge, if any, as the prospectus may provide. The Board may also make such adjustment to the issue price as it may
consider appropriate to ensure fairness between the shareholders. For the avoidance of doubt, the issue price may among
others also be based at any time on the initial subscription price for the relevant Sub-Fund or Class, plus a subscription
charge, if any, as the prospectus may provide.
19356
L
U X E M B O U R G
In addition, a dilution levy may be imposed on subscriptions requests for shares of a Sub-Fund as specified in the
prospectus. Such dilution levy should not exceed such percentage of the Net Asset Value per Share, as may be decided
in the discretion of the Board and/ or of the Investment Manager and disclosed in the prospectus.
The Board may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized
person, the duty of accepting subscriptions and/or delivering and receiving payment for such new shares, remaining always
within the limits imposed by the Law of 2002.
The Board is further authorised to determine the conditions of any such issue and to make any such issue subject to
payment at the time of issue of the shares.
The issue of shares shall be suspended if the calculation of the Net Asset Value is suspended pursuant to Article 11
hereof.
The Board may decide to issue shares against contribution in kind in accordance with Luxembourg law. To the extent
required by the applicable laws and regulations, or if so decided by the Board, the contributed assets shall be valued in a
report issued by an auditor. Any costs incurred in connection with a contribution in kind shall be borne by the relevant
shareholder, unless the Board considers that the subscription in kind is in the interest of the Company in which case such
costs may be borne in all or in part by the Company.
Art. 7. Form of shares. The Company will in principle issue shares in registered form only.
All issued registered shares of the Company shall be inscribed in the register of shareholders (the "Register"), which
shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company. The Register shall
contain the name of each holder of shares, his residence or elected domicile as notified to the Company and the number
and Class(es) of shares held by him.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register. In the event of joint holders of shares, only
one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.
In the event that a shareholder does not provide such address, or such notices and announcements are returned as
undeliverable to such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register and the
shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so
entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder.
The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register by means of a written notification to the
Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the Register as full owner of the
shares. The Company shall be entitled to consider any right, interest or claim of any other person in or upon such shares
to be non-existing, provided that the foregoing shall deprive no person of any right which he might properly have to
request a change in the registration of his shares.
The Company will recognise only one holder per share. In the event of joint ownership the Company may suspend
the exercise of any right deriving from the relevant share(s) until one person shall have been designated to represent the
joint owners vis-à-vis the Company.
In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or
other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
Fractions of shares up to the number of decimal places to be decided by the Board will be issued if so decided by the
Board. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets and any
distributions attributable to the relevant Class on a pro rata basis.
The Company shall decide whether share certificates shall be delivered to the registered shareholders and under which
conditions or whether the shareholders shall receive a written confirmation of their shareholding.
Any share certificates shall be signed by two (2) directors or by a director and an official duly authorized by the Board
for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the
authorized official shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board may
from time to time determine.
Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the Register to be made by the Company
upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee and such other documentation as the
Company may require.
The Board may decide to issue bearer shares. If bearer shares are issued, certificates will be issued in a format to be
determined by the Board. If holders of bearer shares request that their certificates be converted into another form of
certificate, they may be required to bear the cost of this exchange.
Dividends will be paid to bearer shareholders upon delivery of the corresponding coupon to the agents appointed for
this purpose by the Company.
Bearer shares will be transferred when the corresponding share certificates are delivered.
19357
L
U X E M B O U R G
For bearer shares, only certificates showing a whole number of shares will be issued. For all other bearer shares for
which certificates may not be issued due to the denomination of the certificates, as well as for all fractions of such shares,
the Board may decide from time to time to convert them into registered shares, or to reimburse shareholders for the
equivalent value.
The Company will refuse to give effect to any transfer of shares and refuse any transfer of shares to be entered in the
Register in circumstances where such transfer would result in shares being held by any person not authorised.
Art. 8. Mutilation of shares. If share certificates are issued and if any shareholder can prove to the satisfaction of the
Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate share cer-
tificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but
without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it
shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall
become void.
The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in
connection with the annulment of the original share certificate.
Art. 9. Restrictions on the ownership of shares. The Board shall have power to impose such restrictions as it may
think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in
breach of the law or requirement of any country or governmental authority or (b) any person in circumstances which in
the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability or taxation or suffering any pecuniary disad-
vantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered. More specifically, the Company may restrict
or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body.
For such purposes the Company may:
a) decline to issue any share or to register any transfer of any share where it appears to it that such registry would or
might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the
Company;
b) at any time require any person whose name is entered in the Register to furnish it with any information, supported
by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such
shareholder's share rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Company;
c) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Company at any meeting of
shareholders of the Company; and
d) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares or a certain proportion
of the shares in the Company or whom the Company reasonably believes to be precluded from holding shares in the
Company, either alone or in conjunction with any other person is beneficial owner of shares, (i) direct such shareholder
to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request the Company to redeem his shares, or
(ii) compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:
1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the shareholder holding such
shares or appearing in the Register as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as
aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect of such share is
payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope
addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said share-
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates (if issued)
representing the shares specified in the Redemption Notice. Immediately after the close of business on the date specified
in the Redemption Notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held or owned by
him shall be cancelled;
2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the “Redemption
Price") shall be an amount equal to the per share Net Asset Value of shares in the Company of the relevant Class,
determined in accordance with Article 12 hereof less any service charge (if any). Where it appears that, due to the situation
of the shareholder, payment of the redemption price by the Company, any of its agents and/or any other intermediary
may result in either the Company, any of its agents and/or any other intermediary to be liable to a foreign authority for
the payment of taxes or other administrative charges, the Company may further withhold or retain, or allow any of its
agents and/or other intermediary to withhold or retain, from the Redemption Price an amount sufficient to cover such
potential liability until such time that the shareholder provide the Company, any of its agents and/or any other intermediary
with sufficient comfort that their liability shall not be engaged, it being understood (i) that in some cases the amount so
withheld or retained may have to be paid to the relevant foreign authority, in which case such amount may no longer be
claimed by the shareholder, and (ii) that potential liability to be covered may extend to any damage that the Company,
any of its agents and/or any other intermediary may suffer as a result of their obligation to abide by confidentiality rules;
3) Payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency
of denomination for the relevant Class and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a share certificate shall have been issued,
19358
L
U X E M B O U R G
upon surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice. Upon deposit of
such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such Redemption Notice shall have any further
interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right
of the shareholder appearing as the thereof owner to receive the price so deposited (without interest) from such bank
as aforesaid.
4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith.
If it appears that a shareholder in a Class of shares reserved for institutional shareholders within the meaning of the
Law of 2002 (or the Law of 2010 as from the 1
st
of July 2011), is not such an institutional investor, the Company may
either redeem the shares in question using the above-described procedure, or convert these shares into shares in a Class
that is not reserved for institutional investors (on condition that there is a class with similar characteristics), notifying the
relevant shareholder of this conversion.
Art. 10. Redemption and Conversion of Shares. As is more specifically prescribed herein below the Company has the
power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.
All shareholders are entitled to request the redemption of all or part of their shares by the Company.
Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund or Class in the prospectus, any shareholder may request the re-
demption of all or part of his/her/its shares by the Company under the terms, conditions and limits set forth by the Board
in the prospectus and within the limits provided by law and these Articles. Any redemption request must be filed by such
shareholder (i) in written form, subject to the conditions set out in the prospectus of the Company, at the registered
office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of
shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued) (ii) or by way of a request
evidenced by any other electronic means deemed acceptable by the Company subject to the conditions set out in the
prospectus.
Unless otherwise decided by the Board and disclosed in the prospectus, the redemption price shall be based on to
the Net Asset Value for the relevant Class as determined in accordance with the provisions of Article 12 hereof less a
redemption charge, if any, as the prospectus may provide. This price may be rounded up or down to the nearest decimal,
as the Board may determine, and such rounding will accrue to the benefit of the Company, as the case may be. From the
redemption price there may further be deducted any deferred sales charge if such shares form part of a Class in respect
of which a deferred sales charge has been contemplated in the prospectus. The redemption price per share shall be paid
within a period as determined by the Board provided that the share certificates, if issued, and any requested documents
have been received by the Company, subject to Article 11 hereof.
The Board may determine the notice period, if any, required for lodging any redemption request of any specific Class
or Classes. The specific period for payment of the redemption proceeds of any Class of the Company and any applicable
notice period as well as the circumstances of its application will be published in the prospectus relating to the sale of such
shares.
The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payment in relation thereto.
The Board may (subject to the principle of equal treatment of shareholders and, if required by the applicable laws and
regulations, the consent of the shareholder(s) concerned) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by
allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset Value attributable
to the shares to be redeemed as described in the prospectus. If required by the applicable laws and regulations, or by
decision of the Board, such redemption will be subject to a special audit report by the Auditor of the Company, as defined
below.
The specific costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will have to be borne
by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless
the Board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of
the Company.
Any request for redemption is revocable under the conditions determined by the Board and disclosed in the pros-
pectus, if any, and in the event of suspension of redemption pursuant to Article 11 hereof or a deferral of the redemption
request as provided for below. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day, as defined
below, after the end of the suspension.
Unless otherwise provided for in the prospectus, any shareholder may request conversion of whole or part of his
shares of one Class of a Sub-Fund into shares of another Class of that or another Sub-Fund at the respective Net Asset
Values of the shares of the relevant Classes under the terms, conditions and limits set forth by the Board in the prospectus.
The Board may notably impose restrictions between Classes of shares as disclosed in the prospectus as to, inter alia,
frequency of conversion, and may make conversions subject to payment of a charge as specified in the prospectus.
19359
L
U X E M B O U R G
The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has
been fully settled by such shareholder.
If on any given Valuation Day, redemption requests and conversion requests exceed a certain level determined by the
Board and set forth in the prospectus, the Board may decide that part or all of such requests for redemption or conversion
will be deferred for such period and in a manner that the Board considers to be in the best interest of the relevant Sub-
Fund or Class and of the Company. On the next Valuation Day following that period, these redemption and conversion
requests will be met in priority to a later request, subject to the same limitation as above.
The Board may refuse redemptions for an amount less than the minimum redemption amount as determined by the
Board and disclosed in the prospectus, if any, or any other amount the Board would determine in its sole discretion.
If a redemption or conversion would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one Sub-
Fund or Class below the minimum holding amount as the Board shall determine from time to time, then such shareholder
may be deemed to have requested the redemption or conversion, as the case may be, of all his shares of such Sub-Fund
or Class.
The Board may in its absolute discretion compulsory redeem or convert any holding with a value of less than the
minimum holding amount to be determined from time to time by the Board and to be published in the prospectus of the
Company.
The Company may also acquire its own shares in an open-market transaction through a stock exchange or another
regulated market either directly or through a broker. The price at which the Company may acquire its own shares shall
in all circumstances not exceed the last applicable net asset value and subject to such other conditions or restrictions as
may be determined from time to time by a general meeting of shareholders for which no quorum shall be required and
resolutions shall be passed at the majority requirements set forth in Article 24. hereof.
In exceptional circumstances relating to a lack of liquidity of certain investments made by certain Sub-Funds and the
related difficulties in determining the Net Asset Value of the Shares of certain Sub-Funds, the treatment of redemption
requests may be deferred and/or the issue, redemptions and conversions of Shares suspended by the Board.
In the same circumstances, the Board may consider the creation of side-pockets via any means and to the largest extent
authorised pursuant to applicable Luxembourg laws and regulations.
In addition to the foregoing, the Board may decide to temporarily suspend the redemption of shares if exceptional
circumstances as set forth in Article 11, so warrant.
In addition a dilution levy may be imposed on any redemption or conversion requests for Shares of a Sub-Fund. Such
dilution levy should not exceed such percentage of the Net Asset Value per Share, as may be decided in the discretion
of the Investment Manager and disclosed in the prospectus.
Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Art. 11. Frequency of the calculation of the NAV. The Net Asset Value of shares shall, for the purpose of the re-
demption, conversion or issue of shares, be determined by the Company or any agent appointed thereto, under the
responsibility of the Board, from time to time, but in no instance less than twice a month, as the Board may determine
(every such day or time for determination of net asset value being referred to herein as a "Valuation Day").
Unless otherwise indicated in the Company’s prospectus, net asset values will not be calculated for shares in a particular
class on a day when the prices for at least 50% of the assets of the class in question are unavailable due to the closure of
actors on the relevant investment markets in which the assets of that class are invested.
The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of one or more Sub-Fund(s) and
consequently the issue, redemption and conversion of shares of such Sub-Fund(s), it being understood that where the
context so requires "Sub-Fund" may also be read as "Class", during:
(a) any period when any of the stock exchanges or other principal markets on which a substantial portion of the assets
of the Company attributable to such Sub-Fund(s), from time to time, is quoted or dealt in, is closed (otherwise than for
ordinary holidays) or during which dealings therein are restricted or suspended provided that such restriction or sus-
pension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) quoted thereon; or
(b) any period when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the
control, responsibility and power of the Board, or the existence of any state of affairs which constitutes an emergency
in the opinion of the Board, disposal or valuation of assets held by the Company attributable to such Sub-Fund(s) is not
reasonably practical without this being detrimental to the interests of Shareholders, or if in the opinion of the Board, the
issue and, if applicable, redemption prices cannot fairly be calculated; or
(c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price
or value of any of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund(s) or the current prices or values on
any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund(s); or
(d) during any period when dealing the units/shares of an investment vehicle in which the concerned Sub-Fund(s) may
be invested is restricted or suspended; or, more generally, during any period when remittance of monies which will or
may be involved in the realisation of, or in the payment for any of the concerned Sub-Fund(s)' investments is not possible;
or
19360
L
U X E M B O U R G
(e) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption
of shares of such Sub-Fund(s) or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of shares of the Company cannot in the opinion of the Board, be effected at normal
rates of exchange; or
(f) from the time of publication (i) of a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the
purpose of winding up the Company or any Sub-Fund(s) or informing the shareholders of the decision of the Board to
terminate any Sub-Fund(s), or (ii) to the extent any such suspension is justified for the protection of the shareholders, of
a notice convening an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of merging the Company or any
Sub-Fund(s), or informing the shareholders of the decision of the Board to merge any Sub-Fund(s); or
(g) when for any other reason, the prices of any investments owned by the Company, attributable to the concerned
Sub-Fund cannot be promptly or accurately ascertained; or
(h) during any other circumstance where a failure to do so might result in the Company, any of its Sub-Funds or its
shareholders incurring any liability, pecuniary disadvantages or any other detriment which the Company the Sub-Fund or
its shareholders might so otherwise not have suffered.
Shareholders having made an application for subscription, redemption and conversion of Shares in the Sub-Fund(s) for
which the calculation of the Net Asset Value has been suspended will be informed of any such suspension at the time of
the filing of their written request for such subscription, redemption or conversion or as soon as possible thereafter.
In case of suspension of the calculation of the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or Class, in which case
shareholders may give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company,
such application will be dealt with on the first applicable Valuation Day following the end of the period of suspension.
Art. 12. Valuation regulations. The Net Asset Value of shares of each Class within each Sub-Fund (the "Net Asset
Value") shall be expressed in the reference currency of the relevant Class (and/or in such other currencies as the Board
shall from time to time determine) as a per share figure and shall be determined as at any Valuation Day by dividing the
net assets of the Company attributable to the relevant Class, being the value of the assets of the Company attributable
to such Class less the liabilities attributable to such Class as at such Valuation Day, by the number of shares of the relevant
Class then outstanding, in accordance with the rules set forth below.
The Net Asset Value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Board
shall determine.
The Net Asset Value per share will be calculated and available not later than the date set forth in the prospectus.
If, since the time of determination of the Net Asset Value on the relevant Valuation Day, there has been a material
change in the valuations of the investments attributable to the relevant Sub-Fund, the Company may, in order to safeguard
the interests of the shareholders and of the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.
A. The assets of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All cash at hand and on deposit, including interest accrued thereon.
(2) All bills and demand notes payable and accounts receivable (including the proceeds of securities sold but not
delivered).
(3) All bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights,
warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company.
(4) All stock dividends, cash dividends and cash distributions declared receivable by the Company to the extent in-
formation thereon is reasonably available to the Company.
(5) All interest accrued on any interest-bearing asset owned by the Company except to the extent that the same is
included or reflected in the principal amount of such asset.
(6) The preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as they have not been amortised.
(7) The liquidating value of all futures and forward contracts and all call and put options the Company has an open
position in.
(8) All other assets of any kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
a) The securities listed on a stock exchange or another regulated market are valued at the last known price unless
that price is not representative.
Securities not admitted to such stock exchange or on such a regulated market as well as securities that are so admitted
but for which the final price is not representative, are valued based on the probable realization value estimated prudently
and in good faith.
The value of the liquid asset, bills or notes payable on demand and accounts receivable, prepaid expenditures, dividends
and interest announced or come to maturity not yet affected, will be constituted by the nominal value of these assets,
except if it is unlikely that this value could be obtained. In the latter case, the value will be determined by subtracting a
certain amount that the Board deems appropriate to reflect the real value of these assets.
19361
L
U X E M B O U R G
Money market instruments are valued at their nominal value plus any eventually accrued interest or at “marked-to-
market” or according to the amortized cost method.
Assets expressed in a currency other than the currency of the corresponding Sub-Fund will be converted in this Sub-
fund’s reference currency at the applicable exchange rate.
f) In determining the value of the assets of the Company shares in open-ended underlying funds will be valued at the
actual net asset value for such shares or units as of the relevant Valuation Day, or if no such actual net asset value is
available they shall be valued at the estimated net asset value as of such Valuation Day, or if no such estimated net asset
value is available they shall be valued at the last available actual or estimated net asset value which is calculated prior to
such Valuation Day whichever is the closer to such Valuation Day. If events have occurred which may have resulted in a
material change in the net asset value of such shares or units since the date on which such actual or estimated net asset
value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of
the Board, such change but the Board will not be required to revise or recalculate the net asset value on the basis of
which subscriptions, redemptions or conversions may have been previously accepted.
In respect of shares or units held by the Company, for which issues and redemptions are restricted and a secondary
market trading is effected between dealers who, as main market makers, offer prices in response to market conditions,
the Board may decide to value such shares or units in line with the realisation prices so established.
The Company’s administrative agent, the Board and the Company’s management company, if any, may rely solely on
the valuations provided by UCIs with respect to the investment such UCIs have made. Valuations provided by UCIs may
be subject to adjustments made by such UCIs subsequent to the determination of the net asset value of a Sub-Fund. Such
adjustments, whether increasing or decreasing the net asset value of a Sub-Fund, will not affect the amount of the re-
demption proceeds received by redeeming shareholders. As a result, to the extent that such subsequently adjusted
valuations from UCIs adversely affect the net asset value of a Sub-Fund, the remaining outstanding shares of such Sub-
Fund will be adversely affected by redemptions. Conversely, any increases in the net asset value of a Sub-Fund resulting
from such subsequently adjusted valuations will be entirely for the benefit of the remaining outstanding shares of such
Sub-Fund.
The Company’s administrative agent and the Board may consult with the Investment Manager(s) and the investment
adviser(s), if any, in valuing each Sub-Fund’s assets. Year-end net asset value calculations are audited by the Company’s
réviseur d’entreprises agrée (the “Auditor”) and may be revised as a result of such audit. As discussed above, such revisions
may result from adjustments in valuations provided by UCIs.
In no event shall the Board, the Management Company if any, the Custodian, the administrative agent, the Investment
Manager(s) or the investment adviser(s) incur any individual liability or responsibility for any determination made or other
action taken or omitted by them in the absence of negligence, willful misfeasance or bad faith.
Securities held by the Company (including shares or units in closed-end UCI) which are quoted or dealt in on a stock
exchange will be valued at its latest available publicised stock exchange closing price and where appropriate the bid market
price on the stock exchange which is normally the principal market for such security and each security dealt in on any
other organised market will be valued in a manner as near as possible to that for quoted securities.
If events have occurred which may have resulted in a material change of the net asset value of such shares or units in
other investment funds since the day on which the latest official net asset value was calculated, the value of such shares
or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the Board, such change of value.
g) The value of the companies that are not listed on a stock exchange or regulated market will be determined based
on a valuation method proposed in good faith by the Board based on:
- the latest available audited annual accounts and/or on
- the basis of recent events that may have an impact on the value of such security and/or
- any other available assessment.
The choice of method and support for assessment will depend on the relevance of available data. The estimated value
may be corrected by periodic unaudited accounts, if available. If the Board believes that the resulting price is not repre-
sentative of the likely realizable value of such a security, the value shall be determined prudently and in good faith based
on the probable sale price.
h) Futures (and forward contracts) and option contracts that are not traded on a regulated market or a stock exchange
will be valued at their liquidation value determined in accordance with rules established in good faith by the Board,
according to uniform criteria for each type of contract.
The value of futures and option contracts traded on a regulated market or stock exchange will be based on the closing
or settlement price published by the regulated market or stock exchange which is normally the principal place of nego-
tiation for such contracts. If a future or options contract could not be liquidated on the relevant Valuation Day, the criteria
for determining the liquidation value of such futures contract or option contract be determined by the Board may deem
fair and reasonable.
i) Future cash flows expected to be collected and paid by the Sub-Fund under swap contracts will be valued at present
value.
19362
L
U X E M B O U R G
Where the Board considers it necessary, it may seek the assistance of an evaluation committee whose task will be the
prudent estimation of certain assets’ values in good faith.
The Board is authorised to adopt any other appropriate principles for valuing the Company’s assets if extraordinary
circumstances make it impossible or inappropriate to calculate the values based on the aforementioned criteria.
The Board, or any appointed agent, at its discretion, may permit some other method of valuation to be used, if it
considers that such valuation better reflects the fair value and is in accordance with good accounting practice.
For the purpose of determining the value of the Company's assets, the administrative agent, having due regards to the
standard of care and due diligence in this respect, may, when calculating the Net Asset Value, completely and exclusively
rely, unless there is manifest error or negligence on its part, upon the valuations provided (i) by various pricing sources
available on the market such as pricing agencies or fund administrators, (ii) by brokers, or (iii) by a specialist duly authorized
to that effect by the Board. Finally, in the cases no prices are found or when the valuation may not correctly be assessed,
the administrative agent may rely upon the valuation of the Board.
In circumstances where (i) one or more pricing sources fail(s) to provide valuations to the administrative agent, which
could have a significant impact on the Net Asset Value, or where (ii) the value of any asset(s) may not be determined as
rapidly and accurately as required, the administrative agent is authorized to postpone the Net Asset Value calculation
and as a result may be unable to determine subscription, redemption and conversion prices. The Board shall be informed
immediately by the administrative agent should the situation arise. The Board may then decide to suspend the calculation
of the Net Asset Value.
For the avoidance of doubt, the provisions of this Article 12 are rules for determining Net Asset Value per Share and
are not intended to affect the treatment for accounting or legal purposes of the assets and liabilities of the Company or
any securities issued by the Company.
B. The liabilities of the Company shall be deemed to include (without limitation):
(1) All loans, bills and accounts payable.
(2) All accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans).
(3) All accrued or payable fees and expenses (including administrative expenses, management fees, including incentive
fees, custodian fees, central administration agent's fees and registrar and transfer agent's fees).
(4) All known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments in cash or in
kind, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company.
(5) An appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from
time to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as such amount
(if any) as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company.
(6) All other liabilities of the Company, of whatever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses
payable by the Company, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amend-
ments to the constitutional documents, all translation costs, fees and expenses payable to the Investment Manager(s)/
advisor(s), including performance fees, if any, the custodian and its correspondent agents, the administrative agent, do-
miciliary and corporate agent, the registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any distributor or other
agents and employees of the Company, as well as any permanent representatives of the Company in countries where it
is subject to registration, the costs and expenses for legal, accounting and auditing services, any fees and expenses involved
in registering and maintaining the registration of the Company with any government agencies or stock exchanges in the
Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing,
printing, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements,
the cost of printing share certificates, if any, and the costs of any reports to the shareholders, expenses incurred in
determining the Company’s Net Asset Value, the cost of convening and holding shareholders’ and directors’ meetings,
reasonable travelling expenses of directors, directors’ fees, all taxes and duties charged by governmental or similar au-
thorities and stock exchanges, the costs of publishing the issue and repurchase prices as well as any other operating costs,
including the costs of buying and selling assets, finder fees, financial, banking and brokerage expenses and all other admi-
nistrative costs as well as interest, bank charges, currency conversion costs, postage, telephone and telex, insurance costs,
including insurance costs for the directors, employees and agents of the Company, costs and expenses related to legal,
notarial and /or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, involving, directly or
indirectly, the Company, directors, employees and agents of the Company as well as legal, to the extent as permitted by
law, notarial and/or administrative proceedings and indemnifications resulting from such proceedings, related, directly or
indirectly to former or existing shareholders.
In assessing the amount of such liabilities, the Company shall take into account pro rata temporis any expenses or
other costs, administrative and other, that occur regularly or periodically.
C. There shall be established a separate pool of assets and liabilities in respect of each Sub-Fund in the following manner:
(1) Proceeds resulting from the issue of shares in different Sub-Funds shall be allocated in the Company’s books to
the pool of assets of that Sub-Fund and the assets, liabilities, commitments, revenues and expenses relating to that Sub-
Fund shall be allocated to the corresponding pool in compliance with the provisions below.
19363
L
U X E M B O U R G
(2) When an income or asset is derived from another asset, such income or asset will be recorded in the Company’s
books under the same Sub-Fund holding the asset from which it derived, and, on each revaluation of the asset, the increase
or decrease in value shall be allocated to the corresponding Sub-Fund.
(3) When the Company incurs a liability attributable to a specific asset in a given pool of assets or to a transaction
performed in relation to the assets of a given Sub-Fund, this liability shall be allocated to that Sub-Fund.
(4) If an asset or a liability of the Company cannot be allocated to a given Sub-Fund, this asset or liability shall be
allocated to all Sub-Funds pro rata to their respective Net Asset Values or in any other manner the Board may decide in
good faith.
(5) Following a dividend distribution to shareholders of a Sub-Fund, the Net Asset Value of that Sub-Fund shall be
reduced by the amount of such distribution.
If there have been created within a Sub-Fund two or more Classes, the allocation rules set above shall apply, mutatis
mutandis, to such Classes.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken
by the Board or by any agent which the Board may appoint for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be
final and binding on the Company and present, past or future shareholders.
D. For the purpose of valuation under this Article:
(a) each of the Company’s shares subject to a redemption request shall be considered as a share issued and outstanding
until the close of business on the Valuation Day on which it is redeemed and its price shall be considered a liability of the
Company from the close of business on such Valuation Day until the price has been paid.
(b) each share to be issued by the Company in accordance with subscription forms received shall be considered as
issued from the close of business on the Valuation Day of its issue.
(c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the reference
currency in which the Net Asset Value per share of the relevant Class is calculated shall be valued after taking into account
the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant
Class; and
(d) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for the Company on
such Valuation Day to the extent practicable.
Art. 13. Pooling and Co-management.
A. The Board may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two or more Sub-
Funds on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so, as further
detailed into the.
B. The Board may also authorise investment and management of all or any part of the portfolio of assets of the Company
on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg collective investment schemes, all subject
to compliance with applicable regulations.
Title III. Administration and Supervision
Art. 14. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three
members; members of the Board need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period determined by such meeting in
compliance with the law, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at
any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director appointed by a general meeting of shareholders, because of death,
retirement or otherwise, the remaining directors so appointed may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy
until the next general meeting of shareholders.
Art. 15. Meeting of the Board. The Board will choose from among its members a chairman (the “Chairman”), and may
choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall
meet upon call by the Chairman or by any two (2) directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or
the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance
of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram,
telex, telefax or any other electronic means capable of evidencing such waiver of each Director. Separate notice shall not
be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of
the Board.
19364
L
U X E M B O U R G
Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex, telefax message
or any electronic means capable of evidencing such appointment, another Director as his proxy. Any Director may attend
a meeting of the Board using teleconference, videoconference or any other means of telecommunication allowing to
identify such director. Such means must allow the director to effectively act at such meeting of the Board, the proceedings
of which must be retransmitted continuously to such director. Directors may also cast their vote in writing or by cable,
telegram, telex, telefax message or any other electronic means capable of evidencing such vote.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their
individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.
The Board can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present (which may be by way of
telephone conference, videoconference or any other means of telecommunication allowing to identify such director) or
represented by another Director as proxy at a meeting of the Board. Decision shall be taken by a majority of the votes
of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and
against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms in the form of one
or several documents in writing signed by all the directors or by telex, cable, telegram, telefax message or by telephone
provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
The Board from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any
assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operations and manage-
ment of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors
or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the
powers and duties given to them by the Board.
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any physical
person or committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it
thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are directors and that no meeting of the committee
shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those
present are directors of the Company.
Art. 16. Minutes. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or, in his absence by the
chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 17. Powers of the Board. The Board shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine
the corporate and investment policy and the course of conduct of management and business affairs of the Company.
The Board shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the
Company.
In accordance with the conditions set forth in the Law of 2002 and the applicable Luxembourg regulations, any Sub-
Fund may, to the largest extent permitted by the Law of 2002 and the applicable Luxembourg regulations, but in
accordance with the provisions set forth in the prospectus, invest in one or more other Sub-Funds. Should a Sub-Fund
invest in shares of another Sub-Fund of the Company, no subscription, redemption, management or advisory fee will be
charged on account of the Sub-Fund’s investment in the other Sub-Fund.
If permitted by and at the conditions set forth in the applicable Luxembourg laws and regulations, the Board may, at
any time it deems appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in
accordance with the provisions set forth in the prospectus, (i) create any Sub-Fund qualifying either as a feeder undertaking
for collective investment in transferable securities or as a master undertaking for collective investment in transferable
securities, (ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder undertaking for collective investment in transferable securities
Sub-Fund or (iii) change the master undertaking for collective investment in transferable securities of any of its feeder
undertaking for collective investment in transferable securities Sub-Fund.
The Board may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Sub-Fund on a
pooled basis, as described in Article 13, where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do
so.
Art. 18. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company
who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business, shall not, by reason of such connection and/or relationship with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
19365
L
U X E M B O U R G
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted
for approval to the Board conflicting with that of the Company, such Director or officer shall make known to the Board
such conflict and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.
The preceding paragraph does not apply where the decision of the Board or by the single director relates to current
operations entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving any entity promoting the Company or any subsidiary thereof, or such other
company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion, provided that this personal
interest is not considered as a conflicting interest according to applicable laws and regulations.
Art. 19. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified.
Such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged
in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, any
indemnity shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of
indemnity shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 20. Signatory power. The Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or
single signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the Board.
Art. 21. Auditor. The Company shall appoint a réviseur d'entreprises agréé (the “Auditor”) who shall carry out the
duties prescribed by of the Law of 2002. The Auditor shall be elected by the shareholders at their annual general meeting
for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected. The Auditor in office may be
asked to stand down with or without cause at any time further to a resolution by the general shareholders’ meeting.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distribution
Art. 22. General meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the
Company regardless of the Class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.
Art. 23. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Lu-
xembourg law, at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
notice of meeting, on the third Friday of the month of April in each year at 3:00 p.m.(Luxembourg time). If such day is
not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.
If permitted by and at the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of sha-
reholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
or place are to be decided by the Board. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the Board, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders or of holders of shares of any specific Sub-Fund or Class may be held at such place
and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 24. Quorum and Voting. The quorum and notice periods required by law shall govern the conduct of the meetings
of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each full share of whatever Class and regardless of the Net Asset Value per share within the Sub-Fund, is entitled to
one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by
appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex, telefax message or any other electronic
means capable of evidencing such proxy form as permitted by law. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is
not specifically revoked, for any reconvened shareholders’ meeting. A company may execute a proxy under the hand of
a duly authorized officer. The Board may determine that a shareholder may also participate at any meeting of shareholders
by visioconference or any other means of telecommunication allowing to identify such shareholder. Such means must
allow the shareholder to effectively act at such meeting of shareholders, the proceedings of which must be retransmitted
continuously to such shareholder.
Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly
convened will be passed by a simple majority of votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares
represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained
or have returned a blank or invalid vote. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by share-
holders for them to take part in any meeting of shareholders.
19366
L
U X E M B O U R G
Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to
the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and
which contain at least the place, date and time of the general meeting, the agenda of the general meeting, the proposal
submitted to the decision of the general meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to
vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.
Voting forms, which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The
Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders
they relate to.
Within the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders
may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the
shares issued and in circulation at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the general meeting (the “Record
Date”), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting
right attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record
Date.
Art. 25. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on first day of January and shall terminate
on the last day of December of the same year.
Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed upon decision of the Board.
No distribution of dividends may be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the
minimum prescribed by law.
A dividend declared but not paid on a share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of such
share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of
shares.
Title V. Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more
liquidators appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.
The net proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.
Art. 28. Liquidation and Amalgamation. If the net assets of any Sub-Fund or Class fall below or do not reach an amount
determined by the Board and disclosed in the prospectus to be the minimum level for such Sub-Fund or Class to be
operated in an economically efficient manner or if a change in the economic, monetary or political situation relating to
the Sub-Fund or Class concerned justifies it or in order to proceed to an economic rationalisation, the Board has the
discretionary power to liquidate such Sub-Fund or Class by compulsory redemption of shares of such Sub-Fund or Class
at the Net Asset Value per share (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses)
determined as at the Valuation Day at which such a decision shall become effective. The decision of the liquidation will
be published by the Company prior to the effective date of the liquidation and the publication will indicate the reasons
for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board decides otherwise in the interests of, or in order
to ensure equal treatment of, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or Class concerned may continue to
request redemption or conversion of their shares free of redemption or conversion charges (but taking into account
actual realisation prices of investments and realisation expenses).
Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a general meeting of Shareholders
of any Sub-Fund or Class may, upon proposal from the Board and with its approval, redeem all the Shares of such Sub-
Fund or Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realisation
prices of investments and realisation expenses) determined as at the Valuation Day at which such decision shall take
effect. There shall be no quorum requirements for such a general meeting of Shareholders at which resolutions shall be
adopted by simple majority of the votes cast.
Assets which could not be distributed to the relevant shareholders upon the close of the liquidation of a Sub-Fund or
Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant shareholders. Amounts
not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg law.
Upon the circumstances provided for above, the Board may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of
another existing Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment ("UCI"), or to another
sub-fund within such other UCI (the "new Sub-Fund") and to re-designate the shares of the Sub-Fund concerned as shares
of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to
any fractional entitlement to shareholders), it being understood that where the context so requires, "Sub-Fund" may also
be read as "Class". Such decision will be notified to the shareholders concerned (together with information in relation
to the new Sub-Fund), one month before the date on which the amalgamation becomes effective in order to enable
shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. After such period,
19367
L
U X E M B O U R G
the decision commits the entirety of shareholders who have not used this possibility, provided however that, if the
amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type ("fonds commun de placement") or
a foreign based undertaking for collective investment, such decision shall be binding only on the shareholders who are in
favour of such amalgamation.
Notwithstanding the powers conferred to the Board by the preceding paragraph, a contribution of the assets and
liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund of the Company may be decided upon by a general meeting
of the shareholders, upon proposal from the Board and with its approval, of the contributing Sub-Fund for which there
shall be no quorum requirements and which shall decide upon such an amalgamation by resolution adopted by simple
majority of the votes cast, except when such amalgamation is to be implemented with a Luxembourg UCI of the con-
tractual type ("fonds commun de placement") or a foreign based UCI, in which case resolutions shall be binding only on
the shareholders of the contributing Sub-Fund who have voted in favour of such amalgamation.
Upon submission of the Company to the Law of 17 December 2010 (as from the 1
st
of July 2011) concerning un-
dertaking of collective investment transposing the provisions of the EU Directive 2009/65/CE of 13 July 2009 and its
implementing directive which are applicable to the mergers of UCITS (the "provisions on mergers of UCITS"), the pro-
visions set forth in the preceding paragraphs shall no longer be applicable and the provisions on mergers of UCITS shall
be applicable instead. In that case, mergers of a Class of shares or Sub-Fund may be decided by the Board. The Board
may however also decide to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Class of shares or Sub-
Fund concerned for which meeting no quorum is required and decisions are taken at the simple majority of the votes
cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger needs to be decided
by a meeting of shareholders where the quorum and majority requirements for changing these Articles of Incorporation
are required.
Art. 29. Consolidation and Splitting of shares. The Board may decide to consolidate or split the Classes of Shares of
a Sub-Fund within a given Class of Shares.
Title VI. Final provisions
Art. 30. Custodian. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy the require-
ments of the Luxembourg laws and the Law of 2002 (the "Custodian").
In case of withdrawal, whether voluntarily or not, of the Custodian, the Custodian will remain in function until the
appointment, which must happen within two months, of another eligible credit institution.
Art. 31. Amendment of the Articles. These Articles may be amended from time to time by a general meeting of
shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 32. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Law of 2002.
<i>Transitory Dispositions.i>
1)The first accounting year will begin on the date of formation and end on December 31, 2011.
2)The first annual general meeting will be held in the year 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscriber has subscribed for 310 (three hundred and ten) shares and has paid in cash EUR 31,000.- (thirty-one
thousand euros).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary.
The share capital of the Company subscribed by Pictet & Cie (Europe) S.A. shall be reimbursed to Pictet & Cie (Europe)
S.A., without fees, on the payment date of the initial subscription period, only if payment(s) of the initial subscription (s)
has(ve) been received.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 4.000.-.
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The single Shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
19368
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The following persons are appointed directors for a period ending at the first annual general meeting:
- Mr Pascal Chauvaux, born on 25 January 1965 in Bertrix (Belgium), CEO, Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxembourg,
residing professionally 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- - Mr Francesco Ilardi, born on 24 August 1971 in Chêne-Bourg (Switzerland), Senior Vice-President, Pictet & Cie,
Geneva, residing professionally 60 route des Acacias, CH-1211 Geneva, Switzerland;
- - Mrs Michèle Berger, born on 19 May 1967 in Rocourt (Belgium), Executive Vice-President, Pictet Funds (Europe)
S.A., Luxembourg residing professionally 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- - Mr Nicolas Campiche, born on 13 January 1969 in Sainte-Croix (Switzerland), residing professionally 60 route des
Acacias, CH-1211 Geneva, Switzerland;
- - Mr Justin Egan, born on 8 September 1967 in Dublin (Ireland), independent director, Luxembourg; residing pro-
fessionally at Carne Financial Services Luxembourg S.à.r.l, 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- - Mrs Tracey Mc Dermott, born on 22 May 1972 in Dublin (Ireland), independent director, Luxembourg, residing
professionally at Carne Financial Services Luxembourg S.à.r.l., 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
Ernst & Young, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, (RCS Luxembourg B 47771),
has been appointed as auditor of the Company for a period ending at the first annual general meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.
Signé: N. KERFF et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2011. Relation: LAC/2011/7594. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 février 2011.
Référence de publication: 2011024780/818.
(110029926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.
Morgan Stanley Alzette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.023.263,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 132.246.
Monsieur Eugene WONG a donné sa démission en tant que gérant de classe A de la Société avec effet au 10 février
2011.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Magnus LARSEN, gérant de classe A
- Monsieur Paul MOUSEL, gérant de classe B
- Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN, gérant de classe B
- Monsieur Adrian MASTERSON, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2011.
Morgan Stanley Alzette S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011027563/19.
(110033062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.
19369
L
U X E M B O U R G
Morgan Stanley Derivative Products (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 90.102.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.764.
Monsieur Eugene WONG a donné sa démission en tant que gérant de classe A de la Société avec effet au 10 février
2011.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Monsieur Magnus LARSEN, gérant de classe A
- Monsieur Roland ROSINUS, gérant de classe A
- Madame Laurence MAGLOIRE, gérant de classe A
- Monsieur Ian McMAHON, gérant de classe A
- Monsieur Paul MOUSEL, gérant de classe B
- Monsieur Jean-Marc UEBERECKEN, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2011.
Morgan Stanley Derivative Products (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011027564/21.
(110033070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.
Nouvelle GAZEAUTHERME S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-8081 Bertrange, 106, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 35.258.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 23 décembre 2010i>
Monsieur Jorge DA CRUZ ROSA, employé privé, demeurant 18, rue Michel Lentz à L-9068 Ettelbruck agissant en sa
qualité d’associé unique détenant l’intégralité du capital social de la société NOUVELLE GAZEAUTHERME S.à.r.l.
prend les résolutions suivantes:
1. Monsieur Hélio DA SILVA GOMES, né le 1
er
février 1974 à Luxembourg, demeurant 6, Schabeschraïz à L-8528
Colpach-Haut, est nommé gérant administratif de la société.
2. Monsieur Jorge DA CRUZ ROSA occupera désormais la fonction de gérant technique de la société.
3. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou par
la signature conjointe des deux gérants.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l’associé unique.
Jorge DA CRUZ ROSA
<i>L’associé uniquei>
Référence de publication: 2010171564/20.
(100198665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.
Conengineering Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 53.555.
In the yhe year two thousand ten, on the twenty-third of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary with residence in Luxembourg.
Is held the Extraordinary General Meeting of the shareholders is held of the joint stock company (société anonyme)
established in Luxembourg under the denomination of "CONENGINEERING HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg N°
B 53.555, with registered office in Luxembourg 18, rue de l’Eau registered at the Trade and Companies Register in
Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Georgesd’Huart, at that time notary with residence in Petange, on the
date of 11
th
of January 1996, published in the official journal Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
150 of 26
th
of March 1996.
19370
L
U X E M B O U R G
The meeting is opened under the presidency of Mr. Marc KOEUNE, economist, with professional address at 18, rue
de l’Eau, L–1449 Luxembourg.
The President appoints Mrs. Isabel DIAS, lawyer, with professional address at 74, avenue Victo Hugo, L–1750 Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutinizer Mr. Raymond THILL, lawyer, with professional address at 74, avenue Victo Hugo,
L–1750 Luxembourg.
After which the President states the following:
I.- That it appears from the list of presences compiled and certified by the members of the bureau that the six hundred
twenty-four (624) shares with a nominal value of one hundred US Dollars (USD 100,-) each, representing the entirety of
the corporate capital of sixty two thousand four hundred US Dollars (USD 62.400,-) are duly represented at the present
meeting which hence is regularly formed and can deliberate and validly decide on the items on the agenda as provided
here below, all represented shareholders having accepted to meet without previous convening notice.
The said list of presences, with the signatures of the shareholders, all represented, shall remain in the appendix together
with the powers of attorney to be submitted together to the registration formalities.
II.- That the agenda of the present meeting is as follows:
1. Transfer of the company’s domicile from Luxembourg to Cyprus wtithout cancellation of the legal personnality and
adoption of the legal form of a “limited” company under the law applicable in Cyprus;
2. Transfer of the company’s registered office from Luxembourg 18, rue de l’Eau to 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis
Business Center, Office 101, CY3107 Limassol – Cyprus;
3. Change of the corporate denomination into "CONENGINEERING HOLDING LIMITED";
4. Approval of the closing balance sheet of the Luxembourg company;
5. Resignation of the four existing directors and statutory auditor and discharge to be granted to them;
6. Appointment of two directors;
7. Decision relating to the updating of the by-laws in order to adapt them to the provisions laid down by Cypriot Law;
8. Power of attorney to be given in order to carry out all the formalities necessary for the radiation of the company
in the Luxembourg Trade register (Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg);
9. Legal effect of the resolutions taken;
10. Power of attorney to be given to FIDUCENTER (CYPRUS) LIMITED in order to carry out all the formalities
necessary for the registration of the company in the Trade Register of Cyprus
11. Miscellaneous.
The meeting after having approved the statements of the Chairman and acknowledged to be regularly called, went
over the agenda and after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office of the company with effect as from today from the Grand-Duchy
of Luxembourg to the Republic of Cyprus and to change the company’s nationality into Cypriot nationality. The Meeting
states that this resolution has been taken in compliance with article 67 – 1 (1) of the Luxembourg company law.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides that the address of the company’s registered office in Cyprus shall be at 1, Iakovou Tompazi
Street, Vashiotis Business Center, Office 101, CY-3107 Limassol -Cyprus.
The company will not have any subsidiary or other legal entity in Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to change the corporate denomination into
"CONENGINEERING HOLDING LIMITED.".
<i>Forth resolutioni>
The general meeting approves the closing balance sheet as of 23
th
December 2010 of the Luxembourg company which
after it was signed by the representative of the company and the notary will remain in the appendix of the present deed
to be registered at the same time.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to accept the resignation of the current directors and of the statutory auditor of the company
and to grant them full and entire discharge for the execution of their mandates.
19371
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
In replacement of the resigning directors the meeting decides to appoint the following persons as directors of the
company:
- Georges SAVVIDES, born in 6/04/1978 at Limassol, résiding at 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis Business Center,
Office 101, CY-3107 Limassol – Cyprus
- Charalambos KARTOUDES, born in 28/03/1977 in South Africa, résiding at 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis
Business Center, Office 101, CY-3107 Limassol – Cyprus
- Jean HOFFMANN, born in 2/12/1943 à Esch-sur-Alzette, résding à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
<i>Seven resolutioni>
The meeting decides that the by-laws of the company will be subject to a complete updating in order to adopt them
to the provisions laid down by the Cypriot Law.
<i>Eight resolutioni>
The meeting decides to grant all powers to any holder of a certified copy of the present deed, acting individually in
order to carry out the radiation of the company in Luxembourg on the basis of the evidence of the inscription in Cyprus.
<i>Ninth resolutioni>
The resolutions taken under points 1 to 8 are taken with the suspending condition of the receipt of the temporary
registration certificate issued by the Cyprus Trade Register.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting gives full power of attorney to FIDUCENTER (CYPRUS) LIMITED in order to carry out all the adminis-
trative formalities necessary for the registration of the company in the Cyprus.
There being no futher business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille dix, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de "CONENGINEERING HOLDING S.A." R.C.S. LUXEMBOURG Numéro B 53.555 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 janvier
1996 publié au journal offciel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 150 du 26 mars 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au
18, rue de l’Eau, L – 1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Isabel DIAS, juriste, domiciliée profesionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond THILL, juriste, domicilié professsionnellement au 74, avnue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent vingt-quatre
(624) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (USD 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social
de soixante-deux mille quatre cent US dollars (USD 62.400,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de Luxembourg vers Chypre sans rupture de la personnalité juridique, et adoption de la
forme juridique d'une société «limited» selon le droit chypri ote;
2. Transfer du siège social de Luxembourg, 18, rue de l’Eau, au 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis Business Center,
Office 101, CY-3107 Limassol – Chypre;
19372
L
U X E M B O U R G
3. Modification de la dénomination sociale en "CONENGINEERING HOLDING LIMITED";
4. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise;
5. Démission de quatre administrateurs et du commissaire aux comptes en place et décharge à leur donner pour
l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour;
6. Nomination de deux administrateurs;
7. Décision relative à la refonte complète des statuts pour les adapter au droit chypriote;
8. Mandat à donner aux fins d’opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg;
9. Effet juridique relative aux résolutions prises;
10. Mandat à donner à Fiducenter Limited aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires à l'inscription de la
société au Registre du Commerce chypriote;
11. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer ce jour le siège social de la société du Grand Duché de Luxembourg vers Chypre,et
d’adopter la nationalité chypriote. L’assemblée confirme que cette résolution a été prise en conformité avec l’article 67-1
(1) de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société à Chypre au 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis Business
Center, Office 101, CY-3107 Limassol - Chypre.
La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "CONENGINEERING HOLDING LIMITED".
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale approuve le bilan de clôture au 23 décembre 2010 de la société au Luxembourg, lequel bilan
après avoir été signé par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré
en même temps.
<i>Cinquième résolutioni>
Il est pris acte de la démission de quatre administrateurs en place ainsi que du Commissaire aux comptes de la société.
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
En remplacement des administrateurs démissionnaires les personnes suivantes sont nommées en qualité d'adminis-
trateur de la Société:
- Georges SAVVIDES, né le 6/04/1978 à Limassol, résident à 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis Business Center,
Office 101, CY-3107 Limassol – Cyprus
- Charalambos KARTOUDES, né le 28/03/1977 en Afrique du Sud, résident à 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis
Business Center, Office 101, CY3107 Limassol – Cyprus
- Jean HOFFMANN, né le 2/12/1943 à Esch-sur-Alzette, résident à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide que les statuts de la société seront refondus complètement pour être adaptés aux lois applicables
selon la légilsation chypriote.
<i>Huitième résolutioni>
Mandat est donné au porteur d’une copie conforme du présent acte, agissant individuellement pour les besoins de la
radiation de la société au Luxembourg sur la base de la preuve de l’inscrption de la société à Chypre.
<i>Neuvième résolutioni>
Les résolutions aux points 1 à 8 sous pris sous la condition suspensive d’obtention du certificat temporaire d’inscription
émis par Registre des Sociétés chypriotes.
19373
L
U X E M B O U R G
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée confère tous pouvoirs à Fiducenter Limited ayant son siège social au 1, Iakovou Tompazi Street, Vashiotis
Business Center, office 101, CY3107 Limassol -Chypre-aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à l'inscription de
la société au Registre du Commerce chypriote.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, I. Dias, R. Thill et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2011. Relation: LAC/2011/81. Reçu douze euros Eur 12.
<i>Le Receveuri> (signé): p.d. Tom BENNING.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2011.
Référence de publication: 2011003734/179.
(110003647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2011.
Tyche S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 118.110.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société en date du 31 décembre 2008i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 31 décembre 2008 que:
- Monsieur Gérard Schewen, Monsieur Luc Nickels et Monsieur René Moris ont été révoqués comme administrateurs
de la Société
- Les personnes suivantes ont été nommées comme administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale d'ap-
probation des comptes qui se tiendra en 2013:
* Monsieur Carlo Schneider, résidant professionnellement au 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg,
* Monsieur Georges Kohn, résidant professionnellement au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
* Maître Jean-Claude Wolff, résidant professionnellement au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- Premium Investment Partners S.A. a été révoqué comme commissaire aux comptes de la Société
- Madame Carole Daniel, résidant professionnellement au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, a été nommée commis-
saire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes qui se tiendra en 2013
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2010171637/23.
(100198713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.
Eco-Building-Concept AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 67.213.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ECO BUILDING CONCEPT
S.A.", avec siège social à L-1025 Luxembourg 5, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 67 213
tenue en date du 22 février 2010 que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
L'Assemblée a accepté à l'unanimité le renouvellement, pour une durée de six ans,
des mandats de
- des administrateurs à savoir Monsieur PARENT, TRIFON LIMITED et Régine CAILLAU
- de l'administrateur délégué Monsieur PARENT
- du Commissaire aux Comptes WURTH & ASSOCIES
19374
L
U X E M B O U R G
Leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.
La société WURST & ASSOCIES S.A. a déménagé au 29 Place de Paris L-2314 Luxembourg
Luxembourg, le 22 février 2010.
Pour avis sincère et conforme
Signature
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2010171700/23.
(100198382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2010.
Les Bierts, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 51.336.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «LES
BIERTS», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 10 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15819.
- que la société « LES BIERTS » (la « Société »), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
51336,
constituée suivant acte notarié du 1
er
juin 1995 et publié au Mémorial C numéro 433 du 6 septembre 1995 ; les statuts
de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 16 février 2006
et publié au Mémorial C numéro 1110 du 7 juin 2006,
se trouve à partir de la date du 10 décembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 22 novembre 2010 aux termes de laquelle
la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 2010.
Référence de publication: 2010172237/27.
(100200085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
Palca Investments, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 44.058.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «PALCA
INVESTMENTS», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 10 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15817.
- que la société «PALCA INVESTMENTS» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le
numéro 44058,
constituée suivant acte notarié du 24 mai 1993 et publié au Mémorial C numéro 392 du 28 août 1993; les statuts de
la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2001 et publié
au Mémorial C numéro 1198 du 19 décembre 2001,
se trouve à partir de la date du 10 décembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 22 novembre 2010 aux termes de laquelle
la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.
19375
L
U X E M B O U R G
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 2010.
Référence de publication: 2010172302/27.
(100200068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
Revedaflo, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 51.340.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «REVE-
DAFLO», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand- Duché de Luxembourg), en
date du 10 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15815.
- que la société «REVEDAFLO» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
51340,
constituée suivant acte notarié du 1
er
juin 1995 et publié au Mémorial C numéro 433 du 6 septembre 1995; les statuts
de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 16 février 2006
et publié au Mémorial C numéro 1100 du 7 juin2006,
se trouve à partir de la date du 10 décembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 22 novembre 2010 aux termes de laquelle
la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 2010.
Référence de publication: 2010172339/27.
(100200019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
Global Crossing PEC Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 70.471.
<i>Extrait des résolutions pris par l'associé unique de la société en date du 5 janvier 2011i>
Il a décidé de rayer de la Société avec effet au 5 janvier 2011:
- Madame Sylvia INFANGER, en tant que Gérant
et de nommer en remplacement:
- Monsieur Sébastien PAUCHOT, né le 1
er
mars 1976 à Paris 15 en France, avec adresse professionnelle au 208, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg
En tant que Gérant avec effet au 5 janvier 2011, pour une durée indéterminée,
en plus des Gérants:
- Monsieur Arthur ESHUIS;
- Monsieur Bernard KEOGH;
- Monsieur Kuy Ly ANG.
Luxembourg, le 17/1/11.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011011489/21.
(110013013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
19376
L
U X E M B O U R G
Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 14.002,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 157.024.
EXTRAIT
Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales exécutée en date du 10 novembre 2010, entre Babcock
Luxembourg Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B155562, et Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12F,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B157023, que les quatorze mille deux (14.002) parts sociales d'une valeur nominale d'une (1) livre
anglaise chacune, ont été transférées de Babcock Luxembourg Investments S.à r.l., susnommée, à Babcock Luxembourg
Investments I S.à r.l., susnommée.
Depuis lors, tes parts sociales de la Société sont détenues par la société Babcock Luxembourg Investments I S.à r.l.,
seul et unique associé de la Société.0
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 18 janvier 2011.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2011011330/27.
(110013207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Société Luxembourgeoise d'Investissements et de Placements S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.380.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «SO-
CIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-
Alzette A.C., le 15 décembre 2010. Relation: EAC/2010/15820.
- que la société «SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS S.A.» (la «Société»),
société anonyme, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 53380,
constituée suivant acte notarié du 27 décembre 1995 et publié au Mémorial C numéro 68 du 8 février 1996 ; les statuts
de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2002 et publié
au Mémorial C numéro 1416 du 1
er
octobre 2002,
se trouve à partir de la date du 10 décembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 3 décembre 2010 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l’occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 2010.
Référence de publication: 2010172383/28.
(100200111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
19377
L
U X E M B O U R G
Crossroads Property Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 56.208.
<i>Extrait d'une résolution de l'actionnaire unique de la Société prise en date du 19 janvier 2011i>
Il résulte d'une décision de l'actionnaire unique en date du 19 janvier 2011 que:
- M. Rudolf VOGELAAR, Group Director of Tax, né à 's-Gravenhage (Pays-Bas), le 5 septembre 1960, résidant au 68
Tintlaan, 2719 AL Zoetermeer, Pays-Bas; et
- M. Fabrice Philippe MOUCHEL, Deputy CFO, né le 16 avril 1970 à Saint-Cloud (France), résidant professionellement
au 7, Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, France;
ont été nommés administrateurs de la Société à effet immédiat pour une période expirant à l'assemblée générale des
actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2011.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé de:
- Mme Margret ASTOR;
- M. Jean HAMILIUS;
- M. Georges KIOES;
- UNIBAIL-RODAMCO S.E. représenté par son représentant permanent Mme Catherine POURRE;
- M. Rudolf VOGELAAR;
- M. Fabrice Philippe MOUCHEL.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2011.
Crossroads Property Investors SA
Signature
Référence de publication: 2011011386/26.
(110013040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
G3 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.012.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 155.869.
In the year two thousand and ten, on the fifteenth of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
G3 Holdings LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, the
United States of America, with registered office at 450, Racetrack Road, Washington, PA 15301, the United States of
America, here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echter-
nach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 14, 2010.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing entity and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of “G3 Holdings S.à r.l.”, having its registered address at 560A rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155 869, incorporated pursuant to a deed of Maître
Henri Beck dated on October 1
st
, 2010, published in the Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations, number
2446 on November 11
th
, 2010.
II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
III. The sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by two million Euro (EUR 2,000,000.-) to raise it from
its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million twelve thousand five hundred
19378
L
U X E M B O U R G
Euro (EUR 2,012,500.-) by the creation and issue of two million (2,000,000) new shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, G3 Holdings LLC, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to two million (2,000,000)
new shares and have them fully paid up by a cash contribution in the amount of two million Euro (EUR 2,000,000.-), so
that from now on the Company has at its free and entire disposal this amount, as has been certified to the undersigned
notary.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and shall
henceforth read as follows:
“ Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at two million twelve thousand five hundred Euro (EUR 2,012,500.-)
represented by two million twelve thousand five hundred (2,012,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.”
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.
<i>Costsi>
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing entity, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille dix, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
G3 Holdings LLC, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit de l’Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis
d’Amérique, ayant son siège social au 450 Racetrack Road, Washington, PA 15301, Etats-Unis d’Amérique, représentée
par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L6475 Echternach, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 décembre 2010.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.
La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «G3 Holdings S.à r.l.», ayant son siège social au 560A rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155 869, constituée suivant un acte reçu par
Maître Henri Beck en date du 1
er
octobre 2010, publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2446, le 11 novembre 2010.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.
III. L’associé unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions euros (EUR 2.000.000,-) pour
le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux millions douze mille cinq cents
19379
L
U X E M B O U R G
euros (EUR 2.012.500,-) par la création et l’émission de deux millions (2.000.000) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, G3 Holdings LLC, prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux deux millions (2.000.000) parts
sociales nouvelles et les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de deux millions euros (EUR
2.000.000,-), de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition cette somme ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions susmentionnées, l’article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
« Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à deux millions douze mille cinq cents euros (EUR 2.012.500,-),
représenté par deux millions douze mille cinq cents (2.012.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-)
chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la société comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même société et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2010. Relation: ECH/2010/1911. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 27 décembre 2010.
Référence de publication: 2010172990/117.
(100200261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.
Kingsgate Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.626.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société Kingsgate Properties S.à.r.l. qui s'est tenue à Luxembourg le 23i>
<i>décembre 2010.i>
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de remplacer pour une durée illimitée les gérants actuels à savoir, Roberto Monticelli,
Stephen Whale et Jacqueline Annette Ollereshaw par Monsieur Simeone Raccah, Monsieur Marco Sterzi et Mademoiselle
Francesca Docchio.
Le nouveau conseil de gérance est donc composé comme suit:
- Simeone Raccah, né à Tripoli (LBY) le 31 janvier 1949 et résident au 20 Via Antonio Gramsci, I-00197, Rome, Italie
- Marco Sterzi, né à Milan (Italie) le 10 novembre 1964 et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg.
- Francesca Docchio née à Bergame (Italie),le 29 mai 1971 et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg
19380
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 23 décembre 2010.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil de gérance
i>Francesca Docchio
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010174267/24.
(100200054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
Cipio Partners Fund VI S.C.S., SICAR, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.286.
<i>Extracts of the extraordinary general meeting of the limited partners of the company held on November 10, 2010i>
Under a private deed, on November 10, 2010, the limited partners of the Company have resolved to increase the
subscribed share capital of the Company from its amount of 87,476,782 Euros, represented by 87,476,780 Ordinary Units
of a par value of one Euro (EUR 1) each, one (1) General Partner Unit of a par value of one Euro (EUR 1) and one (1)
Participating Unit of a par value of one Euro (EUR 1) up to an amount of 91.715.410 Euros, represented by 91,715,408
Ordinary Units of a par value of one Euro (EUR 1) each, one (1) General Partner Unit of a par value of one Euro (EUR
1) and one (1) Participating Unit of a par value of one Euro (EUR 1), through the issue of 4,238,628 Ordinary Units.
Such increase of capital has been made further to:
- the admission of von Rautenkranz PE Nachfolger GbR, Mainz, (Germany), a BGB company existing and incorporated
under the laws of Germany, having its registered office at An der Favorite 12, D-55131 Mainz, Germany, who has com-
mitted to subscribe to 3,000,000 Ordinary Units with a nominal value of one Euro (EUR 1) each;
- the increase of the commitment of the European Investment Fund, a public-private partnership owned by the Euro-
pean Investment Bank, the European Commission and other financial institutions, having its registered office at 96,
Boulevard Konrad Adenauer, L-2968 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, whose total aggregate commitment is
now 30,000,000 Ordinary Units with a nominal value of one Euro (EUR 1) each; and
- the increase of the commitment of Seneca Pool S.A., SICAR, a company qualifying as a société d'investissement en
capital à risque under Luxembourg law, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section
B 137 358 and having its registered office located at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, limited partner (associé commanditaire) of the Company, whose total aggregate commitment is now 1
Participating Unit and 2,292,885 Ordinary Units with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société du 10 novembre 2010i>
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2010, les associés de la Société ont décidé d'augmenter le capital pour le
porter de son montant de 87.476.782 Euros, représenté par 87.476.780 Parts Ordinaires d'une valeur nominale de un
Euro (EUR 1) chacune, une (1) Part de Commandité d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) et une (1) Part Participative
d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) pour le porter à 91.715.410 Euros, représenté par 91.715.408 Parts Ordinaires
d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, une (1) Part de Commandité d'une valeur nominale de un Euro (EUR
1) et une (1) Part Participative d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1), par l'émission de 4.238.628 Parts Ordinaires.
Cette augmentation de capital a été effectuée par suite de:
- l'admission, en qualité d'associé commanditaire, de von Rautenkranz PE Nachfolger GbR, une société civile, ayant
son siège social au An der Favorite, 12, D-55131 Mainz, Allemagne, qui s'est engagée à souscrire 3.000.000 Parts Ordinaires
d'une valeur nominale de un Euro (EUR l) chacune;
- l'augmentation de l'engagement du European Investment Fund, ayant son siège social au 96, Boulevard Konrad Ade-
nauer, L-2968 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, associé commanditaire, dont l'engagement total cumulé est
désormais de 30.000.000 Parts Ordinaires, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune; et
- l'augmentation de l'engagement de Seneca Pool S.A., SICAR, une société d'investissement en capital à risque de droit
luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137 358, et
ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), associé com-
manditaire, dont l'engagement total cumulé est désormais de 1 Part Participative et 2.292.885 Parts Ordinaires, d'une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
Cipio Partners S.à r.l.
Mr Carlo Schlesser / Mr Christoph Kossmann
Référence de publication: 2010174238/49.
(100200124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
19381
L
U X E M B O U R G
Lambrusco Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 89.437.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 10/12/2010i>
L'assemblée générale du 10 décembre 2010, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de tous les membres présents, de transférer le siège social de la société
Lambrusco Participations S.A. à partir de ce jour à Luxembourg (L-2520) 21-25 Allée Scheffer.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de tous les membres présents, d'accepter la nomination avec effet à ce
jour, 10 décembre 2010, de Monsieur Claude Karp, né le 11 octobre 1972 à Esch/Alzette, résidant professionnellement
à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy, au poste d'administrateur, son mandat commençant ce jour et se terminant
à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de tous les membres présents, d'accepter la nomination avec effet à ce
jour, 10 décembre 2010, de la société EHORAN KAN S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro RC B 78554, ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy, au poste d'administrateur, son
mandat commençant ce jour et se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de
l'année 2013.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de tous les membres présents, d'accepter la nomination avec effet à ce
jour, 10 décembre 2010, de la société AA&C ASSOCIATES S.A., exploitant sous l'enseigne 'Financière Le Lion', inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B 124948, ayant son siège social à L-1941 Luxembourg,
261 route de Longwy, au poste d'administrateur, son mandat commençant ce jour et se terminant à l'assemblée générale
des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année 2013.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de tous les membres présents, d'accepter la nomination avec effet à ce
jour, 10 décembre 2010, de Monsieur Claude Karp, né le 11 octobre 1972 à Esch/Alzette, résidant professionnellement
à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy, au poste d'administrateur-délégué pouvant engager la société par sa seule
signature, son mandat commençant ce jour et se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes
annuels de l'année 2013.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix de tous les membres présents, d'accepter la nomination avec effet à ce
jour, 10 décembre 2010, de la société BRECKEWEE S.à r.l., exploitant sous les enseignes 'Global Accounting Services' et
'Global Compta Services', ayant son siège social à L-8561 Schwebach, 1 Haaptstrooss, enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro RC B 157331, au poste de commissaire aux comptes, son mandat
commençant ce jour et se terminant à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année
2013.
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2010.
Signatures des membres du bureau
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
i>Signatures des actionnaires ou de leurs mandataires
Signatures
Référence de publication: 2010174272/49.
(100200094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
19382
L
U X E M B O U R G
Working Capital Providers S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
R.C.S. Luxembourg B 116.977.
A l'attention des actionnaires
Je vous informe par la présente de ma démission de mon mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 janvier 2011.
Denis Van Den Bulke.
Référence de publication: 2011011737/10.
(110013493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Minerva Patents S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 148.282.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la Société MINERVA PATENTS S.A. qui s'est tenue à Luxembourg 13i>
<i>décembre 2010.i>
<i>Septième résolution:i>
Le mandat du commissaire aux comptes Julien Nicaud arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de nommer la
société Finsev SA, avec adresse au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, nouveau commissaire aux comptes.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2016.
Luxembourg, le 13 décembre 2010.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Xavier Mangiullo
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010174277/19.
(100200056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
Vontobel Exchange Traded Structured Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.940.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 13 décembre 2010 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
M. Dominic GAILLARD
M. Philippe HOSS
M. Anders MALCOLM
M. Markus PFISTER
Mme Annemarie ARENS
en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2011,
- de renouveler le mandat de:
Ernst & Young S.A., Luxembourg,
en sa qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2011.
<i>Pour Vontobel Exchange Traded Structured Fund
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2010174295/25.
(100199984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.
19383
L
U X E M B O U R G
TAXIS Caçao S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
R.C.S. Luxembourg B 141.645.
C/O Monsieur Djamel HACHEMI
Je vous prie de prendre connaissance que j'ai le regret de vous annoncer ma démission comme gérante technique de
votre société, et ceci avec effet immédiat.
Bettembourg le 19 janvier 2011.
Adelino CABECO CACAO.
Référence de publication: 2011012512/10.
(110013410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Macquarie-FSS Infrastructure Funds S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 231.000,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 109.418.
Par résolutions signées en date du 13 décembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Patricia Barata Rodrigues, avec adresse professionnelle au 1, Ropemaker Street,
bâtiment Citypoint, EC2Y 9HD Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant B avec effet au 30 novembre 2010
2. nomination de Juan Cano, avec adresse professionnelle au 1, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Royaume-
Uni, au mandat de gérant B, avec effet au 1
er
décembre 2010 et pour une période indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2011.
Référence de publication: 2011011584/14.
(110012982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Promovis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.
R.C.S. Luxembourg B 67.377.
L'an deux mille dix,
Le vingt-et-un décembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PROMOVIS S.A.", avec siège
social à L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3
décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 98 du 18 février 1999, modifiée
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 112 du 5 février 2007, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9
octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2660 du 20 novembre 2007, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 67.377.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jeannot PHILIPP, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Siyuan Isabelle HAO, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-France PASTORE, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu
comme suit:
19384
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
2. Augmentation du capital à concurrence de treize euros et trente-et-un cents (EUR 13,31), pour le porter de son
montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente-et-un
mille euros (EUR 31.000,00), sans création de nouvelles actions, par un apport en espèces.
<i>Souscription et Libération.i>
3. Création de trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune et souscription
des trois cent dix (310) actions par les actionnaires existants au prorata de leur participation.
4. Augmentation du capital à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,00) pour le porter de son montant de
trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) à cent trente-et-un mille euros (EUR 131.000,00), par la création et l'émission
de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.
5. Souscription des mille (1.000) actions nouvelles par la société "Questra Group International Ltd", société de droit
des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, P.O. Box 144, Road Town, British Virgin Islands, inscrite au
registre de commerce des BVI sous le numéro 276958, et libération à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%), à savoir
vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00).
6. Instauration d'un capital autorisé et modification subséquente de l'article 5 des statuts, lequel aura dorénavant la
teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à cent trente-et-un mille euros (EUR 131.000,00), représenté par mille trois cent dix
(1.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00) par la
création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le conseil d'administration est autorisé et mandaté: -à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par
tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature,
par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation
de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée
d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, et peut être renouvelé par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui d'ici n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute autre personne qu'il aura mandatée
à ces fins."
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de supprimer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize euros et trente-et-un cents (EUR
13,31), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00).
L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée, l'actionnaire
majoritaire, à savoir la société "TRUSTCAPITAL S.A.", société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2715 Lu-
xembourg, 2, rue Walram, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
le numéro 39.680, représentée par ses administrateurs, à savoir Monsieur Jeannot PHILIPP, prénommé, et Madame Marie-
France PASTORE, prénommée.
L'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription.
19385
L
U X E M B O U R G
Le souscripteur a intégralement libéré l'augmentation de capital par un apport en espèces d'un montant de treize euros
et trente-et-un cents (EUR 13,31), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale décide de créer trois cent dix (310) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR
100,00) chacune, les trois cent dix (310) actions étant réparties entre les actionnaires existants au prorata de leur par-
ticipation.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,00) pour
le porter de son montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) à cent trente-et-un mille euros (EUR 131.000,00),
par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Cinquième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital décidée à la quatrième résolution,
la société "Questra Group International Ltd", société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola,
P.O. Box 144, Road Town, British Virgin Islands, inscrite au registre de commerce des BVI sous le numéro 276958, et
représentée par son directeur Monsieur Jeannot PHILIPP, prénommé, les autres actionnaires ayant renoncé à leurs droits
préférentiels de souscription.
Le souscripteur a libéré par un apport en espèces à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%) l'augmentation de capital
ci-avant décidée, de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Sixième résolution:i>
L'assemblée générale décide d'introduire une autorisation de capital autorisé à concurrence de un million huit cent
soixante-neuf mille euros (EUR 1.869.000,00), pour porter le capital social de son montant actuel de cent trente-et-un
mille euros (EUR 131.000,00) à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00), le cas échéant par l'émission de dix-huit mille
six cent quatre-vingt-dix (18.690) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article cinq des statuts, lequel aura
dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social est fixé à cent trente-et-un mille euros (EUR 131.000,00), représenté par mille trois cent dix
(1.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00) par la
création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée
d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, et peut être renouvelé par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui d'ici n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute autre personne qu'il aura mandatée
à ces fins."
<i>Déclaration:i>
Les représentants des actionnaires déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée
par la suite, que leurs mandants sont les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifie que la
société ne se livre pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi
19386
L
U X E M B O U R G
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blan-
chiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: J. Philipp, S. I. Hao, M-F. Pastore, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2010. Relation: LAC / 2010 / 58013. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 30 décembre 2010.
Référence de publication: 2011003350/152.
(110002880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2011.
Lane & Space Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 28.993.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2011.
Référence de publication: 2011015731/10.
(110018851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.
xinex s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises.
R.C.S. Luxembourg B 119.531.
Changement d'adresse de l'associé
Ancienne adresse: EUSCOPE S.A., 18, Rue Hiehl, L - 6131 JUNGLINSTER
Nouvelle adresse: EUSCOPE S.A., 42, rue des Cerises, L - 6113 JUNGLINSTER
Junglinster, le 21 janvier 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011011285/11.
(110013191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
xinex s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises.
R.C.S. Luxembourg B 119.531.
Changement d'adresse du gérant
Ancienne adresse: Paul LAPLUME, 18, Rue Hiehl, L -6131 JUNGLINSTER
Nouvelle adresse: Paul LAPLUME, 42, rue des Cerises, L - 6113 JUNGLINSTER
Junglinster, le 21 janvier 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011011286/11.
(110013191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Andbanc Asset Management Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.174.
En date du 12 octobre 2010, M. Donald Villeneuve a été nommé en tant qu’administrateur-délégué. De ce fait, le
conseil d’administration d’Andbanc Asset Management Luxembourg S.A. se compose à partir du 12 octobre 2010 comme
suit, et ce jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2011:
- M. Ricard Tubau Roca, Président, né le 13/10/1973 à Barcelone, et demeurant professionnellement à Manuel Cerqueda
i Escaler n°6, AD700 Escaldes-Engordany (Andorre);
19387
L
U X E M B O U R G
- M. Hugo Pou Méndez, Administrateur, né le 03/06/1973 à Barcelone, et demeurant professionnellement à Manuel
Cerqueda i Escaler n°6, AD700 Escaldes-Engordany (Andorre);
- M. Josep Garcia Nebot, Administrateur, né le 17/12/1956 à Barcelone, et demeurant professionnellement à Manuel
Cerqueda i Escaler n°6, AD700 Escaldes-Engordany (Andorre);
- M. Philippe Esser, Administrateur délégué, né le 05/06/1964 à Saragosse, et demeurant professionnellement à Rue
Robert Stümper 7A, L-2557 Luxembourg (Luxembourg);
- M. Donald Villeneuve, Administrateur délégué, né le 23/04/1963 à Québec, et demeurant professionnellement à Rue
Robert Stümper 7A, L-2557 Luxembourg (Luxembourg);
Dès lors, Monsieur Donald Villeneuve, Administrateur délégué, est également chargé de la gestion journalière pour
une durée indéterminée.
Andbanc Luxembourg S.A.
Philippe Esser / Donald Villeneuve
<i>Administrateurs-déléguési>
Référence de publication: 2011011306/25.
(110011598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
A & M Industries S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 412.600,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 90.617.
Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l’adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc
d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1
er
janvier 2011.
De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Stewart Kam-Cheong, gérant de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach
Munsbach, le 7 janvier 2011.
Référence de publication: 2011011287/15.
(110012989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Ageasfinlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.976.
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 13 janvier 2011i>
1) Monsieur Benoît NASR a démissionné de son mandat d’administrateur.
2) Monsieur Cédric BRADFER a démissionné de son mandat d’administrateur.
3) Monsieur Paul Jan L GORIS a démissionné de son mandat d’administrateur.
4) Le nombre des administrateurs a été diminué de 6 (six) à 5 (cinq).
5) Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, et Monsieur
David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, tous deux demeurant professionnelle-
ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été nommés comme administrateurs jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2014.
Luxembourg, le 19 janvier 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ageasfinlux S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2011011290/20.
(110013517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
19388
L
U X E M B O U R G
Duaruz Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.843.
Suite à un transfert de parts sociales intervenu en date du 30 décembre 2010, le capital social de la société DUARUZ
INVESTMENTS S.à r.l. est reparti de la manière suivante:
Détenteurs de parts sociales
Nombre
de parts
sociales
DUARUZ GROUP SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Thierry PERENNEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Fait le 30 décembre 2010.
Certifié sincère et conforme
DUARUZ INVESTMENT S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011011412/19.
(110013098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Gottex Shelf Company 7, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 155.561.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de la société Agri SerFinCo S.à r.l. prises par l’associé unique en date du 18 août 2010,
la nomination en tant que gérant de la société de:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., établie et ayant son siège social 20, rue de la Poste à L- 2346
Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37 974
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Agri SerFinCo S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2011011291/16.
(110013387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Gottex Shelf Company 8, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 155.564.
Il résulte des résolutions écrites de la société Agri SubSerFinCo S.à r.l. prises par l’associé unique en date du 18 août
2010, la nomination en tant que gérant de la société de:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., établie et ayant son siège social 20, rue de la Poste à L- 2346
Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37 974
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Agri SubSerFinCo S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2011011292/15.
(110013388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
19389
L
U X E M B O U R G
Cephalon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.702.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 86.498.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 10 décembre 2010.i>
L'associé unique a pris acte et confirmé que les deux gérants en fonction et leur adresse professionnelle actuelle
respective sont comme suit:
- Monsieur J. Kevin BUCHI, avec adresse professionnelle au 41 Moores Road, Frazer, Pennsylvanie 19355, Etats-Unis
d'Amérique;
- Monsieur Gerald John PAPPERT, avec adresse professionnelle au 41 Moores Road, Frazer, Pennsylvanie 19355, Etats-
Unis d'Amérique.
L'associé unique a décidé d'augmenter le nombre de gérants de la Société de deux à cinq.
L'associé unique a décidé de nommer avec effet immédiat chacune des trois personnes suivantes en tant que gérants
additionnels pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc LIESCH, avec adresse professionnelle au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg;
- Monsieur Jan WERKMAN, avec adresse professionnelle à Baarerstrasse 23, 6300 Zug, Suisse;
- Monsieur Sergio CORREA DE SAMPAIO, avec adresse professionnelle au 5, rue Charles Martigny, 94700 Maisons-
Alfort, France;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011011351/24.
(110013673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Alkern Participation, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.042.716,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 146.303.
Le siège social de l'associé et gérant, Fondations Capital I SCA SICAR est à présent au 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2011.
Référence de publication: 2011011293/12.
(110012968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Allied Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.003,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 130.204.
Il résulte d'un contrat signé en date du 20 décembre 2010 que Tyco International Holding S.à r.l. a cédé à Aktore
International, Inc ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19081, Etats Unis et immatriculée
sous le numéro 4889927, la totalité des 17 003 parts sociales de la Société.
Depuis le 20 décembre 2010, Aktore International, Inc est l'associé unique de la Société.00
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Allied Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011011304/16.
(110013759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
19390
L
U X E M B O U R G
Gima S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 59.525.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009,
tenue en date du 15 octobre 2010 que:
Sont réélus, en qualité d'Administrateurs de la société, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année
2016:
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412 F, Route
d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Thierry JACOB, né le 07 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412 F, Route
d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412
F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:
- Monsieur Michele ROMERIO, né le 20 mai 1967 à Sorengo (Suisse), demeurant professionnellement au 26, Carabella,
CH-6582 Pianezzo (Suisse).
Le siège social de la société est transféré du 25, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 412 F, Route d'Esch,
L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 janvier 2011.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2011011883/26.
(110013360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Anglo-Dutch Investment Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 80.881.
Par résolutions signées en date du 20 décembre 2010, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Marie-
Laurence Lambert avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant
avec effet immédiat
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2011.
Référence de publication: 2011011307/13.
(110012969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
ArcIndustrial France Developments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.783.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 112.938.
Suite à une décision du conseil communal de Schuttrange, l’adresse de la Société a été renommée du «6C, Parc
d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1
er
janvier 2011.
De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr.Olivier Dorier, gérant A de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach
- le siège social de l’actionnaire ArcIndustrial European Developments S.à r.l. est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach
Munsbach, le 14 janvier 2011.
Référence de publication: 2011011309/17.
(110012826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
19391
L
U X E M B O U R G
Universal Credit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 142.879.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2010i>
En date du 30 décembre 2010, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- d’accepter la démission, avec effet au 24 septembre 2010, de Monsieur Stephen Zinser en qualité d’Administrateur
- de ratifier la cooptation, avec effet au 24 septembre 2010, de Monsieur Patrick Zurstrassen, MDO Services, 19, rue
de Bitbourg, L – 1273 Luxembourg, en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2011
- de nommer, avec effet au 30 décembre 2010, Monsieur Scott Edel, 10100 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, USA,
en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011
- de nommer, avec effet au 30 décembre 2010, Monsieur Clive Gilchrist, 1 Queen Street Place, UK – EC4R 1QS
Londres, en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011
- de nommer, avec effet au 30 décembre 2010, Monsieur Yves Wagner, MDO Services, 19, rue de Bitbourg, L – 1273
Luxembourg, en qualité d’Administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011
- de nommer, avec effet au 30 décembre 2010, de Monsieur James Pope en qualité de Président du Conseil d’Admi-
nistration pour une durée indéterminée
Luxembourg, le 10 janvier 2011.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2011011717/24.
(110012768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Beyton Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.519.
RECTIFICATIF
Notification rectificative d'une notification enregistrée et déposée le 29 novembre 2010 sous le L100181896.05 E:
- Veuillez prendre note de la correction suivante:
La dénomination de l'associé EES Trustees International Limited
- immatriculé 92182 auprès du Jersey Financial Services Commission
- ayant son siege social à Queensway House, Hilgrove Street, JE4 8YW St Helier au Jersey
- détenteur de 8,803 parts sociales de la Société
se nomme désormais: EES Trustees International Limited as trustee of the Candover 2001 Employee Benefit Trust
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F.W.J.J. Welman
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2011012428/19.
(110013275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Anglesite Sea S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011016045/10.
(110018932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
19392
Agalux Investment Company S.A.
Ageasfinlux S.A.
Alkern Participation
Allied Luxembourg S.à r.l.
A & M Industries S.à.r.l.
Andbanc Asset Management Luxembourg
Anglesite Sea S.à r.l.
Anglo-Dutch Investment Group S.à r.l.
ArcIndustrial France Developments I S.à r.l.
Babcock Luxembourg Investments II S.à r.l.
Beyton Investments S.à r.l.
Britanny Investment
Cephalon Luxembourg S.à r.l.
Cipio Partners Fund VI S.C.S., SICAR
Conengineering Holding S.A.
Convert Technology S.A.
Crossroads Property Investors S.A.
Drayton S.A.
Duaruz Investments S.à r.l.
Eco-Building-Concept AG
Editions Letzeburger Journal S.A.
Eucalyptus
Financial Mathematics S.A.
G3 Holdings S.à r.l.
Gartmore Sicav
Gima S.A.
Global Advantage Funds
Global Crossing PEC Luxembourg I S.à r.l.
Gottex Shelf Company 7
Gottex Shelf Company 8
Immo-Style S.A.
Inland Navigation Luxembourg S.A.
Kingsgate Properties S.à r.l.
Lambrusco Participations S.A.
Lane & Space Holding S.A.
Les Bierts
LUXEMBURGER TEAM, Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Funktions- und Kostenoptimierung S.A.
Macquarie-FSS Infrastructure Funds S.à r.l.
Minerva Patents S.A.
Morgan Stanley Alzette S.à r.l.
Morgan Stanley Derivative Products (Luxembourg) S.à r.l.
Nouvelle GAZEAUTHERME S.à r.l.
Palca Investments
Pictet Select
Promovis S.A.
Quint:Essence Concept
Revedaflo
Société Luxembourgeoise d'Investissements et de Placements S.A.
TAXIS Caçao S.à r.l.
Tyche S.A.
Universal Credit S.A.
Valbonne I
Vontobel Exchange Traded Structured Fund
Working Capital Providers S.A.
xinex s.à r.l.
xinex s.à r.l.