logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 352

22 février 2011

SOMMAIRE

AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean

Star Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

16870

Alpha Advisory Company S.A.  . . . . . . . . . .

16869

Annibal S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16870

Camtech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16870

Catolex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16871

CEREP III Investment W S.à r.l.  . . . . . . . . .

16871

Condor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

16873

Condor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

16873

Condor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

16873

Condor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

16874

Corestate Sailing HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . .

16853

DJ Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16874

Douglas Parfums et Beauté S.à r.l.  . . . . . . .

16874

Eurofins Forensics LUX . . . . . . . . . . . . . . . . .

16874

Eurofins Industrial Testing LUX  . . . . . . . . .

16893

Eurofins Pharma Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16893

Eurofins Product Testing LUX  . . . . . . . . . .

16894

Eurofins Support Services LUX . . . . . . . . . .

16894

Flydutch S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16881

Forvest Investment Group S.A.  . . . . . . . . .

16874

Four Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16875

Global Europ Product. S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

16850

Golf 2010 Luxembourg S.C.A.  . . . . . . . . . . .

16870

Grey Grafton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16875

Hardey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16895

HomeStraight S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16893

I.E.C.L. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16895

Inteuro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16895

Investimmo International S.A.  . . . . . . . . . .

16869

Investimmo International S.A.  . . . . . . . . . .

16869

Julienne Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16896

Lai Fu Cis (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

16882

Lauro 28 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16882

La Vital S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16882

L.C.I. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16881

L'électricien Haag S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

16882

Limage Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16882

Limage Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16892

Limage Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16883

LSH CO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16892

LSH II CO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16893

Lux Developers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16893

Marc Muller Conseils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

16875

MESH S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16871

Montgomery Investment Co S.A. . . . . . . . .

16896

Orestes Holding Société Anonyme  . . . . . .

16894

Saint Patrick Alienations and Acquisitions

Studies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16851

Sapporo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852

Sea-Invest Afrique S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16851

SHIP Investor & Cy S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

16883

SHIP Investor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852

Somurel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16852

Spartakus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16860

Therabel Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16860

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16861

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16861

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16861

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16861

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16861

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16860

Tuxon Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16862

Vuksan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16862

Web Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16863

White Stone Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

16862

16849

L

U X E M B O U R G

Global Europ Product. S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9560 Wiltz, 21, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 157.599.

STATUTS

L'an deux mille dix, le 15 décembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur Abdelaziz AHROUCH, commerçant, né à Nador (Maroc) le 11 avril 1978, demeurant à F-59320 Hau-

bourdin, 5, allée de la Becque.

Lequel comparant a, par les présentes, déclaré constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «Global Europ Product. S.à r.l.» société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Wiltz.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé

(s).

Art. 3. L'objet de la société est l'import et l'export, l'achat et la vente, la commercialisation et la distribution d'articles

et de produits, de quelque nature que ce soit.

La société pourra acquérir et détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et s'occuper de l'administration, de la gestion et du marketing de ces sociétés.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

En général, elle pourra faire toutes opérations et prendre toute mesure se rapportant directement ou indirectement

à son objet et qu'elle jugera utile dans l'accomplissement de son objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le consen-

tement exprès des autres associés.

Art. 7. La société est administrée par un gérant.
L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du gérant.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés.
En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part devront désigner l'un d'eux pour les représenter
à l'égard de la société.

Art. 9. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, l'associé unique se soumet à la législation en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2011.

<i>Souscription:

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique Monsieur Abdelaziz

AHROUCH, prénommé. La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (12.500, EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

16850

L

U X E M B O U R G

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réuni en assemblée générale extraordinaire, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des gérants est fixé à un.
II.- Est nommé gérant unique de la société:
Monsieur Abdelaziz AHROUCH, pré-qualifié, qui accepte son mandat.
La société est valablement engagée par la signature exclusive et individuelle du gérant unique.
III.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-9560 WILTZ, 21, rue du X Septembre.

Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être

le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.

Signé: Ahrouch, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2010. Relation: LAC/2010/57006. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 26 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172152/75.
(100199987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Saint Patrick Alienations and Acquisitions Studies SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 108.037.

We hereby resign as Auditor of your company with immediate effect.
Par la présente, nous vous remettons notre démission comme commissaire aux comptes de votre société avec effet

immédiat.

Le 31 décembre 2010.

CederLux-Services S.à r.l.
Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2011008869/14.
(110008564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Sea-Invest Afrique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 133.563.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 décembre 2010

Le siège social de la société est transféré du 38, Avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg au 10A, rue Henri M.

Schnadt L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2011008873/12.
(110008889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16851

L

U X E M B O U R G

Sapporo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 108.880.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 18 août 2010, les mandats des Administrateurs VALON S.A., société

anonyme,  VALON  S.A.,  société  anonyme  et  KOFFOUR  S.A.,  société  anonyme,  ainsi  que  celui  du  Commissaire  aux
comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2016.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: SAPPORO HOLDING S.A.
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011008870/17.
(110009035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

SHIP Investor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.890.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision des actionnaires de la Société du 30 novembre 2010 que:
- Monsieur Robin MARSHALL a démissionné de son poste d'Administrateur de Catégorie B de la Société;
- Monsieur Michael J. RISTAINO a démissionné de son poste d'Administrateur de Catégorie A de la Société;
- Monsieur Phil LOUGHLIN né le 10 septembre 1967 dans le Missouri, Etats-Unis d'Amérique, résidant au 111, Hun-

tington Avenue, Boston MA 02199, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé en tant qu'Administrateur de Catégorie B de
la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat;

- Monsieur Desmond MITCHELL né le 24 août 1957 dans le Wells, Royaume-Uni, résidant au 41 Rue Siggy vu Letze-

buerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant qu'Administrateur de Catégorie A de
la Société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

Dès lors, le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:

<i>Administrateurs de Catégorie A:

- Madame Maike KIESELBACH Monsieur Desmond MITCHELL

<i>Administrateurs de Catégorie B:

- Madame Ailbhe JENNINGS
- Monsieur Phil LOUGHLIN

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011008879/27.
(110008961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Somurel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 72.789.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 décembre 2010, les actionnaires ont pris les décisions

suivantes:

Acceptation de la démission de Mr. David GOFF, avec adresse au 42, Albermarle Street, W1S 4JH Londres, Royaume-

Uni, en tant qu'administrateur en date du 27 octobre 2010.

Acceptation de la démission de Mr. Jehangir JAMSHED MEHTA, avec adresse au 24, Bedford Row, WC1 4TQ Londres,

Royaume-Uni, en tant qu'administrateur avec effet au 5 novembre 2010.

16852

L

U X E M B O U R G

Nomination de Mr. Gérald Calame, avec adresse professionnelle au 16, rue de Hesse, CH-1204 Genève, Suisse, en

tant qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Nomination de Mr. Joaquim Semiao, avec adresse au 24, Bedford Row, WC1 4TQ Londres, Royaume-Uni, en tant

qu'administrateur avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera les comptes annuels se terminant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2010.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2011008881/25.
(110008904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Corestate Sailing HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 157.605.

STATUTES

In the year two thousand ten, on seventeenth December 2010 at 3.30 p.m.
Before, Maître Camille Mines, notary residing in Capellen.

THERE APPEARED:

CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at

Baarerstrasse  135,  CH-6300  Zug  (Switzerland),  registered  with  the  trade  register  of  Kanton  Zug  under  number
CH-020.3.030.000-1, represented by Mr Thomas Landschreiber, director;

here represented by Mr Philippe Ney, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Tug on December 16 

th

 , 2010.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Co-

restate Sailing HoldCo S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

Euro), represented by 125 (one hundred twenty five) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) per share
each.

16853

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by

16854

L

U X E M B O U R G

other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts are established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>1. Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (one hundred twenty five) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (one hundred twenty five) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

16855

L

U X E M B O U R G

<i>2. Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2011.

<i>3. Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately € 1.200,-.

<i>4. Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 1 (one). The meeting appoints as sole manager of the Company for an unlimited

period of time:

Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Capellen, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend zehn, am siebzehnten Dezember, um 15.30 Uhr.
Vor Maître Camille Mines, Notar mit Amtswohnsitz in Capellen.

IST ERSCHIENEN:

CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300

Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-020.3.030.000-1, vertreten durch
Herrn Thomas Landschreiber, Verwaltungsratsmitglied;

vertreten durch Herrn Philippe Ney, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift, ausgestellt in Zug am 16. Dezember 2010.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung "Corestate Sailing HoldCo S.à r.l." (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-

ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,

sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

16856

L

U X E M B O U R G

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt

in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die  Gesellschafterversammlung  kann  jederzeit  den  Geschäftsführer,  oder  wenn  mehrere  Geschäftsführer  bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-

tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft

16857

L

U X E M B O U R G

mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  anwesend;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden  oder  vertretenen  Geschäftsführern,  im  Falle  einer  von  einem  Vorsitzenden  geleiteten  Sitzung  von  diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen.

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung

16858

L

U X E M B O U R G

einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-

prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach den Artikeln 256 und 215 des
Gesetzes von 1915 keine Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>1. Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

CORESTATE CAPITAL AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)

ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.

<i>2. Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2011.

<i>3. Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr € 1.200,-.

<i>4. Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person

für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Capellen erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Ney, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 21 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4585. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 24. Dezember 2010.

Référence de publication: 2010172062/362.
(100200027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

16859

L

U X E M B O U R G

Spartakus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 15, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 113.060.

<i>Extrait du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 05 septembre 2010.

Démission de Madame Campoy Ruiz Maria Pilar, gérante administrative de la société.

Esch-sur-Alzette, le 05 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011008882/12.
(110009001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Therabel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.202.

- Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2011 que les actionnaires ont décidé

de révoquer le mandat de commissaire aux comptes et de réviseur d'entreprises de la société INTERAUDIT S.à r.l., B
29 501, ayant établie son siège social au 119, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet à la date de l'as-
semblée.

- Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2011 que les actionnaires ont décidé

de nommer en remplacement au poste de réviseur d'entreprises la société KPMG Audit S.à r.l., B 103 590, ayant établie
son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet à la date de l'assemblée.

Le mandat du nouveau réviseur prendra fin lors de l'assemblée qui se réunira pour l'approbation des comptes au

31/12/2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

<i>Pour la société
Jorge Pérez Lozano / Paul Van Baarle
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2011008889/21.
(110008922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Treid SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

La société FIDUCENTER SA avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg dénonce de plein droit son

contrat de domiciliation avec la société:

TREID S.A.
RCS B101021
18, rue de l'Eau
L-1449 Luxembourg
avec effet immédiat.
Partant, le siège social de ladite société est également dénoncé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER SA
<i>Le domiciliataire
Michaël ZIANVENI / Marc KOEUNE
<i>Directeur / Directeur

Référence de publication: 2011008893/21.
(110008588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16860

L

U X E M B O U R G

Treid SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Nicole THOMMES.

Référence de publication: 2011008894/10.
(110008592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Treid SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Andrea DANY.

Référence de publication: 2011008895/10.
(110008595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Treid SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Jean-Yves NICOLAS.

Référence de publication: 2011008896/10.
(110008597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Treid SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

I hereby resign as Director of your company with immediate effect.
Par la présente, je vous remets ma démission comme Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Marc KOEUNE.

Référence de publication: 2011008897/10.
(110008598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Treid SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

We hereby resign as Auditor of your company with immediate effect.
Par la présente, nous vous remettons notre démission comme commissaire aux comptes de votre société avec effet

immédiat.

Le 31 décembre 2010.

CederLux-Services S.à r.l.
Signature
<i>Le gérant

Référence de publication: 2011008898/14.
(110008600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16861

L

U X E M B O U R G

Tuxon Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.594.

Par décision du Conseil d'administration du 06 décembre 2010, le siège social a été transféré du 180, rue des Aubépines,

L-1145 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet immédiat. De plus, veuillez noter que doré-
navant l'adresse professionnelle des administrateurs et du commissaire aux comptes:

Monsieur Guy KETTMANN, Administrateur de la société.
Monsieur Olivier LECLIPTEUR, Administrateur de la société.
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, Commissaire aux comptes de la société
est située au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg avec effet au 06 décembre 2010.
Concernant l'administrateur Monsieur Jean BODONI, veuillez noter que son adresse professionnelle est située au 69,

route d'Esch, L-2953 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 06 DEC. 2010.

<i>Pour: TUXON PROPERTIES S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon

Référence de publication: 2011008899/22.
(110008991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Vuksan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 98.240.

EXTRAIT

Les administrateurs de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société avec effet au 7 janvier 2011 au

36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2011.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2011008903/14.
(110008880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

White Stone Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 63.211.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009

<i>1 

<i>re

<i> Résolution

L'assemblée constate que les mandats d'administrateurs des personnes suivantes sont expirés en date du 12 juin 2009:
- Monsieur Christian HESS, demeurant à L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance
- Monsieur Norbert EBSEN, demeurant à L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l'Eglise
- Monsieur Roland EBSEN, demeurant à L-6633 Wasserbillig, 2, route de Luxembourg
L'assemblée décide de manière unanime la nomination des personnes suivantes au conseil d'administration de la société:
- Monsieur Eric BERNARDY, demeurant à L-8030 Strassen, 93, rue du Kiem
- Monsieur Franco SOLERTE, demeurant à B-6780 Wolcrange, 12 rue des Tilleuls
- Madame Nelly NOËL, demeurant à L-2440 Luxembourg, 121, rue de Rollingergrund
Les mandats des membres du conseil d'administration expireront lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année

2014.

16862

L

U X E M B O U R G

<i>2 

<i>e

<i> Résolution

L'assemblée constate que le mandat comme commissaire aux comptes de la société ACCOUNT DATA EUROPE S.A.

est expiré en date du 12 juin 2009.

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la nomination de Madame Rita JUNKER, demeurant à L-1466 Luxembourg,

2, rue Jean Engling, au poste de commissaire aux comptes de la société dont le mandat expirera lors de l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2014.

<i>3 

<i>e

<i> Résolution

L'assemblée décide unanimement la révocation de Monsieur Roland EBSEN de son mandat d'administrateur-délégué

de la société.

<i>4 

<i>e

<i> Résolution

L'assemblée décide à l'unanimité la nomination de Madame Nelly NOËL, demeurant à L-2440 Luxembourg, 121, rue

de Rollingergrund, au poste d'administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager la société en toutes circons-
tances par sa seule signature.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011008905/34.
(110008951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Web Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 157.600.

STATUTS

L'an deux mille dix, le huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Thomas Muller, directeur de sociétés , avec adresse à 42113 Wuppertal, Katernberger str, 169D, Alle-

magne

dûment représenté par Mrs Anne-Sophie GUILLON, employée privée, avec adresse professionnelle au 18-20 rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée en date du 6 Septembre 2010 à Luxembourg;

2) Monsieur Christoph Gruneberg, directeur de sociétés, avec adresse à Dickmannstr 47, 42287 Wuppertal, Allemagne
dûment  représenté  par  Mrs  Anne-Sophie  GUILLON,  avec  adresse  professionnelle  au  18-20  rue  Michel  Rodange,

L-2430 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée en date du 6 Septembre 2010 à Luxembourg;

3) Monsieur Roger Greden, directeur de sociétés, avec adresse au 4A rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand

Duché de Luxembourg,

dûment  représenté  par  Mrs  Anne-Sophie  GUILLON,  avec  adresse  professionnelle  au  18-20  rue  Michel  Rodange,

L-2430 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée en date du 1 

er

 Décembre 2010 à Luxembourg;

Les prédites procurations resteront annexées au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de

Web Investments S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet principal l'investissement dans les noms de domaine sur internet et l‘investissement

dans toute autre forme de droits de propriété intellectuelle, ainsi que la détention, la gestion, la mise en valeur, la cession,
la concession de ces noms de domaines et de ces autres droits de propriété intellectuelle.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

16863

L

U X E M B O U R G

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions de EUR

100.- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ou des

actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant

au cas où la société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la société
n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société n'a qu'un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration désigne son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est

conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par voie de vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet de pouvoir identifier les participants. Ces moyens de
communication doivent satisfaire aux caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion et
sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette
réunion. La réunion tenue par ces moyens de télécommunication est réputée avoir été tenue au siège social.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs
seront arrêtés par le Conseil d'administration. La délégation à un membre du Conseil d'administration entraîne l'obligation
pour le Conseil d'administration de faire rapport chaque année à l'assemblée générale ordinaire sur le salaire, les frais et
autres  avantages  accordés  au  délégué.  La  société  pourra  également  conférer  des  pouvoirs  spéciaux  par  procuration
authentique ou sous seing privé.

Exceptionnellement, la première personne à laquelle sera déléguée la gestion journalière de la société, pourra, le cas

échéant, être nommée par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société sera engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de

toute  personne  à  qui  de  pareils  pouvoirs  auront  été  délégués  par  le  Conseil  d'administration.  Au  cas  où  le  Conseil
d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par le signature individuelle de l'administrateur
unique.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

16864

L

U X E M B O U R G

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves

autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par
voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que
le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de
participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) A titre exceptionnel, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre

2011.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Mr Thomas Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 actions
2) Mr Christoph Gruneberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 actions
3) Mr Roger Greden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 actions

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25% au moins, de sorte que la

somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.500.-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré qualifiés, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se

reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'una-
nimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
Mr Thomas Muller, avec adresse à 42113 Wuppertal, Katernberger str, 169D, Allemagne, né à Wuppertal, le 18 août

1969.

Mr Christoph Gruneberg, avec adresse à Dickmannstr 47, 42287 Wuppertal, Allemagne, né à Wuppertal, le 21 avril

1971.

Mr Roger Greden , avec adresse au 4A rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, né à Arlon,

le 28 octobre 1953.

16865

L

U X E M B O U R G

L'assemblée, faisant usage de la faculté lui étant reconnue par l'article cinq des statuts, nomme pour une durée n'ex-

pirant pas six ans Monsieur

Roger Greden, prénommé, en qualité d'administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi

que sa représentation en ce qui concerne cette gestion sous sa signature individuelle.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EPI International SA , ayant son siège social au 20 rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, inscrit au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.232.

4.Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-déléguée et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assem-

blée générale annuelle de 2016.

5. Le siège social est fixé au 18 rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Follows the English version of the foregoing text:

In the year two thousand and ten, on the eighth of December.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

1) Mr Thomas Muller, companies'director, having its address at 42113 Wuppertal, Katernberger str, 169D, Germany
duly represented by Mrs Anne-Sophie GUILLON, private employee, with professional address at 18-20 rue Michel

Rodange, L-2430 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 6 September 2010;

2) Mr Christoph Gruneberg, companies'director, having its address at Dickmannstr 47, 42287 Wuppertal, Germany
duly represented by Mrs Anne-Sophie GUILLON, with professional address at 18-20 rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 6 September 2010;

3) Mr Greden Roger, companies'director, having its address at 4A rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg,

duly represented by Mrs Anne-Sophie GUILLON, with professional address at 18-20 rue Michel Rodange, L-2430

Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 1 December 2010;

The said proxies will remain attached to the present deed.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of
Web Investments S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company, which notwithstanding such

provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The company is established for an unlimited period.

Art. 2. The principal object of the company is the investment in domain names on Internet and investment in other

field of intellectual property rights as well as the holding, management, development, transfer, concession of the domain
names and of these others intellectual property rights.

The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg

or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 310 (three hundred and

ten) shares of EUR 100.- (one hundred euro) each.

16866

L

U X E M B O U R G

The  shares  may  be  registered  or  bearer  shares,  at  the  option  of  the  holder,  except  those  shares  for  which  Law

prescribes the registered form.

The company's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or more

shares.

The corporate capital may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders deliberating

in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed

by the old shares.

Art. 4. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders. However, in case the company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
meeting of shareholders that the company has only one shareholder left, the composition of the board of director may
be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that one
shareholders in the company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director will preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the company.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the company as well as the representation of the company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Exceptionally, the first person to whom the daily management of the company will be delegated could be nominated

by the first extraordinary general meeting of the shareholders following the incorporation of the company.

The company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 6.  The  company  shall  be  supervised  by  one  or  more  auditors,  who  need  not  be  shareholders;  they  shall  be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The company's financial year shall begin on the first day of January and shall end on 31 

st

 day of December of

each year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated

in the convening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m..

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the company.

16867

L

U X E M B O U R G

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and
replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reim-
bursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-
redeemed shares.

Art. 12. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these articles of

incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

5. Extraordinary, the first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2011.
6. The first annual general meeting shall be held in 2012.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:

1) Mr Thomas Muller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 shares
2) Mr Christoph Gruneberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 shares
3) Mr Roger Greden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 shares

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

All these shares have been partially paid up by payments in cash at the percentage of 25%, so that the sum of EUR 7

750.- (seven thousand seven hundred and fifty euros) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved
to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an

extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following reso-
lutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at 3 and that of the auditors at 1.
2. The followings are appointed directors:
Mr Thomas Muller, having its address at 42113 Wuppertal, Katernberger str, 169D, Germany, born at Wuppetal, on

August 18, 1969.

Mr Christoph Gruneberg, having its address at Dickmannstr 47, 42287 Wuppertal, Germany, born at Wuppertal, on

April 21, 1971.

Mr Roger Greden, having its address at 4A rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born

at Arlon, on October 28, 1953.

According to article five of the articles of incorporation, the general meeting of shareholders decides to appoint for a

period not exceeding six years,

Mr. Roger Greden, previously named, as managing director to conduct the daily management of the company and to

represent the company by its sole signature.

3. Has been appointed auditor:
EPI International, having its regsitered office at 20 rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, registered at the Lux-

embourg Trade and Companies Register under number B 130.232.

4. The mandates of the directors, the managing director and the auditor shall expire immediately after the annual

general meeting of 2016.

5. The registered office will be fixed at 18 rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

16868

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in French, followed by an English translation and that in case of any divergences between
the English text and the French text, the French version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: A.-S. GUILLON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56750. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172437/315.
(100200014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Investimmo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.298.

Par la présente, je vous informe de ma démission, avec effet immédiat, de mon mandat de Commissaire Aux Comptes

de la Société référencée ci-dessus.

Luxembourg, le 31 décembre 2009.

CLAP SARL
<i>Commissaire Aux Comptes
Arnaud BERNARD
<i>Gérant

Référence de publication: 2011009503/14.
(110007928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Investimmo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 146.298.

Par la présente, la société "FIDUCIAIRE ECCA" représentée par son gérant unique Monsieur Guillaume BERNARD,

informe qu'elle démissionne de sa fonction d'administrateur de la Société référencée ci-dessus, et ceci avec effet immédiat.

Strassen, le 31 décembre 2009.

FIDUCIAIRE ECCA
Guillaume BERNARD
<i>Gérant

Référence de publication: 2011009504/13.
(110007930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Alpha Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.375.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALPHA ADVISORY COMPANY S.A.
Signatures
<i>Director A / Director B

Référence de publication: 2011011305/12.
(110012876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

16869

L

U X E M B O U R G

AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011011320/11.
(110012949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Annibal S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.593.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011011324/14.
(110012902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Camtech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 75.521.

Le bilan au 30 septembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011011361/12.
(110013475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Golf 2010 Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 137.331.

Il résulte de trois courriers adressés à la Société en date du 10 janvier 2011 que Mr José CORREIA, Mr Benoît GEORIS

et la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES S.à r.l. ont démissionné de leurs mandats de membres
du Conseil de Surveillance.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
GOLF 2010 S.à r.l.
<i>Gérant commandité
Représenté par Mr Christophe DAVEZAC / Mr Alan DUNDON
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2011007651/16.
(110008607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16870

L

U X E M B O U R G

Catolex, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5215 Sandweiler, 4, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 146.494.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/01/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011011369/12.
(110013575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

CEREP III Investment W S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 141.127.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011374/11.
(110012973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

MESH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 157.596.

STATUTS

L'an deux mil dix, le quinze décembre.
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Patrick STEFFEN, concepteur de sites Internet, né à Luxembourg, le 17 mai 1980, demeurant à L-9636 Berlé,

57, Duerfstrooss.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «MESH S. à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi à Berlé.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.
La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet le conseil d'entreprises dans le domaine de l'Internet, dit social. En outre, la société

pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale,
elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement
ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi
coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales

bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

16871

L

U X E M B O U R G

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les

présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-

vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.
Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant

les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve

légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août
1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant
sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ 1.100,.

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-

ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi Anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et

déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du
code pénal luxembourgeois.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au

notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique, le comparant, Monsieur Patrick STEFFEN,
préqualifié.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2010.

16872

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à

l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss.
2) La société sera gérée par le gérant unique Monsieur Patrick STEFFEN, concepteur de sites Internet, né à Luxem-

bourg, le 17 mai 1980, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être

identifié au moyen de copie de sa carte d'identité.

Signé: P. Steffen, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 16 décembre 2010. Relation: CAP/2010/4538. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 21 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172265/98.
(100199961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

Condor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 50.251.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.01.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011011380/12.
(110012933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Condor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 50.251.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.01.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011011381/12.
(110012934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Condor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 50.251.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.01.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011011382/12.
(110012935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

16873

L

U X E M B O U R G

Condor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 50.251.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.01.2011.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2011011383/12.
(110012936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

DJ Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 148.440.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
DJ INVESTMENTS S.A.
Signature

Référence de publication: 2011011402/12.
(110013742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Douglas Parfums et Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 29.610.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 21 janvier 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011011404/10.
(110013153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Eurofins Forensics LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 154.225.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011420/10.
(110013438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Forvest Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.825.

Les comptes annuels au 31/05/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/01/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2011011458/12.
(110013577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

16874

L

U X E M B O U R G

Four Tools, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 6, Platinerei.

R.C.S. Luxembourg B 118.515.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2011011459/10.
(110013485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Marc Muller Conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 80.574.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2011011466/14.
(110013300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Grey Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 157.632.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the fourteenth day of December,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED

PWREF I Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Grand Rue, 3 

rd

 Floor, L-1660 Luxembourg, registered with the

Luxembourg trade and companies register under registration number B 132 917.

here represented by Flora Gibert, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized among itself and
the articles of incorporation of which shall be as follows

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the “Company”)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present
articles of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of

participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of  investment,  subscription,  underwriting  or  option,  securities  and  patents,  to  realize  them  by  way  of  sale,  transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a
participation, any assistance, loans, advances and guarantees.

16875

L

U X E M B O U R G

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

The Company may also carry out a licensing activity of trademark as well as a financing activity to its subsidiaries. The

Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its
object.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of “Grey Grafton S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. The registered office may be transferred

within the same municipality by decision of the board of managers. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in
proportion to the share in the capital represented by their shares.

Art. 8. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to

the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the
share capital.

Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the

surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers. In that case, the Company will be

bound in all circumstances by the sole signature of one member of the board of managers or by the signature of any
person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers. The managers may be dismissed
freely at any time, without there having to exist any legitimate reason (“cause légitime”).

The board of managers may grant special power by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman resident in the Grand Duchy of

Luxembourg and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not
deed to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorize all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet as often as required and at least on a quarterly basis in the Grand Duchy of Lu-

xembourg, upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman
shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another
manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be

16876

L

U X E M B O U R G

required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager who is not a resident of the United Kingdom may act at any meeting of the board of managers by

appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) does (do) not assume, by reason of its (their) position, any personal liability in relation to

commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore
merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by the shareholders owning more than

half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year, as of the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by PWREF I Holding S.à r.l. as aforementioned.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

16877

L

U X E M B O U R G

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2010.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to adopt the following

resolutions.

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has im-

mediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 22, Grand Rue, 3 

rd

 Floor, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg,

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period,
- Ms. Valérie Scholtes, born on 23 December 1974 in Leuven, Belgium, with professional address at 22 Grand Rue, 3

rd

 Floor, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

- Mr. Gérard Becquer, born on 29 April 1956 in Briey, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

- Mr. Stéphane Bourg, born on 20 October 1973 in Nantes, France, with professional address at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to

bind the Company by their sole signature.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation, on the request of the same
appearing person, the English version will prevail in case of differences between the English and French text.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le quatorze décembre,
Par devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

PWREF I Holding S.à r.l., une société a responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand Duché du

Luxembourg, ayant son siège social au 22 Grand Rue, 3 

ème

 étage, L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132 917.

Ici représentée par Flora Gibert, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit

A. Objecte - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est d'exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l'administration, le contrôle et
le développement de ces participations.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le
contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs
mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer ses

16878

L

U X E M B O U R G

valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés dans lesquelles la Société a une participation tout type d'as-
sistance, prêts, avance et garanties.

La Société peut s'engager dans n'importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société

peut acquérir, transférer et gérer tout bien immobilier de n'importe quelle forme. La Société peut acquérir, transférer
et gérer des immeubles sous n'importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La Société peut enfin s'engager
dans n'importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à la possession de biens im-
mobiliers.

La Société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement

de ses filiales. La Société pourra également accomplir toutes opérations, activité commerciales ou industrielles, qui favo-
risent directement ou indirectement la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Grey Grafton S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentée par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur de un euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés
existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier peuvent être transmises à des non associés que moyennant

l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Dans ce cas, la Société sera engagée

en toutes circonstances par la signature unique d'un membre du conseil de gérance ou par la signature de toute personne
à laquelle tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout moment
révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président résident au Grand-Duché de Luxembourg et

pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que nécessaire et au minimum de façon trimestrielle au Grand-Duché

de Luxembourg, sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité
des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

16879

L

U X E M B O U R G

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant qui n'est pas résident au Royaume-Uni pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance

en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant qui n'est pas résident au Royaume-Uni peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence

téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaire où toutes les personnes prenant
part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité
au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant la preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que
de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collective des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fond de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pourcent (10%) du capital social. Le solde est à libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par PWREF I Holding S.à r.l., susmentionnée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

16880

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2010.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 22 Grand Rue, 3 

ème

 étage, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg,

2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée
- Madame Valérie Scholtes, née le 23 décembre 1974 à Leuven, Belgique, avec adresse professionnelle au 22 Grand

Rue, 3 

ème

 étage, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Gérard Becquer, né le 29 avril 1956 à Briey, France, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Stéphane Bourg, né le 20 octobre 1973 à Nantes, France, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager

valablement par leur signature unique.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande du même comparant, le texte anglais fera foi en cas
de divergence entre les deux.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2010. Relation: LAC/2010/56665. Reçu soixante-quinze euros (75,-€)

<i>Le Receveur ff. (signé): Tom BENNING.

Référence de publication: 2010172979/322.
(100200495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Flydutch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.077.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011477/10.
(110013654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

L.C.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7795 Bissen, 2, Z.A.C. Klengbousbierg.

R.C.S. Luxembourg B 35.713.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011546/10.
(110012906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

16881

L

U X E M B O U R G

L'électricien Haag S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 108.372.

Les comptes annuels au 31. Dezember 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011011547/10.
(110013469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

La Vital S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011011549/10.
(110012771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Lauro 28 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 137.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011551/10.
(110012976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Lai Fu Cis (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 46.193.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011011559/12.
(110013261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Limage Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 31.367.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011011570/10.
(110012922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

16882

L

U X E M B O U R G

Limage Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 31.367.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011011571/10.
(110012923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

SHIP Investor &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.897.

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth of November.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, (Grand-Duchy of Luxembourg),
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “SHIP Investor &amp; Cy S.C.A.” (the “Company”), a société

en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 154.897, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 3 August 2010, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations (the “Mémorial C”) dated 30 September 2010, number 2046, page 98184. The articles of association have
not been amended as of today’s date.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Christèle ALEXANDRE, maître en droit, residing in Luxembourg, who is also elected

as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To change the nominal value of the shares from one penny (GBP 0.01) each to one British Pound (GBP 1.-) each

and to convert (i) the existing two million five hundred and ninety-nine thousand eight hundred (2,599,800) ordinary
shares into twenty-five thousand nine hundred and ninety-eight (25,998) ordinary shares and (ii) two hundred (200)
Management Shares into two (2) management shares.

2. To create two (2) classes of shares referred to as the class A shares (the “Class A Shares”) and the class B shares

(the “Class B Shares”) and to convert the existing twenty-five thousand nine hundred and ninety-eight (25,998) ordinary
shares into twenty-five thousand nine hundred and ninety-eight (25,998) Class A Shares.

3. To increase the Company's share capital by an amount of four hundred and sixteen million five hundred and thirty-

five thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,535,999.-), so as to raise it from its present amount
of twenty-six thousand British Pounds (GBP 26,000.-) up to four hundred and sixteen million five hundred and sixty-one
thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,561,999.-), by the issue of four hundred and two million
two hundred and ninety-two thousand three hundred and eighty-six (402,292,386) new class A shares (the “New A
Shares”) and fourteen million two hundred and forty-three thousand six hundred and thirteen (14,243,613) new class B
shares (the “New B Shares”), each having a par value of one British Pound (GBP 1.-), (collectively referred as the “New
Shares”), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the
below resolutions, paid up by means of contributions in cash for a total amount of four hundred and sixteen million five
hundred and thirty-five thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,535,999.-), such New Shares
shall be subscribed as follows:

- two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and ninety-three (201,146,193) New

A Shares by Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.665, paid up through
a contribution in cash amounting to two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and
ninety-three British Pounds (GBP 201,146,193.-). The contribution of two hundred and one million one hundred and
forty-six thousand one hundred and ninety-three British Pounds (GBP 201,146,193.-) shall be entirely allocated to the
Company's share capital.

- two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and ninety-three (201,146,193) New

A Shares by Bain Capital WP Integral L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman

16883

L

U X E M B O U R G

Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Limited Partnership in Cayman Islands under number WK-43383, paid up through
a contribution in cash amounting to two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and
ninety-three British Pounds (GBP 201,146,193.-). The contribution of two hundred and one million one hundred and
forty-six thousand one hundred and ninety-three British Pounds (GBP 201,146,193.-). shall be entirely allocated to the
Company's share capital.

- seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one (761,351) New B Shares by Barclays Private Credit

Partners Fund L.P., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at the Registrar of Exempted Limited
Partnerships under number 25954, having its registered office at Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, paid up through a contribution in cash amounting to seven hundred and sixty-
one thousand three hundred and fifty-one British Pounds (GBP 761,351.-). The contribution of seven hundred and sixty-
one thousand three hundred and fifty-one British Pounds (GBP 761,351.-) shall be entirely allocated to the Company's
share capital.

- four million six hundred and fifteen thousand seven hundred and sixty-three (4,615,763) New B Shares by KAM

Credit Investors L.P., a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the
State of Delaware registration authority under number 4890069, having its registered office at 1209 Orange Street, New
Castle County, Wilmington, DE 19801, United States of America, paid up through a contribution in cash amounting to
four million six hundred and fifteen thousand seven hundred and sixty-three British Pounds (GBP 4,615,763.-). The con-
tribution of four million six hundred and fifteen thousand seven hundred and sixty-three British Pounds (GBP 4,615,763.-).
shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- two million six hundred and fifteen thousand four hundred and ninety-two (2,615,492) New B Shares by TCW/

Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, Cayman Islands, registered
at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG -198809, having its registered office at Queensgate
House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, paid up through a contribution in cash
amounting to two million six hundred and fifteen thousand four hundred and ninety-two British Pounds (GBP 2,615,492.-).
The contribution of two million six hundred and fifteen thousand four hundred and ninety-two British Pounds (GBP
2,615,492.-) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- three hundred and twenty-five thousand seven hundred and ninety-five (325,795) New B Shares by MAC EQUITY

HOLDINGS I, LLC, a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State
of Delaware registration authorities under number 65-154-1925, having its registered office at 919 N. Market Street Ste.
770, Wilmington, DE 19801, United States of America, paid up through a contribution in cash amounting to three hundred
and twenty-five thousand seven hundred and ninety-five British Pounds (GBP 325,795.-). The contribution of three hun-
dred and twenty-five thousand seven hundred and ninety-five British Pounds (GBP 325,795.-) shall be entirely allocated
to the Company's share capital.

- six hundred and forty-nine thousand five hundred and thirty (649,530) New B Shares by TCW/Crescent Mezzanine

Partners VB (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cay-
man) Limited under number OG 198800, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O.
Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, paid up through a contribution in cash amounting to six
hundred and forty-nine thousand five hundred and thirty British Pounds (GBP 649,530.-). The contribution of six hundred
and forty-nine thousand five hundred and thirty British Pounds (GBP 649,530.-) shall be entirely allocated to the Com-
pany's share capital.

- one million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirteen (1,175,813) New B Shares by TCW/

Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered registered
at  Ogier  Fiduciary  Services  (Cayman)  Limited  under  number  OG-198812,  having  its  registered  office  at  Queensgate
House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, paid up through a
contribution in cash amounting to one million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirteen British
Pounds (GBP 1,175,813.-). The contribution of one million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and
thirteen British Pounds (GBP 1,175,813.-) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

- two hundred and forty-five thousand five hundred and ninetynine (245,599) New B Shares by Trust Company of the

West, acting as trustee of TCW Capital Trust, a company incorporated in the State of California, United Sates of America,
registered with the California Secretary of State under number A421058, having its registered office at 865 S. Figueroa,
Street, Suite 1800, Los Angeles, Unites States of America, paid up through a contribution in cash amounting to two
hundred and forty-five thousand five hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 245,599.-). The contribution of two
hundred and forty-five thousand five hundred and ninetynine British Pounds (GBP 245,599.-) shall be entirely allocated
to the Company's share capital.

- seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one (761,351) New B Shares by NYLCAP Mezzanine

Partners III, LP, a company incorporated in the United States of America, registered at The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, United States of America, paid up through a contribution in cash amounting to seven hundred and sixty-one
thousand three hundred and fiftyone British Pounds (GBP 761,351,-). The contribution of seven hundred and sixty-one

16884

L

U X E M B O U R G

thousand three hundred and fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-) shall be entirely allocated to the Company's share
capital.

- two million three hundred and thirty-one thousand five hundred and sixty-eight (2,331,568) New B Shares by KKR

Mezzanine Partners I, LP, a company incorporated in the United States of America, registered with the State of Delaware
registration authorities under number 4798952, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, United States of America, paid up through a contribution in cash amounting to two
million three hundred and thirty-one thousand five hundred and sixty-eight British Pounds (GBP 2,331,568,-). The con-
tribution  of  two  million  three  hundred  and  thirty-one  thousand  five  hundred  and  sixty-eight  British  Pounds  (GBP
2,331,568,-) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

-seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one (761,351) New B Shares by Paduba Industries

Limited,  a  company  incorporated  in  Ireland,  registered  at  the  Companies  Registration  Office  Ireland  under  number
403671, having its registered office at Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1,
Ireland, paid up through a contribution in cash amounting to seven hundred and sixty-one thousand three hundred and
fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-). The contribution of seven hundred and sixty-one thousand three hundred and
fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-) shall be entirely allocated to the Company's share capital.

4. To restate article 5.1 of the Company’s articles of incorporation.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the nominal value of the shares from one penny (GBP 0.01) each to one Sterling

Pound (GBP 1,-) each and to convert (i) the existing two million five hundred and ninety-nine thousand eight hundred
(2,599,800) ordinary shares into twenty-five thousand nine hundred and ninety-eight (25,998) ordinary shares and (ii) two
hundred (200) Management Shares into two (2) management shares.

As a consequence of the above, Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l. is the owner of twelve thousand nine hundred and

ninety (12,999) ordinary shares, Bain Capital WP Integral L.P. is the owner of twelve thousand nine hundred and ninety
(12,999) ordinary shares and SHIP Investor S.A. is owner of two (2) Management Shares.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to create two (2) classes of shares referred to as the Class A Shares (the “Class A

Shares”) and the class B shares (the “Class B Shares”) and to convert the existing twenty-five thousand nine hundred and
ninety-eight (25,998) ordinary shares into twenty-five thousand nine hundred and ninety-eight (25,998) Class A Shares.

As a result, Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., prenamed, is holding twelve thousand nine hundred and ninety-nine

(12,999) Class A Shares and Bain Capital WP Integral LP is holding twelve thousand nine hundred and ninety-nine (12,999)
Class A Shares.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of four hundred and sixteen million

five hundred and thirty-five thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,535,999.-), so as to raise it
from its present amount of twenty-six thousand British Pounds (GBP 26,000.-) up to four hundred and sixteen million
five hundred and sixty-one thousand nine hundred and ninetynine British Pounds (GBP 416,561,999.-), by the issue of
four hundred and two million two hundred and ninety-two thousand three hundred and eighty-six (402,292,386) new
class A shares (the “New A Shares”) and forteen million two hundred and forty-three thousand six hundred and thirteen
(14,243,613) new class B shares (the “New B Shares”), each having a par value of one British Pound (GBP 1,-), (collectively
referred as the “New Shares”), having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation
as amended by the below resolutions, paid up by means of contributions in cash for a total amount of four hundred and
sixteen million five hundred and thirty-five thousand nine hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,535,999,-),
such New Shares shall be subscribed as follows:

16885

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment

- two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and ninety-three (201,146,193) New

A Shares by Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.665, represented
by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 25, 2010, paid up through a
contribution in cash amounting to two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and
ninetythree British Pounds (GBP 201,146,193,-). The contribution of two hundred and one million one hundred and forty-
six thousand one hundred and ninetythree British Pounds (GBP 201,146,193,-) is entirely allocated to the Company's
share capital.

- two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and ninety-three (201,146,193) New

A Shares by Bain Capital WP Integral L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Limited Partnership in Cayman Islands under number WK-43383, represented
by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy given on November 25, 2010, paid up through a contribution in cash
amounting to two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one hundred and ninety-three British
Pounds (GBP 201,146,193,-). The contribution of two hundred and one million one hundred and forty-six thousand one
hundred and ninety-three British Pounds (GBP 201,146,193,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

- seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one (761,351) New B Shares by Barclays Private Credit

Partners Fund L.P., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at the Registrar of Exempted Limited
Partnerships under number 25954, having its registered office at Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy given on
November 24, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to seven hundred and sixty-one thousand three
hundred and fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-). The contribution of seven hundred and sixty-one thousand three
hundred and fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

- four million six hundred and fifteen thousand seven hundred and sixty-three (4,615,763) New B Shares by KAM

Credit Investors L.P., a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the
State of Delaware registration authority under number 4890069, having its registered office at 1209 Orange Street, New
Castle County, Wilmington, DE 19801, United States of America, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of
a proxy given on November 23, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to four million six hundred and
fifteen thousand seven hundred and sixty-three British Pounds (GBP 4,615,763,-). The contribution of four million six
hundred and fifteen thousand seven hundred and sixty-three British Pounds (GBP 4,615,763,-) is entirely allocated to the
Company's share capital.

- two million six hundred and fifteen thousand four hundred and ninety-two (2,615,492) New B Shares by TCW/

Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, Cayman Islands, registered
at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG -198809, having its registered office at Queensgate
House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, represented by Linda Harroch, pren-
amed, by virtue of a proxy given on November 24, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to two million
six hundred and fifteen thousand four hundred and ninety-two British Pounds (GBP 2,615,492,-). The contribution of two
million six hundred and fifteen thousand four hundred and ninety-two British Pounds (GBP 2,615,492,-) is entirely allocated
to the Company's share capital.

- three hundred and twenty-five thousand seven hundred and ninety-five (325,795) New B Shares by MAC EQUITY

HOLDINGS I, LLC, a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State
of Delaware registration authorities under number 65-154-1925, having its registered office at 919 N. Market Street Ste.
770, Wilmington, DE 19801, United States of America, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy
given on November 24, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to three hundred and twenty-five thousand
seven hundred and ninety-five British Pounds (GBP 325,795,-). The contribution of three hundred and twenty-five thou-
sand seven hundred and ninety-five British Pounds (GBP 325,795,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

- six hundred and forty-nine thousand five hundred and thirty (649,530) New B Shares by TCW/Crescent Mezzanine

Partners VB (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cay-
man) Limited under number OG 198800, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O.
Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a
proxy given on November 24, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to six hundred and forty-nine
thousand five hundred and thirty British Pounds (GBP 649,530,-). The contribution of six hundred and forty-nine thousand
five hundred and thirty British Pounds (GBP 649,530,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

- one million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirteen (1,175,813) New B Shares by TCW/

Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered registered
at  Ogier  Fiduciary  Services  (Cayman)  Limited  under  number  OG-198812,  having  its  registered  office  at  Queensgate
House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Linda
Harroch, prenamed, by virtue of a proxy given on November 24, 2010, paid up through a contribution in cash amounting

16886

L

U X E M B O U R G

to one million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirteen British Pounds (GBP 1,175,813,-). The
contribution of one million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirteen British Pounds (GBP
1,175,813,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

- two hundred and forty-five thousand five hundred and ninety-nine (245,599) New B Shares by Trust Company of

the West, acting as trustee of TCW Capital Trust, a company incorporated in the State of California, United Sates of
America, registered with the California Secretary of State under number A421058, having its registered office at 865 S.
Figueroa, Street, Suite 1800, Los Angeles, United States of America, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue
of a proxy given on November 24, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to two hundred and forty-
five thousand five hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 245,599,-). The contribution of two hundred and forty-
five thousand five hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 245,599,-) is entirely allocated to the Company's share
capital.

- seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one (761,351) New B Shares by NYLCAP Mezzanine

Partners III, LP, a company incorporated in the United States of America, registered at The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, United States of America, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy given on November 24,
2010, paid up through a contribution in cash amounting to seven hundred and sixty-one thousand three hundred and
fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-). The contribution of seven hundred and sixty-one thousand three hundred and
fifty-one British Pounds (GBP 761,351,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

-two million three hundred and thirty-one thousand five hundred and sixty-eight (2,331,568) New B Shares by KKR

Mezzanine Partners I, LP, a company incorporated in the United States of America, registered with the State of Delaware
registration authorities under number 4798952, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, United States of America, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy
given on November 23, 2010, paid up through a contribution in cash amounting to two million three hundred and thirty-
one  thousand  five  hundred  and  sixty-eight  British  Pounds  (GBP  2,331,568,-).  The  contribution  of  two  million  three
hundred and thirtyone thousand five hundred and sixty-eight British Pounds (GBP 2,331,568,-) is entirely allocated to the
Company's share capital.

- seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one (761,351) New B Shares by Paduba Industries

Limited,  a  company  incorporated  in  Ireland,  registered  at  the  Companies  Registration  Office  Ireland  under  number
403671, having its registered office at Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1,
Ireland, represented by Linda Harroch, prenamed, by virtue of a proxy given on November 24, 2010, paid up through a
contribution in cash amounting to seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one British Pounds
(GBP 761,351,-). The contribution of seven hundred and sixty-one thousand three hundred and fifty-one British Pounds
(GBP 761,351,-) is entirely allocated to the Company's share capital.

The proof of the existence and of the value of the contributions has been produced to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend the article 5.1 of the articles of

incorporation of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:

5.1. The Company has a share capital of four hundred and sixteen million five hundred and sixty-one thousand nine

hundred and ninety-nine British Pounds (GBP 416,561,999,-) represented by four hundred and sixteen million five hundred
and sixty-one thousand nine hundred and ninety-nine (416,561,999) ordinary shares, having a par value of one British
Pound (GBP 1,-) each, divided into:

5.1.1 four hundred and two million three hundred and eighteen thousand three hundred and eighty-four (402,318,384)

ordinary shares of class A (the "Class A Shares", their holders being the "Class A Shareholders");

5.1.2 forteen million two hundred and forty-three thousand six hundred and thirteen (14,243,613) ordinary shares of

class B (the "Class B Shares", their holders being the "Class B Shareholders")

5.1.3 two (2) management shares (the "Management Shares"), held by the unlimited shareholder (actionnaire com-

mandité).”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

16887

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg),
S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  en  commandite  par  actions  «SHIP

Investor &amp; Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.897, ayant son siège social au
2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 3 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 30 septembre
2010, numéro 2046. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés à ce jour.

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Christèle ALEXANDRE, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui est

aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Changer la valeur nominale des actions de la Société d’un penny (GBP 0,01) chacune à une Livre Sterling (GBP 1,-)

chacune et convertir (i) les deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huits cents (2.599.800) actions ordinaires
existantes en vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (25.998) actions ordinaires et (ii) les deux cents (200) actions
de commandité existantes en deux (2) actions de commandité.

2. Création de deux (2) catégories d’actions ordinaires dénommées les actions ordinaires de catégorie A (les «Actions

de Catégorie A») et les actions ordinaires de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») et conversion des vingt-cinq
mille neuf cent quatre-vingt-dixhuit (25.998) actions ordinaires existantes d’une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune en vingt-
cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (25.998) Actions de Catégorie A d’une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

3. Augmentation du capital social de la Société par un montant de quatre cent seize millions cinq cent trente-cinq mille

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.535.999,-), de façon à l’accroître de son montant actuel de vingt-
six mille Livres Sterling (GBP 26.000,-) à quatre cent seize millions cinq cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.561.999,-), par l’émission de quatre cent deux millions deux cent quatre-vingt-douze
mille trois cent quatre-vingt-six (402.292.386) nouvelles actions de catégorie A (les «Nouvelles Actions de Catégorie A»)
et de quatorze millions deux cent quarante-trois mille six cent treize (14.243.613) nouvelles actions de catégorie B (les
«Nouvelles Actions de Catégorie B»), chacune ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) et ayant les mêmes
droits et obligations tels qu’indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées
au moyen d’un apport en numéraire d’un montant total de quatre cent seize millions cinq cent trente-cinq mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.535.999,-), lesquelles Nouvelles Actions de Catégorie A et les Nouvelles
Actions de Catégorie B seront souscrites comme suit:

- deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatrevingt-treize (201.146.193) Nouvelles Actions de Catégorie

A par Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.665, pour un montant
total de deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-). L’apport
s’élevant à deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-) sera
entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatrevingt-treize (201.146.193) Nouvelles Actions de Catégorie

A par Bain Capital WP Integral L.P., un limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son
siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, immatriculé au Registrar
of Limited Partnership des Iles Cayman sous le numéro WK43383, pour un montant total de deux cent un millions cent
quarante-six mille cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-). L’apport s’élevant à deux cent un millions
cent quarante-six mille cent quatre-vingttreize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-) sera entièrement alloué au capital social
de la Société.

- sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une (761.351) Nouvelles Actions de Catégorie B par Barclays

Private Credit Partners Fund L.P., un limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son
siège social à Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, imma-
triculé au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 25954, pour un montant total de
sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 761.351,-). L’apport s’élevant à sept cent
soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 761.351,-) sera entièrement alloué au capital social
de la Société.

- quatre millions six cent quinze mille sept cent soixante-trois (4.615.763) Nouvelles Actions de Catégorie B par KAM

Credit Investors L.P., une société constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au registre
de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 4890069, ayant son siège social au 1209 Orange Street, New Castle

16888

L

U X E M B O U R G

County, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique pour un montant total de quatre millions six cent quinze mille
sept cent soixante-trois Livres Sterling (GBP 4.615.763,-). L’apport s’élevant à quatre millions six cent quinze mille sept
cent soixante-trois Livres Sterling (GBP 4.615.763,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux millions six cent quinze mille quatre cent quatre-vingtdouze (2.615.492) Nouvelles Actions de Catégorie B par

TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez
Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG -198809, ayant son siège social à Queensgate House,
South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, pour un montant total de deux
millions six cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 2.615.492,-). L’apport s’élevant à deux
millions six cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 2.615.492,-) sera entièrement alloué au
capital social de la Société.

-  trois  cent  vingt-cinq  mille  sept  cent  quatre-vingt-quinze  (325.795)  Nouvelles  Actions  de  Catégorie  B  par  MAC

EQUITY HOLDINGS I, LLC, une société constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au
registre de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 65-154-1925, ayant son siège social au 919 N. Market Street
Ste. 770, Wilmington, DE 19801, Etats- Unis d’Amérique, pour un montant total de trois cent vingt-cinq mille sept cent
quatre-vingt-quinze Livres Sterling (GBP 325.795,-). L’apport s’élevant à trois cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-
quinze Livres Sterling (GBP 325.795,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- six cent quarante-neuf mille cinq cent trente (649.530) Nouvelles Actions de Catégorie B par TCW/Crescent Mez-

zanine  Partners  VB  (Cayman),  Ltd.,  une  société  constituée  dans  les  Iles  Cayman,  immatriculée  chez  Ogier  Fiduciary
Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198800, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street,
P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, pour un montant total de six cent quarante-neuf mille
cinq cent trente Livres Sterling (GBP 649.530,-). L’apport s’élevant à six cent quarante-neuf mille cinq cent trente Livres
Sterling (GBP 649.530,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

-  un  million  cent  soixante-quinze  mille  huit  cent  treize  (1.175.813)  Nouvelles  Actions  de  Catégorie  B  par  TCW/

Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier
Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198812, ayant son siège social à Queensgate House, South
Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, pour un montant total de un million cent
soixante-quinze mille huit cent treize Livres Sterling (GBP 1.175.813,-). L’apport s’élevant à un million cent soixante-
quinze mille huit cent treize Livres Sterling (GBP 1.175.813,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (245.599) Nouvelles Actions de Catégorie B par Trust

Company of the West, agissant en tant que trustee of TCW Capital Trust, une société constituée dans l’Etat de Californie,
Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au California Secretary of State sous le numéro A421058, ayant son siège social au
865 S. Figueora Street, Suite 1800, Los Angeles, Etats-Unis d’Amérique pour un montant total de deux cent quarante-
cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 245.599,-). L’apport s’élevant à deux cent quarante-cinq
mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 245.599,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une (761.351) Nouvelles Actions de Catégorie B par NYLCAP

Mezzanine Partners III, LP, une société constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée à The
Corporation Trust Company, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, Etats-Unis d’Amérique, pour un montant total de sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres
Sterling (GBP 761.351,-). L’apport s’élevant à sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling
(GBP 761.351,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux millions trois cent trente et un mille cinq cent soixante-huit (2.331.568) Nouvelles Actions de Catégorie B par

KKR Mezzanine Partners I, LP, un limited partnership, constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, im-
matriculée au regsitre de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 4798952, ayant son siège social au 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, pour un montant total de deux millions
trois cent trente et un mille cinq cent soixante-huit Livres Sterling (GBP 2.331.568,-). L’apport s’élevant à deux millions
trois cent trente et un mille cinq cent soixante-huit Livres Sterling (GBP 2.331.568,-) sera entièrement alloué au capital
social de la Société.

- sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une (761.351) Nouvelles Actions de Catégorie B par Paduba

Industries Limited, une société constituée en Irlande, immatriculée au the Companies Registration Office Ireland sous le
numéro 403971, ayant son siège social au Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin
1, Irlande, pour un montant total de pour un montant total de sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une
Livres Sterling (GBP 761.351,-). L’apport s’élevant à sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres
Sterling (GBP 761.351,-) sera entièrement alloué au capital social de la Société.

4. Modification de l’ article 5.1 des statuts de la Société.
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement

16889

L

U X E M B O U R G

annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la valeur nominale des actions d’un penny (GBP 0,01) chacune à une Livre

Sterling (GBP 1,-) chacune et de convertir (i) les deux million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cents (2.599.800)
actions ordinaires existantes en vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (25.998) actions ordinaires et (ii) les deux
cents (200) actions de commandité existantes en deux (2) actions de commandité.

En conséquence de ce qui précède, Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., détient douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf (12.999) actions ordinaires, Bain Capital WP Integral L.P., détient douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (12.999)
actions ordinaires et SHIP Investor S.A., détient deux (2) actions de commandité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de créer deux (2) catégories d’actions ordinaires dénommées les actions ordinaires de

catégorie A (les «Actions de Catégorie A») et les actions ordinaires de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») et de
convertir des vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dixhuit (25.998) actions ordinaires existantes d’une Livre Sterling
(GBP 1,-) chacune en vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (25.998) Actions de Catégorie A d’une Livre Sterling
(GBP 1,-) chacune.

En conséquence de ce qui précède, Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., détient douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf (12.999) Actions de Catégorie A et Bain Capital WP Integral LP détient douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
(12.999) Actions de Catégorie A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de quatre cent seize millions

cinq cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.535.999,-), de façon à l’accroître de
son montant actuel de vingt-six mille Livres Sterling (GBP 26.000,-) à quatre cent seize millions cinq cent soixante-et-un
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.561.999,-), par l’émission de quatre cent deux millions deux
cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-six (402.292.386) nouvelles actions de catégorie A (les «Nouvelles
Actions de Catégorie A») et de quatorze millions deux cent quarante-trois mille six cent treize (14.243.613) nouvelles
actions de catégorie B (les «Nouvelles Actions de Catégorie B»), chacune ayant une valeur nominale d’un penny (GBP
0,01) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu’indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les
résolutions ci-dessous, payées au moyen d’un apport en numéraire d’un montant total de quatre cent seize millions cinq
cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.535.999,-), lesquelles Nouvelles Actions
de Catégorie A et les Nouvelles Actions de Catégorie B sont souscrites comme suit:

<i>Souscription - Paiement

- deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatrevingt-treize (201.146.193) Nouvelles Actions de Catégorie

A par Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.665, ici représentée par
Linda Harroch, précitée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 25 novembre 2010, pour un montant total
de deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatrevingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-). L’apport
s’élevant à deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-) est
entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux cent un millions cent quarante-six mille cent quatre-vingt-treize (201.146.193) Nouvelles Actions de Catégorie

A par Bain Capital WP Integral L.P., un limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son
siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, immatriculé au Registrar
of Limited Partnership des Iles Cayman sous le numéro WK43383, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en vertu
d’une procuration donnée le 25 novembre 2010, pour un montant total de deux cent un millions cent quarante-six mille
cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,-). L’apport s’élevant à deux cent un millions cent quarante-six
mille cent quatre-vingt-treize Livres Sterling (GBP 201.146.193,) est entièrement alloué au capital social de la Société.

- sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une (761.351) Nouvelles Actions de Catégorie B par Barclays

Private Credit Partners Fund L.P., un limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son
siège social à Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, imma-
triculé au Registrar of Exempted Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro 25954, ici représentée par Linda

16890

L

U X E M B O U R G

Harroch, précitée, en vertu d’une procuration donnée le 24 novembre 2010, pour un montant total de sept cent soixante-
et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 761.351,-). L’apport s’élevant à sept cent soixante-et-un mille
trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 761.351,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

- quatre millions six cent quinze mille sept cent soixante-trois (4.615.763) Nouvelles Actions de Catégorie B par KAM

Credit Investors L.P., une société constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au registre
de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 4890069, ayant son siège social au 1209 Orange Street, New Castle
County, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en vertu d’une
procuration donnée le 23 novembre 2010, pour un montant total de quatre million six cent quinze mille sept cent soixante-
trois Livres Sterling (GBP 4.615.763,-). L’apport s’élevant à quatre millions six cent quinze mille sept cent soixante-trois
Livres Sterling (GBP 4.615.763,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux millions six cent quinze mille quatre cent quatre-vingtdouze (2.615.492) Nouvelles Actions de Catégorie B par

TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez
Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG -198809, ayant son siège social à Queensgate House,
South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Linda Harroch,
précitée, en vertu d’une procuration donnée le 24 novembre 2010, pour un montant total de deux million six cent quinze
mille quatre cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 2.615.492,-). L’apport s’élevant à deux millions six cent quinze
mille quatre cent quatre-vingt-douze Livres Sterling (GBP 2.615.492,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

-  trois  cent  vingt-cinq  mille  sept  cent  quatre-vingt-quinze  (325.795)  Nouvelles  Actions  de  Catégorie  B  par  MAC

EQUITY HOLDINGS I, LLC, une société constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au
registre de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 65-154-1925, ayant son siège social au 919 N. Market Street
Ste. 770, Wilmington, DE 19801, Etats- Unis d’Amérique, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en vertu d’une
procuration donnée le 24 novembre 2010, pour un montant total de trois cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-
quinze Livres Sterling (GBP 325.795,-). L’apport s’élevant à trois cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze Livres
Sterling (GBP 325.795,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

- six cent quarante-neuf mille cinq cent trente (649.530) Nouvelles Actions de Catégorie B par TCW/Crescent Mez-

zanine  Partners  VB  (Cayman),  Ltd.,  une  société  constituée  dans  les  Iles  Cayman,  immatriculée  chez  Ogier  Fiduciary
Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198800, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street,
P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en vertu
d’une procuration donnée le 24 novembre 2010, pour un montant total de six cent quarante-neuf mille cinq cent trente
Livres Sterling (GBP 649.530,-). L’apport s’élevant à six cent quarante-neuf mille cinq cent trente Livres Sterling (GBP
649.530,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

-  un  million  cent  soixante-quinze  mille  huit  cent  treize  (1.175.813)  Nouvelles  Actions  de  Catégorie  B  par  TCW/

Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., une société constituée dans les Iles Cayman, immatriculée chez Ogier
Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG- 198812, ayant son siège social à Queensgate House, South
Church  Street,  P.O. Box 1234  GT,  George  Town,  Grand  Cayman, Iles Cayman, ici  représentée par Linda Harroch,
précitée, en vertu d’une procuration donnée le 24 novembre 2010, pour un montant total d’un million cent soixante-
quinze mille huit cent treize Livres Sterling (GBP 1.175.813,-). L’apport s’élevant à un million cent soixante-quinze mille
huit cent treize Livres Sterling (GBP 1.175.813,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (245.599) Nouvelles Actions de Catégorie B par Trust

Company of the West, agissant en tant que trustee of TCW Capital Trust, une société constituée dans l’Etat de Californie,
Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au California Secretary of State sous le numéro A421058, ayant son siège social au
865 S. Figueora Street, Suite 1800, Los Angeles, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en
vertu d’une procuration donnée le 24 novembre 2010, pour un montant total de deux cent quarante-cinq mille cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 245.599,-). L’apport s’élevant à deux cent quarante-cinq mille cinq cent quatre-
vingt-dix-neuf Livres Sterling (GBP 245.599,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

- sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une (761.351) Nouvelles Actions de Catégorie B par NYLCAP

Mezzanine Partners III, LP, une société constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée à The
Corporation Trust Company, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en vertu d’une procuration donnée le 24
novembre 2010, pour un montant total de sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP
761.351,-). L’apport s’élevant à sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 761.351,-)
est entièrement alloué au capital social de la Société.

- deux million trois cent trente et un mille cinq cent soixante-huit (2.331.568) Nouvelles Actions de Catégorie B par

KKR Mezzanine Partners I, LP, un limited partnership, constituée dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, im-
matriculée au regsitre de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro 4798952, ayant son siège social au 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par Linda Harroch,
précitée, en vertu d’une procuration donnée le 23 novembre 2010, pour un montant total de deux millions trois cent
trente et un mille cinq cent soixante-huit Livres Sterling (GBP 2.331.568,-). L’apport s’élevant à deux millions trois cent
trente et un mille cinq cent soixante-huit Livres Sterling (GBP 2.331.568,) est entièrement alloué au capital social de la
Société.

16891

L

U X E M B O U R G

- sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une (761.351) Nouvelles Actions de Catégorie B par Paduba

Industries Limited, une société constituée en Irlande, immatriculée au the Companies Registration Office Ireland sous le
numéro 403971, ayant son siège social au Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin
1, Irlande, ici représentée par Linda Harroch, précitée, en vertu d’une procuration donnée le 24 novembre 2010, pour
un montant total de pour un montant total de sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling
(GBP 761.351,-). L’apport s’élevant à sept cent soixante-et-un mille trois cent cinquante et une Livres Sterling (GBP
761.351,-) est entièrement alloué au capital social de la Société.

<i>Quatrième résolution

En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les déci-

sions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. La Société a un capital social de quatre cent seize millions cinq cent soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf Livres Sterling (GBP 416.561.999,-) représenté par quatre cent seize millions cinq cent soixante-et-un mille neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf (416.561.999) actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP
1,-), divisées en:

5.1.1 quatre cent deux millions trois cent dix-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre ((402.318.384) actions ordinaires

de classe A, (les «Actions A», leurs détenteurs étant les «Actionnaires A»);

5.1.2 quatorze millions deux cent quarante-trois mille six cent treize (14.243.613) actions ordinaires de classe B, (les

«Actions B», leurs détenteurs étant les «Actionnaires B»);

5.1.3 deux (2) actions de commandité (les «Actions de Commandités») détenues par l’actionnaire commandité.».

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à sept mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, C. ALEXANDRE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14855. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010173253/549.
(100200947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Limage Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 31.367.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011011572/10.
(110012924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

LSH CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.026.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011575/10.
(110013269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

16892

L

U X E M B O U R G

LSH II CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.024.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011576/10.
(110013344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Lux Developers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.888.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011011578/12.
(110013748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Eurofins Industrial Testing LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 155.534.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011424/10.
(110013440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Eurofins Pharma Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.862.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011427/10.
(110013441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

HomeStraight S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 108.709.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 06 janvier 2011 du conseil d’administration

Le siège social de la société est transféré à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 janvier 2011.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’administration

Référence de publication: 2011007659/13.
(110007981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16893

L

U X E M B O U R G

Eurofins Product Testing LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.487.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011429/10.
(110013442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Eurofins Support Services LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 153.149.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2011.

Référence de publication: 2011011431/10.
(110013443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

Orestes Holding Société Anonyme, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 38.318.

<i>Extrait des décisions prises par l’associée unique et par le conseil d’administration en date du 29 décembre 2010

1. Madame Marie Paul VAN WAELEM a démissionné de son mandat d’administrateur.
2. Madame Marie Joseph RENDERS a démissionné de son mandat d’administrateur.
3. La société anonyme FIDIGA S.A. a démissionné de son mandat d’administrateur.
4. Le siège social de la société a été transférée de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

5. Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.

6. Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Reeuwijk (Pays-Bas), le 19 avril 1950, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme adminis-
trateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.

7. Madame Nancy BLEUMER, administrateur de sociétés, née à Doetinchem (Pays-Bas), le 30 novembre 1971, de-

meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme
administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.

8. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 (trois) à 4 (quatre).
9. Madame Monique JUNCKER, administrateur de sociétés, née à Ettelbrück (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril

1964, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée
comme administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.

10. Monsieur Philippe TOUSSAINT, pré-nommé, a été nommé comme président du conseil d’administration, jusqu’à

l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ORESTES HOLDING Société Anonyme
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011007798/32.
(110008708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16894

L

U X E M B O U R G

Inteuro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 93.041.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 4 janvier 2011

1) Est nommé administrateur, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2008, qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 4 janvier 2011.
2) Est nommé Président du conseil d'administration, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2009, qui se tiendra extraordinairement au cours de l’année 2011.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Référence de publication: 2011007700/22.
(110008144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Hardey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall.

R.C.S. Luxembourg B 46.724.

Les comptes annuels redressés de l'année 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Ces comptes annuels remplacent les comptes annuels déposés le 29 juillet 2010 au Registre de Commerce et des

Sociétés sous le N° L100115972.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 17 décembre 2010.

<i>Pour HARDEY S.à r.l.
Arend &amp; Partners S.à r.l., Mersch
Signature

Référence de publication: 2011007660/16.
(110008279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

I.E.C.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.100.

A la suite de la cession en date du 14 décembre 2010 des 3.017.300 parts sociales détenues par la société Black Bear

Holdings Corp., celles-ci sont dorénavant toutes détenues par:

- La société Aragon Investments Limited, avec certificat de constitution de Hong Kong sous le n° 1532199 et avec

siège social à Hong Kong, Wanchai, 3806 Central Plaza, 18 Harbour Road.

Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour I.E.C.L. S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011007677/15.
(110008085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

16895

L

U X E M B O U R G

Montgomery Investment Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 157.756.

EXTRAIT

Il en résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 12 janvier, 2011

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Charles Henry James MARFLEET, director des sociétés, né à Louth

(GB), le 11 janvier 1969, demeurant à 7 Wood Street, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2QS, Royaume-Uni en tant qu'ad-
ministrateur de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires se tenant en 2017.
Monsieur Charles Henry James MARFLEET a le pouvoir de signature conjointement avec un des autres administrateurs
de la société MONTGOMERY INVESTMENT CO SA.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Charles HOWSON, director des sociétés, né à Salisbury, Wiltshire

(GB), le 12 avril 1966, demeurant à The Old Rectory, Rectory Road, Steppingley, Beds, MK45 5AT, Royaume-Uni en tant
qu'administrateur de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires se tenant en
2017. Monsieur Charles HOWSON a le pouvoir de signature conjointement avec un des autres administrateurs de la
société MONTGOMERY INVESTMENT CO SA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch le 12 janvier 2011.

<i>Pour la société
Coficom Trust S.à r.l.
50 Esplanade
L-9227 Diekirch

Référence de publication: 2011008728/27.
(110007973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2011.

Julienne Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, Z.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 135.962.

<i>Extrait de la résolution écrite de l'associé unique du 21 décembre 2010

KBC Real Estate NV, une société de droit belge, ayant son siège social à 12 Avenue du Port, 1080 Bruxelles, numéro

d'entreprise 0404.040.632 (RPM Bruxelles) ("l'associé") a constaté le transfert de 500 parts sociales dans la Société par
Kenavon Drive Holdings II S.à r.l. (le "Vendeur") à l'associé conformément à un seulement agreement du 21 décembre
2010 conclu entre AIG Global Real Estate Investment Corp. et le Vendeur d'une part et l'Associé, KBC Bank NV et la
Société d'autre part.

L'associé a pris acte de la démission de M. Jan Dijkstra et M. Fabrice Coste de leurs fonctions de gérants de la Société

avec effet au 21 décembre 2010.

L'associé a nommé:
- Paul Vanderstappen, de nationalité belge, demeurant à Builoogstraat 32, 3360 Bierbeek,
- Kim Creten, de nationalité belge, demeurant à Hoogveld 24, 9340 Lede, et
- Gerrit Callaerts, de nationalité belge, demeurant à Stuivenbergvaart 110, 2800 Mechelen,
gérants de la Société à partir de 21 décembre 2010. Leurs mandats prendra fin immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire des associés de la Société, ou en cas d'associé unique, immédiatement après la résolution de l'associé
unique approuvant les comptes annuels pour l'année se clôturant le 31 Décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gerrit Callaerts / Paul Vanderstappen
<i>Gérant de la Société / Gérant de la Société

Référence de publication: 2011007704/26.
(110008610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

16896


Document Outline

AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg S.à r.l.

Alpha Advisory Company S.A.

Annibal S.A., SPF

Camtech S.A.

Catolex

CEREP III Investment W S.à r.l.

Condor Investments S.A.

Condor Investments S.A.

Condor Investments S.A.

Condor Investments S.A.

Corestate Sailing HoldCo S.à r.l.

DJ Investments S.A.

Douglas Parfums et Beauté S.à r.l.

Eurofins Forensics LUX

Eurofins Industrial Testing LUX

Eurofins Pharma Lux

Eurofins Product Testing LUX

Eurofins Support Services LUX

Flydutch S.A.

Forvest Investment Group S.A.

Four Tools

Global Europ Product. S.à r.l.

Golf 2010 Luxembourg S.C.A.

Grey Grafton S.à r.l.

Hardey S.à r.l.

HomeStraight S.A.

I.E.C.L. S.à r.l.

Inteuro S.A.

Investimmo International S.A.

Investimmo International S.A.

Julienne Sàrl

Lai Fu Cis (Luxembourg) S.A.

Lauro 28 S.A.

La Vital S. à r.l.

L.C.I. S.à r.l.

L'électricien Haag S. à r. l.

Limage Holding S.A.

Limage Holding S.A.

Limage Holding S.A.

LSH CO

LSH II CO

Lux Developers S.A.

Marc Muller Conseils S.à r.l.

MESH S.à r.l.

Montgomery Investment Co S.A.

Orestes Holding Société Anonyme

Saint Patrick Alienations and Acquisitions Studies SA

Sapporo Holding S.A.

Sea-Invest Afrique S.A.

SHIP Investor &amp; Cy S.C.A.

SHIP Investor S.A.

Somurel S.A.

Spartakus S.à r.l.

Therabel Group S.A.

Treid SA

Treid SA

Treid SA

Treid SA

Treid SA

Treid SA

Tuxon Properties S.A.

Vuksan S.A.

Web Investments S.A.

White Stone Holding S.A.