logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2857

29 décembre 2010

SOMMAIRE

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Li-

mited Luxembourg S.C.S.  . . . . . . . . . . . . .

137121

Abira Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137099

Advent Key Investor & Cy S.C.A.  . . . . . . . .

137106

Augur Financial Holding V S.A. . . . . . . . . . .

137113

Berlisa International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

137099

Bessel Re S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137099

BFO Group International S.A. . . . . . . . . . . .

137099

Biosystem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137103

Bosquet, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137103

BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137103

British Cars Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

137103

British Cars Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

137104

Calidris 28 AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137120

Calidris 28 AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137112

Calidris 28 EU S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137120

Capital Pierre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137113

Captain North Sea Finance Limited  . . . . .

137103

Carillon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137121

Carta Capital Investments II S.à r.l. . . . . . .

137104

Cartainvest II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

CEP II Stahl S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137128

Chang An S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137121

Cheyne Special Situations Investments S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

CIGOGNE Management S.A.  . . . . . . . . . . .

137127

City Parking Group Holdings S.A.  . . . . . . .

137105

Clearwire Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

137111

Clemenceau Participations S.A.  . . . . . . . . .

137128

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137102

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137104

Cobelfret Waterways S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

137128

Coginvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137131

ColPlay S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

ColPlay S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

Compagnie de Réassurance Akzo Nobel

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137116

Copine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137134

Cube Properties S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

137112

Desifaldi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137134

DIF Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

137098

Erdmann S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137128

Fidji Luxco (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137131

Fidji Luxco (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137136

Fidji Luxco (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137120

GSMP 2006 Onshore S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

137105

Hotel Gestion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137090

Hudson Euro Co. S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

Human Capital Group S.A.  . . . . . . . . . . . . .

137130

Lancaster Coinvestors A S.à r.l.  . . . . . . . . .

137131

Lexsis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137120

LTH Lighting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137127

Luxgsm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137097

Novator Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

137112

RCG Re III S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137116

Rosenzweig Immobilien AG SARL  . . . . . . .

137135

UniCredit Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

137105

Vegan Society Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . .

137109

W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137098

WAT Editions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137132

137089

L

U X E M B O U R G

Hotel Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8340 Olm, 83, boulevard Schumann.

R.C.S. Luxembourg B 156.946.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. The company JP Commercial VII S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office at

6, rue Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
section B, number 143756,

duly represented by Ms. Diane Wolf, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,

on the 12 

th

 of November 2010.

2. The company AURELIUS Commercial Management GmbH, a company incorporated under German law, with re-

gistered office at Ludwig-Ganghofer-Str. 6, 82031 Grünwald, Germany, recorded at the Munich Trade Register “Han-
delsregister B des Amtsgerichts München” under number HRB 188642,

duly represented by Ms. Diane Wolf, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munich, on

the 12 

th

 of November 2010.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of

association of a private limited company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws and the present
articles:

Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the Companies' Act of August
10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of "Hotel Gestion S.à r.l.".

Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. The registered office of the company is established in Olm (Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of the
manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager
(s).

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will be made
and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under
the given circumstances.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in

which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnership or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by ten thousand

(10,000) shares with a par value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, which have been fully subscribed.

137090

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of

the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority

consent of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member

or by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change
the nationality of the company by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The members may also take resolutions in writing without meeting if there are twenty-five (25) members or less.

Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner
or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.

Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship

with the number of shares in existence.

Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes

or drawn-up in writing.

Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members

representing at least three quarters (3/4) of the company's share capital.

In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares

representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.

Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets

or documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.

Title III. Administration and audit

Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines

their powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are
appointed.

The managers may be removed without cause.

Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who needs

not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of the members.

The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of

the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, telegram
or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the managers.

Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by e-mail, telegram or telefax another

manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram or telefax.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those

reserved by law to be decided upon by the members.

Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who presided at such meeting.

137091

L

U X E M B O U R G

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. Each manager may confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers, appoint

and dismiss all officers and employees, and fix their remuneration.

Art. 16. The company will be bound by the sole signature of any manager or by any person(s) to whom power has

been delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.

Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the

company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.

Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1 

st

 of each year and shall terminate on December

31 

st

 of the same year.

Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the disposal

of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual accounts and
in general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit and loss
account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the
net profit of the company.

Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but
will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this
threshold is not met anymore.

The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual

net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).

Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent auditors.

The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall determine
their number, remuneration and term of office.

Title IV. Winding up - Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the

shares they are holding.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Subscription

The ten thousand (10,000) shares are subscribed as follows:
- 5,000 shares by JP Commercial VII S.à r.l., prenamed, and
- 5,000 shares by AURELIUS Commercial Management GmbH, prenamed
and have been fully paid-in in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the

free disposal of the company, as was certified to the notary executing this deed.

137092

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>General meeting of the member

Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital represented

as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:

1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at two (2).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today for an unlimited period:
- Hubert Hansen, 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxembourg, born 17.10.1951 in Ettelbrück, Bank Director
- Lothar Rafalski, 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxembourg, born 29.11.1952 in Hamburg, Senior Consultant.
3) The registered office of the Company is at 8340 Olm, 83 Boulevard Schumann, Luxembourg.
4) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2011.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

this deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausend und zehn, am sechzehnten November,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

1. Die Gesellschaft JP Commercial VII S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, rue

Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg, unter der
Sektion B, Nummer 143756,

hier vertreten durch Frau Diane Wolf, mit Geschäftssitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,

ausgestellt in Luxembourg am 12. November 2010.

2.  Die  Gesellschaft  AURELIUS  Commercial  Management  GmbH,  eine  Gesellschaft  Deutschen  Rechts,  mit  Gesell-

schaftssitz in Ludwig-Ganghofer-Str. 6, 82031 Grünwald, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts
München unter HRB 188642,

hier vertreten durch Frau Diane Wolf, mit Geschäftssitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht,

ausgestellt in München am 12. November 2010.

Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die erschienene Person und den unterzeichneten

Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, die dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung unterliegt, zu beurkunden.

Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, die später Gesellschafter der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem derzeitig geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und der folgenden
Satzung unterliegt und die Bezeichnung "Hotel Gestion S.à r.l." trägt.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Olm (Großherzogtum Luxemburg).
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der

Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch die Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung einer Verlegung
an Dritte hat durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, das unter den gegebenen Umständen hierzu am besten in
der Lage ist.

137093

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere
Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann zudem als Komplementär oder Kommanditist mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung

für alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.

Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung

ihres Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.

Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingeteilt in zehntau-

send (10.000) Gesellschaftsanteile zu je einem Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), die vollständig einbezahlt wurden.

Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-

schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte
der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.

Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafter-

versammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.

Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters

oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.

Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.

Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-

undzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter besitzt.

Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen. Falls ein Geschäftsanteil im Besitz

von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde. Das gleiche gilt für den
Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen dem Schuld-
ner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der Ge-

sellschaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-

schafterversammlung aus.

Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, die im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Pro-

tokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.

Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen

Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.

Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesell-

schaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung der Gesellschafter,

die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, in einer Gesellschafterversammlung.

Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der

Zustimmung der Gesellschafter, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
repräsentieren.

In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-

lebenden Lebenspartner erfolgt.

Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur

Folge.

137094

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-

sellschaftseigentum  oder  Gesellschaftsdokumenten  stellen  noch  in  irgendeiner  Weise  in  die  Geschäftsführung  der
Gesellschaft eingreifen.

Titel III. Geschäftsführung und Prüfung

Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, die Vergütung und die Dauer des Mandats der Geschäfts-

führer, wobei diese ihr Amt solange ausüben, bis ein Nachfolger bestimmt wurde.

Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Aufzeichnung

der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.

Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar

an dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.

Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens

vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, in
denen die Art der Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.

Auf die Einberufung kann durch die schriftlich oder per E-Mail, Telegramm oder Fax erteilte Zustimmung eines jeden

Geschäftsführers verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen,
die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die aus einem Zeitplan hervorgehen, der vorher durch einen Geschäfts-
führungsbeschluss genehmigt wurde.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per E-Mail, Telegramm

oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.

Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm oder Fax durchgeführt werden.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des

Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.

Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in

dessen Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden.

Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vor-

sitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung jeg-

liche  Befugnisse  und  Sondervollmachten  an  jede  Person,  die  nicht  unbedingt  Geschäftsführer  sein  muss,  übertragen,
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Vergütung festsetzen.

Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder durch die Einzelunter-

schrift jeder in Übereinstimmung mit dem Artikel 15 bevollmächtigten Person verpflichtet.

Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen

der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des

gleichen Jahres.

Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den

Gesellschaftern  am  Sitz  der  Gesellschaft  zur  Verfügung  gestellt.  Jeder  Gesellschafter  kann  zu  jeder  Zeit  am  Sitz  der
Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.

Das Guthaben der Gewinn- und Verlustbilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-

visionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5 % (fünf Prozent)
zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet, wenn
die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10 % (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht, lebt
aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Gründen
auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.

Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über

die Verwendung des jährlichen Gewinnes.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;

137095

L

U X E M B O U R G

2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde gegebenenfalls von dem Wirtschaftsprüfer geprüft;
4. Dieser Zwischenabschluss weist ausreichend Gewinne auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der an-

deren freien Reserven;

5. Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren, wird durch die Geschäftsführung getroffen.

Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unab-

hängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung einer
oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandats fest.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die

natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über
diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu den Ge-

schäftsanteilen, die sie halten, zugeteilt.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung.

Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern

oder zwischen dem/den Geschäftsführer(n) und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes ("arbitrage“) gemäß der Zivilprozessordnung.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.

<i>Zeichnung

Die zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
- 5.000 Anteile durch JP Commercial VII S.à r.l., vorbenannt, und
- 5.000 Anteile durch AURELIUS Commercial Management GmbH, vorbenannt
und wurden vollständig einbezahlt, sodaß der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft

zur freien Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer

Gründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500.- geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, der das gesamte Stammkapital vertritt,

vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste folgende Beschlüsse:

1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf zwei (2) festzusetzen.
2)  Die  folgenden  Personen  werden  mit  Wirkung  zum  heutigen  Tage  zu  Geschäftsführern  auf  unbegrenzte  Dauer

ernannt:

- Hubert Hansen, wohnhaft 21, rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxemburg, geboren am 17.10.1951 in Ettelbrück,

Bankdirektor

- Lothar Rafalski, wohnhaft 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxemburg, geboren am 29.11.1952 in Hamburg, Senior

Consultant.

3) Der Sitz der Gesellschaft ist in 8340 Olm, 83 Boulevard Schumann, Luxemburg.
4) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-

zember 2011.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben ge-

nannten erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat dieser zusammen mit dem Notar die

vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: D. WOLF und H. HELLINCKX.

137096

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52563. Reçu soixante-quinze euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 30. November 2010.

Référence de publication: 2010158064/378.
(100182415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Luxgsm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R.C.S. Luxembourg B 43.290.

<i>Extrait d'assemblée générale

L'assemblée générale extraordinaire en date du 18 octobre 2010 a nommé les membres du conseil d'administration

de l'EPT comme membres du conseil de surveillance de Luxgsm S.A. conformément à l'article 15 des statuts à savoir:

- Monsieur Gaston Reinesch, né le 17/05/1958 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-2996 Luxem-

bourg, 1 rue Emile Bian

- Monsieur Pierre Ahlborn, né le 06/06/1962 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg,

1 rue Emile Bian

- Monsieur Serge Allegrezza, né le 25/10/1959 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg,

1 rue Emile Bian

- Monsieur Michel Brachmond, né le 17/03/1954 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1 rue

Emile Bian

- Monsieur Paul Duhr, né le 17/09/1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1 rue

Emile Bian

- Monsieur Edouard Felix, né le 04/11/1956 à Dudelange, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1 rue

Emile Bian

- Monsieur Romain Fouarge, né le 22/08/1967 à Dudelange, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1

rue Emile Bian

- Monsieur Gilbert Goergen, né le 14/12/1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-2996 Luxem-

bourg, 1 rue Emile Bian

- Monsieur Georges Heinrich, né le 29/10/1971 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg,

1 rue Emile Bian

- Monsieur Raymond Hencks né le 30/03/1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement à L-2996 Luxem-

bourg, 1 rue Emile Bian

- Monsieur Jean-Marie Heyder, né le 08/12/1956 à Grevenmacher, demeurant professionnellement à L-2996 Luxem-

bourg, 1 rue Emile Bian

- Monsieur Eugène Kirsch, né le 09/07/1957 à Differdange, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1

rue Emile Bian

- Monsieur Axel Ludwig, né le 21/03/1969 à Hermeskeil, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1 rue

Emile Bian

- Madame Anne-Catherine Ries, née le 01/04/1973 à Pétange, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg,

1 rue Emile Bian

- Madame Marie-Josée Ries, née le 25/03/1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg,

1 rue Emile Bian

- Monsieur Jean-Paul Zens, né le 08/01/1953 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1

rue Emile Bian

Leur mandat expire le 31/12/2012.
L'assemblée générale extraordinaire en date du 18 octobre 2010 a nommé les membres du comité de direction de

l'EPT comme membres du directoire de Luxgsm S.A. conformément à l'article 21 des statuts à savoir:

- Monsieur Marcel Gross, né le 20/09/1947 à Biwer, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1 rue

Emile Bian

- Monsieur Joseph Glod, né le 31/01/1954 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1 rue Emile

Bian

- Monsieur Jean-Marie Spaus, né le 31/01/1966 à Clervaux, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1

rue Emile Bian

137097

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Paul Peckels, né le 13/06/1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg, 1

rue Emile Bian

- Monsieur Marc Rosenfeld, né le 26/12/1958 à Bettembourg, demeurant professionnellement à L-2996 Luxembourg,

1 rue Emile Bian

Leur mandat expire le 31/08/2016.

Fait à Luxembourg le 18 octobre 2010.

Monsieur Marcel Gross / Monsieur Guy Modert / Madame Aude Barbier
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2010158278/59.
(100181113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 127.366.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1 

er

 novembre 2010, a décidé d'accepter:

- la démission de Gerardus Meijssen en qualité de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 novembre 2010.

- La nomination avec effet au 1 

er

 novembre 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société

de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536
Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1 

er

 novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, gérant
- Maxime NINO, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Fabrice HABLOT, gérant
- Véronique MENARD, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Nicole Götz
<i>Gérant

Référence de publication: 2010158385/23.
(100181459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

DIF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.915.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Un extrait référencé sous le numéro L100126200.05 a été déposé le 16 août 2010 en vue de la publication au Mémorial

de l'élection de la nouvelle personne chargée du contrôle des comptes de la Société.

Cet extrait est rectifié comme suit:
La société BDO Audit, immatriculée sous le numéro B 147570 au R.C.S. de Luxembourg et ayant son siège social au

2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, n'est pas commissaire aux comptes de la Société mais Réviseur d'En-
treprise de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137098

L

U X E M B O U R G

DIF Luxembourg S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2010157115/21.
(100180604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Berlisa International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 93.814.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156591/9.
(100180777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Bessel Re S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156594/9.
(100180778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

BFO Group International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.676.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée

<i>Générale des Actionnaires, en date du 29 octobre 2010

- révocation de Monsieur Johan Hemelaere de son poste d’administrateur et de Président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156596/11.
(100180696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Abira Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 54.617.

In the year two thousand ten, on the twenty-eighth of October,
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of shareholders of "ABIRA HOLDING S.A.", a société anonyme having its registered

office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 54.617, incorporated pursuant to a notarial deed dated 27 March 1996, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 350 of 22 July 1996 (hereafter the "Company").

The meeting is opened at 2.00 p.m. with Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in L-1212

Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,

who appointed as secretary Ms Anita Maggipinto, private employee, residing professionally in L-1212 Luxembourg, 17,

rue des Bains.

The meeting elected as scrutineer Ms Martine Zellinger, private employee, residing professionally in L-1212 Luxem-

bourg, 17, rue des Bains.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

137099

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1,687,600 (one million six hundred eighty-seven

thousand six hundred US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 350,000 (three hundred fifty thousand
US Dollars), up to USD 2,037,600 two million thirty-seven thousand six hundred US Dollars), by creating 16,876 (sixteen
thousand eight hundred seventy-six) new shares;

2. Subscription and payment of the 16,876 (sixteen thousand eight hundred seventy-six) new created shares by Dia-

rough SCA SICAR by a contribution of a certain liquid and due claim;

3. Modification of article 5 of the articles of incorporation in order to take into consideration the above mentioned

modifications;

4. Miscellaneous.
II.- That the represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the

represented shareholder declaring that he had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting then takes the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1,687,600 (one million

six hundred eighty-seven thousand six hundred US Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 350,000
(three hundred fifty thousand US Dollars), up to USD 2,037,600 (two million thirty-seven thousand six hundred US
Dollars), through the issue of 16,876 (sixteen thousand eight hundred seventy-six) new shares, having a nominal value of
USD 100 (one hundred US Dollars) each.

<i>Subscription and Payment

The 16,876 (sixteen thousand eight hundred seventy-six) new shares are all subscribed by the sole shareholder DIA-

ROUGH S.C.A. SICAR, a société en commandite par actions, with registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route
d'Esch, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 119.865,

here represented by Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on 9 September 2010,
and entirely paid up in exchange of a contribution in kind consisting of a conversion of a claim that DIAROUGH S.C.A.

SICAR, prenamed, has against the Company.

Pursuant to articles 26-1 and 32-1(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the valuation

of the contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated 28 October 2010 established
by RSM Audit Luxembourg, réviseurs d'entreprises, established in L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, which report,
after signature ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be filed at the same time.

The value of said claims is confirmed by said report which concludes as follows:
"On the basis of controls as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the

value of the loan owned by DIAROUGH S.C.A. SICAR (USD 1,687,600.00) retained at the time of the capital increase is
less than the value of shares of ABIRA HOLDING S.A. issued in exchange, i.e. 16,876 shares with a nominal value of USD
100."

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is

amended and will henceforth read as follows:

"The subscribed capital is fixed at two million thirty-seven thousand six hundred US Dollars (USD 2,037,600) repre-

sented by twenty thousand three hundred seventy-six (20,376) shares with a nominal value of one hundred US Dollars
(USD 100) each."

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

137100

L

U X E M B O U R G

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the appearers, the said appearers signed together with the notary this original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-huit octobre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ABIRA HOLDING S.A.", ayant son siège

social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 54.617, constituée suivant acte notarié en date du 27 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 350 du 22 juillet 1996 (ci-après la "Société").

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant

professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anita Maggipinto, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Martine Zellinger, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 1.687.600 (un million six cent quatre-vingt-sept mille six cents

Dollars US) pour le porter de son montant actuel de USD 350.000 (trois cent cinquante mille Dollars US) à USD 2.037.600
(deux millions trente-sept mille six cents Dollars US) par la création de 16.876 (seize mille huit cent soixante-seize) actions
nouvelles.

2. Souscription et libération des 16.876 (seize mille huit cent soixante-seize) actions nouvellement créées par DIA-

ROUGH SCA SICAR par conversion d'une dette certaine, liquide et exigible.

3. Modification de l'article 5 des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises.
II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de USD 1.687.600 (un million

six cent quatre-vingt-sept mille six cents Dollars US) pour le porter de son montant actuel de USD 350.000 (trois cent
cinquante mille Dollars US) à USD 2.037.600 (deux millions trente-sept mille six cents Dollars US) par la création de
16.876  (seize  mille  huit  cent  soixante-seize)  actions  nouvelles  d'une  valeur  nominale  de  USD  100  (cent  Dollars  US)
chacune.

<i>Souscription et Libération

Les 16.876 (seize mille huit cent soixante-seize) actions nouvelles sont toutes souscrites par l'actionnaire unique DIA-

ROUGH S.C.A. SICAR, une société en commandite par actions, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route
d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 119.865,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

137101

L

U X E M B O U R G

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 septembre 2010 et qui restera attachée au

présent acte,

et intégralement libérées en contrepartie d'un apport en nature consistant en la conversion d'une créance que DIA-

ROUGH S.C.A. SICAR, prénommée, a sur la Société.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi en date du 28 octobre 2010 par RSM Audit Luxembourg,
réviseur d'entreprises, établi à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, lequel rapport, après signature ne varietur par les
comparants et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de ladite créance est constatée par ledit rapport dont la conclusion est la suivante:
"On the basis of controls as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the

value of the loan owned by DIAROUGH S.C.A. SICAR (USD 1,687,600.00) retained at the time of the capital increase is
less than the value of shares of ABIRA HOLDING S.A. issued in exchange, i.e. 16,876 shares with a nominal value of USD
100."

<i>Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1 

er

 de l'article 5 des statuts de la

Société qui aura désormais la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à USD 2.037.600 (deux millions trente-sept mille six cents Dollars US) représenté par vingt

mille trois cent soixante-seize (20.376) actions d'une valeur nominale de USD 100 (cent Dollars US) chacune."

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. STOLZ-PAGE, A. MAGGIPINTO, M. ZELLINGER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2010. LAC/2010/48395. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010157744/164.
(100181363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

CLCC S.A., Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 82.290.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2010

L’assemblée précise, en complément des articles 9 et 10 des statuts, que la société sera, dans tous les cas, valablement

engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de Monsieur Wuytack Kristof.

Pour extrait sincère et conforme
Kristof Wuytack / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010156625/13.
(100181196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137102

L

U X E M B O U R G

Biosystem, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.867.

<i>Extrait de assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2009

L'assemblé générale accepte la nomination de M. Luc-Henri JAMAR, né le 20/07/1954 à Ixelles (Belgique) demeurant

21, rue Léon Metz, L-4238 Esch s/Alzette, aux fonctions de gérant administratif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156597/11.
(100181009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Captain North Sea Finance Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.000.002,00.

Siège de direction effectif: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.820.

Le siège social de l'associé unique Captain Holdings S.à r.l. a changé et se trouve à présent au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Référence de publication: 2010156603/12.
(100180937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Bosquet, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2555 Luxembourg, 62, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 99.417.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BOSQUET SARL

Référence de publication: 2010156599/10.
(100180838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 72.801.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010156600/10.
(100181160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

British Cars Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 164, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 62.816.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 26 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010156601/10.
(100180959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137103

L

U X E M B O U R G

British Cars Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 164, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 62.816.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 26 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010156602/10.
(100180960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 82.290.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration du 26 novembre 2010

Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social
du 55-57, rue de Merl L-2146 Luxembourg
au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme
Kristof Wuytack / Freddy Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010156624/14.
(100181038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Carta Capital Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 135.560.

Le siège de la société Carta Capital Investments II S.à r.l., numéro RC B 135560, avec adresse au 560A, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 18 novembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2010

Signature.

Référence de publication: 2010156604/10.
(100181126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Cartainvest II S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 105.233.

Le  siège  de  la  société  Cartainvest  II  S.A.,  numéro  RC  B  105233,  avec  adresse  au  560A,  rue  de  Neudorf,  L-2220

Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 18 novembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010156605/10.
(100181127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Cheyne Special Situations Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 106.589.

Les comptes de liquidation au 31 mai 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156606/9.
(100181177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137104

L

U X E M B O U R G

GSMP 2006 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 113.776.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1 

er

 Novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Christophe Cahuzac comme gérant de la Société avec effet immédiat au 2 août 2010.
- La nomination avec effet immédiat au 2 août 2010 de Nicole Götz, née à Brackenheim (Germany) le 4 juin 1967, et

résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La démission de Gérard Meijssen comme gérant de la Société avec effet immédiat au 1 

er

 novembre 2010.

- La nomination avec effet immédiat au 1 

er

 novembre 2010 de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978,

et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1 

er

 novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, Manager
- Michael FURTH, Manager
- Véronique MENARD, Manager
- Maxime NINO, Manager
- Fabrice HABLOT, Manager
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Gérant

Référence de publication: 2010157030/25.
(100179947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2010.

City Parking Group Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 76.515.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Référence de publication: 2010156608/10.
(100180536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

<i>Auszug aus der außerordentlichen Generalversammlung vom 21. Oktober 2010

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
Herr Jan Wohlschiess legt sein Verwaltungsratsmandat mit Datum vom 0l. Juli 2010 nieder.
Die Versammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Ernennung von Herrn Dr. Andreas Wagner, geboren am 08. Oktober 1967, in München, Geschäftsadresse Arabellastr.

12, 81925 München, zum Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 22. Oktober 2010.

Die Wahl von Herrn Dr. Wagner als Verwaltungsratsmitglied gilt bis zur ordentlichen Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2013 beschließt und im Jahr 2014 stattfindet.

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01. Januar 2011 verlegt nach 8-10, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg

Unterschriften
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmzähler / Aktionärsvertreter

Référence de publication: 2010157236/19.
(100180920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137105

L

U X E M B O U R G

Advent Key Investor &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 156.031.

In the year two thousand and ten, on the tenth of November.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, (Grand-Duchy of Luxembourg),
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Advent Key Investor &amp; Cy S.C.A.” (the “Company”),

a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 156.031, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 4 October 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial
C")..

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mrs. Valerie-Anne BASTIAN, private employee, residing in Luxembourg, who is also elected

as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To acknowledge and approve the increase of the Company's share capital by an amount of twenty-six million nine

hundred and fifteen thousand Euro (EUR 26,915,000.-), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand
Euro (EUR 31,000.-) up to twentysix million nine hundred and forty-six thousand Euro (EUR 26,946,000.-), by the issue
of two billion six hundred and ninety-one million five hundred thousand (2,691,500,000) New Ordinary Shares (collectively
referred as the "New Ordinary Shares"), each having a par value of one cent euro (EUR 0.01) and having the same rights
and obligations as set out in the Company's articles of incorporation, paid up by a contribution in cash.

2. To amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company according to the above resolution.
3. To increase the amount of the authorized share capital up to an amount of thirty million euros (EUR 30,000,000.-)

and amend article 6.1 of the Company’s articles of incorporation accordingly.

4. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties
will also remain annexed to the present deed.

III.-  That  the  entire  share  capital  being  represented  at  the  present  meeting  and  all  the  shareholders  represented

declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase of the Company's share capital by an amount of twenty-six million nine

hundred and fifteen thousand Euro (EUR 26,915,000.-), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand
Euro (EUR 31,000.-) up to twenty-six million nine hundred and forty-six thousand Euro (EUR 26,946,000.-), by the issue
of two billion six hundred and ninety-one million five hundred thousand (2,691,500,000) New Ordinary Shares (collectively
referred as the "New Ordinary Shares"), each having a par value of one cent euro (EUR 0.01) and having the same rights
and obligations as set out in the Company's articles of incorporation, paid up by a contribution in cash.

The New Ordinary Shares are fully subscribed and paid up by “Advent Key (Luxembourg) S.à r.l.", a société à res-

ponsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 156.021, represented by Mrs Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, hereto annexed.

The total contribution amount of twenty-six million nine hundred and fifteen thousand Euro (EUR 26,915,000.-) is

entirely allocated to the Company’s share capital.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

137106

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend article 5.1 of the articles of incor-

poration of the Company relating to the share capital, which shall henceforth be read as follows:

"  5.1.  The  Company  has  a  share  capital  of  twenty-six  million  nine  hundred  and  forty-six  thousand  Euro  (EUR

26,946,000.-) divided into two billion six hundred and ninety-four million five hundred and ninety-nine thousand nine
hundred (2,694,599,900) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and one hundred (100) management shares (the "Ma-
nagement Shares") with a par value of one cent euro (EUR 0.01) each (all shares together referred to as the "Shares").
The Management Shares shall be held by Advent Key Investor S.à r.l., prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire
commandité)”.

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the amount of the authorized share capital up to an amount of thirty million

euros (EUR 30,000,000.00) and to amend article 6.1 of the Company’s articles of incorporation accordingly which shall
henceforth be read as follows:

“  6.1.  The  Company  has  an  un-issued  but  authorised  capital  of  a  maximum  amount  of  thirty  million  euros  (EUR

30,000,000.-) to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares”.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions «Advent

Key Investor &amp; Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.031, ayant son siège social au
2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 4 octobre 2010, dont les statuts n’ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations (le «Mémorial C»).

L'Assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne BASTIAN, employée, demeurant à Luxembourg, qui est aussi

choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de vingt-six millions neuf cent quinze mille euros (EUR

26.915.000,-), de façon à l’accroître de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à vingt-six millions
neuf cent quarante-six mille euros (EUR 26.946.000,-), par l’émission de deux milliards six cent quatre-vingt onze millions
cinq cent mille (2.691.500.000) nouvelles actions ordinaires (collectivement désignées comme les «Nouvelles Actions
Ordinaires») chacune ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1.00) et ayant les mêmes droits et obligations tels
qu’indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par un apport en nu-
méraire.

2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société suite à la résolution ci-dessus.
3. Augmentation du montant du capital autorisé à montant maximum de trente millions d’euros (EUR 30.000.000,-)

et modification de l’article 6.1 des statuts de la Société en conséquence.

4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera

137107

L

U X E M B O U R G

annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de vingt-six millions neuf cent

quinze mille euros (EUR 26.915.000,-), de façon à l’accroître de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) à vingt-six millions neuf cent quarante-six mille euros (EUR 26.946.000,-), par l’émission de deux milliards six
cent quatre-vingt onze millions cinq cent mille (2.691.500.000) nouvelles actions ordinaires (collectivement désignées
comme les «Nouvelles Actions Ordinaires») chacune ayant une valeur nominale d’un cent (EUR 0.01) et ayant les mêmes
droits et obligations tels qu’indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées
par un apport en numéraire.

Les Nouvelles Actions Ordinaires sont intégralement souscrites et payées par Advent Key (Luxembourg) S.à r.l.",

société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 156.021, représentée par Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d’une procuration ci-annexée.

Le montant total de l’apport vingt-six millions neuf cent quinze mille euros (EUR 26.915.000,-) pour ces Nouvelles

Parts Sociales est intégralement alloué au capital social de la Société.

La preuve du montant total de l’apport a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l'Article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les déci-

sions ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5.1. Le capital social de la Société est de vingt-six millions neuf cent quarante-six mille euros (EUR 26.946.000,-),

représenté par deux milliards six cent quatre-vingt quatorze millions cinq cent quatre vingt dix-neuf mille neuf cents
(2.694.599.900) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires") et cent (100) actions de commandité (les'"Actions de Com-
mandité") ayant chacune une valeur nominale d’un cent (EUR 0.01) chacune (toutes ensembles les «Actions»). Les Actions
de Commandité seront détenues par Advent Key Investor S.à r.l., précité, actionnaire commandité de la Société.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé de la Société jusqu’à un montant de trente millions d’euros

maximum et de modifier l’article 6.1 en conséquence qui aura désormais la teneur suivante:

«  6.1.  La  Société  a  un  capital  non  émis  mais  autorisé  d'un  montant  maximum  de  trente  millions  d’euros  (EUR

30,000,000.-) devant être utilisé afin d'émettre de nouvelles actions ou d'augmenter la valeur nominale des Actions».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, V. A. BASTIAN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13742. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010156547/161.
(100181020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137108

L

U X E M B O U R G

Vegan Society Luxemburg, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5626 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Elise Deroche.

R.C.S. Luxembourg F 8.548.

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichneten:
alle wohnhaft in Luxemburg und all denjenigen die in der Folge den gegenwärtigen Statuten beitreten werden, wird

eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom einundzwanzigsten April 1928 ge-
gründet.

Kapitel I. - Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen "Vegan Society Luxemburg". Ihr Sitz ist Mondorf-les-Bains.

Art. 2. Die Vereinigung ist unabhängig und überparteilich.

Art. 3. Zweck des Vereins ist, durch Aufklärung, Vermittlung von Fachwissen und gutes Beispiel die Förderung des

Veganismus; dies beinhaltet die vegane Ernährung so wie eine vegane Lebensweise.

Dies soll durch
a) Informationen sammeln und zur Verfügung stellen
b) Vorträge, Versammlungen, Veranstaltungen, gesellige Zusammenkünfte, Kochkurse, Wanderungen, Diskussionsa-

bende, Infostände, etc.

c) Unterstützung veganer Initiativen aller Art
d) Einflussnahme auf politische Entscheidungen mittels Öffentlichkeitsarbeit
e) Verbreitung von Informationsmaterial, durch Versammlungen und Veranstaltungen, öffentliche Kundgebungen, so-

wie Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk, Fernsehen und anderen Medien

f) Gewinnung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so wie der Wissenschaft zur Unterstützung
g) Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gleicher Zielsetzung und gegebenenfalls Beitritt zu einer den Zielen

des Vereins entsprechenden Dachorganisation

erreicht werden.

Art. 4. Die Vereinigung wird gebildet für eine unbegrenzte Dauer. Sie kann zu jeder Zeit aufgelöst werden.

Kapitel II. - Mitglieder

Art. 5. Die Zahl der Mitglieder der Vereinigung ist unbeschränkt, ohne aber unter drei zu fallen.

Art. 6. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die Ziele

und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördert und unterstützt. Ordentliche Mitglieder sind dazu verp-
flichtet, durch praktische Tätigkeiten an der Verwirklichung der Vereinsziele aktiv mitzuarbeiten und sind angehalten,
regelmäßig an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen.

Art. 7. Jede natürliche Person kann Mitglied werden, solange sie die Ziele der Vereinigung unterstützt. Nur vegan

lebende Personen können in den Vorstand gewählt werden und den Verein nach außen vertreten.

Art. 8. Die ersten Mitglieder der Vereinigung sind die Unterzeichneten dieses Aktes. Die Aufnahme neuer Mitglieder

ist dem Vorstand vorbehalten, der nicht verpflichtet ist dem Bittsteller etwaige Ablehnungsgründe zu bringen.

Art. 9. Die ordentliche Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Ob der/die An-

tragsteller/in  die  Anforderungen  nach  Art.  6.  erfüllt,  entscheidet  der  Vorstand  mit  einfacher  Stimmenmehrheit.  Die
ordentliche Mitgliedschaft beginnt mit Zustellung der schriftlichen Bestätigung des Antrages.

Art. 10. Jede Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds, Auflösung des Vereins.

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Die Kün-
digung tritt sofort in Kraft.

Art. 11. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied

ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen schriftlich zu äußern.
Nach Erhalt dieser schriftlichen Stellungnahme entscheidet der Vorstand abschließend. Der Ausschluss eines Mitglieds
mit sofortiger Wirkung kann dann ausgesprochen werden, wenn

a) das Mitglied gegen die Satzung oder die Vereinsinteressen verstößt
b) das Mitglied im Verein Unfrieden stiftet
c) für ein ordentliches Mitglied die Vorraussetzungen aus §6 und 7 nicht mehr erfüllt sind
d) das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag trotz Mahnung 4 Monate im Rückstand ist.

137109

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund (siehe Art. 10), erlöschen alle Ansprüche aus

dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grund-
sätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

Art. 13. Jedes ordentliche Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu zahlen, dessen Höhe jeweils von ihm bestimmt wird, aber

den Mindestbeitrag nicht unterschreiten darf. Die Höhe des Mindestbeitrages beschließt die Mitgliederversammlung. Der
Vorstand ist ermächtigt, in Härtefällen den Beitrag zu ermäßigen oder befristet auszusetzen.

Art. 14. Der Jahresbeitrag ist im Januar eines jeden Kalenderjahres oder in Teilen am Beginn eines jeden Halbjahres

ohne besondere Aufforderung fällig. Bei Vereinseintritt ist der Mitgliedsbeitrag spätestens 2 Wochen nach Zustellung der
Aufnahmebestätigung fällig. Der Ausschluss oder Austritt eines Mitgliedes entbindet dieses nicht von der Verpflichtung
des zur Zahlung fälligen Jahresbeitrages.

Kapitel III. - Organe des Vereins

Art. 15. Organe des Vereines sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

Der Vorstand

Art. 16. Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vorsitzenden und ein bis fünf

weiteren Vorstandsmitgliedern.

Art. 17. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung in allgemeiner, gleicher, unmit-

telbarer und geheimer Wahl für die Dauer von zwei Jahren. Die austretenden Ratsmitglieder sind wieder wählbar. Gewählt
ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Stimmen, deren Ungültigkeit der/die Vorsitzende der
Versammlung feststellt, gelten als nicht abgegeben. Ist mehr als ein/e Kandidat/in für einen Vorstandsposten vorgeschlagen
und hat dann keine/r dieser Kandidatinnen/Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, so
findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist dann die/derjenige,
die/der die meisten Stimmen erhält; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

Art. 18. Der Vorstand wählt aus seinem Schoße einen Präsidenten, einen Sekretär, einen Kassierer und einen Sprecher.

Art. 19. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei vertre-

tungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 20. Der Vorstand tritt auf Einladung des Präsidenten so oft zusammen, wie die Interessen der Vereinigung es

verlangen. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder kann zu jeder Zeit die Einberufung des Verwaltungsrates verlangen. In
diesem Fall muss der Präsident den Vorstand innerhalb von 14 Tagen zusammenrufen. Der Vorstand kann nur beschließen,
wenn mindestens zwei Drittel der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfa-
cher Mehrheit der Abstimmenden getroffen, indem die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters bei Stimmen-
gleichheit ausschlaggebend ist. Sie werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt, die durch zwei vertretungsberechtig-
ten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden.

Mitgliederversammlung

Art. 21. Ordentliche Mitgliederversammlungen sind einmal jährlich, möglichst im dritten Viertel eines Jahres, einzu-

berufen. In der ordentlichen Mitgliederversammlung ist von der/dem Vorsitzenden oder deren/dessen Beauftragten ein
Tätigkeitsbericht und ein Kassenbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr zu erstatten. Die Generalversammlung ist
beschlussfähig, welches auch die Zahl der anwesenden Mitglieder sein mag. Die ordentliche Mitgliederversammlung:

a. beschließt über die Entlastung des Vorstandes
b. wählt den Vorstand und die 2 Kassenrevisoren
c. nimmt den Kassenbericht entgegen
d. beschließt über Satzungsänderungen
e. legt den Mindestmitgliederbeitrag fest, der 50 € nicht überschreiten darf
f. beschließt über die Auflösung des Vereins
g. beschließt über Anträge.

Art. 22. Die Generalversammlung wird präsidiert durch den Präsidenten des Vorstandes und in dessen Abwesenheit

durch einen Stellvertreter.

Art. 23. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind nach Bedarf vom Vorstand einzuberufen. Sie müssen binnen

Monatsfrist einberufen werden, wenn wenigstens ein Drittel der ordentlichen Mitglieder schriftlich und unter Angabe des
Grundes dies verlangt oder wenn das Interesse des Vereins es erfordert.

Art. 24. Ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen sind mindestens zwei Wochen vor ihrem Zeit-

punkt unter Angabe der vorgesehenen Tagesordnung den stimmberechtigten Vereinsmitgliedern schriftlich durch einfa-
chen  Brief  bekannt  zu  machen.  Anträge  für  diese  Versammlung  sind  mindestens  eine  Woche  vorher  mit  kurzer

137110

L

U X E M B O U R G

Begründung einzureichen. Darüber, ob später gestellte Anträge noch auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, ent-
scheidet die Mitgliederversammlung.

Art. 25. Zu Beschlüssen der Mitgliederversammlungen ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder

einfache Stimmenmehrheit erforderlich und ausreichend. Im Falle von Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.

Art. 26. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens

zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel IV. - Jährliche Rechnung, Budget

Art. 27. Das Gesellschaftsjahr beginnt mit dem ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Ausnahms-

weise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Unterzeichnung gegenwärtiger Statuten.

Art. 28. Der Verwaltungsrat legt in der ersten Hälfte eines jeden Jahres der Generalversammlung die Jahresabrechnung

des verflossenen Jahres und das Budget für das kommende Jahr zur Genehmigung vor.

Art. 29. Der Einnahmeüberschuss dient zur Reserve oder wird in der Vereinigung zweckdienlich verwendet.

Kapitel V. - Statutenänderung, Auflösung

Art. 30. Die Änderung der Statuten erfolgt im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die

Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Art. 31. Die Auflösung der Vereinigung erfolgt durch die Generalversammlung im Rahmen der Bestimmungen des

Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Art. 32. Im Falle einer Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung, auf Vorschlag des Vorstandes,

über die Übertragung des gesamten Vermögens des Vereins an eine gemeinnützige Vereinigung, die mit den Prinzipien
der "Vegan Society Luxemburg" vereinbar sind.

Kapitel VI. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 33. Für alle nicht näher bestimmte oder nicht näher zu bestimmende Fälle gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 21. April 1928.

Kapitel VII. - Ernennung des ersten Verwaltungsrates

Art. 34. Zu den ersten Mitgliedern des Vorstands sind ernannt:

Sascha Speck, Lehrer, Mondorf-les-Bains, Luxemburger;
Fabien Mussot, Beamter, Dudelange, Luxemburger;
Camille Muller, Privatbeamter, Asselscheuer, Luxemburger;
Da Silva Freitas Toni, Student, Bissen, Portugiese;
Jeff Mannes, Student, Bascharage, Luxemburger;
Christine Garnie-Schumann, Hausfrau, Aspelt, Luxemburgerin.

Angefertigt in soviel Exemplaren wie Parteien.

Mondorf-les-Bains, den 23.11.2010.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010158379/140.
(100181683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Clearwire Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 100.259.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010156609/10.
(100180885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137111

L

U X E M B O U R G

Cube Properties S.àr.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Novator Properties S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 136.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Référence de publication: 2010156612/12.
(100181250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Calidris 28 AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 139.001.

Im Jahre zweitausendzehn, den vierundzwanzigsten November.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette (Großherzogtum Lu-

xemburg)

hat sich die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft, CALIDRIS 28 AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in

L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der
Nummer B 139001, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am 23. Mai 2008, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1523 vom 19. Juni 2008, Seite 73086.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am 4. Mai 2009,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1033 vom 19. Mai 2009, Seite 49581 (die
„Gesellschaft“) eingefunden.

Die Generalversammlung beginnt um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Christian KIEFER, Angestellter, mit

Berufsanschrift in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

Zum Schriftführer und Stimmenzähler wird ernannt Herr Jérôme SCHMIT, Angestellter, mit Berufsanschrift in Esch/

Alzette.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertreter, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Es geht aus der vorgenannten Anwesenheitliste hervor, dass neunhundertsiebenundzwanzigtausend vierhundertz-

weiundfünfzig (927.452) Aktien, welche 85,87 % des Kapitals der Gesellschaft darstellen, bei dieser Generalversammlung
anwesend sind, welche somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung abstimmen kann.

III.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
„1. Abändern von Artikel 4 der Satzung.
2. Verschiedenes.“
So dem und nachdem die Generalversammlung festgestellt hat, dass sie rechtsmäßig zusammengetreten ist und somit

über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann und nach Kenntnisnahme der Feststellungen des Vorsitzenden
werden folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 4 der Satzung abzuändern wie folgt:

„ IV. Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1. Gesellschaftszweck der Gesellschaft als Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe CALIDRIS ist der Erwerb,

die Verwertung und die Veräußerung von Patenten, Lizenzen, Markenrechten oder ähnlichen Eigentumsrechten, sowie
davon abgeleiteten oder die selben ergänzenden Rechten an Produkten des Lifestyles, wie Getränke, Kleidung, Acces-
soires.

4.2. Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit ganz oder teilweise durch die Beteiligung an anderen Unternehmen aus. Zweck

der Gesellschaft ist deshalb auch der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, die im Bereich Lifestyle, sowie allen diesem Gesellschaftszweck dienenden Bereichen tätig
sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anla-
geformen.

137112

L

U X E M B O U R G

4.3. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder Gesellschaften, die

derselben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

4.4. Gesellschaftszweck ist ferner der weltweite Vertrieb von Produkten des Lifestyles, wie Getränke, Kleidung, Ac-

cessoires.

4.5. Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobi-

liarer und immobiliarer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen
vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks för-
dern können, vornehmen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen aufnehmen.“

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Generalversammlung

für geschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von € 1.000.-

abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Esch/Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Kiefer, J. Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14551. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 2010.

Référence de publication: 2010156613/69.
(100180717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Capital Pierre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.137.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société en date du 20 octobre 2010:
- L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick LEFEBVRE, Monsieur Jean-Fran-

çois CAEYMAEX et Monsieur Michel-Yves BOLLORE jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'année
se clôturant au 31 mai 2011.

-  L'Assemblée  décide  de  renouveler  le  mandat  de  la  société  CLYBOUW  et  ASSOCIES  comme  commissaire  aux

comptes jusqu'à l'assemblée générale statuant au 31 mai 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Monsieur Caeymaex
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2010157325/17.
(100181286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Augur Financial Holding V S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 153.749.

Im Jahre zweitausendundzehn, am elften November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Fand  die  Ausserordentliche  Generalversammlung  der  Aktionäre  (die  "Generalversammlung")  der  Augur  Financial

Holding V S.A. (Société Anonyme) gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gemäß
Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, vorbenannt, am 09. Juni 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Num-
mer 1534 vom 27. Juli 2010, und mit Gesellschaftssitz in 6, rue Dicks, L-1417 Luxemburg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 153.749 statt.

137113

L

U X E M B O U R G

Als Vorsitzende der Generalversammlung amtiert Frau Diane Wolf, Privatangestellte, beruflich ansässig, in 6, rue Dicks,

1417 Luxemburg.

welche Frau Solange Wolter Privatangestellte, beruflich ansässig in 101, rue Cents, L-1319 Luxemburg, zum Sekretär

bestellt.

Die Generalversammlung bestellt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich ansässig in 101, rue Cents, L-1319

Luxemburg, zur Stimmenzähler.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis der Aktionäre beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde vom Allei-

naktionär bzw. dessen Vertreter, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und dem unterzeich-
neten Notar unterschrieben.

Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten sind ebenfalls dieser Urkunde "ne varietur" paraphiert beigefügt,

um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Da sämtliche dreihundertzehn (310) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger

Generalversammlung  vertreten  sind,  waren  Einberufungen  hinfällig.  Somit  ist  gegenwärtige  Versammlung  rechtsgültig
zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
Änderung der folgenden Artikel:
Art. 3
Art. 6
Neu: zu Punkt III. Tag-along und Drag-along Rechte
Neuer Art. 7
Neuer Art. 8
Neuer Art. 9
Nach Beratung fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse

<i>Erster Beschluss

1. Änderung des Artikels 3. der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Bisheriger Artikel 3.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen unter jedweder Form in anderen in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Art von Investition, von Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder jede
andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf jede andere Art und Weise von Wertpapieren jeder Art,
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und der Entwicklung von in- und ausländischen Handels-, Industrie- oder

Finanzgesellschaften beteiligen und sie kann diesen Gesellschaften jede Art von Beistand leisten, sei es in der Form von
Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jedweder Form aufnehmen, Schuldverschreibungen ausgeben und Sicherheiten bes-

tellen.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Industrie- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten

ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

<i>Zweiter Beschluss

1. Änderung des Artikels 3. der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Neuer Artikel 3.:

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen unter jedweder Form in anderen in-

und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Art von Investition, von Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder jede
andere Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf jede andere Art und Weise von Wertpapieren jeder Art,
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und der Entwicklung von in- und ausländischen Handels-, Industrie- oder

Finanzgesellschaften beteiligen und sie kann diesen Gesellschaften jede Art von Beistand leisten, sei es in der Form von
Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jedweder Form aufnehmen, Schuldverschreibungen ausgeben und Sicherheiten bes-

tellen. Ferner kann die Gesellschaft jederzeit Genussscheine ausgeben. Solche Genussscheine, deren Zahl vom Verwal-
tungsrat festgesetzt wird geben den Genussscheininhabern kein Stimmrecht. Jeder Genussschein hat jedoch den gleichen

137114

L

U X E M B O U R G

Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationsergebnis der Gesellschaft wie eine der in Art. 6. dieser Statuten beschriebenen
Aktien.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Industrie- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten

ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

<i>Dritter Beschluss

1. Änderung des Artikels 6. der Gesellschaftssatzung wie folgt:
Bisheriger Artikel 6:

Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an
Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

Neuer Artikel 6:

Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an
Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

Wollen Aktionäre, die allein oder zusammen 50% oder weniger des Aktienkapitals der Gesellschaft halten (die "Min-

derheit"), Aktien der Gesellschaft an Dritte veräußern, so dürfen Sie dieses nur mit Zustimmung der Mehrheit (wie in
nachfolgendem Art. 7. definiert).

<i>Vierter Beschluss

Neu Punkt III Tag-along und Drag –along Rechte

<i>Fünfter Beschluss

Neuer Artikel 7 unter Punkt III Tag –along und Drag –along Rechte

Neuer Art. 7. Wollen Aktionäre, die allein oder zusammen mehr als 50% des Aktienkapitals der Gesellschaft halten

(die "Mehrheit"), ihre gesamten Aktien der Gesellschaft unter Vereinbarung einer Gegenleistung an einen Dritten, der
nicht ein mit der Mehrheit verbundenes Unternehmen (ein verbundenes Unternehmen im Sinne des deutschen Aktien-
gesetzes) ist, übertragen, so ist die Mehrheit (i) verpflichtet, die übrigen Aktionäre unverzüglich über ihre Veräußerung-
sabsicht sowie über den bisherigen Verlauf etwaiger Veräußerungsverhandlungen zu unterrichten und (ii) auf Verlangen
aller übrigen Aktionäre verpflichtet, sicherzustellen, dass alle mitveräußerungswilligen Aktionäre ihre Aktien der Gesell-
schaft  zu  wirtschaftlich  vergleichbaren  Bedingungen  mit  übertragen  können.  Die  Mehrheit  wird  ferner  den
mitveräußerungswilligen Aktionären, sofern vernünftigerweise möglich, spätestens 7 Tage vor Abschluss des entspre-
chenden  Aktienkaufvertrages  (bzw.  des  entsprechenden,  der  Aktienübertragung  zugrundeliegenden  Vertrages)  den
Vertragsentwurf der sämtliche materiellen Bedingungen des beabsichtigten Aktienverkaufs enthalten muss zuleiten.

Jeder der mitveräußerungswilligen Aktionäre ist dann berechtigt, durch schriftliche Mitteilung an die Mehrheit, die

dieser spätestens 4 Tage nach Zugang des Kaufvertragsentwurfes bei dem entsprechenden mitveräußerungswilligen Ak-
tionär zugehen muss, zu verlangen, dass die von ihm gehaltenen Aktien zu wirtschaftlich vergleichbaren Bedingungen an
den Erwerber mitveräußert werden.

Ist der Erwerber nicht bereit, auch die Aktien der mitveräußerungswilligen Aktionäre zu übernehmen, so steht den

mitveräußerungswilligen Aktionären ein Schadensersatzanspruch gegen die Mehrheit ausschließlich nach Maßgabe der
nachfolgenden Regelung zu: in diesem Fall ist der jeweilige mitveräußerungswillige Aktionär dazu berechtigt, der Mehrheit
seine Aktie(n) zu Bedingungen, die denen wirtschaftlich vergleichbar sind, zu denen die Mehrheit ihre Aktien an den
Erwerber  veräußert  hat,  anzudienen  und  die  Mehrheit  ist  dazu  verpflichtet,  dieses  Angebot  anzunehmen.  Der

137115

L

U X E M B O U R G

mitveräußerungswillige Aktionär muss dieses Recht innerhalb eines Monats nach Ablehnung seines Kaufangebots nach
Maßgabe von Art. 7. Abs. 2 an den Erwerber schriftlich gegenüber der Mehrheit ausüben (Ausschlussfrist).

Wird das in Art. 7. Abs. 1 bis 3 zum Mitverkaufsrecht geregelte Verfahren eingehalten, sind alle Aktionäre verpflichtet,

die nach dieser Satzung für die Übertragung von Geschäftsanteilen erforderlichen Zustimmungserklärungen zu erteilen.

<i>Sechster Beschluss

Neuer Artikel 8 unter Punkt III Tag –along und Drag –along Rechte

Neuer Art. 8. Sofern die Mehrheit unter Vorlage eines Aktienkaufvertrages oder eines rechtlich bindenden Angebots

(das "Kaufangebot"), der bzw. das sämtliche materiellen Bedingungen des Anteilsverkaufs enthalten muss, verlangt, dass
sämtliche Aktien an der Gesellschaft an einen Dritten, der nicht Aktionär oder mit der Mehrheit verbundenes Unter-
nehmen (ein verbundenes Unternehmen im Sinne des deutschen Aktiengesetzes) , unter Vereinbarung einer Gegenleis-
tung zu wirtschaftlich vergleichbaren Bedingungen übertragen werden sollen, sind alle übrigen Aktionäre verpflichtet,
hieran mitzuwirken und ihre Aktien an diesen Dritten zu veräußern.

Das Kaufangebot darf bedingt sein durch übliche Closing-Bedingungen, die binnen einer vernünftigen Frist erfüllt sein

müssen, einschließlich der Bedingung, eine Due Diligence in vernünftigem zeitlichem Ausmaß durchzuführen, und darf
Gewährleistungen und Garantien jedes Aktionärs als Alleinschuldner (und nicht als Gesamtschuldner) enthalten. Eine
etwaige Schadensersatzpflicht nach dem auf der Basis des Kaufangebots geschlossenen Kaufvertrages darf im Verhältnis
der veräußernden Aktionäre zueinander die Höhe der veräußerten Beteiligungsquote nicht überschreiten. Das Kaufan-
gebot darf zudem alle anderen üblichen Regelungen enthalten, einschließlich der Einrichtung eines Treuhandkontos (oder
der Ersetzung eines selbigen durch andere Formen der Sicherheit).

<i>Siebter Beschluss

Neuer Artikel 9 unter Punkt III Tag –along und Drag –along Rechte

Neuer Art. 9. Genussscheininhaber stehen den Aktionären in Bezug auf die oben genannten Tag-along und Drag-along

Rechte gleich. Die Regelungen der Art. 7. und 8. sind auf Genussscheininhaber entsprechend anwendbar.

Die übrigen Artikel der Gesellschaftssatzung bleiben unberührt, lediglich die Nummerierung der nachfolgenden Artikel

wird angepasst

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgeschehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch

Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. WOLF, S. WOLTER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51204. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. November 2010.

Référence de publication: 2010156550/159.
(100180854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

RCG Re III S.A., Société Anonyme,

(anc. Compagnie de Réassurance Akzo Nobel S.A.).

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 28.687.

In the year two thousand and ten, the twenty-seventh day of October, before Maître Francis Kesseler, notary residing

in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of Compagnie de Réas-

surance Akzo Nobel S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg with registered office at 74, rue de Merl, L-2146, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 28.687 (the Company). The Com-
pany was incorporated on 11 August 1988 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Mersch,
Grand Duchy of Luxembourg, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 302
of 16 November 1988. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and
for the last time on 18 June 2010 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand

137116

L

U X E M B O U R G

Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 1652
of 13 August 2010.

The Meeting is chaired by Christophe Balthazard, lawyer, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Edoardo Romano, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting appoints Gilles Durdu, lawyer,
professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The
Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively hereafter referred to as the Bureau.

The Shareholders, present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an

attendance list, which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the
Shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the Shareholders represented at the Meeting will also remain attached to the present minutes after

having been signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record:
I. that it appears from the attendance list that all the 250,000 shares of the Company, representing the entire share

capital of the Company amounting to EUR 10,500,000 are present or represented at the Meeting, which is consequently
duly constituted and may validly debate and take resolutions on the items of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Change of the name of the Company into "RCG Re III S.A." and subsequent amendment of article 1 of the articles

of association of the Company (the Articles).

3. Transfer of the Company's registered office from its current address to 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-

sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg and subsequent amendment of article 2 of the Articles.

4. Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR (Euro) to USD (United States dollars)

and subsequent amendment of article 5 of the Articles.

5. Amendment of article 10 of the Articles.
6. Miscellaneous.
III. that the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Shareholders (present or represented) consider themselves as duly convened and declare to have full knowledge of
the agenda of the Meeting which was communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company into "RCG Re III S.A.".
As a result, the Meeting resolves to amend article 1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"Art. 1. There exists a company under the name of RCG Re III S.A. (the "Company")."

<i>Third resolution

The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company from its current address at 74, rue de Merl,

L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy
of Luxembourg.

As a result, the Meeting resolves to amend article 2 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"Art. 2. The registered office is established in Esch-sur-Alzette. It may be transferred to any other address within the

municipality by a simple resolution of the Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of the abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg corporation."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to convert the currency of the share capital of the Company from EUR (euro) to USD (United

States dollars), and to that effect to convert the share capital of the Company of EUR 10,500,000 to USD 14,716,800 by
applying an average exchange rate of USD 1.4016 for EUR 1.

137117

L

U X E M B O U R G

The Meeting further resolves that this conversion of the currency of the share capital of the Company is simultaneously

accompanied by an increase of the number of existing shares of the Company from 250,000 to 350,400.

As a consequence, the Meeting resolves to amend article 5 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

"Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at fourteen million seven hundred and sixteen thousand eight

hundred United States dollars (USD 14,716,800) divided into three hundred and fifty thousand four hundred (350,400)
shares without nominal value."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 10, paragraph 6, of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
"The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented".

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately one thousand euro (€

1,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Shareholders, the

present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the Shareholders, it is also stated that,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the Shareholders, said proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre, par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

Grand-Duché de Luxembourg,

se tient une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Compagnie de

Réassurance Akzo Nobel S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 74, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 28.687 (la Société). La Société a été constituée le 11 août 1988 suivant un acte de Maître
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations CN° 302 du 16 novembre 1988. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
plusieurs fois et pour la dernière fois le 18 juin 2010 selon un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
CN° 1652 du 13 août 2010.

L'Assemblée est présidée par Christophe Balthazard, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg

(le Président). Le Président désigne Edoardo Romano, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que
secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée désigne Gilles Durdu, Avocat, demeurant professionnellement à
Luxembourg en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent
ensemble le Bureau.

Les Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste

de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par les mandataires des Actionnaires et les membres
du Bureau.

Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes

après avoir été signées par chacune des parties.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:
I. qu'il résulte de la liste de présence que toutes les 250.000 actions de la Société sans valeur nominale, représentant

l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de 10.500.000 EUR sont présentes ou représentées à l'Assemblée,
qui est par conséquent dûment constituée et peut valablement débattre et délibérer sur les points de l'ordre du jour.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Changement de la dénomination de la Société en "RCG Re III S.A." et modification subséquente de l’article 1 des

statuts de la Société (les Statuts).

3. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg et modification subséquente de l’article 2 des Statuts.

4. Conversion de la devise du capital social de la Société de EUR (euro) en USD (dollars des Etats-Unis d'Amérique)

et modification subséquente de l’article 5 des Statuts.

5. Modification de l'article 10 des Statuts.
6. Divers.
III. que l'Assemblé prend de manière unanime les résolutions suivantes:

137118

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les Actionnaires (présents ou représentés) se considèrent comme dûment convoqués et déclarent
avoir pleinement connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en "RCG Re III S.A.".
En conséquence, l’Assemblée décide de modifier l’article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"Art. 1 

er

 .  Il existe une société sous la dénomination RCG Re III S.A. (la "Société")."

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 74, rue de Merl, L-2146 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

En conséquence l’Assemblée décide de modifier l’article 2 des Statuts de telle sorte qu’il aura désormais la teneur

suivante:

"Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Admi-

nistration en tout autre endroit de la commune du siège.

Le Conseil d'Administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l'étranger se produiraient ou seraient imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise."

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de convertir la devise du capital social de la Société de EUR (euro) en USD (dollars des Etats-Unis

d'Amérique), et par conséquent de convertir le capital social de la Société de 10.500.000 EUR en 14.716.800 USD en
appliquant un taux de change moyen fixé à 1,4016 USD pour 1 EUR.

L’Assemblée décide également que cette conversion de la devise du capital social de la Société est simultanément

accompagnée d’une augmentation du nombre des actions de la Société existantes de 250.000 à 350.400.

En conséquence, l’Assemblée décide de modifier l’article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatorze millions sept cent seize mille huit cents dollars des Etats-Unis d'Amérique

(14.716.800 USD) représenté par trois cent cinquante mille quatre cents (350.400) actions sans désignation de valeur
nominale."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier l’article 10, paragraphe 6, des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
"Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux administrateurs sont pré-

sents ou représentés."

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par

la Société en conséquence du présent acte est estimé approximativement à mille euros (€ 1.000,-)

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, indique qu'à la requête des Actionnaires, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes Actionnaires, il est précisé qu'en cas de diver-
gences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des Actionnaires, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du

présent acte.

Signé: Balthazard, Romano, Durdu, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 novembre 2010 Relation: EAC/2010/13224 Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff  . (signé): M.-N. Kirchen.

137119

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2010156610/178.
(100181204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Lexsis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 66.278.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 14 octobre 2010.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés les résolutions

suivantes:

L’Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises à la Société MAZARS S.A. sise 10A, rue Henri

Schnadt à L-2530 LUXEMBOURG.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au

31 décembre 2010.

Bettembourg, le 14 octobre 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2010156743/18.
(100181163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Calidris 28 AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 139.001.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, den 26. November 2010.

Référence de publication: 2010156614/10.
(100181078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Calidris 28 EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 145.960.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, den 26. November 2010.

Référence de publication: 2010156616/10.
(100181079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 111.801.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°386 du 22 février 2006.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fidji Luxco (BC)
Signature

Référence de publication: 2010156667/14.
(100180831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137120

L

U X E M B O U R G

Carillon Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 78.221.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Référence de publication: 2010156617/10.
(100180651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Chang An S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 17, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010156620/10.
(100181016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: USD 570.479.088,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 145.810.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Lu-

xembourg S.C.S.”, a Luxembourg “société en commandite simple”, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B 145.810, incorporated by a deed held under private seal on 24 March 2009, published in the “Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations” (“Mémorial C”) number 947 dated 6 May 2009, and whose articles of association have been
lastly amended by a deed held under private seal on 30 April 2010, published in the Mémorial C number 1014 dated 14
May 2010, pages 48665 (the “Company”).

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at

5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Miss Sophie HENRYON, private employee, with professional address at 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg and the meeting elects as scrutineer Miss Claudia
ROUCKERT private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy
of Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain here annexed to be
registered with the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 569,925,088 (five hundred sixty-nine million nine hundred twenty-five

thousand eighty-eight) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing
the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 554,000 (five hundred fifty-four thousand United

States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 569,925,088 (five hundred sixty-nine million nine hundred
twenty-five thousand eighty-eight United States Dollars) to USD 570,479,088 (five hundred seventy million four hundred
seventy-nine thousand eighty-eight United States Dollars) by the issue of (i) 520,760 (five hundred twenty thousand seven
hundred sixty) new limited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, (ii) 27,700 (twenty-

137121

L

U X E M B O U R G

seven thousand seven hundred) new non-voting preferred limited shares, with a nominal value of USD 1 (one United
States Dollar) each and (iii) 5,540 (five thousand five hundred forty) new unlimited shares, with a nominal value of USD
1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 4,988,800 (four
million nine hundred eighty-eight thousand eight hundred United States Dollars);

3. Subscription and payment by the contributors of all (i) the new limited shares, (ii) the new unlimited shares and (iii)

the new non-voting preferred limited shares by way of contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is unanimously resolved that the shareholders of the Company waive their right to the prior notice of the current

meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agree to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the relevant documentation
has been put at the disposal of the shareholders of the Company within a sufficient period of time in order to allow them
to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 554,000 (five hundred

fifty-four thousand United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 569,925,088 (five hundred
sixty-nine million nine hundred twenty-five thousand eighty-eight United States Dollars) to USD 570,479,088 (five hundred
seventy million four hundred seventy-nine thousand eighty-eight United States Dollars) by the issue of (i) 520,760 (five
hundred twenty thousand seven hundred sixty) new limited shares, with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar) each (the "New Limited Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 4,689,472
(four million six hundred eighty-nine thousand four hundred seventy-two United States Dollars) (the "First Share Pre-
mium"), (ii) 5,540 (five thousand five hundred forty) new unlimited shares, with a nominal value of USD 1 (one United
States Dollar) each (the "New Unlimited Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD
49,888 (forty-nine thousand eight hundred eighty-eight United States Dollars) (the "Second Share Premium"), and (iii)
27,700 (twenty-seven thousand seven hundred) new non-voting preferred limited shares with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar) each (the "New Non-Voting Preferred Limited Shares"), and together with the New Limited
Shares and the New Unlimited Shares, the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting
to USD 249,440 (two hundred forty-nine thousand four hundred forty United States Dollars) (the "Third Share Premium",
and together with the First Share Premium and the Second Share Premium, the “Share Premiums”), the whole to be fully
paid up through contributions in kind consisting of the Contributed Shares 1 and Contributed Shares 2 (as such terms
are defined hereafter) respectively held by Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited (the "Contributor 1") and Abbott
Holding (Gibraltar) Limited (the "Contributor 2"), and together with the Contributor 1, the "Contributors"), both com-
panies organized under the laws of Gibraltar, having their registered office at 10/8 International Commercial Centre,
Casemates Square, Gibraltar.

<i>Third resolution:

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Contributors of the New Shares and the

payment of the Share Premiums through the contribution in kind as described below.

<i>Intervention - Subscription - Payment

(a) Thereupon intervenes the Contributor 1, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by

virtue of a proxy given under private seal, here annexed, who declares to subscribe the New Unlimited Shares.

The issue of the New Unlimited Shares is also subject to the payment of the Second Share Premium. The New Unlimited

Shares, as well as the Second Share Premium, have been fully paid up by the Contributor 1 through a contribution in kind
consisting of the Contributed Shares 1.

(b) Thereupon intervenes the Contributor 2, here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by

virtue of a proxy given under private seal, here annexed, who declares to subscribe the New Limited Shares and the New
Non-Voting Preferred Limited Shares.

The issue of the New Limited Shares and the New Non-Voting Preferred Limited Shares is also subject to the payment

of the First Share Premium and the Third Share Premium. The New Limited Shares and the New Non-Voting Preferred
Limited Shares, as well as the First Share Premium and the Third Share Premium, have been fully paid up by the Contributor
2 through a contribution in kind consisting of the Contributed Shares 2, which is now at the disposal of the Company.

137122

L

U X E M B O U R G

<i>Description of the contribution

The contributions made by the Contributors (the “Contributions”) in exchange for the issuance of the New Shares

and the payment of the Share Premiums, represents:

- 25 shares having a nominal value of LTL 100 (one hundred Lithuanian Litas) each, issued by UAB Abbott Laboratories,

a limited liability company incorporated under the laws of Lithuania, having its registered office at Zalgirio g. 92, Vilnius,
Lithuania, registered with the Register of Legal Entities under number 302252348 (“Abbott Lithuania”), and representing
1% (one percent) of the entire subscribed share capital of Abbott Lithuania (the “Contributed Shares 1”);

- 2,475 shares having a nominal value of LTL 100 (one hundred Lithuanian Litas) each, issued by Abbott Lithuania and

representing 99% (ninety-nine percent) of the entire subscribed share capital of Abbott Lithuania (the “Contributed Shares
2”).

<i>Valuation

The net value of the Contribution amounts to EUR 4,000,000 (four million Euro), which is the equivalent of USD

5,542,800 (five million five hundred forty-two thousand eight hundred United States Dollars) pursuant to the EUR/USD
exchange rate of 1.3857 provided by the European Central Bank on 28 October 2010.

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 29 October 2010, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution's existence

A proof of the Contributions has been given to the Company.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervene:
a) Mr. AJ Shoultz, manager of the Company, residing at 1115 Acorn Trail, Lake Forest, IL 60045, United States of

America; and

b) Mrs. Kimberly Deloian, manager of the Company, residing at 18340 South Christine Court, Mokena, IL 60448,

United States of America;

all represented by Mrs. Sofia Aonfos-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement

of contribution value established on 29 October 2010.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contributions, expressly agree with the description of these Contributions, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

- Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited: 5,704,789 (five million seven hundred four thousand seven hundred

eighty-nine) unlimited shares; and

- Abbott Holding (Gibraltar) Limited: (i) 536,262,267 (five hundred thirty-six million two hundred sixty-two thousand

two hundred sixty-seven) limited shares and (ii) 28,512,032 (twenty-eight million five hundred twelve thousand thirty-
two) non-voting preferred limited shares.

The notary acts that (i) the 5,704,789 (five million seven hundred four thousand seven hundred eighty-nine) unlimited

shares, (ii) the 536,262,267 (five hundred thirty-six million two hundred sixty-two thousand two hundred sixty-seven)
limited shares and (iii) the 28,512,032 (twenty-eight million five hundred twelve thousand thirty-two) non-voting preferred
limited shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it

is unanimously resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read
as follows:

“ Art. 8. The issued share capital is fixed at USD 570,479,088 (five hundred seventy million four hundred seventy-nine

thousand eighty-eight United States Dollars) represented by (a) 541,967,056 (five hundred forty-one million nine hundred
sixty-seven thousand fifty-six) issued ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each,
divided into (i) 5,704,789 (five million seven hundred four thousand seven hundred eighty-nine) unlimited shares for
Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited (the "Unlimited Shares"), the unlimited shareholder ("commandité"), (ii)
536,262,267 (five hundred thirty-six million two hundred sixtytwo thousand two hundred sixty-seven) limited shares for
Abbott Holding (Gibraltar) Limited, the limited shareholder ("commanditaire") (the "Limited Shares") and together with

137123

L

U X E M B O U R G

the Unlimited Shares, the "Ordinary Shares") and (b) 28,512,032 (twenty-eight million five hundred twelve thousand thirty-
two) Non-Voting Shares (as such term is defined below).”

No other amendment is to be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about three thousand three hundred euro (€
3,300.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof,  the  present  notary  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translattion. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited

Luxembourg S.C.S.», une société en commandite simple, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social sis au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.810, constituée par acte notarié tenu sous seing privé le 24 mars
2009, publié au “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” («Mémorial C») numéro 947 du 6 mai 2009, et dont
les statuts ont été modifiées par un acte tenu sous seing privé du 30 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1014 du
14 mai 2010, pages 48665 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse profession-

nelle  au  5,  rue  Zénon  Bernard,  L-4030  Esch-sur-Alzette,  Grand  Duché  de  Luxembourg  et  l'assemblée  élit  comme
scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur la liste de

présence. Cette liste et les procurations, signées par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

II.- Que les 569.925.088 (cinq cent soixante-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille quatre-vingt-huit) parts sociales de

la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la
Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour
sur lesquels les associés reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Renonciation au droit de convocation;
2.- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 554.000 USD (cinq cent cinquante-quatre mille Dollars

américains) afin de le porter de son montant actuel de 569.925.088 USD (cinq cent soixante-neuf millions neuf cent vingt-
cinq mille quatre-vingt-huit Dollars américains) à 570.479.088 USD (cinq cent soixante-dix millions quatre cent soixante-
dix-neuf mille quatre-vingt-huit Dollars américains) par l'émission de (i) 520.760 (cinq cent vingt mille sept cent soixante)
nouvelles parts sociales de commanditaire d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, (ii) 27.700
(vingt-sept mille sept cents) nouvelles parts sociales de commanditaire sans droit de vote préférentiel d'une valeur no-
minale de 1 USD (un Dollar américain) chacune et (iii) 5.540 (cinq mille cinq cent quarante) nouvelles parts sociales de
commandité d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émis-
sion d'un montant total de 4.988.800 USD (quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cents Dollars américains);

3.- Souscription et paiement par les associés de toutes (i) les nouvelles parts sociales de commanditaire, (ii) les nouvelles

parts sociales de commandité et (iii) les nouvelles parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote par voie
d'apport en nature;

4.- Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5.- Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter cette action; et

137124

L

U X E M B O U R G

6.- Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé unanimement que les associés de la Société renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable

afférente à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent avoir
été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du
jour. Il est en outre décidé unanimement que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des
associés de la Société dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Second résolution:

Il est décidé unanimement d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 554.000 USD (cinq cent cin-

quante-quatre mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 569.925.088 USD (cinq cent soixante-
neuf millions neuf cent vingt-cinq mille quatre-vingt-huit Dollars américains) à un montant de 570.479.088 USD (cinq cent
soixante-dix millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-huit Dollars américains) par l'émission de (i) 520.760
(cinq cent vingt mille sept cent soixante) nouvelles parts sociales de commanditaire d'une valeur nominale de 1 USD (un
Dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts de Commanditaire»), moyennant le paiement d'une prime d'émission
globale d'un montant de 4.689.472 USD (quatre millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-douze
Dollars américains) (la «Première Prime d'Emission»), (ii) 5.540 (cinq mille cinq cent quarante) parts sociales de com-
mandité  d'une  valeur  nominale  de  1  USD  (un  Dollar  américain)  chacune  (les  «Nouvelles  Parts  de  Commandité»),
moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 49.888 USD (quarante-neuf mille huit cent quatre-
vingt-huit Dollars américains) (la «Seconde Prime d'Emission»), et (iii) 27.700 (vingt-sept mille sept cents) nouvelles parts
sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune
(les  «Nouvelles  Parts  Privilégiées  de  Commanditaire  Sans  Droit  de  Vote»,  et  ensemble  avec  les  Nouvelles  Parts  de
Commanditaire et les Nouvelles Parts de Commandité, les «Nouvelles Parts»), moyennant le paiement d'une prime
d'émission globale dont le montant s'élève à USD 249.440 (deux cent quarante-neuf mille quatre cent quarante Dollars
américains)  (la  «Troisième  Prime  d'Emission»,  et  ensemble  avec  la  Première  Prime  d'Emission  et  la  Seconde  Prime
d'Emission, les «Primes d'Emission»), lesquelles ont été totalement payées par des apports en nature consistant en les
Parts Apportées 1 et les Parts Apportées 2 (tels que ces termes seront définis ci-dessous) respectivement détenues par
Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited (l'«Apporteur 1») et Abbott Holding (Gibraltar) Limited (l'«Apporteur 2»,
et ensemble avec l'Apporteur 1, les «Apporteurs»), deux sociétés constituées selon les lois de Gibraltar, ayant leur siège
social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar.

<i>Troisième résolution:

Il est décidé unanimement d'accepter la souscription et le paiement par les Apporteurs des Nouvelles Parts et des

Primes d'Emission par voie des apports en nature tel que décrits ci-dessous.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

(a)  Intervient  ensuite  l'Apporteur  1,  ici  représenté  par  Mme  Sofia  Afonso-Da  Chao,  prénommée,  en  vertu  d'une

procuration donnée sous seing privé, ci annexée, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts de Commandité.

L'émission des Nouvelles Parts de Commandité est également sujette au paiement de la Seconde Prime d'Emission.

Les Nouvelles Parts de commandité, ainsi que la Seconde Prime d'Emission, ont été entièrement payées par l'Apporteur
1 par voie d'un apport en nature constitué des Parts Apportées 1.

(b)  Intervient  ensuite  l'Apporteur  2,  ici  représenté  par  Mme  Sofia  Afonso-Da  Chao,  prénommée,  en  vertu  d'une

procuration donnée sous seing privé, ci-annexée, qui déclare souscrire les Nouvelles Parts de Commanditaire et les
Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote.

L'émission des Nouvelles Parts de Commanditaire et les Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit

de Vote est également sujette au paiement de la Première Prime d'Emission et de la Troisième Prime d'Emission. Les
Nouvelles Parts de Commanditaire et les Nouvelles Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote, ainsi que
la Première Prime d'Emission et la Troisième Prime d'Emission, ont été entièrement payées par l'Apporteur 2 par voie
d'un apport en nature constitué des Parts Apportées 2, qui est désormais à la disposition de la société.

<i>Description de l'apport

Les apports réalisés par les Apporteurs (les «Apports»), en échange de l'émission des Nouvelles Parts et du paiement

des Primes d'Emission, sont composés:

- 25 parts sociales d'une valeur nominale de 100 LTL (cent litai) chacune, émises par UAB Abbott Laboratories, une

société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Lituanie, ayant son siège social à Zalgirio g.92, Vilnius, Lituanie,
inscrite au Register of Legal Entities sous le numéro 302252348 («Abbott Lituanie»), et représentant 1% (un pourcent)
du capital social souscrit de Abbott Lituanie (les «Parts Apportées 1»);

- 2.475 parts sociales d'une valeur nominale de 100 LTL (cent litai) chacune, émises par Abbott Lituanie et représentant

99% (quatre-vingt-dix-neuf pourcent) du capital social souscrit de Abbott Lituanie (les «Parts Apportées 2»).

137125

L

U X E M B O U R G

<i>Evaluation

La valeur nette totale des Apports s'élève à 4.000.000 EUR (quatre millions euros), soit l'équivalent de 5.542.800 USD

(cinq millions cinq cent quarante-deux mille huit cents Dollars américains) en fonction du taux de change EUR/USD de
1,3857 fourni par la Banque Centrale Européenne le 28 octobre 2010.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur des apports en

date du 29 octobre 2010, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence des Apports

Preuve de l'existence des Apports a été donnée à la Société.

<i>Intervention des gérants

Interviennent ensuite:
a) M. AJ Shoultz, gérant de la Société, résidant au 1115, Acorn Trail, Lake Forest, IL 60045, Etats-Unis d'Amérique; et
b) Mme Kimberly Deloian, gérant de la Société, résidant à 18340 South Christine Court, Mokena, IL 600448, Etats-

Unis d'Amérique;

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration

de valeur d'apport établie le 29 octobre 2010.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison des Apports, acceptent expressément la description de ces Apports, avec leur évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes la participation au capital social de la Société est désormais

composée:

- Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited.: 5.704.789 (cinq millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-

neuf) parts sociales de commandité;

- Abbott Holding (Gibraltar) Limited.: (i) 536.262.267 (cinq cent trente-six millions deux cent soixante-deux mille deux

cent soixante-sept) parts sociales de commanditaire et (ii) 28.512.032 (vingt-huit millions cinq cent douze mille trente-
deux) parts sociales privilégiées de commanditaire sans droit de vote.

Le notaire établit que (i) les 5.704.789 (cinq millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf) parts sociales

de commandité, (ii) les 536.262.267 (cinq cent trente-six millions deux cent soixante-deux mille deux cent soixante-sept)
parts sociales de commanditaire et (iii) les 28.512.032 (vingt-huit millions cinq cent douze mille trente-deux) parts sociales
privilégiées de commanditaire sans droit de vote, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées
de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et les Apports décrits ci-dessus étant totalement réalisés,

il est décidé unanimement de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la
teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social est fixé à 570.479.088 USD (cinq cent soixante-dix millions quatre cent soixante-dix-neuf

mille quatre-vingt-huit Dollars américains) représenté par (a) 541.967.056 (cinq cent quarante-et-un millions neuf cent
soixante-sept mille cinquante-six) parts sociales émises d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune,
elles-mêmes divisées en (i) 5.704.789 (cinq millions sept cent quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de
commandité  pour  Abbott  Holding  Subsidiary  (Gibraltar)  Limited  (les  «Parts  de  Commandité»),  le  commandité,  (ii)
536.262.267 (cinq cent trente-six millions deux cent soixante-deux mille deux cent soixante-sept) parts sociales de com-
manditaire pour Abbott Holding (Gibraltar) Limited le commanditaire (les «Parts de Commanditaire») et ensemble avec
les Parts de Commandité, (les «Parts Ordinaires») et (b) 28.512.032 (vingt-huit millions cinq cent douze mille trente-
deux)

les Parts Privilégiées de Commanditaire Sans Droit de Vote (telles que définies précédemment).»
Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ trois mille trois cents euros (€ 3.300,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

137126

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13508. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010157254/319.
(100181314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

CIGOGNE Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 101.547.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Référence de publication: 2010156621/10.
(100181186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

LTH Lighting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8386 Koerich, 3, rue Arsène Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 155.209.

L'an deux mille dix, le quinze novembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Laurent THOLL, commerçant, demeurant à F-08110 Messincourt, 26, rue Basse, représentant l’intégralité

du capital social de la société à responsabilité limitée LTH LIGHTING S.à r.l , ayant son siège social à 69, rue de Hobscheid,
L-8422 Steinfort,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date 23 août 2010, publié au Mémorial C numéro 2166

du 13 octobre 2010, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155209,
a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Le siège social est transféré de son adresse actuelle vers 3, rue Arsène Mersch, L-8386 Koerich et modifie en consé-

quence le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura la teneur suivante:

« Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la Société est établi dans la Commune de Koerich.»

<i>Déclaration du comparant

Le comparant déclare au nom et pour compte du bénéficiaire réel que l’avoir social de la société à transformer ne

constitue pas un produit d’activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blan-
chiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 750,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-

ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. THOLL; P.DECKER
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 novembre 2010. Relation: LAC/2010/50419. Reçu 75.-€ ( soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

137127

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157441/36.
(100181835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Erdmann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 20.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010156660/12.
(100180628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Clemenceau Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156622/9.
(100180779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Cobelfret Waterways S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 92.721.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A-M. Grieder / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010156626/11.
(100181039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

CEP II Stahl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 111.504.

DISSOLUTION

In the year two thousand and ten on the twenty-seventh day of October.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- CEP II Participations S.à r.l. SICAR, a Luxembourg private limited liability company incorporated and existing under

the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 96.017
and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

here represented by Ms Fatima Lahmer, employee, having their professional address at 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, by virtue of one proxy given on October 26 

th

 , 2010,

The said proxy, signed “ne varietur” by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities. Such appearing party, through its proxy holder, has requested
the undersigned notary to state that:

I.- The appearing party is the sole shareholder of “CEP II Stahl S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company,

having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade

137128

L

U X E M B O U R G

and Companies Register under number B 111.504 (the “Company”), and whose deed of incorporation was enacted by
Maître Joseph Elvinger, notary in Luxembourg, on September 19, 2005, and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 254 as of February 4, 2006, which bylaws have been last amended pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, notary in Luxembourg, dated December 21, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 462 dated March 27, 2007.

II.- The Company’s share capital is presently fixed at one million twelve thousand and five hundred Euro (€ 1,012,500.-)

represented by forty thousand five hundred (40,500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€ 25.-) each, all of
the shares held by the sole shareholder CEP II Participations S.à r.l. SICAR, prenamed.

The share capital is thus fully represented and all decisions shall be validly taken.
III.- The appearing party declares to have full knowledge and understanding of the bylaws and of the financial situation

of the Company.

IV.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution of the Company, with immediate effect.

V.- The appearing party declares that the activity of the Company has ceased; all assets of the Company are transferred

to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those actually
unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

VI.- The appearing party declares that the shareholder’s register of the dissolved Company has been cancelled.
VII.- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for their mandate as of

today.

VIII.- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

registered office of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the presents are estimated at approximately one thousand euro (€ 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof The present notarised deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by their

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille dix, le vingt-sept octobre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg),

A comparu:

- CEP II Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.017

ici représentée par Melle Fatima Lahmer, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg, vertu d’une en procuration donnée le 26 octobre 2010;

Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

pour être enregistrée au registre.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I.- La comparante est l’associé unique de “CEP II Stahl S.à r.l.”,une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.504 (la «Société»), constituée suivant acte du Maître
Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg, instrumentant reçu en date du 19 septembre 2005, et, publié au Mémorial C
numéro 254 du 4 février 2006, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire à Luxembourg, en date du 21 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 462 le 27 mars 2007.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à un million douze mille cinq cents Euro (€ 1,012.500.-) représenté

par quarante mille cinq cents (40.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25.-) chacune, toutes
détenues par l’associé unique CEP II Participations S.à r.l. SICAR, suscitée.

Le capital social est par conséquent intégralement représenté et toutes décisions peuvent être valablement prises.

137129

L

U X E M B O U R G

III.- La comparante déclare avoir parfaite connaissance et compréhension des statuts et de la situation financière de la

Société.

IV.-  La  comparante,  en  sa  qualité  d’associé  unique  de  la  Société,  déclare  expressément  procéder  à  sa  dissolution

anticipée avec effet immédiat.

V.- La comparante déclare que l’activité de la Société a cessé; l’associé unique est investi de tout l’actif et il répondra

personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l’heure actuelle; que la liquidation de la Société
a été effectuée aux droits de la partie et est achevée.

VI.- La comparante déclare qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.
VII.- L’associé unique décharge pleinement et entièrement les gérants de la Société dissoute pour l'exécution de leur

mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- La comparante déclare que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au

siège social de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’environ mille euros (€ 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par leur nom et prénom, état

et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Lahmer, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 novembre 2010. Relation: EAC/2010/13222. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010156619/105.
(100180538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Human Capital Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 30.107.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 3 novembre 2010

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission en date du 20 mai 2010 de la société G.S.L. FIDUCIAIRE, S.A R.L.,

ayant son siège social au 37, Rue Romain Fandel L-4149 Esch-sur-Alzette, de son poste de Commissaire et il nomme en
remplacement du Commissaire démissionnaire, la société H.R.T. REVISION S.A.., ayant son siège social au 23, Val Fleuri,
L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous la section B-51238.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission en date du 3 novembre 2010 de M. Julien DIDIERJEAN de son poste

d'Administrateur.

Il nomme en remplacement de l'Administrateur démissionnaire, M. Philippe RICHELLE, demeurant professionnelle-

ment au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2011.

Signatures.

Référence de publication: 2010157705/19.
(100181183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137130

L

U X E M B O U R G

Coginvest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 37.294.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18/11/2010 à Luxembourg

L'Assemblée prend acte du décès de Monsieur Jacques Tordoor et décide de nommer en tant qu'administrateur et

président du conseil d'administration Monsieur Jean-Louis ANDREUX, né le 20 novembre 1952 à Namur (Belgique) et
demeurant avenue Molière 315 à B-1180 Bruxelles; son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire
à tenir en 2014

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010156627/15.
(100180862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Lancaster Coinvestors A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 143.157.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 1 

er

 Novembre 2010, a décidé d'accepter:

- La démission de Christophe Cahuzac comme gérant de la Société avec effet immédiat au 2 aôut 2010.
- La nomination avec effet immédiat au 2 aôut 2010 de Nicole Götz, née à Brackenheim (Germany) le 4 juin 1967, et

résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

- La démission de Gerard Meijssen comme gérant de la Société avec effet immédiat au 1 

er

 novembre 2010.

- La nomination avec effet immédiat au 1 

er

 novembre 2010 de Fabrice Hablot, né à Brest (France) le 23 mars 1978,

et résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 1 

er

 novembre 2010, composé comme suit:

- Nicole GÖTZ, Manager
- Michael FURTH, Manager
- Véronique MENARD, Manager
- Maxime NINO, Manager
- Fabrice HABLOT, Manager

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Maxime Nino
<i>Gérant

Référence de publication: 2010157040/25.
(100179937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 111.801.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

<i>des actionnaires de la Société tenue en date du 5 novembre 2010

En date du 5 novembre 2010, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCooopers en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec

effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

137131

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Fidji Luxco (BC)
Signature

Référence de publication: 2010156666/16.
(100180610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

ColPlay S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 102.656.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010156628/10.
(100181257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

ColPlay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 102.656.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Signature.

Référence de publication: 2010156629/10.
(100181258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Hudson Euro Co. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 72.175.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010156696/14.
(100180837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

WAT Editions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 156.938.

STATUTS

L’an deux mille dix, le quinze novembre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Paule KIÉNERT, employée privée, née le 8 mai 1983 à Nancy (F), demeurant à L-2561 Luxembourg, 97,

rue de Strasbourg;

2. Madame Maria PIETRANGELI, gérante, née le 12 octobre 1961 à Hayange (F), demeurant à L-7248 Béreldange, 8,

rue Michel Rodange;

3. Madame Patricia SCIOTTI, employée privée, née le 17 décembre 1966 à Hayange (F), demeurant à L-1726 Luxem-

bourg, 45, rue Pierre Hentges

137132

L

U X E M B O U R G

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuelles des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, ainsi que l’édition d’imprimés, ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de «WAT Editions S.à.r.l.».

Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune d’un commun accord entre associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représentée par cent (100)

parts sociales, d’une valeur de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés laquelle fixe la durée de leur

mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum par les associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-àvis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements pris par lui ( eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Libération des parts sociales

Les cent (100) parts ont été souscrites comme suit:

1.- Mme Paule KIÉNERT, préqualifiée, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.- Mme Maria PIETRANGELI, préqualifiée, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3.- Mme Patricia SCIOTTI , préqualifiée, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.

137133

L

U X E M B O U R G

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2011. Frais Le montant des frais,

rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce doit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en
raison de sa constitution, s’élève à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social se considérant comme dûment convoquées,

se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommée gérante pour une durée indéterminée: Mme Paule KIÉNERT, préqualifiée.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

<i>Déclaration

Les comparantes déclarent en qualité de bénéficiaires économiques que les fonds servant à la libération du capital ne

proviennent pas, respectivement que l’objet de la société à constituer ne servira pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. KIÉNERT, M. PIETRANGELI, P. SCIOTTI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 novembre 2010. Relation: LAC/2010/51835. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Référence de publication: 2010158259/92.
(100182139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2010.

Copine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 15.480.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2010156630/10.
(100180636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Desifaldi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 58.934.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010156634/11.
(100180993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

137134

L

U X E M B O U R G

Rosenzweig Immobilien AG SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 156.932.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzehn, am zwanzigsten September.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Ana Maria FARIA MARQUES, Kauffrau, wohnhaft zu L-6933 Mensdorf, 17A, rue de Roodt-sur-Syre.

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: Rosenzweig Immobilien AG SARL.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Promotion und die Konstruktion von Immobilien.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer  Natur  tätigen,  die  mittelbar  oder  unmittelbar  mit  dem  Hauptzweck  in  Zusammenhang  stehen  oder  zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Esch-sur-Alzette.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (12.500,- €) und ist in HUN-

DERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (125,- €) eingeteilt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. An Drittpersonen dürfen die Anteile nur abgetreten

werden nachdem sie vorher per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung den verbleibenden Gesellschaftern zur Über-
nahme angeboten wurden zum Wert wie er sich aus der letzten Bilanz ergibt und diese dieses Angebot nicht angenommen
haben innerhalb von zwei (2) Monaten nach obengenannter Inkenntnissetzung.

Im Fall einer Annahme des Angebots durch die verbleibenden Gesellschafter geschieht dies im Verhältnis zur Anzahl

der schon durch sie gehaltenen Gesellschaftsanteile. Verzichtet ein Gesellschafter auf sein Vorkaufsrecht, so geht letzteres
auf die anderen Gesellschafter über im Verhältnis zur Anzahl der schon durch sie gehaltenen Anteile. Für den Fall daß
Anteile von Todes wegen an einen Nichtgesellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder Nachkommen,
übergegangen sind, so ist letzterer verpflichtet sie innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ableben des vorherigen Besitzers
den übrigen Gesellschaftern unter Einhaltung obengenannter Prozedur zur Übernahme anzubieten.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse  durch  die  Generalversammlung  festgesetzt  werden  und  die  zu  jeder  Zeit  durch  letztere  abberufen  werden
können, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Gesell-

schaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesellschaft
anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden wie
sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:

- fünf (5%) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10%) vom

Hundert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einpersonengesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der Gene-

ralversammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.

137135

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Die Komparentin, Ana Maria FARIA MARQUES, vorgenannt, erklärt die wirklich Berechtigte des eingezahlten Gesell-

schaftskapitals zu sein, welche Gelder aus keiner Straftat entstammen.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien

auf SIEBEN HUNDERT EURO (700,- €) abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) Ana Maria FARIA MARQUES, hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT

EURO (12.500,- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2010.

<i>Generalversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
2) Wird zum Geschäftsführer ernannt:
Ana Maria FARIA MARQUES, Kauffrau, wohnhaft zu L-6933 Mensdorf, 17A, rue de Roodt-sur-Syre.
3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4011 Esch-sur-Alzette, 127, rue de l'Alzette.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparentin auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, nach Vorlesung an die Komparentin, hat dieselbe gegenwärtige

Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: FARIA MARQUES, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 4 octobre 2010. REM/2010/1295. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Mondorf-les-Bains, le 29 novembre 2010.

Référence de publication: 2010157510/87.
(100182048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 111.801.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 386 du 22 février 2006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fidji Luxco (BC)
Signature

Référence de publication: 2010156665/13.
(100180584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

137136


Document Outline

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S.

Abira Holding S.A.

Advent Key Investor &amp; Cy S.C.A.

Augur Financial Holding V S.A.

Berlisa International S.A.

Bessel Re S.à.r.l.

BFO Group International S.A.

Biosystem

Bosquet, S.à r.l.

BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg

British Cars Luxembourg

British Cars Luxembourg

Calidris 28 AG

Calidris 28 AG

Calidris 28 EU S.à r.l.

Capital Pierre S.A.

Captain North Sea Finance Limited

Carillon Holding S.A.

Carta Capital Investments II S.à r.l.

Cartainvest II S.A.

CEP II Stahl S.à r.l.

Chang An S.à r.l.

Cheyne Special Situations Investments S.à r.l.

CIGOGNE Management S.A.

City Parking Group Holdings S.A.

Clearwire Europe S.à r.l.

Clemenceau Participations S.A.

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.

Cobelfret Luxembourg Car Carriers S.A.

Cobelfret Waterways S.A.

Coginvest S.A.

ColPlay S.à r.l.

ColPlay S.à r.l.

Compagnie de Réassurance Akzo Nobel S.A.

Copine S.à r.l.

Cube Properties S.àr.l.

Desifaldi S.A.

DIF Luxembourg S.à r.l.

Erdmann S.A.

Fidji Luxco (BC)

Fidji Luxco (BC)

Fidji Luxco (BC)

GSMP 2006 Onshore S.à r.l.

Hotel Gestion S.à r.l.

Hudson Euro Co. S.à.r.l.

Human Capital Group S.A.

Lancaster Coinvestors A S.à r.l.

Lexsis S.A.

LTH Lighting S.à r.l.

Luxgsm S.A.

Novator Properties S.à r.l.

RCG Re III S.A.

Rosenzweig Immobilien AG SARL

UniCredit Luxembourg S.A.

Vegan Society Luxemburg

W2005/W2007 Vernal Holding 1 Luxembourg

WAT Editions S.à r.l.