logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2683

7 décembre 2010

SOMMAIRE

Advent Green Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

128766

Alder Consultancy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

128738

b+ architectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128784

Carring Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128770

Eclaircie s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128738

Efin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128745

Euro Participations et Investissements S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128746

Europa Services Belux S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

128738

Eventus Management Partners S.A.  . . . . .

128747

Eventus Management Partners S.A.  . . . . .

128746

Fareale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128746

Fidji Luxco (BC) Commandite  . . . . . . . . . .

128765

Filtilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128747

Finlyinx S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128747

Finlyinx S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128749

Florakerk Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

128748

Fondation pour la Promotion du Tennis au

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128748

Fumolux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128750

Geam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128750

Gestion - Investissement - Promotion S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128750

Giolin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128750

Gogo Holding International S.A. . . . . . . . . .

128764

Goldenstein & Goldenstein S.A.  . . . . . . . . .

128765

Grid Architectes S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

128765

GSCP VI Lux Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

128766

GS Lux Debt Holdings II S.à r.l.  . . . . . . . . .

128765

GS Lux Debt Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

128766

Gymika S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128767

Gymika S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128766

H.C.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128770

Horizon Tours S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128783

Ideo Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128784

Ilix Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128784

Jardinier-Paysagiste Lemmer S.à r.l.  . . . . .

128769

JLD Activities S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128770

Jose Manuel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128771

King Cheetah Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . .

128770

Klynveld Peat Marwick Goerdeler  . . . . . . .

128774

KPMG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128775

LFS Property Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

128784

LSF Gennecab Investments S.à r.l. . . . . . . .

128747

LSF PlattenB Investments  . . . . . . . . . . . . . .

128749

LuxCo 126 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128775

Macete S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128776

Madeco Decors S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128746

Magepar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128776

Marigny Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .

128776

Metec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128783

Misys Overseas Investments S.à r.l.  . . . . . .

128775

Onea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128751

Riva Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128768

Saldanha S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128780

Silverfleet Sixth Investment Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128779

Solid Rock SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128777

Sonterra Finance S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

128779

Spaqui S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128771

Trilon (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

128751

TVA Trade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128780

TV Vertical S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128780

Ulysses Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

128783

Ulysses Participation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

128783

Upton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128783

WPP Luxembourg Beta Three S.à r.l.  . . .

128776

128737

L

U X E M B O U R G

Europa Services Belux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Centre Le 2000.

R.C.S. Luxembourg B 139.686.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010146294/9.
(100167938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Eclaircie s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 121.861.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ECLAIRCIE S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2010146296/13.
(100167876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Alder Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.519.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth day of October,
Before us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

Stonewall Securities S.à r.l, a limited liability company qualifying as a securitisation company (société de titrisation)

within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation (the Securitisation Act 2004),
with its registered office at 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company
Register under number 148570 acting on behalf of its Compartment 2 and its Compartment 3,

here represented by Mr. Roel Schrijen, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,

by virtue of a power of attorney, given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Alder

Consultancy S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the development and the sale of innovative product ideas

to any third parties in Luxembourg or abroad, without being involved in the implementation of such products, and to the
exclusion of any activity that would fall within the scope of the Luxembourg act dated 5 April 1993 relating to the financial
sector, as amended, and require a license (agrément) from the Luxembourg Ministry of Treasury and Budget.

The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of, and may acquire or

hold, participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg and foreign
companies and may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the administration, management, control
and development of those participations. The Company may make any other form of investment and acquire by purchase,
subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise securities of any kind.

The Company may lend funds and give assistance to companies in which it holds a direct or indirect participation or

which form part of the same group of companies as the Company. The Company may also pledge, transfer, encumber
or otherwise create security over some or all of its assets to that end. The Company may give guarantee and grant security
in favour of third parties or subsidiaries and/or affiliates of the Company to secure its obligations and the obligations of

128738

L

U X E M B O U R G

companies  in  which  the  Company  holds  a  direct  or  indirect  participation  or  which  form  part  of  the  same  group  of
companies as the Company.

The Company may, for so long as it is necessary to facilitate the performance of its corporate objects, borrow in any

form (except by issuing securities by way of public offer) and enter into any type of loan agreement. It may issue, exclusively,
by way of private placement, any kind of debt securities such as notes, bonds (including Genussrechte and Genussscheine),
debentures, certificates, shares, warrants and any kind of equity securities.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to
facilitate the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally use any techniques and
instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques
and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the sole manager or of the board of managers of the Company taken in accordance with article 12 below.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

euro) represented by 100 (one hundred) shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro)
per share each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an
end.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in

all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

128739

L

U X E M B O U R G

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his power for specific tasks to one or

several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.

128740

L

U X E M B O U R G

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by an internal auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. A
statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69
(2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and
financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

Stonewall Securities S.à r.l, acting on behalf of its Compartment 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 (fifty) shares

Stonewall Securities S.à r.l, acting on behalf of its Compartment 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 (fifty) shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 (one hundred) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred

Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2010.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand euros (EUR 1,000).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 2 (two). The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

Mr Thomas Baumgartner, manager, whose private address is at 20, Rue du Genêt, L-8023 Strassen, Luxembourg.
Mr Sebastian Müller, manager, whose private address is at Finkenhofstraße 32, 60322 Frankfurt am Main, Germany.
2. The registered office is established at 43, Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Le notaire instrumentant a rendu la partie comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Sennigerberg date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove

mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzehn, am fünfundzwanzigsten Oktober.
Vor Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitze zu Niederanven.

IST ERSCHIENEN:

128741

L

U X E M B O U R G

Stonewall Securities S.à r.l, eine in Luxembourg eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche die Form

einer Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Verbriefungsgesetzes vom 22. März 2004 (das Ver-
briefungsgesetz)  angenommen  hat  und  dessen  Regelungen  und  Bestimmungen  unterliegt,  mit  Gesellschaftssitz  in  43,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, eingetragen im Luxemburgischen Handelsregister unter Num-
mer B148570,

vertreten durch Herrn Roel Schrijen, mit Berufsanschrift in 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg aufgrund

einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten

Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht der Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die er hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung "Alder Consultancy S.à r.l.", (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und den Verkauf von innovativen Produktideen

an Dritte in Luxemburg und im Ausland, ohne sich jedoch an der Ausführung dieser Produkte zu beteiligen und mit
Ausnahme von jeglicher Tätigkeit, die unter das luxemburgische Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor fallen
und eine Lizenz (agrément) von dem luxemburgischen Ministerium für Finanzen und Haushalt erfordern würde.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mittelbar und unmittelbar im Bezug stehen zur Erschaffung und

Erwerb von Beteiligungen, unter jeglicher Form, in jeglichen Handels-, Industrie- oder Finanzgesellschaft oder andere
Gesellschaft in Luxemburg und im Ausland sowie alle Transaktionen, die mittelbar und unmittelbar in Verbindung zur
Verwaltung, Management, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen stehen. Die Gesellschaft kann auf jeglicher
anderer Weise investieren und durch Ankauf, Zeichnung und auf andere Art sowie durch Übertragung durch Veräusse-
rung, Tausch oder auf andere Weise, sich jegliche Wertpapiere anschaffen.

Weiter kann die Gesellschaft Darlehen gewähren und Gesellschaften unterstützen, in denen sie eine mittelbare und

unmittelbare  Beteiligung  besitzt  oder  die  derselben  Unternehmensgruppe  angehören.  Auch  kann  die  Gesellschaft,  in
diesem Zusammenhang, all oder Teil ihres Vermögens verpfänden, veräussern, belegen oder damit Bürgschaft leisten. Die
Gesellschaft darf Garantien begeben an und Bürgschaft leisten zugunsten Dritter oder Tochtergesellschaften und/oder
Zweiggesellschaften, um ihre eigenen Verbindlichkeiten sowie die Verbindlichkeiten von Gesellschaften in denen sie eine
mittelbare und unmittelbare Beteiligung besitzt oder die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu sichern.

Die Gesellschaft kann, solange es die Durchführung ihres Zwecks unterstützt, Kredite jeder Art aufnehmen (mit Aus-

nahme von einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren) und Darlehensverträge jeglicher Art unterschreiben. Sie kann,
ausschliesslich über den Weg von Privatplazierung, jede Art von Schuldtitel, wie z.B. Schuldinstrumente, Schuldverschrei-
bungen  (einschliesslich  Genussrechte  und  Genusscheine),  Privatschuldverschreibungen,  Zertifikate,  Anteile,  Options-
cheine und jegliche Art von Bürgschaften ausgeben.

Die Gesellschaft kann Swap-Transaktionen, Terminkontrakte, Termingeschäfte, Derivativgeschäfte, Optionen, Rück-

kaufsrechte, Anleihen und vergleichbare Kontrakte durchführen und ausgeben, solange diese Verträge und Geschäfte
notwendigerweise der Durchführung des gesellschaftlichen Zwecks dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Investment-
methoden  und  –Instrumente  zum  Zweck  einer  effizienten  Investmentverwaltung  nutzen,  einschliesslich  aber  nicht
beschränkt auf Investmentmethoden und –Instrumente, die derart gestaltet sind, um die Gesellschaft vor Kreditausfällen,
Währungsschwankungen, Zinsrisiken und andere Risiken zu schützen.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art ausführen, die der Verwirkli-

chung des Gesellschaftszweckes dienen.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung gemäß
Artikel 12 verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), darge-

stellt von 100 (einhundert) Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 125 (einhundertfünfundzwanzig Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

128742

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Ge-
schäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach
Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die  Gesellschafterversammlung  kann  jederzeit  den  Geschäftsführer,  oder  wenn  mehrere  Geschäftsführer  bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich
aus diesem Artikel nichts anderes ergibt.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-

tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seineBefugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten und die Ver-
gütung  des  Bevollmächtigten  (wenn  das  Mandat  vergütet  wird),  die  Dauer  der  Bevollmächtigung  und  alle  anderen
relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

128743

L

U X E M B O U R G

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  erschienen;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden  oder  vertretenen  Geschäftsführern,  im  Falle  einer  von  einem  Vorsitzenden  geleiteten  Sitzung  von  diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern ver-

abschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten; die Änderung des Gesellschafts-
status (d.h. der Nationalität der Gesellschaft) kann nur einstimmig beschlossen werden, soweit nicht das Gesetz von 1915
etwas anderes zulässt.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung

nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
eine Zwischendividende auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft nur einen Wirt-

schaftsprüfer  (commissaire  aux  comptes)  ernennen,  wenn  sie  mehr  als  25  (fünfundzwanzig)  Gesellschafter  hat.  Ein
unabhängiger zugelassener Abschlussprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach

128744

L

U X E M B O U R G

Artikel 69 (2) des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 zum Handels- und Firmenregister sowie zur Buchhaltung und den
Jahreskonten der Unternehmen keine Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Stonewall Securities S.à r.l, handelnd für Compartment 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 (fünfzig) Anteile

Stonewall Securities S.à r.l, handelnd für Compartment 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 (fünfzig) Anteile

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: 100 (einhundert) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)

ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2010.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr EUR 1.000 (eintausend Euro).

<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete

Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 2 (zwei) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte

Zeit ernannt:

Herr Thomas Baumgartner, Manager, dessen Privatanschrift wie folgt lautet: Rue du Genêt, L-8023 Strassen, Gross-

herzogtum Luxemburg Herr Sebastian Müller, Manager, dessen Privatanschrift wie folgt lautet: Finkenhofstraße 32, 60322
Frankfurt am Main, Germany.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 43, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grossherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Der Notar hat den Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was den Erschienenen ausdrücklich anerkennen.

Worüber, die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Senningerberg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte des Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Roel Schrijen, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 27 octobre 2010. LAC / 2010 / 47175. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 4. November 2010.

Référence de publication: 2010148910/410.
(100171264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.

Efin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 145.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

128745

L

U X E M B O U R G

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2010146297/11.
(100167753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Euro Participations et Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 41.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146298/10.
(100167328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Eventus Management Partners S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 76.815.

En date du 22 octobre 2010, Maître Sabrina MARTIN, demeurant à L-2520 LUXEMBOURG, 21-25, Allée Scheffer, a

mis fin, avec effet immédiat, à la convention de domiciliation conclue en date du 1 

er

 avril 2005 avec la société EVENTUS

MANAGEMENT PARTNERS S.A., avec siège social à L-1230 LUXEMBOURG, 5, rue Jean Bertels, R.C. Luxembourg B
76815.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2010.

Sabrina MARTIN

Référence de publication: 2010146299/13.
(100167847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Fareale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 89.378.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Norbert SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010146301/11.
(100167761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Madeco Decors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 227, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 25.632.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 28 octobre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- Madeco Decors S.à.r.l., avec siège social à L-3515 Dudelange, 227, route de Luxembourg, de fait inconnue à cette

adresse,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge, et liquidateur Maître Nicolas BERNAR-

DY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 19 novembre 2010 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

128746

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Me Nicolas BERNARDY
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010146352/20.
(100167702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Eventus Management Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Berthels.

R.C.S. Luxembourg B 76.815.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146300/10.
(100167850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Filtilux S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 41.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146302/10.
(100167382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Finlyinx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010146303/9.
(100167806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

LSF Gennecab Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 111.963.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 29 octobre 2010, enregistré à Luxembourg AC, le 3 novembre 2010, LAC/2010/48135, aux droits de soixante-
quinze euros (75,- EUR), que la société LSF Gennecab Investments S.à r.l., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg,
7, rue Robert Stümper, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 111.963, constituée selon
acte du notaire Maître Martine Schaeffer, remplaçant de Maître André Schwachtgen, en date du 10 novembre 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 366 du 18 février 2006, modifié en dernier lieu par un acte de
Maître André Schwachtgen en date du 26 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
652 du 19 avril 2007,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et autres documents de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la

publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations,
Mémorial C, à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

128747

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Référence de publication: 2010147226/23.
(100168713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Florakerk Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 35.690.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 28 octobre 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme FLORAKERK
HOLDING S.A., dont le siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, a été dénoncé en date du 27 mars 2007,

Pour extrait conforme
Me Nicolas BERNARDY
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010146305/13.
(100167697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Fondation pour la Promotion du Tennis au Luxembourg, Fondation.

Siège social: Esch-sur-Alzette,

R.C.S. Luxembourg G 81.

<i>Bilan au 31 décembre 2008 (en EUR)

ACTIF

Notes

31.12.2008

EUR

31.12.2007

EUR

C. ACTIF IMMOBILISE
II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

1 705 432,49 1 883 195,90

D. ACTIF CIRCULANT
II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4)

16 112,47

12 139,17

IV. Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5)

18 764,66

15 464,58

34 877,13

27 603,75

E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

1 740 309,62 1 910 799,65

PASSIF
A. CAPITAUX PROPRES
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 478,94

2 478,94

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-313 086,75 -378 024,86

VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 373,81

64 938,11

VII. Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(6)

1 685 444,91 1 844 151,40

VIII. Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134 949,42

134 949,42

1 524 160,33 1 668 493,01

C. DETTES
1. Dettes envers les établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7)

203 749,10

214 229,83

2. Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 518,42

7 462,93

3. Dettes fiscales et au titre de la Sécurité Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(8)

881,77

750,72

4. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9)

0,00

19 863,16

216 149,29

242 306,64

1 740 309,62 1 910 799,65

<i>Compte de Profits et Pertes du 1 

<i>er

<i> janvier au 31 décembre 2008

A. CHARGES

Notes

2008

EUR

12 mois

2007

EUR

15 mois

2. b) Autres charges externes

(10)

73 856,93 121 497,51

3. Frais de personnel

(11)

40 916,80

44 415,26

128748

L

U X E M B O U R G

4. Corrections de valeur sur éléments de l'actif

(12)

19 056,92

19 056,92

7. Intérêts et charges assimilées

(13)

15 445,97

19 253,47

13. Bénéfice de l'exercice

14 373,81

64 938,11

163 650,43 269161,27

B. PRODUITS
2. Montant net du chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(14)

38 903,00

36 527,80

4. Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(15)

122 500,00 232 623,00

7. Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(16)

101,84

10,47

9. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(17)

2 145,59

0,00

163 650,43 269 161,27

<i>Budget 2009

Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000,00

Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.500,00
Subventions extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,00

Total produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162.500,00

Charges d'exploitation
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -75.000,00
Frais personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -45.000,00
Correct. de valeur sur frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20.000,00
Total charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-140.000,00

Résultat d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.500,00

Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15.000,00

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.500,00

Esch/Alzette le 19 janvier 2009.

Thill Francois / Dahm Francois
<i>Trésorier / Secrétaire

Référence de publication: 2010146306/66.
(100167279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Finlyinx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010146304/9.
(100167809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

LSF PlattenB Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 88.665.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 29 octobre 2010, enregistré à Luxembourg AC, le 3 novembre 2010, LAC/2010/48136, aux droits de soixante-
quinze euros (75,- EUR), que la société LSF PlattenB Investments S.à r.l., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7,
rue Robert Stümper, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 88.665, constituée selon
acte du notaire Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 19 juillet 2002, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1478 du 12 octobre 2002, modifié en dernier lieu par un acte de Maître Martine
Schaeffer, en date du 27 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 530 du 11 mars
2010,

a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.

128749

L

U X E M B O U R G

Les livres et autres documents de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la

publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations,
Mémorial C, à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Référence de publication: 2010147228/23.
(100168715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Fumolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5328 Contern, Bruechermillen.

R.C.S. Luxembourg B 115.091.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146308/10.
(100167555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Geam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.422.

Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010146309/9.
(100167800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Gestion - Investissement - Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 41, boulevard du Général Patton.

R.C.S. Luxembourg B 103.100.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gestion-Investissement-Promotion S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2010146310/12.
(100167868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Giolin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 82.475.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

<i>Pour la société
GIOLIN S.A.
BANQUE BPP S.A.
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2010146311/14.
(100167799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

128750

L

U X E M B O U R G

Onea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 130.986.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 19 mai 2010:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Com-

missaire sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

Mr Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg,

Administrateur et Président;

Mr Rémy MENEGUZ, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, Admi-

nistrateur

Mr Frédéric NOEL, Avocat, avec adresse professionnelle au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Administrateur.

<i>Commissaire:

Fiduciaire MEVEA S.à r.l. établie au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg.
pour une période de trois ans.
Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ONEA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010147266/23.
(100168655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Trilon (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 491.164.710,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 100.461.

In the year two thousand and ten on the twenty-ninth day of October
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Trilon Luxembourg Branch, represented by Trilon Bancorp Inc., a company, organised under the laws of Ontario,

having its registered office at 181, Bay Street, Brookfield Place, CDN-M5J 2T3 Toronto, Ontario, Canada, registered with
the Trade Register of Canada under the number 1665334 (Trilon Bancorp Inc.),

in its capacity as sole partner of Trilon (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 100.461, incorporated pursuant
to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on April 21, 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, on June 18, 2004, number 630 (the Company), which articles of association of the
Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of notary Joseph Elvinger, on July 30,
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on October 5, 2010, number 2080,

here represented by Me Hana Witzke, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Luxembourg on October 29, 2010. Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary
and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose
of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Trilon Luxembourg Branch represented by Trilon Bancorp Inc. is the sole partner (the Sole Partner) of the Company;
II. The Company’s share capital is presently set at four hundred ninety-one million one hundred sixty-four thousand

seven hundred and ten US dollars (USD 491,164,710.-) represented by sixteen million three hundred seventy-two thou-
sand one hundred and fifty-seven (16,372,157) shares, each having a par value of thirty US dollars (USD 30.-);

III. The agenda is as follows:
1. Change of the accounting year of the Company from August 1 to July 31 to July 1 to June 30 of each year;

128751

L

U X E M B O U R G

2. Creation of classes of shares in the share capital of the Company namely (i) ordinary shares (the Ordinary Shares)

and (ii) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS) all having a nominal value of thirty US dollars (USD 30.-)
each, which will have such rights and features as set out in the articles of association of the Company (the Articles);

3. To requalify the sixteen million three hundred seventy-two thousand one hundred and fifty-seven (16,372,157)

existing shares in the share capital of the Company into Ordinary Shares and to convert seven million one hundred
seventy-seven thousand seven hundred and ninety-eight (7,177,798) of the Ordinary Shares into MRPS;

4. Subsequent full restatement of the Articles in order to reflect the creation of the Ordinary Shares and MRPS adopted

under item 2 and 3;

5. Increase of the share capital of the Company by an amount of twelve million seven hundred thirty-seven thousand

one hundred and thirty US dollars (USD 12,737,130.-) so as to raise it from its present amount of four hundred ninety-
one million one hundred sixty-four thousand seven hundred and ten US dollars (USD 491,164,710.-) consisting of nine
million one hundred nnety-four thousand three hundred and fiftynine (9,194,359) Ordinary Shares and seven million one
hundred seventy-seven thousand seven hundred and ninety-eight (7,177,798) MRPS to five hundred three million nine
hundred one thousand eight hundred and forty US dollars (USD 503,901,840.-) by the creation and issue of four hundred
twenty-four thousand five hundred and seventy-one (424,571) MRPS with a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each;

6. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 5. above;
7. Subsequent amendment and restatement of article 8 of the Articles in order to reflect the increase of the share

capital adopted under item 5. above;

8. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company and any employee of AIB Administrative Services Luxembourg S.àr.l. to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;
and

9. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner resolves to change the accounting year of the Company which currently begins on August 1 and ends

on July 31 to July 1 to June 30 of each year with effect as of the date of the present deed.

Subsequently, a transitory accounting year shall start on August 1, 2010 and shall terminate on June 30, 2011.

<i>Second resolution

The Sole Partner resolves to create classes of shares in the share capital of the Company namely
(i) ordinary shares (the Ordinary Shares) and (ii) mandatory redeemable preferred shares (the MRPS) all having a par

value of thirty US dollars (USD 30.-) each, which will have such rights and features as set out in the Articles.

<i>Third resolution

The Sole Partner resolves to:
(a) requalify the existing sixteen million three hundred seventy-two thousand one hundred and fifty-seven (16,372,157)

shares in the share capital of the Company as Ordinary Shares, and

(b) to convert seven million one hundred seventy-seven thousand seven hundred and ninety-eight (7,177,798) of the

Ordinary Shares into MRPS, with the rights and features as set out in the Articles.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above and in order to reflect the above resolutions and to set forth the rights and features

of the MRPS, the Sole Partner resolves to fully restate the Articles as follows and has thus requested the undersigned
notary to enact the following amendment and full restatement of the Articles:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies, of September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended,

and the present articles of incorporation.

Art. 2. The Company’s name is "Trilon (Luxembourg) S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in

128752

L

U X E M B O U R G

particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31 

st

 , 1929, on Holding

Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to

require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

II. Capital - Shares

Art. 8. The share capital is set at four hundred ninety-one million one hundred sixty-four thousand seven hundred and

ten US dollars (USD 491,164,710.-), represented by nine million one hundred nnety-four thousand three hundred and
fifty-nine (9,194,359) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each and
seven million one hundred seventy-seven thousand seven hundred and ninety-eight (7,177,798) mandatory redeemable
preferred shares (the “MRPS”), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each, all in registered form, all subscribed
and fully paid-up. The MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter referred to individually as a "Share" and collectively
as the "Shares”. The Ordinary Shares and the MRPS shall constitute separate classes of shares in the Company. The MRPS
shall have preferred dividend and preferred liquidation rights vis-à-vis the Ordinary Shares subject to the terms and
conditions described hereafter.

The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the partners, acting in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The partners may decide to create reserves
and/or share premium accounts which may be connected to classes of Shares as set out above.

The holders of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if

any) paid for the subscription of Ordinary Shares. The holders of MRPS will be exclusively entitled to any and all rights
attached to the share premium (if any) paid for the subscription of MRPS.

All MRPS are issued in the form of redeemable shares and the redemption of the MRPS can only be made by means

of sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary
reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or proceeds of a new issue made for the
redemption purpose and through extraordinary general meeting of partners. The MRPS will be redeemed pursuant to
the following terms and conditions:

(i) in any circumstances whatsoever, the Company shall redeem all of the MRPS then in issue upon expiry of a thirteen

(13) years period from the date on which the MRPS are issued (the “Final Mandatory Redemption Date”);

(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holders of MRPS may

request by prior written notice to redeem all or part of the MRPS through and subject to the approval by the extraordinary
general meeting of partners; and

(iii) the redemption price of the MRPS to be redeemed will be equal to the par value of the redeemed MRPS increased

by the share premium (if any) attached to the MRPS and that is attributable to the MRPS so redeemed plus any accrued
and undeclared dividends (if any).

128753

L

U X E M B O U R G

Redeemed  MRPS  will  be  cancelled  forthwith  after  redemption  and  through  the  extraordinary  general  meeting  of

partners resolving on such redemption.

All MRPS are issued in the form of convertible Shares into Ordinary Shares. MRPS may be converted pursuant to the

following terms and conditions:

(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of MRPS may at any time before such date,

request (in one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of the MRPS to the fair market
value equivalent of the Ordinary Shares equal to the relevant MRPS par value, attached share premium and any declared
and unpaid dividends (if any), subject to the approval by the extraordinary general meeting of partners; and

(ii) the number of Shares to be issued through extraordinary general meeting of shareholders upon such conversion

of MRPS into Ordinary Shares will be equal to the number of Shares converted in the relevant MRPS. The share premium
(if any) attached to the converted MRPS and that is attributable to the MRPS so converted will be allocated to the share
premium of the Ordinary Shares or to the share premium of the relevant MRPS.

The MRPS shall confer upon the holder(s) thereof as a class the right, in priority to the payment of dividends to the

holder(s) of Ordinary Shares to receive out of the profits of the Company available for distribution by way of dividend a
fixed cumulative preferential cash dividend (hereinafter called the MRPS Preferred Dividend), of 0.01% of the subscription
price paid by the relevant holder per MRPS (being the par value of each MRPS increased by the MRPS share premium
paid for each MRPS) (the MRPS Subscription Price), which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year.
The holder(s) of the MRPS shall not be entitled to participate in the distribution of dividends (if any) paid in excess of the
MRPS Preferred Dividend. [No dividend, whether in cash or kind, shall be paid or declared, nor shall any other distribution
be made (i) on the Ordinary Shares until any accrued MRPS Preferred Dividend shall have been declared and paid in full].

In case of dissolution of the Company, the holder of MRPS will rank junior to all debts incurred by the Company but

will rank senior to the holder of Ordinary Shares as set forth in article 20 below.

Art. 9. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.
Shares are freely transferable among the partners.
Where the Company has a sole partner, Shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one partner, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to the

prior approval of the partners representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

A register of partners is kept at the registered office and may be examined by each partner upon request.
The Company may redeem its own Shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

III. Management

Art. 10. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by
- the signature of any two managers for any transactions or dealings up to an amount of USD 20,000.-(twenty thousand

US Dollars)

- the signature of all the managers for any transactions of dealings above to an amount of USD 20,000.-(twenty thousand

US Dollars).

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that all managers be present or

represented. In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the unanimous vote of the managers
present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

128754

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 12. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

IV. Partners decisions

Art. 13. Partner's decisions are taken by partner's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partner's number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions

to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 14. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of partners

representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second

meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the partners.

V. Financial year - Balance sheet

Art. 15. The Company’s financial year begins on July 1 

st

 and closes on June 30 

th

 .

Art. 16. Each year, as of the 30 

th

 of June, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of partners together with the balance sheet.

Art. 17. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The partners determine how the balance of the annual net profits is allocated. They may allocate such balance to the

payment of a dividend and in particular the dividend referred to in article 8 above, transfer such balance to a reserve
account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

Interim dividends may be distributed, at any time, subject to article 8 and under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the managers;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the partners within two (2) months from the date

of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the partners must

refund the excess to the Company.

128755

L

U X E M B O U R G

VI. Winding-up - Liquidation

Art. 19. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the partners, adopted with the consent of a

majority (in number) of partners owning at least three-quarters of the share capital. The partners appoint one or several
liquidators, who need not be partners, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the partners, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the
liabilities of the Company.

The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities will be paid as follow:
(i) firstly, in repayment to the holder(s) of the MRPS (if any such shares are then outstanding) of the MRPS Preferential

Liquidation Right (as defined hereafter), such payment to be made on an equal per share basis, and

(ii) secondly, after payment in full of the MRPS Preferential Liquidation Right, the holder(s) of the Ordinary Shares (if

any such shares are then outstanding) shall be entitled to be paid the remainder of the surplus, such payment to be made
on an equal per share basis among the Ordinary Shares.

If the surplus available for distribution among the shareholders is insufficient to make payment of the MRPS Preferential

Liquidation Right in full to all holders of the MRPS, then such a surplus shall be distributed among the holder(s) of the
MRPS, ratably in proportion to the full amounts to which they would otherwise be respectively entitled.

VII. Applicable law

Art. 20. The laws here above mentioned in article 1 

st

 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Fifth resolution

The Sole Partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twelve million seven hundred

thirty-seven thousand one hundred and thirty US dollars (USD 12,737,130.-) so as to raise it from its present amount of
four hundred ninety-one million one hundred sixty-four thousand seven hundred and ten US dollars (USD 491,164,710.-)
consisting of nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine (9,194,359) Ordinary Shares
and seven million one hundred seventy-seven thousand seven hundred and ninety-eight (7,177,798) MRPS to five hundred
three million nine hundred one thousand eight hundred and forty US dollars (USD 503,901,840.-) by the creation and
issue of four hundred twenty-four thousand five hundred and seventy-one (424,571) MRPS with a par value of thirty US
dollars (USD 30.-) each.

<i>Intervention / Subscription payment

Thereupon, Trilon Luxembourg Branch represented by Trilon Bancorp Inc. declares to subscribe to four hundred

twenty-four thousand five hundred and seventy-one (424,571) MRPS with a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each,
and to fully pay them up by:

1. an aggregate amount of four hundred nine million nine hundred thirty two thousand nine hundred and twenty-five

US dollars (USD 409,932,925.-) which will be taken out of the Ordinary Shares capital account of the Company, which
will be split for the purpose of the allocation and/or reallocation to the MRPS premium account and MRPS reserve account
as follows:

(i)  two  hundred  fifteen  million  three  hundred  thirty-three  thousand  nine  hundred  and  forty  US  dollars  (USD

215,333,940.-) will be taken out of the Ordinary Shares share capital account;

(ii) an amount of one hundred two million five hundred ninety thousand four hundred and forty-four US dollars (USD

102,590,444.-) will be taken out of the Ordinary Shares share premium account;

(iii) an amount of twenty-one million five hundred thirty-three thousand three hundred and ninety-six US dollars (USD

21,533,396.-) will be taken out of the Ordinary Shares legal reserve account; and

(iv) an amount of seventy million four hundred and seventy-five million one hundred and forty-five US dollars (USD

70,475,145.-) will be taken out of the Ordinary Shares other available reserves;

as stated in the interim accounts of the Company dated October 29, 2010.
2. thereto and following the allocation and/or reallocation as above mentioned, an amount of one hundred ninety-four

million five hundred ninety-eight thousand nine hundred and eighty-five US dollars (USD 194,598,985.-) to be allocated
as follows:

(i) an amount of ten million one hundred twenty-nine thousand one hundred and forty US dollars (USD 10,129,140.-)

to the MRPS share capital account of the Company;

(ii) an amount of one hundred sixty-one million nine hundred twenty-three thousand five hundred and thirty-seven

US dollars (USD 161,923,537.-) to the MRPS share premium account of the Company stapled to the MRPS; and

(iii)  an  amount  of  twenty-two  million  five  hundred  forty-six  thousand  three  hundred  and  eight  US  dollars  (USD

22,546,308.-) to the MRPS legal reserve account of the Company.

Consequently, the three hundred thirty seven thousand six hundred and thirty-eight (337,638) MRPS have been duly

issued.

128756

L

U X E M B O U R G

2. a contribution in kind to the Company consisting of a receivable amounting to two hundred sixty million and eight

hundred thousand US dollars (USD 260,800,000) (the Receivable) to be allocated as follows:

(i) an amount of two million six hundred and seven thousand nine hundred and ninety US dollars (USD 2,607,990) to

the MRPS share capital account of the Company;

(ii) an amount of two hundred fifty-seven million nine hundred thirty-one thousand two hundred and ten US dollars

(USD 257,931,210) to the MRPS share premium account of the Company stapled to the MRPS; and

(iii) an amount of two hundred sixty thousand and eight hundred US dollars (USD 260,800.-) to the MRPS legal reserve

account of the Company.

It further results from a certificate issued on October 29, 2010 by the management of the Sole Partner and the Company

(the Certificate) that:

- the Sole Partner is the legal and beneficial owner of the Receivable.
- the Sole Partner is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable.
- The Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment.

- There exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that the Receivable be transferred to him.

- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,

the Receivable is freely transferable.

- All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the

Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind.

- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the

Company, as the case may be, have been obtained [or, in the case of the Sole Partner will be obtained in a manner
permitted by the laws of the jurisdiction.

- Based on US GAAP, the value of the Receivable is at least equal to two hundred sixty million and eight hundred

thousand US dollars (USD 260,800,000) as shown by the balance sheet of Trilon Luxembourg Branch represented by
Trilon Bancorp Inc. dated October 29, 2010 and since such valuation no material changes have occurred which would
have depreciated the contribution made to the Company.

Such Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and restate article 8 of the Articles in order to reflect the capital increase,

so that it reads henceforth as follows:

“ Art. 8. The share capital is set at five hundred three million nine hundred one thousand eight hundred and forty US

dollars (USD 503,901,840.-), represented by nine million one hundred ninety-four thousand three hundred and fifty-nine
(9,194,359) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each and seven
million six hundred two thousand three hundred and sixty-nine (7,602,369) mandatory redeemable preferred shares (the
“MRPS”), having a par value of thirty US dollars (USD 30.-) each, all in registered form, all subscribed and fully paid-up.
The MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter referred to individually as a "Share" and collectively as the "Shares”.
The Ordinary Shares and the MRPS shall constitute separate classes of shares in the Company. The MRPS shall have
preferred dividend and preferred liquidation rights vis-à-vis the Ordinary Shares subject to the terms and conditions
described hereafter. […/…]”

<i>Seventh resolution

The Sole Partner resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company and any employee of AIB Administrative Services Lu-
xembourg S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately ten thousand Euros.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREUPON the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

128757

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an dix mille dix, le quinzième jour d’octobre,
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Trilon Luxembourg Branch, représentée par Trilon Bancorp Inc., une société régie par les lois de l’Ontario, dont le

siège social se situe au 181, Bay Street, Brookfield Place, CDN-M5J 2T3 Toronto, Ontario, Canada, immatriculée au
Registre de Commerce du Canada sous le numéro 1665334 (Trilon Bancorp Inc.),

en sa qualité d’associé unique de Trilon (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limité de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.461, constituée le 21 avril 2004 suivant acte du notaire instrumentant,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 630 du 18 juin 2004 (la Société), dont les
statuts (les Statuts) ont été modifié pour la dernière fois le 30 juillet 2010 suivant acte du notaire instrumentant, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2080 du 5 octobre 2010,

représentée par Hana Witzke, Rechtsanwältin, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourg le 29 octobre 2010.

Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire de la partie

comparante, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Trilon Luxembourg Branch, représenté part Trilon Bancorp Inc., est l’associé unique (l’Associé Unique) de la Société;
II. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatre-vingt onze millions cent soixante-quatre mille sept cent

dix dollars américains (USD 491.164.710) représenté seize millions trois cent soixante douze mille cent cinquante-sept
(16.372.157) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30);

III. L’ordre du jour est le suivant:
1. Changement de l’exercice social de la Société commençant au 1 

er

 août et se terminant au 31 juillet pour que celui-

ci commence le 1 

er

 juillet et se termine le 30 juin de chaque année;

2. Création de classes de parts sociales dans le capital sociale de la Société, à savoir (i) des parts sociales ordinaires

(les Parts Sociales Ordinaires) et (ii) des parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les PSPOR), ayant une
valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels que définis
dans les statuts de la Société (les Statuts);

3. Requalification seize millions trois cent soixante douze mille cent cinquante-sept (16.372.157) part sociales existantes

dans le capital social de la Société en Parts Sociales Ordinaires et conversion de sept millions cent soixante dix-sept mille
sept cent quatre-vingt dix huit (7.177.798) Parts Sociales Ordinaires en PSPOR;

4. Refonte complète subséquente des Statut afin d’y refléter notamment la création des Parts Sociales Ordinaires et

des PSPOR adoptée aux points 2. et 3. ci-dessus;

5. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de douze millions sept cent trente-sept mille cent trente

dollars américains (12.737.130) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt onze millions cent
soixante-quatre mille sept cent dix dollars américains (USD 491.164.710) consistant en neuf millions cent quatre-vingt
quatorze mille trois cent cinquante-neuf (9.194.359) Parts Sociales Ordinaires et sept millions cent soixante dix-sept mille
sept cent quatre-vingt dix huit PSPOR à cinq cent trois millions neuf cent un mille huit cent quarente dollars américains
(USD 503.901.840) par la création et l’émission de quatre cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-onze (424,571)
PSPOR ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30);

6. Souscription et libération de l’augmentation de capital social tel qu’indiqué au point 5. ci-dessus;
7. Modification subséquente et refonte de l’article 8 des Statuts afin d’y refléter l’augmentation de capital social adoptée

au point 5. ci-dessus;

6. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout employé de AIB Administrative Services Luxembourg S.à r.l. pour
procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société; et

7. Divers.
Maintenant, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire instrumentant à acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de changer l’exercice social de la Société qui actuellement commence le 1 

er

 août et se termine

le 31 juillet pour que celui-ci commence le 1 

er

 juillet et se termine le 30 juin de chaque année avec effet immédiat.

128758

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de créer des classes de parts sociales dans le capital sociale de la Société, à savoir (i) des parts

sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et (ii) des parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les
PSPOR), ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune, qui auront les droits et caractéristiques
tels que définis dans les statuts de la Société (les Statuts).

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de:
a. requalifier seize millions trois cent soixante douze mille cent cinquante-sept (16.372.157) parts sociales dans le capital

social de la Société en Parts Sociales Ordinaires; et

b. convertir sept millions cent soixante dix-sept mille sept cent quatre-vingt dix huit (7.177.798) Parts Sociales Ordi-

naries en PSPOR, avec les mêmes droits et obligation, qui auront les droits et caractéristiques tels que définis dans les
Statuts.

<i>Quatrième résoution

Comme  conséquence  ce  que  qui  précède  et  afin  de  refléter  les  résolutions  ci-dessus  et  déterminer  les  droits  et

caractéristiques des PSPOR, l’Associé Unique décide de refondre entièrement les Statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est ici constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les

lois luxembourgoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du
18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est "Trilon (Luxembourg) S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger. Au cas où la gérance estimerait

que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale
au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents,
il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la
connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

128759

L

U X E M B O U R G

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 491.164.710 USD ( quatre cent quatre-vingt onze million cent soixante quatre mille

sept cent dix USD) divisé en 9.194.359 (neuf millions cent quatre-vingt quatorze mille trois cent cinquante-neuf) parts
sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars américains)
chacune et 7.177.798 (sept millions cent soixante dix-sept mille sept cent quatre-vingt dix huit) parts sociales préféren-
tielles  obligatoirement  rachetables  (les  «PSPOR»),  ayant  une  valeur  nominale  de  USD  30  (trente  dollars  américains)
chacune, toutes sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées. Les PSPOR et les Parts Sociales Or-
dinaires sont ci-après désignées individuellement comme une «Part Sociale» et collectivement comme les «Parts Sociales».
Les Parts Sociales Ordinaires et les PSPOR constitueront des catégories séparées de parts sociales dans la Société. Les
PSPOR auont des dividendes préférentiels et des droits de liquidation préférentiels vis-à-vis des Parts Sociales Ordinaires,
sujet aux termes et condition décrites ci-après.

Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Les associés peuvent décider de créer des réserves et/ou des comptes de prime d’émission qui seront rattachés aux

classes des Parts Sociales définies ci-dessus.

Les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront exclusivement tous les droits quels qu’ils soient rattachés à la

prime d’émission (le cas échéant) payée pour la souscription des Parts Sociales Ordinaires. Les détenteurs des PSPOR
auront exclusivement tous les droits quels qu’ils soient rattachés à la prime d’émission (le cas échéant) payée pour la
souscription des PSPOR.

Toutes les PSPOR sont émises sous forme de parts sociales rachetables et le rachat des PSPOR pourra uniquement

se faire au moyen de sommes disponibles à la distribution en vertu de l’Article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, en ce
compris la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la Société comme prime d’émission) ou le produit d’une
nouvelle émission effectuée pour les fins de rachat et par assemblée générale extraordinaire des associés. Les PSPOR
seront rachetées selon les modalités suivantes:

(i) quelques soient les circonstances, la Société rachètera toutes les PSPOR alors en circulation à l’expiration d’une

période de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les PSPOR ont été émises (la «Date Ultime de Rachat Obliga-
toire»);

(ii) Nonobstant la Date Ultime de Rachat Obligatoire et à tout moment avant cette Date, les détenteurs de PSPOR

peuvent demander par avis écrit préalable à racheter toutes ou une partie des PSPOR en et sous réserve de l’approbation
de l’assemblée générale extraordinaire; et

(iii) Le prix de rachat des PSPOR sera égal à la valeur nominale des PSPOR rachetées augmenté de la prime d’émission

(s’il y en a) rattachée aux PSPOR et attribuable aux PSPOR ainsi rachetées plus tous dividendes cumulés mais non déclarés
(le cas échéant).

Les  PSPOR  rachetées  seront  immédiatement  annulée  après  le  rachat  par  l’assemblée  générale  extraordinaire  des

associés qui a décidé ce rachat.

Toutes les PSPOR sont émises sous la forme de parts sociales convertibles en Parts Sociales Ordinaires. Les PSPOR

peuvent être converties selon les modalités suivantes:

(i) nonobstant la Date Ultime de Rachat Obligatoire, le détenteur de PSPOR peut à tout moment avant cette date,

demander (en une ou plusieurs occasions) par écrit de convertir en Parts Sociales Ordinaires toutes ou une partie des
PSPOR à la valeur marchande équivalente des Parts Sociales Ordinaires égale à la valeur nominale des PSPOR en question,
la prime d’émission rattachée et les dividendes déclarés mais non payés (le cas échéant) sous réserve de l’approbation
par l’assemblée générale extraordinaire des associés; et

(ii) le nombre de Parts Sociales à émettre par assemblée générale extraordinaire des associés pour cette conversion

de PSPOR en Parts Sociales Ordinaires sera égale au nombre de Parts Sociales converties en PSPOR. La prime d’émission
(le cas échéant) rattachée aux PSPOR converties et qui est attribuable aux PSPOR ainsi converties sera affectée à la prime
d’émission des Parts Sociales Ordinaires ou à la prime d’émission des PSPOR concernées.

Les PSPOR conféreront sur leur(s) détenteur(s) comme une catégorie le droit, prioritairement au paiement de divi-

dendes au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires, de recevoir hors des bénéfices de la Société disponibles pour
distribution, par dividende en numéraire préférentiel cumulatif fixe (ci-après dénomé lse Dividendes Préférentiels PSPOR),
de 0,01 % du prix de souscription payé by le détenteur concerné par PSPOR (étant la valeur nominale et chaque PSPOR
augmentée par la prime d’émission PSPOR payé pour chaque PSPOR) (le Prix de Souscription PSPOR), qui sera journa-
lièrement cumulé et calculé sur 365 jours par an. Le(s) détenteur(s) des PSPOR n’auront pas droit de participer à la
distribution de dividendes (s’il y en a) payés en supplément des Dividendes Préférentiels PSPOR. [Aucun dividende, qu’il
soit en numéraire ou en nature, ne sera payé ou déclaré, et aucune autre distribution ne sera faite (i) sur les Parts Sociales
Ordinaires jusqu’à ce que tous les dividendes Préférentiels PSPOR aient été déclarés et entièrement payé.

En cas de dissolution de la Société, les détenteurs de PSPOR auront un rang inférieur à toutes les dettes de la Société

mais auront un rang supérieur aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires tel que défini à l’article 20 ci-dessous.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.

128760

L

U X E M B O U R G

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes

à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par:
- la signature conjointe de deux gérants pour toutes transactions d’un montant inférieur ou égal à USD 20.000 (vingt

mille dollars américains);

- la signature de tous les gérants pour toutes transactions d’un montant supérieur à USD 20.000 (vingt mille dollars

américains).

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si tous les gérants sont

présents ou représentés.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées par le vote unanime des gérants présents ou repré-

sentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 12. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 14. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

128761

L

U X E M B O U R G

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'exercice social commence le 1 

er

 juillet et se termine le 30 juin.

Art. 16. Chaque année, avec effet au 30 juin, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes de(s) gérant(s) envers la société. Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui
sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 17. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d'une obligation légale ou statutaire. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions
suivantes:

a. des comptes intérimaires sont établis par les gérants;
b. ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la
réserve légale;

c. la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

d. les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
e. si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,

les associés doivent reverser l’excédent à la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en

nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liqui-
dateurs,  qui  n’ont  pas  besoin  d’être  associés,  pour  réaliser  la  liquidation  et  déterminent  leur  nombre,  pouvoirs  et
rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les actifs et payer les dettes de la Société. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes
est distribué comme suit:

(i) premièrement, en repaiement au(x) détenteur(s) des PSPOR (si de telles parts sociales existent toujours) de leur

Droit de Boni Préférentiel PSPOR (tel que défini ci-après), un tel paiement devant être fait sur une base proportionnelle
par part sociale; et

(ii) deuxièmement, après paiement entier du Droit de Boni Préférentiel PSPOR, le(s) détenteur(s) des Parts Sociales

Ordinaires (si de telles parts sociales existent toujours) auront le droit d’être payé avec l’excédent restant, un tel paiement
devant être fait sur une base proportionnelle par part sociale parmi les Parts Sociales Ordinaires.

Loi applicable

Art. 20. Les lois mentionnées à l’article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

128762

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résoution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de de douze millions sept cent trente-

sept mille cent trente dollars américains (USD 12.737.130) afin de porter le capital social de son montant actuel de quatre
cent quatre-vingt onze millions cent soixante-quatre mille sept cent dix dollars américains (USD 491.164.710) représenté
par neuf millions cent quatre-vingt quatorze mille trois cent cinquante-neuf (9.194.359) Parts Sociales Ordinaires et sept
millions cent soixante dix-sept mille sept cent quatre-vingt dix huit (7.177.798) PSPOR, à cinq cent trois millions neuf
cent un mille huit cent quarente dollars américains (USD 503.901.840) par la création et l’émission de quatre cent vingt-
quatre mille cinq cent soixante-onze (424.571) PSPOR ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30)
chacune.

<i>Intervention / Souscription / Libération

Sur ces faits, Trilon Luxembourg Branch, représenté par Trilon Bancorp Inc., déclare souscrire à quatre cent vingt-

quatre mille cinq cent soixante et onze (424,571) PSPOR ayant une valeur nominale de trente dollars américains (USD
30) chacune, et de les libérer intégralement par:

1. un montant de quatre cent neuf millions neuf cent trente-deux mille neuf cent vingt-cinq dollars américains (USD

409.932.925) qui seront pris hors du compte de capital social des Parts Sociales Ordinaires de la Société, qui sera divisé
pour l’allocation et la ré-allocation du compte de prime d’émission des PSPOR et du compte de réserve des PSPOR
comme suit:

(i) deux cent quinze millions trois cent trente-trois mille neuf cent quarante dollars américains (USD 215.333.940)

seront pris hors du compte de capital social des Parts Sociales Ordinaires;

(ii) un montant de cent deux millions cinq cent quatre-vingt dix mille quatre cent quarante-quatre dollars américains

(USD 102.590.444) sera pris hors du compte de prime d’émission des Parts Sociales Ordinaires;

(iii) un montant de vingt et un millions cinq cent trente-trois mille trois cent quatre-vingt seize dollars américains (USD

21.533.396) sera pris hors du compte de réserve légale des Parts Sociales Ordinaires; et

(iv) un montant de soixante dix millions quatre cent soixante quinze mille cent quarante-cinq dollars américains (USD

70.475.145) seront pris hors des autres réserves disponibles des Parts Sociales Ordinaires.

tel qu’indiqué dans les comptes intérimaires de la Société datés du 29 octobre 2010.
2. Là-dessus et suivant l’allocation et la ré-allocation mentionnée ci-dessus, un montant de cent quatre-vingt quatorze

millions cinq cent quatre-vingt dix huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq dollars américains (USD 194.598.985) est assigné
comme suit:

(i) un montant de dix millions cent vingt-neuf mille cent quarante dollars américains (USD 10.129.140) au compte de

capital social PSPOR de la Société;

(ii) un montant de cent soixante et un millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent trente-sept dollars américains (USD

161.923.537) au compte de prime d’émission PSPOR de la Société, lié aux PSPOR; et

(iii) un montant de vingt-deux millions cinq cent quarante-six mille trois cent huit dollars américains (USD 22.546.309)

au compte de réserve légale PSPOR de la Société.

En conséquence, les trois cent trente-sept mille six cent trente-huit (337.638) PSPOR ont été émises.
3. une contribution en nature à la Société consistant en une créance s’élevant à deux cent soixante millions huit cent

mille dollars américains (USD 260.800.000) (la Créance) devant être assignée comme suit:

(i) un montant de deux millions six cent sept mille neuf cent quatre-vingt dix dollars américains (USD 2.607.990) au

compte de capital social PSPOR de la Société;

(ii) un montant de deux cent cinquante-sept millions neuf cent trente et un mille deux cent dix dollars américains (USD

257.931.210) au compte de prime d’émission PSPOR de la Société, lié aux PSPOR; et

(iii) un montant de deux cent soixante mille huit cent dollars américains (USD 260.800) au compte de réserve légale

PSPOR de la Société.

Il ressort par ailleurs d’un certificat daté du 29 octobre 2010 émis par la direction de Highvale Power Corporation et

la Société (le Certificat) que:

- L’Associé Unique est le détenteur et bénéficiaire légale de la Créance;
- L’ Associé Unique est le seul autorisé à détenir la Créance à le pouvoir de disposer de la Créance;
- La Créance n’est grevée d’aucun nantissement ou usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement ou un

usufruit sur la Créance et la Créance n’est sujette à aucun attachement;

- Il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que

la Créance lui soit cédée;

- Conformément au droit applicable et aux Statuts ou à d’autres documents organisationnels, tels que modifiés, la

Créance est librement cessible;

- Toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans tout autre juridiction, consécutives à l’apport en nature de la

Créance à la Société seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant cet apport en
nature;

128763

L

U X E M B O U R G

- Toutes les approbations pour l’exécution et le transfert de la Créance à la Société, selon le cas, ont été obtenues

ou, dans le cas du Cotisant, seront obtenues d’une manière permise par les lois de la juridiction dans laquelle le Cotisant
est immatriculé;

- Se basant sur US GAAP, la valeur de la Créance est évaluée au moins à deux cent soixante millions huit cent mille

dollars américains (USD 260.800.000) tel que démontré par le bilan de Trilon Luxembourg Branch, représenté par Trilon
Bancorp Inc. daté du 29 octobre 2010 et depuis cette évaluation, il n’y a pas eu de changements matériels qui auraient
déprécié la valeur de l’apport fait à la Société.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de modifier et refondre l’article 8 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital, qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social est fixé à cinq cent trois millions neuf cent un mille huit cent quarante dollars américains

(USD 503.901.840) divisé en 9.194.359 (neuf millions cent quatre-vingt quatorze mille trois cent cinquante-neuf) parts
sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»), ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars américains)
chacune et 7.602.369 (sept millions six cent deux mille throis cent soixante-neuf) parts sociales préférentielles obligatoi-
rement rachetables (les «PSPOR»), ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars américains) chacune, toutes
sous forme nominative, toutes souscrites et entièrement libérées. Les PSPOR et les Parts Sociales Ordinaires sont ci-
après désignées individuellement comme une «Part Sociale» et collectivement comme les «Parts Sociales». Les Parts
Sociales Ordinaires et les PSPOR constitueront des catégories séparées de parts sociales dans la Société. Les PSPOR
auont des dividendes préférentiels et des droits de liquidation préférentiels vis-à-vis des Parts Sociales Ordinaires, sujet
aux termes et condition décrites ci-après. […/…]»

<i>Septième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-

dessus avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société et à tout employé de AIB Administrative Services
Luxembourg S.à r.l. pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société en raison du présent acte

sont estimés à environ dix mille euros.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même partie comparante, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra. Et après lecture faite à la partie comparante, elle a
signé ensemble avec le notaire, l’original du présent acte.

Signé: H. WITZKE, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 03 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48067. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Référence de publication: 2010149883/730.
(100172088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2010.

Gogo Holding International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 38.458.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146312/10.
(100167385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

128764

L

U X E M B O U R G

Goldenstein &amp; Goldenstein S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 112.266.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146313/10.
(100167739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Grid Architectes S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 108.140.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P.351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010146314/15.
(100167661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Fidji Luxco (BC) Commandite, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 111.800.

Lors de l'assemblée générale tenue en date du 30 août 2010, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social au 400, Route d'Esch, L-1471

Luxembourg en tant que commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

2. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Ailbhe Jennings, avec adresse professionnelle au 17, Rue du Verger, L-5372 Schuttrange
- Walid Sarkis, avec adresse professionnelle au Mayfair Place, W1J 8AJ, Londres, Royaume-Uni
- Michel Plantevin, avec adresse professionnelle au 16, Belsize Crescent, MW3 5QU, London, Royaume-Uni
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2010 et qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Référence de publication: 2010146537/19.
(100168377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

GS Lux Debt Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.676,76.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 137.038.

Constituée par-devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 février 2008, acte publié au

Mémorial C no 889 du 10 avril 2008

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

128765

L

U X E M B O U R G

<i>Pour GS Lux Debt Holdings II S.à r.l.
Maxime Nino
<i>Manager

Référence de publication: 2010146315/15.
(100167859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

GS Lux Debt Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GSCP VI Lux Holdings S.à r.l.).

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 131.021.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juillet 2007, acte publié

au Mémorial C, no 2146 du 29 septembre 2007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Maxime Nino
<i>Manager

Référence de publication: 2010146316/15.
(100167816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Advent Green Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 125.911.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «AD-

VENT GREEN LUXEMBOURG S.à r.l.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 20 octobre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 octobre 2010. Relation:
EAC/2010/12895.

- que la société «ADVENT GREEN LUXEMBOURG S.à r.l.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège

social au 32, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 125911,

constituée suivant acte du notaire soussigné du 22 mars 2007 et publié au Mémorial C numéro 1074 du 06 juin 2007,
se trouve à partir de la date du 20 octobre 2010 définitivement liquidée, l’assemblée générale extraordinaire prémen-

tionnée faisant suite à celle du 04 avril 2008 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en
liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.

concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l’occurrence au 32, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.

Belvaux, le 9 novembre 2010.

Référence de publication: 2010147654/24.
(100169898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Gymika S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 59.326.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alex WEBER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010146318/11.
(100167403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

128766

L

U X E M B O U R G

Gymika S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 59.326.

L'an deux mille dix, le vingt octobre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GYMIKA S.A." (numéro

d'identité 1997 22 08 666), avec siège social à L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 59.326, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 16
mai 1997, publié au Mémorial C, numéro 462 du 26 août 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus
par le prédit notaire Jean SECKLER, en date du 4 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 584 du 28 juillet 2001
et en date du 3 novembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1328 du 12 décembre 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Miranda JANIN, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon à L-8354 Garnich, 55, rue des Trois Cantons

et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts de la société.

2) Renouvellement des mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes jusqu'à l'is-

sue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon à L-8354 Garnich, 55,

rue des Trois Cantons.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts de la société pour lui

donner la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 . al. 2.  Le siège social est établi à Garnich."

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Michel GYNGOLD, Madame Josiane

DELBOVIER et Monsieur Jacky LIEBESKIND, de l'administrateur-délégué Monsieur Jacky LIEBESKIND et du commissaire
aux comptes Monsieur Serge KUPERBLUM.

Leurs mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à huit cent cinquante euros (€ 850,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J.-M. WEBER, JANIN, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 22 octobre 2010. Relation: CAP/2010/3668. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

128767

L

U X E M B O U R G

Bascharage, le 28 octobre 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010146317/56.
(100167401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Riva Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 131.356.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the nineteenth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DELEK-BELRON LUXEMBOURG SA, a company having its registered office at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,
here represented by Mr Frank Trinteler, employee, residing professionally in Schuttrange,
by virtue of a proxy signed on the 18 

th

 day of October 2010.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "Riva Holdings S.à.r.l.", having its registered office in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, was

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 8 

th

 day of August, 2007, published in the Mémorial

Recueil des Sociétés et Associations, number 2205 on the 5 

th

 day of October, 2007;

- that the capital of the corporation “Riva Holdings S.à.r.l." is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one Euro (1.- EUR) each, all subscribed and fully
paid-up.

- that DELEK-BELRON LUXEMBOURG SA, aforenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at the 19 

th

 day of October, 2010, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities

arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at the 19 

th

 day of October, 2010 being only one

information for all purposes;

- following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be arranged the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-5367 Schuttrange, 64,

rue Principale;

The undersigned notary, who knows and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at THOUSAND EURO (1,000.-Eur).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day first above written.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-neuf octobre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

128768

L

U X E M B O U R G

DELEK-BELRON LUXEMBOURG SA, une société ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,
ici représentée par Monsieur Frank TRINTELER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration accordée le 18 octobre 2010,
laquelle, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour

être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
-que la société Riva Holdings S.à.r.l., ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, a été constituée

suivant acte du notaire instrumentant en date du 8 août 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2205 en date du 5 octobre 2007;

- que les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors;
- que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cent euros (12.500,-EUR) représenté par

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1.-EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.;

- que DELEK-BELRON LUXEMBOURG SA, précité, est seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 19 octobre 2010,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associé unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 19 octobre 2010 étant seulement un
des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société; il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les

parts sociales et/ ou du registre des associés;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-5367 Schuttrange,

64, rue Principale.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.-Eur).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F.TRINTELER, G.LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46058. Reçu: soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Référence de publication: 2010147986/95.
(100169858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Jardinier-Paysagiste Lemmer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7397 Hunsdorf, 4, rue Alsbich.

R.C.S. Luxembourg B 50.326.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

128769

L

U X E M B O U R G

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
Signature

Référence de publication: 2010146327/11.
(100167713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Carring Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.787.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 juin 2010 et d'une réunion du conseil d'admi-

nistration du même jour que les modifications suivantes ont été apportées:

- Renouvellement des mandats des organes sociaux:
* Le mandat d'administrateur de Monsieur Guennadi Timtchenko a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d'administrateur de Madame Elena Timtchenko a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Renouvellement des mandats des administrateurs délégués:
* Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Guennadi Timtchenko a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
* Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
Les mandats susvisés prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en

2016.

Pour extrait sincère et conforme
Patrick Meunier
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010147724/23.
(100170206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

H.C.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 121.567.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146319/10.
(100167552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

JLD Activities S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9647 Doncols, 96, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 147.834.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146328/10.
(100167452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

King Cheetah Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.679.

Le Bilan au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

128770

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 3 Novembre 2010.

<i>Pour King Cheetah holdings SA
Banque Havilland S.A.
Signature

Référence de publication: 2010146330/13.
(100167907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Jose Manuel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4204 Esch-sur-Alzette, 14, rue Large.

R.C.S. Luxembourg B 117.351.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146329/10.
(100167551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Spaqui S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 47.623.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth of October;
Before M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the public limited company ("société anonyme")

“SPAQUI S.A.”, established and having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscribed in
the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 47623, (the ”Company”), incorporated
pursuant to a deed of Me Martine WEINANDY, notary residing in Clervaux, on the 19 

th

 of May 1994, published in the

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 351 of the 22 

nd

 of September 1994,

and whose articles of association have been amended:
- pursuant to a deed of the said notary Martine WEINANDY, on the 4 

th

 of June 1994, published in the Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 398 of the 15 

th

 of October 1994;

- pursuant to a deed of M 

e

 André Jean Joseph SCHWACHTGEN, notary then residing in Luxembourg, on the 7 

th

 of

May 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 624 of the 10 

th

 of June 2003; and

- pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 26 

th

 of August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, number 2258 of the 22 

nd

 of October 2010.

The meeting is presided by Mrs. Sophie THEISEN, private employee, professionally residing in L-2134 Luxembourg,

58, rue Charles Martel.

The Chairman appoints as secretary Mrs. Sandrine GONRY, private employee, professionally residing in L-2134 Lu-

xembourg, 58, rue Charles Martel.

The meeting elects as scrutineer Mr. Mathieu GANGLOFF, private employee, professionally residing in L-2134 Lu-

xembourg, 58 rue Charles Martel.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
A) That the sole shareholder of the Company present or represented and the number of shares held by him are shown

on an attendance list signed ne varietur by the sole shareholder present and/or the proxy of the represented sole sha-
reholder, the board of the meeting and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed
with the registration authorities.

B) That, as it appears from said attendance list, all the three hundred fifty-nine (359) shares in issue are represented

at the present general meeting and the sole shareholder declares that he considers himself duly convened and that he
had prior knowledge of the agenda so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

C) That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer the registered office from Luxembourg to Spain and adopt the Spanish nationality;
2. Acceptance of the resignations of the members of the board of directors and the statutory auditor;
3. Appointment of a sole director of the Company;
4. Decision to amend the articles of association of the Company in order to conform them to the Spanish law;

128771

L

U X E M B O U R G

5. Maintenance for the Company of the legal form of a public limited company as well as the actual corporate deno-

mination;

6. Miscellaneous.

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the statutory registered office, the principal place of business, the central adminis-

tration and the effective headquarters of the Company from Luxembourg to Spain, and more specifically to E-08006
Barcelona (Spain), Calle Balmes 351.

This change of nationality having not as effect a change of the legal entity of the Company that stays unchanged more

specifically on the legal and on the financial point of view, so that as a consequence without a change of the legal entity
and this without a liquidation of the Luxembourg company, the nationality of the Company is changed from the Luxem-
bourg to Spanish nationality.

<i>Second resolution

The meeting accepts the resignations of all the members of the board of directors and of the statutory auditor and

grants them full discharge for the performance of their mandates until the date hereof.

<i>Third resolution

The meeting appoints Mr. Pelayo RUBIO RUBIRALTA, born in Barcelona (Spain), on July 11, 1977, residing in Barcelona

(Spain), Josep Irla I Bosch 8, as new and sole director of the Company.

His mandate will be valid until revocation.

<i>Fourth resolution

The meeting decides that an extraordinary general meeting of the sole shareholder will be held before a notary in

Spain in order to modify the articles of association and to put them in conformity to the Spanish law and language.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to maintain for the Company the legal form of a public limited company as well as the actual

corporate denomination.

<i>Sixth resolution

The meeting unanimously resolves to submit all the resolutions taken above to the condition precedent ("condition

suspensive") of the transfer of the Company's registered office to Spain and the registration of the Company with the
Spanish Trade Register.

The procedure for the deregistration of the Company will be effected at the Luxembourg Trade and Companies'

Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) as soon as a statement attesting registration with the
Trade Register of Barcelona in Spain is received.

<i>Declaration of the notary

The Luxembourg legislation allows the possibility of transferring abroad the corporate domicile of a company located

in Luxembourg, as long as the agreements are taken in accordance with article 67-1 (1) of the Luxembourg Law of the
commercial companies.

The said agreements are registered in the Companies and Trade Register of Luxembourg (Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg), which is public. These agreements as well as the any other documentation of a Company,
which has to be or has already been deposited at this Register, can be accessed by any citizen who is interessed to, even
before the Documents will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Offical Paper of the
Grand-Duchy of Luxembourg).

The migration decision has been taken in accordance with the regulation contained in the company bylaws and the

applicable Luxembourg legislation.

There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

128772

L

U X E M B O U R G

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt-neuf octobre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme “SPAQUI S.A.”, (la

"Société"), établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47623, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par
Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux, en date du 19 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 351 du 22 septembre 1994,

et dont les statuts ont été modifies:
- suivant acte reçu par ledit notaire Martine WEINANDY, en date du 4 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 398 du 15 octobre 1994;

- suivant acte reçu par Maître André Jean Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en

date du 7 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 624 du 10 juin 2003; et

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 2258 du 22 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Madame Sophie THEISEN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2134

Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine GONRY, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mathieu GANGLOFF, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'actionnaire unique présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une

liste de présence signée "ne varietur" par l'actionnaire unique présent et/ou le mandataire de l'actionnaire unique repré-
senté, les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste de présence restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera enregistrée.

B) Qu'il résulte de la liste de présence ci-annexée que les trois cent cinquante-neuf (359) actions représentant l'inté-

gralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée et que l'actionnaire unique considère
avoir été dûment convoqué et qu'il a eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée peut vala-
blement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Espagne et adoption de la nationalité espagnole;
2. Acceptation des démissions des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Nomination d'un administrateur unique;
4. Décision de modifier les statuts de la Société afin de les rendre conformes à la loi espagnole;
5. Maintien pour la Société de la forme juridique d'une société anonyme et de la dénomination sociale actuelle;
6. Divers.

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège réel, l'administration centrale et le lieu du principal

établissement, de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Espagne, et plus précisément à E-08006 Barcelone
(Espagne), Calle Balmes 351.

Ce changement de nationalité n'ayant pas pour effet de modifier la personnalité juridique de la Société qui restera

inchangée spécialement d'un point de vue légal et financier, a pour conséquence que la Société passera de la nationalité
luxembourgeoise à la nationalité espagnole et ce sans liquidation ni changement dans la personnalité juridique de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accepte les démissions de tous les membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

et leur accorde décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'en date de ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée nomme Monsieur Pelayo RUBIO RUBIRALTA, né à Barcelone (Espagne), le 11 juillet 1977, demeurant à

Barcelone (Espagne), Josep Irla I Bosch 8, comme nouvel et unique administrateur de la Société.

128773

L

U X E M B O U R G

Son mandat restera valable jusqu'à révocation.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra devant notaire en Espagne

pour modifier les statuts et afin de les mettre en conformité à la loi et à la langue espagnole.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de maintenir pour la Société la forme juridique d'une société anonyme ainsi que la dénomination

sociale actuelle.

<i>Sixième résolution

L'assemblée  décide  à  l'unanimité  de  soumettre  toutes  les  résolutions  prises  ci-avant  à  la  condition  suspensive  du

transfert du siège social de la Société en Espagne et l'immatriculation de la Société auprès du Registre des Sociétés
espagnol.

La procédure de radiation de la Société sera effectuée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

dès réception de l'extrait attestant de son inscription auprès du Registre de Commerce de Barcelone en Espagne.

<i>Déclaration du notaire

La législation luxembourgeoise accorde aux sociétés ayant leur siège social à Luxembourg, la possibilité de transférer

leur siège vers l'étranger, si toutefois cette décision est prise en conformité avec les dispositions de l'article 67-1 (1) de
la loi sur les sociétés commerciales au Luxembourg.

Lesdites résolutions seront inscrites au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, qui est publique. Ces

résolutions ainsi que toute autre documentation dont le dépôt est obligatoire et a été fait au dit Registre, peuvent être
consultés par toute personne intéressée, même avant que l'acte ne soit publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (Gazette officielle du Grand-Duché de Luxembourg).

La décision de migration a été prise conformément à la réglementation contenue dans les statuts de la société et la

législation luxembourgeoise en vigueur.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente a ajourné l'assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme mille cinq cents
euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français et l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des

comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connu du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, lesdits

comparants ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. THEISEN, S. GONRY, M. GANGLOFF, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2010. LAC/2010/47963. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Référence de publication: 2010148026/185.
(100169691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 28.124.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

128774

L

U X E M B O U R G

<i>Pour Klynweld Peat Marwick Goerdeler S.à r.l.
Carlo JENTGEN
<i>Directeur Financier

Référence de publication: 2010146331/12.
(100167578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

KPMG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 103.065.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KPMG S.à r.l.
Carlo JENTGEN
<i>Directeur Financier

Référence de publication: 2010146332/12.
(100167584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Misys Overseas Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 72.849.

Les comptes annuels au 31 mai 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146350/10.
(100167735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

LuxCo 126 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 155.764.

Par résolutions signées en date du 3 novembre 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
Acceptation  de  la  démission  de  TMF  CORPORATE  SERVICES  S.A.,  avec  siège  social  au  1,  allée  Scheffer,  L-2520

Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Mark Doherty, avec adresse professionnelle au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Nomination de Monsieur Richard Crombie, avec adresse professionnelle au Finsbury Dials, 20, Finsbury Street, EC2Y

9AQ Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Nomination de Monsieur James Walsh, avec adresse professionnelle au 245, Park Avenue, 10167 New York, Etats-

Unis, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Nomination de Monsieur Jean-Christophe Ehlinger, avec adresse professionnelle au 6, route de Trèves, L-2633 Sen-

ningerberg, en tant que gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2010.

<i>Pour la société
TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010149322/24.
(100169649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

128775

L

U X E M B O U R G

Macete S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.101.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146351/10.
(100167313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Magepar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.

R.C.S. Luxembourg B 104.373.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 02.11.2010.

Fiduciaire S.à r.l.
CabexcO
Centre Helfent
1, rue Pletzer - L-8080 Bertrange
Signature

Référence de publication: 2010146353/15.
(100167642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Marigny Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 93.828.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146354/10.
(100167749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

WPP Luxembourg Beta Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.214.575.100,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 106.207.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 22 octobre 2010 entre Barleycorn LLC,

une société à responsabilité limitée constituée sous le droit des Etats-Unis d'Amérique avec siège social au Berger House,
Berkeley Square, Londres, Royaume Uni et WPP 1178, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit de
l'Angleterre et du Pays de Galle avec siège social au 27 Farm Street, Londres Wl 5RJ, Royaume Uni, immatriculée auprès
du registre de la Companies House sous le numéro 2670626, que 1.768.594 (un millions sept cent soixante-huit mille
cinq cent quatre-vingt quatorze) parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société d'une valeur nominale de 100 USD
(cent dollars américain) chacune ont été cédées avec effet au 22 octobre 2010 par Barleycorn LLC à WPP 1178.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WPP Luxembourg Beta Three S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2010146749/19.
(100168640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

128776

L

U X E M B O U R G

Solid Rock SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 146.401.

In the year two thousand ten,
on the twentieth day of the month of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Stichting Legatus”, a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Ams-

teldijk 166, 1079LH Amsterdam, registered with the trade register of the Chambers of Commerce for Amsterdam under
number 34234797,

here represented by Mrs Giovanna Carles, employee, having her professional address at 9B, Boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg,

by virtue of a proxy, given under private seal in Amsterdam, on 20 October 2010
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party as well as by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

“Stichting Legatus” is the sole shareholder of “Solid Rock S.A.”, a société anonyme governed by the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 9b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000.-
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B.146.401 (the Company). The
Company was incorporated on 28 May 2009 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1228 of 25 June 2009.

The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted

by the undersigned notary, on 17 September 2009, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1966 of 08 October 2009.

Which appearing party, acting in the above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to record the that

the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to approve the pro forma accounts (the Pro Forma Accounts) of the Company for the

period from 1 January 2010 to 20 October 2010 (up to and excluding liquidation) (the Financial Year) substantially in the
form attached hereto as Schedule 1.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary

liquidation (liquidation volontaire).

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr. Marcel STEPHANY, chartered accountant, with professional address at

23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 BERELDANGE, as the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of
the Company (the Liquidator).

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the

Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Act).

The sole shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the cir-

cumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The sole shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all

operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Act, without the prior autho-
risation of the sole shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one
or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The sole shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liqui-

dation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The sole shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sole shareholder, in accordance with
article 148 of the Act.

128777

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to give full discharge (quitus) to the members of the board of directors and to the

statutory auditor of the Company for the performance of their respective mandates during and in connection with, the
Financial Year.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix,
le vingt octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

«Stichting Legatus», une société de droit néerlandais avec siège social au Amsteldijk 166, 1079LH Amsterdam, imma-

triculée auprès de la Chambre du Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34234797,

ici représentée par Madame Giovanna Carles, employée privée, demeurant professionnellement au 9B, Boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé à Amsterdam, le 20 octobre 2010,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante ainsi que par le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

«Stichting Legatus» est l'actionnaire unique de la société «Solid Rock S.A.», une société anonyme de droit luxembour-

geois avec siège social au 9b, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 146.401 (la Société), qui a été constituée en date du 28 mai 2009 suivant
acte dressé par le notaire soussigné, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1228 du 25 juin 2009.

Les statuts de la Société furent modifiés tout dernièrement suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27

septembre 2009, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1966 du 08 octobre
2009.

La partie comparante, es qualité qu'elle agit a requis le notaire instrumentaire d'acter que l'associé unique a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'approuver des comptes pro forma (les Comptes Pro Forma) de la Société pour la période

allant du 1 

er

 janvier 2010 au 20 octobre 2010 (jusqu'à et excluant la liquidation) (l'Exercice Social) dans la forme annexée

aux présentes à l'Annexe 1.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation

volontaire.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de nommer M. Marcel STEPHANY, expert-comptable, demeurant professionnellement au 23,

Cité Aline Mayrisch, L-7268 BERELDANGE, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le
Liquidateur).

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144

et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L'associé unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,

afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'associé unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de

la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'associé
unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs
personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

128778

L

U X E M B O U R G

L'associé unique e décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en

liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'associé unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation à l'associé unique, conformément à l'article 148
de la Loi..

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide d'accorder décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes de la Société

pour l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de, et en rapport avec, l'Exercice Social.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, ladite mandataire a signé ensemble avec Nous le notaire,

le présent acte.

Signé: G. CARLES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 octobre 2010. Relation: EAC/2010/12889. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010146695/126.
(100168232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

Silverfleet Sixth Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 152.513.

Par résolutions prises en date du 14 octobre 2010, l'associé unique a décidé de nommer Yves Cheret avec adresse

professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2010.

Référence de publication: 2010146694/13.
(100168050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

Sonterra Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 432.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 132.149.

<i>Extrait des résolutions de l’associé du 3 novembre 2010

Les associés de Sonterra Finance S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Frank Walenta de sa fonction comme gérant de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Robin Naudin ten Cate, né le 5 mars 1974 à ‘s-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement

au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée
indéterminée;

- de transférer le siège social de la Société du 14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 15, rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg.

Il convient également de noter que l’adresse professionnelle de Mme Marjoleine van Oort, gérant, sera désormais au

15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 05/11/2010.

Référence de publication: 2010146696/19.
(100168187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

128779

L

U X E M B O U R G

Saldanha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 145.887.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SALDANHA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010146697/11.
(100168520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

TV Vertical S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 49.576.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 4 novembre 2010 à 15.00 heures, a pris à l'unanimité les

résolutions suivantes:

1) L'assemblée a pris acte de la démission de deux administrateurs, Messieurs Marc Koeune et Jean-Yves Nicolas.
2) L’assemblée a nommé deux nouveaux administrateurs, à savoir, Monsieur Michael Zianveni, né le 4 mars 1974 à

Villepinte/France et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et Monsieur Gérald Job, né
le 12 juin 1981 à Verviers/Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. Ils achèveront
le mandat de leurs prédécesseurs.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.
3) L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social au 2A, rue Jean-Baptiste Esch, à L-1473 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010146728/18.
(100168009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

TVA Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 156.399.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

- Herr Christian THEILMANN, Diplom-Betriebswirt, geboren in Ludwigshafen (Bundesrepublik Deutschland) am 14.

Mai 1965, wohnhaft in 10, Am Mitbach, D-53879 Euskirchen (Bundesrepublik Deutschland),

- Herr Harald VON AMELN, Kaufmann, geboren in Traunstein (Bundesrepublik Deutschland) am 27. September 1967

wohnhaft in 107, Herman-Löns Strasse, D-52078 Aachen (Bundesrepublik Deutschland).

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die

hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

§ 1. Zweck, Dauer, Name, Sitz.
1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesellschaft»)

gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neueste
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

1.1. Zweck der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und die Übernahme der persönlichen Haftung von Unternehmen

sowie  das  Halten  von  Beteiligungen  an  Kapital-bzw.  Personengesellschaften.  Daneben  kann  die  Gesellschaft  den
gewerbsmäßigen An- und Verkauf von Edelmetallen, Nicht-Edelmetallen, sonstigen Rohstoffen sowie Waren einschließlich
deren jeweiliger Weiterverarbeitung betreiben, sowie die Unternehmensberatung für jedwede Personen juristischer bzw.
privater Natur ausüben.

1.2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur

berechtigt, die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können. Hierzu gehören auch die

128780

L

U X E M B O U R G

Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen bzw. die Beteili-
gung daran.

1.3. Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen

Dienstleistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
auf die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

1.4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
1.5. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung führt die Bezeichnung TVA Trade S.à r.l.
1.6. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt. Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an

jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

§ 2. Gesellschaftskapital, Anteile.
2. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile

mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) pro Anteil. Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei
ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.

2.1. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese

Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.

2.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

2.3. Rechtsgeschäftliche Verfügungen eines Gesellschafters über seinen Gesellschaftsanteil oder Teilen hiervon be-

dürfen zu ihrer Wirksamkeit eines zustimmenden Beschlusses aller anderen Gesellschafter.

2.4. Der Tod, die Rechtsunfähigkeit, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

2.5. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgegens-

tänden oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

§ 3. Geschäftsführung.
3.1.  Die  Gesellschaft  wird  geführt  durch  einen  oder  mehrere  Geschäftsführer.  Die  Geschäftsführer  müssen  nicht

Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterver-
sammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen
aus ihren Funktionen entlassen werden.

3.2. Dritten gegenüber ist - auch im Fall mehrerer Geschäftsführer  jeder Geschäftsführer unbeschränkt bevollmächtigt,

jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesell-
schaftszweck in Einklang stehen (Alleinvertretungsberechtigung). Die Geschäftsführer sind von etwaigen Beschränkungen
des Selbstkontrahierens befreit. Vollmachten werden durch die Geschäftsführer privatschriftlich oder aufgrund notariell
beglaubigter Urkunde erteilt.

3.3. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Gesellschaft

nicht aufgelöst.

3.4. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen

der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

§ 4. Entscheidungen der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung.
4.1. Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

4.2. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung

(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter,
(ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
4.3. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesellschaf-

terversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neueste Fassung,
zustehen.

§ 5. Geschäftsjahr, Konten, Gewinnausschüttungen.
5.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

5.2. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer

stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

128781

L

U X E M B O U R G

5.3. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Jeder Gesellschaft-
santeil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

§ 6. Gesellschaftsauflösung, Liquidation.

6. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung
legt Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Ver-
mögens guter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil
aufgeteilt.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden vollständig von den beiden Anteilhabern wie folgt gezeichnet:

- Herr Christian Theilmann, vorbenannt, zweihundertfünfzig Anteile

250

- Herr Harald Von Ameln, vorbenannt, zweihundertfünfzig Anteile

250

Total: fünfhundert Anteile

500

Alle vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend

Euro (EUR 1.000) geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

2. Die Herren Christian THEILMANN und Harald VON AMELN, vorbenannt, werden beide als Geschäftsführer auf

unbestimmte Zeit ernannt. Als Geschäftsführer können beide die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift vertreten.

<i>Erklärung der Komparenten

Die Komparenten erklären im Namen der dinglich Begünstigten der Gesellschaft, dass die Mittel zur Gründung des

Gesellschaftskapitals nicht von irgendeiner Tätigkeit stammen, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel
8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenab-
hängigkeit oder einer terroristischen Handlung, im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des
Terrorismus definiert).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräu-

chlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: C. THEILMANN, H. VON AMELN, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2010. Relation: LAC/2010/46972. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxemburg, den 5. November 2010.

Référence de publication: 2010146729/126.

(100168071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

128782

L

U X E M B O U R G

Ulysses Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 156.472.728,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 125.646.

L'adresse du gérant Gijsbert Cornells Vuursteen a changé et se trouve à présent au 712, Fifth Avenue, NY 10019 New

York, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010146730/12.
(100168382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

Ulysses Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.050.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.220.

L'adresse du gérant Emanuela Brero a changé et se trouve à présent au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Référence de publication: 2010146731/11.
(100168383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

Upton S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 134.974.

Les Comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 5 novembre 2010.

Référence de publication: 2010146734/10.
(100168544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

Horizon Tours S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 25, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 39.740.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146321/10.
(100167558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Metec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 21.173.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 août 2010

Est nommé administrateur, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2014:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur John SEIL, administrateur démissionnaire en date du 11 août 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2010.

128783

L

U X E M B O U R G

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 11 août 2010

Est nommé Président du conseil d'administration,
Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Son mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Référence de publication: 2010147930/26.
(100169989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

Ideo Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 147.129.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146323/10.
(100167325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Ilix Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 77.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BRIMEYER Georges.

Référence de publication: 2010146324/10.
(100167477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

b+ architectes, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7237 Bereldange, 6, Cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 112.089.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010146450/9.
(100168039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2010.

LFS Property Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 37.917.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010146340/10.
(100167573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

128784


Document Outline

Advent Green Luxembourg S.à r.l.

Alder Consultancy S.à r.l.

b+ architectes

Carring Finance S.A.

Eclaircie s.à.r.l.

Efin S.à r.l.

Euro Participations et Investissements S.A.

Europa Services Belux S.à r.l.

Eventus Management Partners S.A.

Eventus Management Partners S.A.

Fareale S.A.

Fidji Luxco (BC) Commandite

Filtilux S.A.

Finlyinx S.A.

Finlyinx S.A.

Florakerk Holding S.A.

Fondation pour la Promotion du Tennis au Luxembourg

Fumolux S.à r.l.

Geam S.A.

Gestion - Investissement - Promotion S.A.

Giolin S.A.

Gogo Holding International S.A.

Goldenstein &amp; Goldenstein S.A.

Grid Architectes S.àr.l.

GSCP VI Lux Holdings S.à r.l.

GS Lux Debt Holdings II S.à r.l.

GS Lux Debt Holdings S.à r.l.

Gymika S.A.

Gymika S.A.

H.C.L.

Horizon Tours S.à.r.l.

Ideo Finance S.A.

Ilix Holding S.A.

Jardinier-Paysagiste Lemmer S.à r.l.

JLD Activities S.à r.l.

Jose Manuel S.à r.l.

King Cheetah Holdings S.A.

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

KPMG

LFS Property Services S.A.

LSF Gennecab Investments S.à r.l.

LSF PlattenB Investments

LuxCo 126 S.à r.l.

Macete S.A.

Madeco Decors S.à r.l.

Magepar S.A.

Marigny Development S.A.

Metec S.A.

Misys Overseas Investments S.à r.l.

Onea S.A.

Riva Holdings S.à r.l.

Saldanha S.A.

Silverfleet Sixth Investment Company S.à r.l.

Solid Rock SA

Sonterra Finance S.à.r.l.

Spaqui S.A.

Trilon (Luxembourg) S.à r.l.

TVA Trade S.à r.l.

TV Vertical S.A.

Ulysses Luxembourg S.à r.l.

Ulysses Participation S.à r.l.

Upton S.à r.l.

WPP Luxembourg Beta Three S.à r.l.