logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2607

30 novembre 2010

SOMMAIRE

A-DGZ 13-Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125122

amandea MK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125132

AMB Bonneuil Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

125123

AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.  . .

125123

AMB Le Havre Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

125123

AMB Port of Rouen Holding S. à r.l.  . . . . .

125123

AMB St Pathus Holding S. à r.l. . . . . . . . . . .

125123

Cash Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125121

C.C.B. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125114

Celesta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125112

Deka-WorldGarant 10/2011  . . . . . . . . . . . . .

125122

Eurizon Alternative Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

125114

Eurizon Focus Capitale Protetto  . . . . . . . .

125121

Eurizon Liquidity Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125114

EURO SPEED Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

125135

EURO SPEED Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

125136

EURO SPEED Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

125135

EURO SPEED Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

125135

EURO SPEED Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

125135

Exakt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125136

FCP OP Medical  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125121

Fiduciaire DMD S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125136

Finb International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125136

First Class  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125122

FS Invest II S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125117

Glogger Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125122

GodmodeTrader.de Strategie I . . . . . . . . . .

125121

Golding Investments III S.A.  . . . . . . . . . . . .

125121

Golding Investments IV S.A.  . . . . . . . . . . . .

125120

Golding Investments IV TF2 S.A.  . . . . . . . .

125120

Golding Mezzanine SICAV III  . . . . . . . . . . .

125120

Golding Mezzanine SICAV IV  . . . . . . . . . . .

125117

Grellmann Fire Protection S.àr.l.  . . . . . . . .

125134

Haspa PB Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125122

Hill International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125090

Indra Holding Société Anonyme . . . . . . . . .

125090

Kikuoka Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

125132

NV Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125123

NV Strategie Emerging  . . . . . . . . . . . . . . . . .

125122

Selcius S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125112

Sireo Immobilienfonds No.6 Türkiye I S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125114

Sofi S.C.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125136

Whitehall French RE 12 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

125135

125089

L

U X E M B O U R G

Indra Holding Société Anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 35.746.

La première assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 29 novembre 2010 n'ayant pu délibérer faute de

quorum requis, les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>31 décembre 2010 devant notaire à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en Indra Spf S.A. et modification subséquente de l'article 1, première

phrase des statuts de la société.

2. Transformation de holding en société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) et modification subséquente

de l'article 4 des statuts de la société.

3. Divers.

L'assemblée délibérera valablement sans condition de quorum et les résolutions devront réunir les 2/3 des voix des

actionnaires présents ou représentés.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010157605/1031/19.

Hill International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 106.594.

Hill International N.V., Naamloze Venootschap.

Siège social: Claude Debussylaan, 24, 1082 MD Amsterdam, The Netherlands.

Trade Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam, The Netherlands

under number 50919679.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth of November.
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The Acquiring Company, HILL INTERNATIONAL N.V. Naamloze venootschap, with registred office at Claude

Debussylaan, 24, 1082 MD Amsterdam, The Netherlands, inscribed in the Trade Register of the Chamber of Commerce
for Amsterdam, the Netherlands, under number 50919679, here represented by Mr Stef OOSTVOGELS, Attorney at
Law, with professional address in L-1150 Luxembourg, route d'Arlon, 291, pursuant to a resolution of the Board of
Directors, taken on November 25, 2010;

2) The Disappearing Company, HILL INTERNATIONAL S.A., which will be merged by absorption into the Acquiring

Company, incorporated as a société anonyme and having its registered office at 41, boulevard du prince Henri, L-1724
Luxembourg, registered with the Luxembourg commercial register under number B 106.594, here represented by Mr
Stef OOSTVOGELS, Attorney at Law, with professional address in L-1150 Luxembourg, route d'Arlon, 291, pursuant to
a resolution of the Board of Directors, taken on November 25, 2010;

copies of which resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary

will be attached to the present deed.

The appearing persons requested the undersigned notary to record the merger project of the Absorbing Company

and the Absorbed Company as more fully specified hereafter:

Common Draft Terms of Cross-Border Merger

The management boards and the supervisory board (as the case may be) of:
1. Hill International N.V., a public company under Dutch law ('naamloze vennootschap'), having its official seat in

Amsterdam, the Netherlands and its office address at Claude Debussylaan, 24, 1082 MD Amsterdam, the Netherlands,
registered  with  the  Trade  Register  of  the  Chamber  of  Commerce  for  Amsterdam,  the  Netherlands  under  number
50919679 (the "Acquiring Company"); and

2. Hill International S.A., a public company limited by shares (société anonyme) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered seat at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre du Commerce et

125090

L

U X E M B O U R G

des Sociétés, Luxembourg) under section B number 106.594 (the "Company Ceasing to Exist" and together with the
Acquiring Company, the "Merging Companies");

Whereas:
(i) the Acquiring Company is the holder of the entire issued share capital of the Company Ceasing to Exist and therefore

(i) Book 2, Article 333 paragraph 2 of the Dutch Civil Code applies pursuant to which the sections 2:326 - 328 of the
Dutch Civil Code do not apply, and (ii) Section (XIV) (Des fusions), Sub-section 3 (Absorption d'une société par une
autre possédant 90% ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société) of the Lux-
embourg law dated 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Company Act"), applies;

(ii) the Acquiring Company has a supervisory board;
(iii) the Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been

declared with respect to the Merging Companies;

(iv) none of the Merging Companies has a works council or a trade union that has amongst its members employees

of one of the Merging Companies.

The management boards and the supervisory board (as the case may be) of the Merging Companies propose a cross-

border merger within the meaning of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26
October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies and the relevant local laws applicable to the Merging
Companies as a result of which merger:

- the Company Ceasing to Exist will cease to exist; and
- the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist under a universal title

of succession.

The data to be mentioned pursuant to Sections 2:312 paragraph 2 and 2:333d of the Dutch Civil Code and articles

261 (2) and (4) and 278 of the Company Act, are as follows:

a. Type of legal entity, name and official seat of the Merging Companies.
(i) The public company Hill International N.V., having its official seat Claude Debussylaan, 24, 1082 MD Amsterdam,

the Netherlands

(ii) The société anonyme Hill International S.A. having its official seat at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lux-

embourg, Grand Duchy of Luxembourg.

b. Articles of association of the Acquiring Company.
The articles of association of the Acquiring Company shall not be amended in connection with the merger.
The articles of association of the Acquiring Company were drawn up by deed of incorporation executed on the twenty-

seventh day of September two thousand ten before G.C. van Eck, civil-law notary in Rotterdam, the Netherlands. The
consecutive wording of the current articles of association of the Acquiring Company is attached to these draft terms of
cross-border merger as Annex A.

c. Rights and compensations at the expense of the Acquiring Company granted pursuant to Section 2:320 of the Dutch

Civil Code and Article 261 (1) f) of the Company Act.

As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Company

Ceasing to Exist, NO SPECIAL RIGHTS and no compensations will be granted at the expense of the Acquiring Company
to anyone.

d. Benefits to be granted to a member of the management board or of the supervisory board of the Merging Companies

or to another party involved with the merger, in connection with the merger.

NONE.
e. Intentions with regard to the composition of the management board and the supervisory board of the Acquiring

Company after the cross-border merger.

There is NO INTENTION to change the composition of the management board and of the supervisory board after

the cross-border merger.

The present composition is as follows:

<i>Management board:

- Petrus Hendrik Bosse
- Raouf Sobhi Ghali

<i>Supervisory board:

- David Louis Richter
- Irvin Elliot Richter
f. Date per which the financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of

the Acquiring Company.

125091

L

U X E M B O U R G

The financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring

Company as per 1 JANUARY 2011. The last financial year of the Company Ceasing to Exist will therefore end on 31
December 2010.

g. Proposed measures in connection with the allotment of shares.
In this cross-border merger, the Acquiring Company holds the entire issued share capital of the Company Ceasing to

Exist and there shall be NO ALLOTMENT OF SHARES in the Acquiring Company.

h. Contemplated continuation or termination of activities.
The activities of the Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company.
i. Corporate approvals of the draft terms of cross-border merger.
The approval of the supervisory board of the Acquiring Company to the cross-border merger is evidenced by the co-

signing of this proposal by all supervisory board members, which also has to be considered as a written resolution of the
supervisory board in accordance with Section 19 subsection 4 of the Articles of Association of the Acquiring Company.

j. Effects of the merger on the goodwill and the distributable reserves of the Acquiring Company.
The effects of the cross-border merger on the goodwill are as follows: NONE
The effects of the cross-border merger on distributable reserves of the Acquiring Company are as follows: NONE
k. Likely effects on employment.
The cross-border merger is NOT EXPECTED TO HAVE ANY MATERIAL EFFECT on employment because the

activities of the Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company.

l. Procedures for employee participation.
As none of the Merging Companies is subject to national rules concerning employee participation in the Member State

of the European Union where it has its registered office, NO EMPLOYEE PARTICIPATION ARRANGEMENTS as referred
to in Section 2:333k of the Dutch Civil Code have to be made by the Acquiring Company.

m. Information on the valuation of assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring

Company.

The valuation of the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring Company

shall be made on the basis of the annual accounts as of December 31, 2009 established in compliance with the Luxembourg
legal and regulatory provisions and the Luxembourg generally accepted accounting principles:

- the valuation method used to valuate the financial assets of the Acquiring Company is the acquisition cost;
- aforementioned acquisition cost includes the charges and expenses in connection with the acquisition;
- assets in currencies other than EUR are translated into EUR at the exchange rates prevailing on the transaction date;
- claims and liabilities in currencies other than EUR are translated into EUR at year-end exchange rates unless con-

version would result in an unrealised exchange gain;

- all unrealised and realised exchange loss and the realised exchange gain resulting from these conversions are ac-

counted for in the profit and loss account.

n. Date of the most recently annual accounts or interim financial statements.
The date of the most recently annual accounts of the Merging Companies' accounts used to establish the conditions

of the cross-border merger is:

Acquiring Company:
Not available as the Acquiring Company has only been recently incorporated
Company Ceasing to Exist:
December 31, 2009
o. Proposal for the level of compensation of shareholders.
No compensation for shareholders that vote against the proposal to effectuate the cross-border merger is proposed,

as it is not expected that votes will be cast against this proposal.

p. Annexes.
Annexes to these draft terms form an integrated part of this proposal.
q. Ancillary information
All documents pertaining to the Absorbing Company are filed with the trade and companies register of Amsterdam.
All the corporate books and accounting documents of the Company Ceasing to Exist will be desposited and available,

upon request, at the registered office of the Acquiring Company during the period required by the Company Act.

The present deed is worded in English followed by a French version. In case of divergences between the English and

the French text, the English version will be prevailing.

Suit la traduction française:

L'an deux mille dix, le vingt-cinq novembre.

125092

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La Société Absorbante, HILL INTERNATIONAL N.V. un Naamloze venootschap, avec siège social à Claude De-

bussylaan,  24,  1082  MD  Amsterdam,  Pays-Bas,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  de  la  Chambre  de  Commerce
d'Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 50919679, ici représentée par Maître Stef OOSTVOGELS, Avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, suivant résolution du Conseil d'Administration
prise le 25 novembre 2010;

2) La Société Absorbée HILL INTERNATIONAL S.A., qui sera absorbée par fusion dans la Société Absorbante, con-

stituée  sous  la  forme  d'une  société  anonyme  et  ayant  son  siège  social  au  41,  boulevard  du  Prince  Henri,  L-1150
Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 106.594,
ici représentée par Maître Stef OOSTVOGELS, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
291, route d'Arlon, suivant résolution du Conseil d'Administration prise le 25 novembre 2010;

copies des dites décisions, après avoir été signées ne varietur par le comparante et le notaire soussigné resteront

annexées aux présentes.

Les comparants ont requis le notaire d'acter le projet de fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée

suivant les termes et conditions suivantes:

Projet Commun de Fusion Transfrontalière

Les conseils d'administration et collège des commissaires aux comptes (le cas échéant) de:
1. Hill International N.V., une société anonyme de droit Hollandais ('naamloze vennootschap'), ayant son siège social

à Amsterdam, Pays-Bas et son adresse à Claude Debussylaan, 24, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du
registre du commerce de la chambre de commerce d'Amsterdam, Pays-Bas sous le numéro 50919679 (la "Société Ac-
quérante"); et

2. Hill International S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 106.594 (la "Société Dissoute" et
ensemble avec la Société Acquérante, les "Sociétés Fusionnantes");

Attendu que:
(i) la Société Acquérante détient la totalité du capital social de la Société Dissoute et par conséquent (i) le Livre 2,

Article 333 paragraphe 2 du Code civil Hollandais s'applique selon lequel les sections 2:326 - 328 du Code civil hollandais
ne s'appliquent pas, et (ii) Section (XIV) (Des fusions), Sous-section 3 (Absorption d'une société par une autre possédant
90% ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société) de la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, (la "Loi sur les Sociétés"), s'applique;

(ii) la Société Acquérante a un collège des commissaires aux comptes;
(iii) les Sociétés Fusionnantes n'ont pas été dissoutes ni déclarées en faillite, ni déclarées en état de suspension des

paiements;

(iv) aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de comité d'entreprise ni de syndicat qui a parmi ses membres des employés

de l'une des Sociétés Fusionnantes.

Les conseils d'administration et le collège des commissaires aux comptes (le cas échéant) des Sociétés Fusionnantes

proposent une fusion transfrontalière au sens de la Directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil en date
du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et des lois locales applicables aux Sociétés
Fusionnantes par suite de ladite fusion:

- la Société Dissoute cessera d'exister; et
- la Société Acquérante acquerra les actifs et passifs de la Société Dissoute par transfert universel de patrimoine.
Les informations devant être mentionnées conformément aux Sections 2:312 paragraphes 2 et 2:333d du Code civil

hollandais et aux articles 261 (2) et (4) et 278 de la Loi sur les Sociétés, sont les suivantes:

a. Forme juridique, dénomination et siège social des Sociétés Fusionnantes.
(i) La société anonyme Hill International N.V., ayant son siège social à Claude Debussylaan, 24, 1082 MD Amsterdam,

Pays-Bas;

(ii) La société Hill International S.A. ayant son siège social à 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

b. Statuts de la Société Acquérante.
Les statuts de la Société Acquérante ne seront pas modifiés lors de cette fusion.
Les statuts de la Société Acquérante ont été établis selon acte de constitution signé en date du vingt sept septembre

deux mille dix par devant G.C. van Eck, notaire de droit civil à Rotterdam, Pays-Bas. Les statuts actuels de la Société
Acquérante sont attachés au présent projet de fusion transfrontalière en Annexe A.

c. Droits et dédommagements aux frais de la Société Acquérante accordés conformément à la Section 2:320 du Code

civil hollandais et de l'article 261 (1) f) de la Loi sur les Sociétés.

125093

L

U X E M B O U R G

Dans la mesure où il n'existe personne qui n'ait, en toute autre capacité que celle d'associé, de droits spécifiques à

rencontre de la Société Dissoute, AUCUN DROIT SPÉCIFIQUE ni compensation ne sera accordé aux frais de la Société
Acquérante à une quelconque personne.

d. Avantages à accorder à un membre du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes des

Sociétés Fusionnantes ou à un tiers à la fusion, relativement à la fusion.

AUCUN.
e. Intentions relatives à la composition du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes de la

Société Acquérante après la fusion transfrontalière.

Il n'y a PAS D'INTENTION de modifier la composition du conseil d'administration et du collège des commissaires aux

comptes après la fusion.

La composition actuelle est la suivante:
Conseil d'administration:
- Petrus Hendrik Bosse
- Raouf Sobhi Ghali
Collège des commissaires aux comptes:
- David Louis Richter
- Irvin Elliot Richter
f. Date à laquelle les données financières de la Société Dissoute seront comptabilisées dans les comptes annuels de la

Société Acquérante.

Les données financières de la Société Dissoute seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Acqué-

rante au 1 

er

 JANVIER 2011. Le dernier exercice financier de la Société Dissoute se terminera par conséquent le 31

décembre 2010.

g. Mesures proposées relatives à l'attribution d'actions.
Dans cette fusion transfrontalière, la Société Acquérante détient l'intégralité du capital social de la Société Dissoute

et il n'y aura PAS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS dans la Société Acquérante.

h. Projet de continuation ou de cessation des activités.
Les activités de la Société Dissoute seront poursuivies par la Société Acquérante.
i. Approbations sociales du projet commun de fusion.
L'approbation par le collège des commissaires aux comptes de la Société Acquérante de la fusion transfrontalière est

prouvée par la signature conjointe de ce projet par tous les membres du collège des commissaires aux comptes, qui devra
également être considérée comme une résolution écrite du collège des commissaires aux comptes conformément à la
Section 19 sous-section 4 des statuts de la Société Acquérante.

j. Effets de la fusion sur la clientèle et les réserves distribuables de la Société Acquérante.
Les effets de la fusion transfrontalière sur la clientèle sont les suivants:
AUCUN.
Les effets de la fusion transfrontalière sur les réserves distribuables de la Société Acquérante sont les suivants:
AUCUN,
k. Effets probables sur l'emploi.
La  fusion  transfrontalière  n'est  PAS  CENSÉE  AVOIR  UN  QUELCONQUE  EFFET  MATÉRIEL  sur  l'emploi  car  les

activités de la Société Dissoute seront poursuivies par la Société Acquérante.

l. Procédures de participation des salariés.
Dans la mesure où aucune des Sociétés Fusionnantes n'est sujette à des règles nationales relatives à la participation

des salariés dans l'Etat Membre de l'Union Européenne dans lequel elle a son siège social, AUCUN ACCORD DE PAR-
TICIPATION DES SALARIÉS conformément à la Section 2:333k du Code civil Hollandais ne doit être établi par la Société
Acquérante.

m. Information sur l'évaluation des actifs et passifs de la Société Dissoute qui seront acquis par la Société Acquérante.
L'évaluation des actifs et passifs de la Société Dissoute qui seront acquis par la Société Acquérante sera établie sur

base des comptes annuels au 31 décembre 2009 établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires
luxembourgeoises et les principes comptables généralement acceptés à Luxembourg:

- la méthode d'évaluation utilisée afin d'évaluer les actifs financiers de la Société Acquérante est le coût d'acquisition;
- les coûts d'acquisition visés ci-dessus incluent les frais et dépenses liés à l'acquisition;
- les actifs en devises autres qu'EUR sont convertis en EUR au taux de change en vigueur au jour de la transaction;
- les droits et obligations en devises autres qu'EUR sont convertis en EUR au taux de change en vigueur en fin d'année

sauf si la conversion abouti à un gain de change non réalisé;

- toute perte de change réalisée ou non et le gain de change résultant de ces conversions sont comptabilisés dans le

compte de résultat.

125094

L

U X E M B O U R G

n. Date des derniers comptes annuels ou comptes intérimaires.
La date des derniers comptes annuels des Sociétés Fusionnantes utilisés afin d'établir les conditions de la fusion trans-

frontalière est:

Société Acquérante:
Non disponible car la Société Acquérante n'a été constituée que récemment.
Société Dissoute:
31 décembre 2009
o. Proposition relative au niveau de contrepartie des associés.
Aucune contrepartie n'est proposée aux associés qui voteront contre la proposition d'effectuer une fusion transfron-

talière dans la mesure où il n'est pas envisageable que ces votes puissent être émis contre la proposition.

p. Annexes.
Les annexes à la présente font partie intégrante de ce projet.
q. Informations accessoires
Tous documents se rapportant à la Société Acquérante sont enregistrés au registre de commerce et des sociétés

d'Amsterdam.

Tous les documents sociaux et livres de comptes de la Société Dissoute seront déposés et disponibles, sur demande,

au siège social de la Société Acquérante durant le période requise par la Loi sur les Sociétés.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaut.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Oostvogels et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52416. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2010.

Martine SCHAEFFER.

Loyens &amp; Loeff N.V.
Blaak 31, 3011 GA Rotterdam
Postbus 2888,3000 CW Rotterdam

Deed of incorporation of:
Hill International N.V.
27 September 2010

OPRICHTING N.V.
(Hill International N.V.)

Op zeven en twintig september twee duizend tien is voor mij, mr. Gerard Cornelis van Eck, notaris met plaats van

vestiging Rotterdam, verschenen:

mr. Bastiaan Cornelis Cornelisse, geboren te Reimerswaal op veertien oktober negentienhonderd vierenzeventig, met

kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

Hill International, Inc., een vennootschap naar het recht van de Staat New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,

gevestigd te Marlton, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, kantoorhoudende te 303 Lippincott Centre, Marlton,
NJ 0805341, Verenigde Staten van Amerika, hierna: de "oprichter".

De comparant heeft het volgende verklaard:
de oprichter richt hierbij op een naamloze vennootschap, hierna: de "vennootschap", met de volgende Statuten.

Statuten

Art. 1. Begripsbepalingen.
1.1 In deze Statuten wordt verstaan onder:
a. een "aandeel":
een aandeel in net kapitaal van de vennootschap;
b. een "aandeelhouder":

125095

L

U X E M B O U R G

een houder van één of meer aandelen;
c. de "algemene vergadering":
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders;
d. een "algemene vergadering van aandeelhouders":
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
e. de "directie":
het bestuur van de vennootschap;
f. de "raad van commissarissen":
de raad van commissarissen van de vennootschap;
g. "schriftelijk":
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische - weg toegezonden leesbaar en reprodu-

ceerbaar bericht, mits de identiteit - van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

h. het "uitkeerbare eigen vermogen":
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die

krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

i. een "vennootschapsorgaan":
de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze Statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

Art. 2. Naam en zetel.
2.1 De naam van de vennootschap is:
Hill international N.V.
2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. Doel. De vennootschap heeft ten doel:
a. advisering in de bouwsector, in het bijzonder, het managen van bouwprocessen en het proces na constructie;
b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen

en vennootschappen;

c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of

andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de

vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap

ten behoeve  van ondernemingen  en vennootschappen  waarmee de vennootschap in een groep  is  verbonden  en ten
behoeve van derden;

g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het alge-

meen;

h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigen-

domsrechten;

j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Art. 4. Maatschappelijk kapitaal.
4.1  Het  maatschappelijk  kapitaal  van  de  vennootschap  bedraagt  twee  honderd  vijf  en  twintig  duizend  euro  (EUR

225.000).

4.2  Het  maatschappelijk  kapitaal  is  verdeeld  in  twee  honderd  vijf  en  twintig  duizend  (225.000)  aandelen  met  een

nominaal bedrag van één euro (EUR 1) elk.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Art. 5. Register van aandeelhouders.
5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden

opgenomen.

5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

125096

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Uitgifte van aandelen.
6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootscha-

psorgaan  dat  daartoe  bij  besluit  van  de  algemene  vergadering  voor  een  bepaalde  duur  van  ten  hoogste  vijf  jaren  is
aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens
voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
6.3 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke

nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 6.4. De ven-
nootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan. De aankondiging
geschiedt schriftelijk aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.

6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene

vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig artikel 6.1 aangewezen
vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren
is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan teikens voor niet
langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor
een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een
meerderheid  van  ten  minste  twee  derden  van  de  uitgebrachte  stemmen  vereist,  indien  minder  dan  de  helft  van  het
geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.

6.5 Binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan

als bedoeld in artikel 6.1, danwel tot beperking of uitsluiting van voorkeurs rechten als bedoeld in artikel 6.4, legt de
vennootschap de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.

6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van

vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

6.7 Het bepaalde in de artikelen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten

tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6.8 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel

voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

Art. 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.
7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen,

met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.

7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met

inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

Art. 8. Levering van aandelen.
8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van

vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zeit bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel ver-

bonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar
is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Art. 9. Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering).
9.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit

artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle medeaandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben
verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

9.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (hierna: de "verzoeker") behoeft daarvoor de

goedkeuring van de algemene vergadering. Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving
gericht aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat de verzoeker wenst over te dragen en de persoon of
personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De directie is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot
goedkeuring een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na
ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld.

9.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de verzoeker tot drie maanden nadien

de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe
in het verzoek om goedkeuring waren genoemd.

9.4 Indien:
a. door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken

nadat het verzoek door de directie is ontvangen; of

125097

L

U X E M B O U R G

b. de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de

verzoeker opgave doet van één of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring
betrekking heeft tegen contante betaling te kopen (hierna: "gegadigden"), wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn
verleend en wel, in het onder a bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes weken. De
vennootschap kan alleen met instemming van de verzoeker als gegadigde optreden.

9.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen door de gegadigden worden gekocht

tegen een prijs, die wordt vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer door
hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de
prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te
benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handels-
register.

Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap

en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

9.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de

aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij wensen te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen
genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin
kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden.

9.7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke

gegadigde of gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen
welke prijs.

9.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen

ontvangstbewijs. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt overeenkomstig hetgeen ter-
zake in deze Statuten is bepaald.

9.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun prijsvaststelling komen ten laste van:
a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door gegadigden zijn gekocht,

met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.
9.10 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen

van aandelen en voorkeursrechten.

Art. 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.
10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en

op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.

10.2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een

aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend. De pandhouder of vruchtge-
bruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap
uitgegeven certificaten van haar aandelen.

Art. 11. Certificaten van aandelen. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van

aandelen.

Art. 12. Directeuren.
12.1 De directie bestaat uit één of meerdirecteuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur

zijn.

12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
12.3 ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een directeur

kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

12.4 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast.
12.5 De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het in artikel 12.4 bedoelde beleid vastgesteld door

de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn
bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directeuren mogen worden toegekend en welke
criteria gelden voor toekenning of wijziging.

12.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering fast de bevoegdheid van de raad van commis-

sarissen op grond van artikel 12.5 niet aan.

Art. 13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.
13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.

125098

L

U X E M B O U R G

13.2 In de directie heeft ledere directeur één stem.
13.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uit gebrachte stemmen.
13.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriffelijk of op andere wijze, mits

het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie
zijnde directeuren.

13.5 Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door de directie wordt gehouden.
13.6 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader

kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van
commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en
taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.

13.7  De  directie  stelt  ten  minste  één  keer  per  jaar  de  raad  van  commissarissen  schriftelijk  op  de  hoogte  van  de

hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de
vennootschap.

Art. 14. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.
14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt

mede aan iedere directeur toe.

14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van

hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur
van  deze  functionarissen  wordt  door  de  directie  bepaald.  Deze  functionarissen  kunnen  worden  ingeschreven  in  het
Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbe-
voegdheid  van  een  aldus  benoemde  functionaris  kan  zich  niet  uitstrekken  tot  gevallen  waarin  de  vennootschap  een
tegenstrijdig belang heeft met de des betreffende functionaris of met één of meer directeuren.

14.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het

bepaalde in artikel 14.1 onverkort van kracht tenzij de algemene vergaderîng één of meer andere personen heeft aange-
wezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van
de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé
betreff, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, maar het ontbreken van zodanige goed-
keuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Art. 15. Goedkeuring van directiebesluiten.
15.1 Onverminderd het in de wet en het eiders in deze Statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van

commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omirent:

a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven

van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verieend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, aismede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het

gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of vennootschap en het ver-

breken van zodanige samenwerking;

e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen

van de omvang van zodanige deelneming;

f. het oprichten van vennootschappen;
g. (des)investeringen;
h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

i. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 14.2 van deze Statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid

en titulatuur;

j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen

van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de algemene

vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;

m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen

voortvloeien;

n. het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen.

125099

L

U X E M B O U R G

15.2 De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 15.1 hiervoor bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring

is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan
de directie op te geven waarde niet te boven gaat.

15.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 15.1 hiervoor zijn genoemd aan

haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de
directie te worden meegedeeld.

15.4 Voor de toepassing van de artikelen 15.1,15.2 en 15.3 hiervoor wordt met een besluit van de directie tot het

verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan
van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan
goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van de directie zou zijn.

15.5 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast

de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Art. 16. Ontstentenis of belet. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren

of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet
van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap
belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/
of één of meer andere personen.

Art. 17. Commissarissen.
17.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit één of meer commissarissen. Alleen natuurlijke

personen kunnen commissaris zijn.

17.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
17.3 ledere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
17.4 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen.

Art. 18. Taak en werkwijze van de raad van commissarissen.
18.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene

gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbunden onderneming. Hij Staat de directie met raad terzijde. Bij
de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.

18.2 De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissa-

rissen.

18.3 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van

commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze Statuten is bepaald.

18.4 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de directie dat nodig acht.
18.5 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere

commissaris.

18.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de -raad van commissarissen of de

directie dat nodig acht.

Art. 19. Besluitvorming door de raad van commissarissen.
19.1 In de raad van commissarissen heeft ledere commissaris één stem.
19.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte

stemmen.

19.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van

de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

19.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op

andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen
zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.

Art. 20. Boekjaar en jaarrekening.
20.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
20.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste

zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening
op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

20.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396

lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

20.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
20.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening

van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

125100

L

U X E M B O U R G

20.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd.

Het bepaalde in artikel 20.3 is van overeenkomstige toepassing.

20.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wetteiijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot on-

derzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.

20.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
20.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren en de commissarissen

voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Art. 21. Winst en uitkeringen.
21.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene

vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt
tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.

21.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
21.3 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen en/of tot het doen

van uitkeringen op aandelen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot het doen
van tussentijdse uitkeringen op aandelen.

21.4 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddeliijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een ander

tijdstip is vastgesteld.

21.5 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen

vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermo-
gensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling
ten kantore van het Handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend
gemaakt.

21.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, teilen de aandelen in haar kapitaal die de

vennootschap houdt, niet mee.

Art. 22. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
22.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het

boekjaar.

22.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van

commissarissen dat nodig acht.

22.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van

de vennootschap hebben het recht aan de directie of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering
van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie
of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen
zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Art. 23. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.
23.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commis-

sarissen.  Voorts  kunnen  aigemene  vergaderingen  van  aandeelhouders  bijeengeroepen  worden  door  aandeelhouders,
tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van net geplaatste kapitaal van de vennootschap, onverminderd het
bepaalde in artikel 22.3.

23.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
23.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in

artikel 23.2 bedoelde termijn.

23.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan zestig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is

verzocht door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het ge-
plaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de
overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

23.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals

deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van door een
oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

23.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens

deze Statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan
kunnen geldige besluiten van de aigemene vergadering alleen worden genomen, Indien het gehele geplaatste kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigd is.

125101

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Toegang en vergaderrechten.
24.1 ledere aandeelhouder is bevoegd de aigemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord

te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door
een schriftelijk gevolmachtigde.

24.2 ledere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de

vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering
aanwezig zijn.

24.3 De directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een

raadgevende stem.

24.4 Indien aan een accountant opdracht is verleend tot onderzoek van de jaarrekening, is de desbetreffende accountant

bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten bij
te wonen en daarin het woord te voeren.

24.5 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Art. 25. Voorzitter en notulist van de vergadering.
25.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de raad van commis-

sarissen. Bij gebreke daarvan wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige
stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het motnent waarop dat is gebeurd, treedt
een directeur als voorzitter op, danwel Indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter ver-
gadering aanwezige persoon.

25.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Art. 26. Notulen, aantekening van aandeelhoudersbesiuiten.
26.1 Van het verhandele in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist

van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke
daarvan door hen ondertekend.

26.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet

ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen
besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit
de aantekeningen verstrekt.

Art. 27. Besluitvorming in vergadering.
27.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
27.2 Voor zover de wet of deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de

algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

27.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
27.4 Indien de door de wet of deze Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene

vergaderingen  van  aandeelhouders  niet  in  acht  zijn  genomen,  kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten  van de
algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd
en met algemene stemmen.

27.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de

vennootschap  of  een  dochtermaatschappij  de certificaten houdt, kan in de  algemene vergadering geen  stem worden
uitgebracht.

Art. 28. Besluitvorming buiten vergadering.
28.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook

schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in
artikel 24.3 is van overeenkomstige toepassing.

28.2 ledere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besiuiten zo spoedig mogelijk

schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besiuiten aantekening en voegt
deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 26.2.

Art. 29. Statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd deze Statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene

vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot
de vergadering worden vermeld.

Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten

kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

125102

L

U X E M B O U R G

Art. 30. Ontbinding en vereffening.
30.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt
gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.

30.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren

vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besiuiten andere personen
tot vereffenaars te benoemen.

30.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zo veel mogelijk van kracht.
30.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen

aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

30.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk

Wetboek.

Art. 31. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december twee duizend elf. Dit artikel

vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

<i>Overgangsbepaling

Het bepaaide in de artikelen 17 tot en met 19 van deze Statuten, alsmede het overigens in deze Statuten bepaalde

omtrent commissarissen en de raad van commissarissen, wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de
algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het Handelsregister. Tot dat moment
komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend, voor zover mogelijk,
toe aan de algemene vergadering.

<i>Slotbepalingen

Op rechtshandelingen van de vennootschap
a. strekkende tot het verkrijgen van goederen die een jaar voor oprichting van de vennootschap of nadien toebe-

hoorden aan de oprichter van de vennootschap; en

b. die worden verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving van de vennootschap in het Handelsregister,
is van toepassing het bepaalde in artikel 2:94c van het Burgerlijk Wetboek.

<i>Ten slotte heeft de comparant verklaard:

a. Het bij oprichting geplaatste kapilaal van de vennootschap bedraagt vijf en veertig duizend euro (EUR 45.000) en is

verdeeld in vijf en veertig duizend (45.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1) elk (hierna: de
"geplaatste aandelen").

Alle geplaatste aandelen worden hierbij genomen door de oprichter.
De geplaatste aandelen worden a pari geplaatst.
De geplaatste aandelen zijn in geld volgestort. Storfing in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de

stukken waarvan artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage). De vennootschap aanvaardt
hierbij de Stortingen op de geplaatste aandelen.

b. Voor de eerste maal worden tot directeur van de vennootschap benoemd:
- Petrus Hendrik Bosse, wonende te (1187 VZ) Amstelveen, Bertus Aafjeslaan 28 en geboren in Amstelveen op vijf

november negentien honderd vijf en zestig; en

- Raouf Sobhi Ghali, wonende te Lord Byron 4, Pallini, Athene 15344, Griekenland en geboren in Egypte, Egypte op

zes en twintig juni negentien honderd één en zestig.

<i>Verklaring van geen bezwaar

Terzake van deze oprichting is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op vier en twintig September

twee duizend tien, onder nummer N.V. 1614549, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van
Justitie die aan deze akte is gehecht (Bijlage).

<i>Volmacht

Van gemeide volmacht op de comparant is mij, notaris, gebleken uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke

aan deze minuut zal worden gehecht (Bijlage).

<i>Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de

inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

125103

L

U X E M B O U R G

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
mr. G.C. van ECK
<i>Notaris te Rotterdam

NOTE ABOUT TRANSLATION:
This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has

been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however,
differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The

concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood
under the laws of other jurisdictions.

INCORPORATION N.V.
(Hill International N.V.)

This twenty-seventh day of September two thousand ten, there appeared before me, Gerard Cornelis van Eck, civil-

law notary at Rotterdam:

Bastiaan  Cornelis  Cornelisse,  born  in  Reimerswaal,  the  Netherlands,  on  the  fourteenth  day  of  October  nineteen

hundred and seventy-four, employed at Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, the Netherlands, for the purposes hereof acting
as attorney duly authorized in writing of:

Hill International, Inc., a company under the laws of the State of New Jersey, having its official seat in Marlton, New

Jersey, United States of America, and its office address at 303 Lippincott Centre, Marlton, NJ 0805341, United States of
America, hereinafter: the "Incorporator".

The person appearing declared the following:
the Incorporator hereby incorporates a limited liability company under Dutch law ('naamloze vennootschap) (here-

inafter: the "Company"), with the following Articles of Association.

Articles of Association:

Art. 1. Definitions.
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a "Share":
a share in the capital of the Company;
b. a "Shareholder":
a holder of one or more Shares;
c. the "Shareholders' Body":
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
d. a "General Meeting of Shareholders":
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
e. the "Management Board":
the management board of the Company;
f. the "Supervisory Board":
the supervisory board of the Company;
g. "in writing":
by letter, by telecopier, by e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided

that the identity of the sender can be sufficiently established;

h. the "Distributable Equity":
the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be

maintained pursuant to the law;

i. a "Company Body":
the Management Board, the Supervisory Board or the Shareholders' Body.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is

apparent.

Art. 2. Name and Official Seat.
2.1 The Company's name is:
Hill International N.V.

125104

L

U X E M B O U R G

2.2 The official seat of the Company is in Amsterdam, the Netherlands.

Art. 3. Objects.
The objects of the Company are:
a. consulting in the area of the real estate construction, in particular, the management of construction process and the

follow up of construction;

b. to Incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies;
c. to finance businesses and companies;
d. to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence

of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities;

e. to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third

parties;

f. to grant guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with

which it forms a group and on behalf of third parties;

g. to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;
h. to trade in currencies, securities and items of property in general;
i. to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial property rights;
j. to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature; and to do all that is connected

therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Art. 4. Authorized Capital.
4.1 The authorized capital of the Company equals two hundred twenty-five thousand euro (EUR 225,000).
4.2 The authorized capital of the Company is divided into two hundred twenty-five thousand (225,000) Shares with a

nominal value of one euro (EUR 1) each.

4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.

Art. 5. Register of Shareholders.
5.1 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders

are recorded.

5.2 Section 2:85 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders.

Art. 6. Issuance of Shares.
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the Shareholders' Body or of another Company Body designated

for that purpose by a resolution of the Shareholders' Body for a fixed period, not exceeding five years. On such designation
the number of Shares which may be issued must be specified. The designation may be extended, from time to time, for
periods not exceeding five years. Unless such designation provides otherwise, it may not be withdrawn.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal

value of his Shares, subject to the relevant limitations prescribed by law and the provisions of Article 6.4. The Company
announces the issue of Shares with a right of pre-emption and the period in which that right can be exercised. The
announcement shall be made in writing to all shareholders at the address stated by them to the Company.

6.4 Prior to each single issuance, the right of pre-emption may be limited or excluded by a resolution of the Share-

holders' Body. The right of pre-emption may also be limited or excluded by the Company Body designated pursuant to
Article 6.1, if, by a resolution of the Shareholders' Body, it was designated and authorized for a fixed period, not exceeding
five years, to limit or exclude such right of pre-emption. The designation may be extended, from time to time, for a period
not exceeding five years. Unless the designation provides otherwise, it may not be withdrawn. If less than one-half of the
Company's issued capital is represented at the meeting, a majority of at least two-thirds of the votes cast shall be required
for a resolution of the Shareholders' Body to limit or exclude such right of pre-emption or to make such designation.

6.5 Within eight days after a resolution to issue Shares or to designate another Company Body as referred to in Article

6.1, or to limit or exclude rights of preemption as referred to in Article 6.4, the Company shall deposit the complete text
thereof at the office of the Commercial Register.

6.6 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law

notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.

6.7 The provisions of Articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for

Shares, but do not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.

6.8 On issue of a Share, the full nominal value thereof must be paid in, and, in addition, if the Share is issued at a higher

amount, the difference between such amounts.

125105

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Own Shares; Reduction of the Issued Capital.
7.1 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due ob-

servance of the limitations prescribed by law.

7.2 The Shareholders' Body may resolve to reduce the Company's issued capital in accordance with the relevant

provisions prescribed by law.

Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

8.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it, in accordance with the relevant
provisions of the law.

Art. 9. Blocking Clause (approval Shareholders' Body).
9.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article

9, unless (i) all co-Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a
period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder.

9.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the "Applicant") shall require the approval

of the Shareholders' Body for such transfer. The request for approval shall be made by the Applicant by means of a written
notification to the Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer and the person or persons to
whom the Applicant wishes to transfer such Shares. The Management Board shall be obliged to convene and to hold a
Genera! Meeting of Shareholders to discuss the request for approval within six weeks from the date of receipt of the
request. The contents of such request shall be stated in the convocation.

9.3 Within a period of three months of the Shareholders' Body granting the approval requested, the Applicant may

transfer the total number of the Shares to which the request relates, and not part thereof, to the person or persons
named in the request.

9.4 If:
a. the Shareholders' Body does not adopt a resolution regarding the request for approval within six weeks after the

request has been received by the Management Board; or

b. the approval has been refused without the Shareholders' Body having informed the Applicant, at the same time as

the refusal, of one or more interested parties who are prepared to purchase all the Shares to which the request for
approval relates for payment in cash (hereinafter: "Interested Parties"),

the approval requested shall be considered to have been granted, in the event mentioned under a on the final day of

the six week period mentioned under a.

The Company shall only be entitled to act as an Interested Party with the consent of the Applicant.
9.5 The Shares to which the request for approval relates can be purchased by the Interested Parties at a price to be

mutually agreed between the Applicant and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they
do not reach agreement on the price or the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more
independent experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the
Chamber of Commerce at which the Company is registered in the Commercial Register. If an expert is appointed, he
shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful
to him in setting the price.

9.6 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of the

number of the Shares to which the request for approval relates they wish to purchase. An Interested Party who fails to
submit notice within said term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the
preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

9.7 The Applicant may withdraw up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party or

Parties he can sell all the Shares to which the request for approval relates and at what price.

9.8 All notifications and notices referred to in this Article 9 shall be made by certified mail or against acknowledgement

of  receipt.  The  convocation  of  the  General  Meeting  of  Shareholders  shall  be  made  in  accordance  with  the  relevant
provisions of these Articles of Association.

9.9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,

shall be borne by:

a. the Applicant if he withdraws;
b. the Applicant and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,

provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;

c. the Company, in cases not provided for under a or b.
9.10 The preceding provisions of this Article 9 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of

pre-emption.

125106

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.
10.1 The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a

usufruct in Shares.

10.2 If a Share is pledged or if a usufruct in a Share is created or transferred, the voting rights attributable to such

Share may not be assigned to the pledgee or usufructuary. The pledgee or usufructuary shall not have the rights conferred
by law upon holders of depositary receipts issued with a company's cooperation for shares in its capital.

Art. 11. Depositary Receipts for Shares. The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for

Shares.

Art. 12. Management Board Members.
12.1 The Management Board shall consist of one or more members. Both individuals and legal entities can be Man-

agement Board members.

12.2 Management Board members are appointed by the Shareholders' Body.
12.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the Shareholders' Body at any time. A Man-

agement Board member may also be suspended by the Supervisory Board. A suspension by the Supervisory Board may
be discontinued at any time by the Shareholders' Body.

12.4 The Shareholders' Body shall adopt the remuneration policy in respect of remuneration of the Management Board.
12.5 The remuneration for Management Board members shall be adopted by the Supervisory Board taking into account

the policy referred to in Article 12.4, provided that arrangements in the form of Shares or rights to subscribe for Shares
are subject to the approval of the Shareholders' Body. The request for approval shall at least state the number of Shares
or rights to subscribe for Shares that may be granted to the Management Board members and which criteria apply to the
granting or amendment thereof.

12.6 The absence of approval of the Shareholders' Body shall not affect the authority of the Supervisory Board pursuant

to Article 12.5.

Art. 13. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.
13.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
13.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
13.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast.
13.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided

the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this
manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Man-
agement Board members then in office.

13.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management

Board.

13.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.

In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The Supervisory Board may decide that such rules and allocation of duties must be put in
writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

13.7 The Management Board shall at least once a year inform the Supervisory Board in writing of the headlines of the

strategic policy, the general and financial risks and the management and control system of the Company.

Art. 14. Representation; Conflicts of Interest.
14.1 The Company shall be represented by the Management Board. Each Management Board member shall also be

authorized to represent the Company.

14.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each

officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board
shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, indicating the scope of
their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not extend to any transaction
where  the  Company  has  a  conflict  of  interest  with  the  officer  concerned  or  with  one  or  more  Management  Board
members.

14.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the

provisions of Article 14.1 shall continue to apply unimpaired unless the Shareholders' Body has appointed one or more
other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict. A resolution
of the Management Board with respect to a matter involving a conflict of interest with one or more Management Board
members in a private capacity shall be subject to the approval of the Supervisory Board, but the absence of such approval
shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

125107

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Approval of Management Board Resolutions,
15.1 Without prejudice to any other applicable provisions of the law or these Articles of Association, the Management

Board shall require the prior approval of the Supervisory Board for resolutions relating to:

a. acquiring, alienating, encumbering, leasing, letting and in any other way obtaining and giving the use or benefit of

registered property;

b. entering into agreements, whereby the Company is granted credit by a bank;
c. lending and borrowing money, with the exception of acquiring money under a credit already granted to the Company

by a bank;

d. long term direct or indirect cooperation with another company and the termination of such cooperation;
e. direct or indirect participation in the capital of another company and changing the size of any such participation;
f. incorporating new companies;
g. investments and divestitures;
h. entering into agreements by which the Company binds itself as guarantor or as severally-liable co-debtor, or oth-

erwise guarantees or agrees to bind itself as security for a debt of a third party;

i. appointing staff members as referred to in Article 14.2 of these Articles of Association and determining their authority

and title;

j. making settlements;
k. being a party to legal proceedings, including conducting arbitration proceedings with the exception of taking legal

measures that cannot be delayed;

l. entering into and changing employment agreements, whereby remuneration is granted, which exceeds the annual

maximum amount determined by the Shareholders' Body and notified to the Management Board in writing;

m. establishing pension plans and granting pension rights in excess of those arising from existing arrangements;
n. exercising the voting rights attributable to shares held by the Company.
15.2 The Supervisory Board may determine that a resolution as referred to in Article 15.1 hereof shall not require its

approval if the amount involved does not exceed a value fixed by the Supervisory Board and notified to the Management
Board in writing.

15.3 The Supervisory Board shall be entitled to require further resolutions of the Management Board in addition to

those listed in Article 15.1 hereof to be subject to its approval. Such further resolutions shall be clearly specified and
notified to the Management Board in writing.

15.4 For the application of the provisions of Articles 15.1,15.2 and 15.3 hereof, a resolution of the Management Board

approving a resolution of any body of a company in which the Company participates shall be treated as a resolution of
the Management Board to enter into a transaction, if the resolution to be approved would be subject to the prior express
approval provided for in this Article 15 if it were a resolution of the Management Board.

15.5 The absence of approval by the Supervisory Board for a resolution as referred to in this Article 15 shall not affect

the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

Art. 16. Vacancy or Inability to Act. If a seat is vacant on the Management Board ('onistentenis') or a Management

Board member is unable to perform his duties ('belet'), the remaining Management Board members or member shall be
temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all
Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their
duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to the Supervisory Board, with the authority to
temporarily entrust the management of the Company to one or more Supervisory Board members and/or one or more
other persons.

Art. 17. Supervisory Board Members.
17.1 The Company shall have a Supervisory Board consisting of one or more members. Only individuals may be

Supervisory Board members.

17.2 Supervisory Board members are appointed by the Shareholders' Body.
17.3 Each Supervisory Board member may be suspended or dismissed by the Shareholders' Body at any time.
17.4 The Shareholders Body may establish a remuneration for Supervisory Board members.

Art. 18. Duties and Proceedings of the Supervisory Board.
18.1 It shall be the duty of the Supervisory Board to supervise the management of the Management Board and the

general course of affairs in the Company and the business connected with it. The Supervisory Board shall assist the
Management Board by giving advice. In performing their duties the Supervisory Board members shall act in accordance
with the interests of the Company and the business connected with it.

18.2 The Shareholders' Body may appoint one of the Supervisory Board members as chairperson of the Supervisory

Board.

125108

L

U X E M B O U R G

18.3 The Supervisory Board may establish rules regarding its decision-making process and working methods, in addition

to the relevant provisions of these Articles of Association.

18.4 The Supervisory Board shall meet whenever a Supervisory Board member or the Management Board deems

necessary.

18.5 A Supervisory Board member may be represented at a meeting by another Supervisory Board member authorized

in writing.

18.6 The Supervisory Board shall meet with the Management Board as often as the Supervisory Board or the Man-

agement Board deems necessary.

Art. 19. Decision-making Process of the Supervisory Board.
19.1 When making Supervisory Board resolutions, each Supervisory Board member may cast one vote.
19.2 All resolutions of the Supervisory Board shall be adopted with more than half of the votes cast.
19.3 At a meeting, the Supervisory Board may only pass valid resolutions if the majority of the Supervisory Board

members then in office are present or represented.

19.4 Supervisory Board resolutions may also be adopted in a manner other than at a meeting, in writing or otherwise,

provided the proposal concerned is submitted to all Supervisory Board members then in office and none of them objects
to the relevant manner of adopting resolutions.

Art. 20. Financial Year and Annual Accounts.
20.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
20.2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances

this period is extended by the Shareholders' Body by not more than six months, the Management Board shall prepare
annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.

20.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the annual report for inspection by the Share-

holders, unless Section 2:396, subsection 6 or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company.

20.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
20.5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members and the Supervisory Board members. If

the signature of one or more of them is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

20.6 Annually, the Supervisory Board shall prepare a report, which shall be enclosed to the annual accounts and the

annual report. The provision of Article 20.3 shall apply by analogy.

20.7 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the Shareholders' Body.

20.8 The Shareholders' Body shall adopt the annual accounts.
20.9 The Shareholders' Body may grant full or limited discharge to the Management Board members and the Super-

visory Board members for the management pursued and the supervision thereof, respectively.

Art. 21. Profits and Distributions.
21.1 The allocation of profits accrued in a financial year shall be determined by the Shareholders' Body. If the Share-

holders' Body does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at latest immediately after
the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved.

21.2 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the law given the

contents of the annual accounts.

21.3 The Shareholders' Body may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make distributions on

Shares at the expense of any reserve of the Company. In addition, the Management Board may decide to make interim
distributions on Shares.

21.4 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless

another date of payment has been determined in the resolution.

21.5 Distributions may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable Equity

and, if it concerns an interim distribution, the compliance with this requirement is evidenced by an interim statement of
assets and liabilities as referred to in Section 2:105, subsection 4, of the Dutch Civil Code. The Company shall deposit
the statement of assets and liabilities at the office of the Commercial Register within eight days after the day on which
the resolution to distribute is published.

21.6 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

Art. 22. General Meetings of Shareholders.
22.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within six months after the end of the financial year.
22.2 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board or the Supervisory

Board deems such necessary.

22.3 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the

Management Board or the Supervisory Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the

125109

L

U X E M B O U R G

subjects to be discussed. If the Management Board or the Supervisory Board has not given proper notice of a General
Meeting of Shareholders within four weeks following receipt of such request such that the meeting can be held within six
weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves.

Art. 23. Notice, Agenda and Venue of Meetings.
23.1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board or the Supervisory Board.

Furthermore, notice of General Meetings of Shareholders may be given by Shareholders representing in the aggregate at
least half of the Company's issued capital, without prejudice to the provisions of Article 22.3.

23.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
23.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 23.2.

23.4 A subject for discussion of which discussion has been requested In writing not later than sixty days before the

day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent of the Com-
pany's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion,
provided that no important interest ('zwaarwichtig belang') of the Company dictates otherwise.

23.5 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders.

Instead of through notice fetters, any Shareholder that gives his consent, may be sent notice of the meeting by means of
a legible and reproducible message electronically sent to the address stated by him for this purpose to the company.

23.6 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association,

the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held elsewhere, but in that case valid
resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted if all of the Company's issued capital is represented.

Art. 24. Admittance and Rights at Meetings.
24.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and

to exercise his voting rights.

Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing.
24.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meeting

may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

24.3 The Management Board members and the Supervisory Board members shall, as such, have the right to give advice

in the General Meetings of Shareholders.

24.4 If an accountant has been appointed to audit the annual accounts, the accountant shall have the right to attend

the General Meeting of Shareholders and to express his views.

24.5 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

Art. 25. Chairperson and Secretary of the Meeting.
25.1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders shall be appointed by the Supervisory Board. If no such

appointment is made, the chairperson of the meeting shall be appointed with more than the half of the votes cast by the
persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall
act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the
meeting shall act as chairperson.

25.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Art. 26. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.
26.1 The secretary of a General Meeting of Shareholders shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The

minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by
them.

26.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the Shareholders' Body. If the Management

Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Management Board is provided
with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the
Company's office for inspection by the Shareholders. On application, each of them shall be provided with a copy of or
an extract from the records.

Art. 27. Adoption of Resolutions in a Meeting.
27.1 Each Share confers the right to cast one vote.
27.2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of

the Shareholders' Body shall be adopted by more than half of the votes cast.

27.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
27.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by law or these

Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted
in a meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by
unanimous vote.

125110

L

U X E M B O U R G

27.5 In the Shareholders' Body, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company or a subsidiary,

nor for any Share for which the Company or a subsidiary holds the depositary receipts.

Art. 28. Adoption of Resolutions without holding Meetings.
28.1 Resolutions of the Shareholders' Body may also be adopted in writing without holding a General Meeting of

Shareholders, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of
Article 24.3 shall apply by analogy.

28.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 26.2.

Art. 29. Amendment of the Articles of Association. The Shareholders' Body may resolve to amend these Articles of

Association. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting of Shareholders.
The notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited
and kept available at the Company's office for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting.

Art. 30. Dissolution and Liquidation.
30.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the Shareholders' Body. When a proposal

to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders, this must be stated in the notice of such
meeting.

30.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the Shareholders' Body, the Management Board members

shall become liquidators of the dissolved Company's property. The Shareholders' Body may decide to appoint other
persons as liquidators.

30.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
30.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

30.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of Book 2, Title 1, of the Dutch Civil Code.

Art. 31. The first financial year of the Company shall end on the thirty-first day of December two thousand eleven.

This article shall cease to exist after the end of the first financial year.

<i>Transitory Provision

The provisions of Articles 17 through 19 of these Articles of Association, as well as ail other provisions of these Articles

of Association with regard to the Supervisory Board and its members shall only come into effect if and as soon as a
resolution adopted by the Shareholders' Body pertaining to the formation of a Supervisory Board has been filed with the
Commercial Register. Until such time, all powers vested In the Supervisory Board under these Articles of Association
shall, to the extent possible, be vested in the Shareholders' Body.

<i>Final Provisions

Legal acts of the Company
a. pertaining to the acquisition of assets which were owned by the Incorporator of the Company, in either case within

one year prior to incorporation of the Company or thereafter, and

b. which occur within the two-years period following registration of the Company with the Trade Register,
shall be subject to the provisions of Section 2:94c of the Dutch Civil Code.
Finally, the person appearing has declared:
a. At incorporation, the issued capital of the Company equals forty-five thousand euro (EUR 45,000) and is divided

into forty-five thousand (45,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter: the "Issued Shares").

All of the issued Shares are hereby subscribed for by the incorporator.
The issued Shares are issued at par.
The Issued Shares have been paid for in cash. Payment in foreign currency is permitted. The documents which must

be attached by virtue of Section 2:93a of the Dutch Civil Code have been attached to this deed (Annex). The Company
hereby accepts the payments made for the Issued Shares.

b. The first Management Board members of the Company are:
- Petrus Hendrik Bosse, residing at (1187 VZ) Amstelveen, Bertus Aafjeslaan 28, the Netherlands and born in Am-

stelveen, the Netherlands, on the fifth day of November nineteen hundred sixty-five;

- Raouf Sobhi Ghali, residing at Lord Byron 4, Pallini, Athens 15344, Greece and born in Egypt, Egypt, on the twenty-

sixth day of June nineteen hundred sixty-one.

125111

L

U X E M B O U R G

<i>Statement Of No Objections

With respect to the foregoing incorporation, a ministerial Statement of No Objections of the Dutch Ministry of Justice

was granted on the twenty-fourth day of September two thousand ten, under number N.V. 1614549, which is evidenced
by a written statement from the Dutch Ministry of Justice attached to this deed (Annex).

<i>Power of Attorney

The authorization granted to the appearer is evidenced by one (1) power of attorney, which immediately after the

execution of this deed shall be attached to this deed (Annex).

<i>End

The person appearing is known to me, civil-law notary.
This deed was executed in Rotterdam on the date stated in the first paragraph of this deed.
The contents of the deed have been stated and clarified to the person appearing.
The person appearing has declared not to wish the deed to be fully read out, to have noted the contents of the deed

timely before its execution and to agree with the contents.

After limited reading, this deed was signed first by the person appearing and thereafter by me, civil-law notary.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2010. Relation: LAC/2010/52416. Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010156947/1197.
(100181836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Celesta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 118.742.

Selcius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 122.268.

L'an deux mille dix, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

a) Monsieur Régis DONATI, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-

mont,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme CELESTA S.A., ayant son siège social

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 118742, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 2 août 2006, publié au Mémorial C numéro 1986 du 24 octobre 2006,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 11 février 2010;
un  extrait  du  procès-verbal  de  ladite  réunion,  après  avoir  été  signé  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

b) Monsieur Jacopo ROSSI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme SELCIUS S.A., ayant son siège social

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 122268, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 8 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 103 du 2 février 2007,

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 11 février 2010;
un  extrait  du  procès-verbal  de  ladite  réunion,  après  avoir  été  signé  ne  varietur  par  les  comparants  et  le  notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes

et conditions du projet de fusion (fusion inversée) intervenu entre elles et ce, ainsi qu'il suit:

1. La société anonyme CELESTA S.A., prédésignée, au capital social de cent cinquante-cinq mille huit cent quarante

euros (155.840,- EUR) représenté par quinze mille cinq cent quatre-vingt-quatre (15.584) actions d'une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées, est détenue à 100% (actions, représentant la totalité du capital
social et donnant droit de vote) par la société anonyme SELCIUS S.A., prédésignée, au capital social de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune, entièrement libérées;

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés fusionnantes;

125112

L

U X E M B O U R G

- que les sociétés CELESTA S.A. et SELCIUS S.A. souhaitent fusionner pour des raisons de facilités administratives, de

gestion et de rationalisation économique;

- qu'il est projeté de réaliser une opération de fusion inversée par laquelle la filiale CELESTA S.A. absorberait la mère

SELCIUS S.A.;

- que les actionnaires de la société absorbée recevront les actions de la société absorbante au prorata du nombre des

actions qu'ils possédaient dans la société absorbée sans augmentation de capital dans la société CELESTA S.A.;

- qu'il y a donc lieu, afin de rationaliser la structure administrative et économique de ces entités, de procéder à une

fusion.

La société anonyme SELCIUS S.A., à absorber, ne possède aucun bien immobilier.
2. La société anonyme CELESTA S.A., société absorbante, entend fusionner (fusion inversée) conformément aux dis-

positions des articles 257 à 284 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, avec la société
anonyme SELCIUS S.A., société absorbée, par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1 

er

 janvier 2010.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent.
5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C

du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du

capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion.

8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive

comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations

à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits
au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
11.  Les  documents  sociaux  de  la  société  absorbée  seront  conservés  pendant  le  délai  légal  au  siège  de  la  société

absorbante.

12. Formalités
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-

viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;

- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
13. Remise de titres
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques
relatifs aux éléments et droits apportés.

14. Frais et droits
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article

271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

L'opération est considérée comme une fusion par absorption. Du point de vue fiscal, cette fusion s'opérera, en exo-

nération d'impôts conformément à l'application de l'article 170, alinéa 2 L.I.R.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s'élève approximativement à huit cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

125113

L

U X E M B O U R G

Signé: Régis DONATI, Jacopo ROSSI, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 24 novembre 2010. Relation GRE/2010/4052. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial. Recueil des Sociétés

et Associations.

Junglinster, le 24 novembre 2010.

J. SECKLER.

Référence de publication: 2010156386/99.
(100180216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2010.

Eurizon Liquidity Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2010155702/10.
(100178926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Eurizon Alternative Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2010155701/10.
(100178924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2010.

C.C.B. S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 258.052,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.733.

Sireo Immobilienfonds No.6 Türkiye I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 335.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 137.941.

Im Jahr zweitausendundzehn,
am zweiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz zu Sassenheim Großherzogtum Lu-

xemburg,

sind erschienen:

1. Herr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
handelnd für und im Namen des Verwaltungsrates (conseil d'administration) der Gesellschaft C.C.B. S.A. (vormals

Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV-FIS; vormals Sireo Immobilienfonds No. 6 SICAV), einer luxemburgischen Aktien-
gesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
registriert beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 119.733, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 27. September
2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 10. Oktober 2006, Nummer 1904, zuletzt
geändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars am 30. Juli 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations am 6. Oktober 2010, Nummer 2099 (die "Übernehmende Gesellschaft");

auf Grund einer Vollmacht, welche am 19. November 2010 durch den Verwaltungsrat der Übernehmenden Gesell-

schaft erteilt wurde,

UND

125114

L

U X E M B O U R G

2. Herr Tobias Lochen, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
handelnd für und im Namen des Geschäftsführerrates (conseil de gérance) der Gesellschaft Sireo Immobilienfonds No.

6 Türkiye I S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz
in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, registriert beim luxemburgischen Handels-
und  Gesellschaftsregister  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés)  unter  der  Nummer  B  137.941,  gegründet  gemäß
Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 10. April 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations am 16. Mai 2008, Nummer 1192, zuletzt geändert durch ... der Notarin Maître Blanche
Moutrier mit Amtssitz zu Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg) am 22. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations am 10. Juli 2009, Nummer 1335 (die "Übernommene Gesellschaft"),

auf Grund einer Vollmacht, welche am 19. November 2010 durch den Verwaltungsrat der Übernommenen Gesellschaft

erteilt wurde.

Die besagten Vollmachten, "ne varietur" durch die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und den unterzeich-

nenden Notar unterzeichnet, bleiben dieser Urkunde beigefügt um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen den Notar den folgenden Verschmelzungsplan

hinsichtlich der Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft in Form einer no-
tariellen Urkunde wie folgt zu erstellen:

I. Gemeinsamer Verschmelzungsplan

§ 1. Beteiligte Rechtsträger und Beteiligungsverhältnisse.
1.1 Die Firma der Übernommenen Gesellschaft lautet Sireo Immobilienfonds No. 6 Türkiye I S.à r.l. Die Übernommene

Gesellschaft ist eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in
4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, registriert beim luxemburgischen Handels-
und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 137.941. Das Gesellschaftskapital
der Übernommenen Gesellschaft beträgt EUR 335.500 (in Worten: Euro dreihundertfünfunddreißigtausendfünfhundert)
und ist eingeteilt in 3.355 (in Worten: dreitausenddreihundertfünfundfünfzig) Anteile. Die Einlagen auf die Gesellschaft-
santeile sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übernommenen Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

1.2 Einzige Gesellschafterin der Übernommenen Gesellschaft ist die Übernehmende Gesellschaft.
1.3 Die Firma der Übernehmenden Gesellschaft lautet C.C.B. S.A. Die Übernehmende Gesellschaft ist eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, registriert beim luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés)
unter der Nummer B 119.733. Das Gesellschaftskapital der Übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 258.052 (in Wor-
ten: Euro zweihundertachtundfünfzigtausendzweiundfünfzig) und ist eingeteilt in 280,760 (in Worten: zweihundertachtzig
Komma sieben sechs null) Aktien. Die Einlagen auf die Geschäftsanteile sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Über-
nehmenden Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

1.4 Sonderrechte im Sinne des Artikels 261 (2)f) des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10.

August 1915, wie geändert (das "Gesetz von 1915"), bestehen nicht und es wurden keine anderen Wertpapiere im Sinne
des Artikels 261 (2)f) des Gesetzes von 1915 als die Aktien in der Übernehmenden Gesellschaft ausgegeben.

§ 2. Gegenstand der Verschmelzung.
2.1 Die Übernehmende Gesellschaft plant die Verschmelzung mit der Übernommenen Gesellschaft durch deren Über-

nahme unter Anwendung der vereinfachten Verschmelzungsmodalitäten der Artikel 278 und 279 des Gesetzes von 1915.
Diese finden Anwendung, da die Übernehmende Gesellschaft sämtliche Gesellschaftsanteile an der Übernommenen Ge-
sellschaft hält.

2.2 Die Übernommene Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Vermögenswerten, Rechten und

Verbindlichkeiten auf die Übernehmende Gesellschaft im Wege einer vereinfachten Verschmelzung gemäß den Artikeln
261-264, 267, 268, 271-273, 274 des Gesetzes von 1915, jeweils soweit gemäß den Artikeln 278 und 279 des Gesetzes
von 1915 anwendbar, sowie gemäß den Artikeln 278 und 279 des Gesetzes von 1915.

2.3 Die Übernehmende Gesellschaft wird, sofern einschlägig, alle gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten erfüllen,

einschließlich Veröffentlichungen, Erklärungen und Zahlung von Gebühren oder Steuern, die im Rahmen der Übertragung
der Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten notwendig werden. Sie wird insbesondere, sofern einschlägig, alle
gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten erfüllen, um die Vermögenswerte in ihrem Namen eintragen zu lassen und um
die Übertragung der Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wirksam werden zu lassen.

2.4 Zum Wirksamkeitsdatum nach §3.1 dieses Verschmelzungsplans wird die Übernommene Gesellschaft der Über-

nehmenden Gesellschaft alle Originale ihrer Gesellschaftsdokumente, Kassenbücher, sonstige Dokumente der Buchhal-
tung,  Eigentumstitel  bezüglich  der  übernommenen  Vermögenswerte  und  Rechte,  Dokumente  über  vollzogene  oder
laufende Transaktionen, bestehende Verträge (zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf Bank-, Treuhand- oder Darle-
hensverträge), Konten, Akten, Archive und jegliche sonstige Dokumente in Bezug auf die übernommenen Vermögens-
werte und Rechte sowie ihr gesamtes bewegliches Vermögen übergeben. Die Übernommene Gesellschaft besitzt kein
unbewegliches Vermögen.

125115

L

U X E M B O U R G

2.5 Zum Wirksamkeitsdatum nach § 3.1 dieses Verschmelzungsplans erlischt die Übernommene Gesellschaft und die

Übernehmende Gesellschaft besteht mit den Angaben unter § 1.3 dieses Verschmelzungsplans fort.

2.6 Zum Wirksamkeitsdatum nach § 3.1 dieses Verschmelzungsplans enden die Mandate der Geschäftsführer und

Wirtschaftprüfer der Übernommenen Gesellschaft. Ihnen wird zu diesem Tag vollständige Entlastung erteilt.

2.7 Alle Dokumente, Akten und Unterlagen der Übernommenen Gesellschaft werden am Sitz der Übernehmenden

Gesellschaft während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufbewahrt.

§ 3. Wirksamkeit der Verschmelzung; Buchhalterischer Verschmelzungsstichtag.
3.1 Zwischen den Parteien sowie gegenüber Dritten wird die Verschmelzung einen Monat nach Veröffentlichung dieses

Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations gemäß Artikel 9 des Gesetzes von 1915 wirk-
sam (das "Wirksamkeitsdatum").

3.2 Für buchhalterische Zwecke gilt die Verschmelzung als vollzogen zum Ablauf des 30. November 2010. Nach dem

30. November 2010 (der "Verschmelzungsstichtag") gilt der Geschäftsbetrieb der Übernommenen Gesellschaft als auf
Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft geführt.

§ 4. Gegenleistung. Eine Gegenleistung entfällt, da die Übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der Über-

nommenen Gesellschaft ist (Artikel 278 des Gesetzes von 1915).

§ 5. Besondere Rechte und Vorteile.
5.1 Besondere Rechte im Sinne des Artikels 261 (2)f) des Gesetzes von 1915 sind nicht gewährt. Maßnahmen im Sinne

dieser Vorschriften sind nicht vorgesehen.

5.2 Besondere Vorteile im Sinne des Artikels 261 (2) g) des Gesetzes von 1915 werden nicht gewährt.

§ 6. Keine Prüfung des Verschmelzungsplans.
6.1 Gemäß Artikel 278 des Gesetzes von 1915 ist eine Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen

Prüfer nicht erforderlich.

6.2 Die Parteien verzichten hiermit auch ausdrücklich auf eine Prüfung des Verschmelzungsplans.

§ 7. Einsichtnahme und Aktionärsversammlung. Die Aktionäre der Übernehmenden Gesellschaft haben das Recht, die

in Artikel 267 (1) a), b) und c) des Gesetzes von 1915 aufgezählten Dokumente am Sitz der Übernehmenden Gesellschaft
während eines Monats ab Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions einzusehen. Ihnen werden auf einfache Anfrage vollständige oder teilweise Kopien dieser Dokumente kostenlos zur
Verfügung gestellt. Ein Aktionär der Übernehmenden Gesellschaft, der mindestens 5% der ... der Übernehmenden Ge-
sellschaft hält, hat das Recht, während eines ... Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations die Einberufung einer außerordentlichen Aktionärsversammlung zu verlangen, um über die Zus-
timmung zur Verschmelzung zu beschließen.

§ 8. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Verschmelzungsplans oder eine später in ihn aufgenommene

Bestimmung ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesem Verschmelzungsplan
herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Bestimmung
oder zur Ausfüllung der Lücke gilt mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die
rechtlich und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck
dieses Verschmelzungsplans gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des Verschmelzungsplans bedacht
hätten.

§ 9. Veröffentlichung des Verschmelzungsplans. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird der vorliegende Versch-

melzungsplan  in  Form  einer  notariellen  Urkunde  erstellt  und  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,
veröffentlicht.

§ 10. Kosten und Aufwendungen; Steuern. Die Kosten und Aufwendungen der Verschmelzung sowie etwaige Steuern

trägt die Übernehmende Gesellschaft. Das gilt auch bei einem Scheitern der Verschmelzung (soweit in diesem Fall Kosten
oder Steuern anfallen). Sofern notwendig wird die Übernehmende Gesellschaft Steuern der Übernommenen Gesellschaft
zahlen, die bis zum Verschmelzungsstichtag noch nicht veranschlagt bzw. bezahlt worden sind.

II. Notarielle Bestätigung

Der unterzeichnende Notar erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 271 des Gesetzes von 1915, dass er das Vorliegen

und die Rechtmäßigkeit der erforderlichen Rechtshandlungen und Formalitäten hinsichtlich des vorliegenden Verschmel-
zungsplans überprüft hat und bestätigt diese.

III. Kosten und Aufwendungen

Die Kosten, Aufwendungen, Entgelte oder Gebühren, in welcher Form auch immer, die im Zusammenhang mit der

vorliegen Urkunde der Übernehmenden Gesellschaft auferlegt und ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf zwei-
tausend Euro geschätzt.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg, an dem eingangs erwähnten Datum erstellt.

125116

L

U X E M B O U R G

Nachdem dieses Dokument den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar nach ihren Namen,

Vornamen, Familienstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die Bevollmächtigten der erschienenen
Parteien zusammen dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: T. LOCHEN, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 23. November 2010. Relation: EAC/2010/14403. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75,- EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 23. November 2010.

J.-J. WAGNER.

Référence de publication: 2010155683/149.
(100179084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Golding Mezzanine SICAV IV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 129.182.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 14. Juni 2010

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Harald Strelen als Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV mit

Wirkung zum 14. Mai 2010 zur Kenntnis.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2010 wurde Herr Franz-Josef Glauben, geboren am 23.09.1965 in Wadern, Deutschland,

beruflich ansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, für die Restdauer des Mandats, bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung im Jahre 2013, als neues Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Des Weiteren wurde Herr Jan-Hendrik Bornemann, beruflich ansässig in Küterstraße 8-12, D-24103 Kiel, Deutschland,

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010155635/18.
(100178546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

FS Invest II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 107.850.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third of November.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

FS Invest S.àr.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) formed and existing under the laws of

Luxembourg, registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.851 having its registered
office at L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé, acting throught is board of managers, here represented by Me Sabine Hinz,
attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal which proxy shall be signed “ne
varietur” by the mandatory of the above named persons and the undersigned notary and shall remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.

FS Invest S. à r.l. is the sole partner of “FS Invest II S.àr.l.”, société à responsabilité limitée, having its registered office

in L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé, incorporated by a deed of Me Paul Bettingen, notary residing at Niederanven,
dated April 28 2005 published in the Mémorial C, number 944 of September 26, 2005 and whose articles of incorporation
were amended several times and for the last time by Me Paul Bettingen, notary prenamed, on October 23, 2007 published
in the Mémorial C, number 839 of April 5, 2008 (the “Company”).

- the share capital of the Company is fixed at 1,546,018,200.- DKK (one billion five hundred forty six million eighteen

thousand two hundred Danish Krone) divided into 7,730,091 (seven million seven hundred thirty thousand ninety one)
parts of 200.- DKK (two hundred Danish Krone) each.

All this being declared, the appearing person, acting in its abovementioned capacities, requested the undersigned notary

to draw up as follows:

<i>I. Agenda

Approval of the merger whereby ISS Equity A/S, a Danish public limited liability company, having its registered office

at Bredgade 30, DK-1260 Copenhagen, Denmark and registered with the Danish Commerce and Companies Agency

125117

L

U X E M B O U R G

under CVR-no. 28697554 („DanCo“, and together with the Company, the „Merging Companies“), shall merge into the
Company, its parent company holding the entire present share capital of Danco, by way of a merger by absorption of
DanCo and subsequent dissolution without liquidation of DanCo (the „Merger“) as contemplated by the merger plan
filed with the Luxembourg Trade and Company Register (the "RCSL") on July 29, 2010 and published in the Mémorial C,
Receuil des Sociétés et Associations on August 3, 2010 (the „Merger Plan“)

II. The undersigned notary hereby confirms and states that all provisions of the law on commercial companies dated

10 August 1915, as amended (the „LSC“) relating to mergers have been respected as follows:

1. The Merger Plan as jointly drawn up by the Boards of Directors of the Merging Companies was published in the

Mémorial C on July 29, 2010, therefore at least one month before the date of today's extraordinary general meeting of
the Company.

2. Reports were signed by the Board of Managers of the Company on September 21, 2010 and the Board of Directors

of DanCo on August 24, 2010 describing the reasons for the Merger, the anticipated consequences for the respective
activities of each of the Merging Companies and the legal, economic and social related implications of the Merger.

3. The respective documents required pursuant to Article 267 of the LSC, were deposited at the registered office of

the Company, for inspection by the partners on September 21, 2010 as confirmed by a certificate of the Board of Managers
presented to the general meeting and therefore at least one month prior to the date of today's extraordinary general
meeting of the Company.

4. The undersigned notary received a certificate issued by the Danish competent authority which certifies that all

Danish law conditions in connection with the Merger are met, in compliance with Article 271 (2) of the LSC and section
289 (1) of the Danish Companies Act.

After the fulfillment of the merger conditions had been confirmed, the sole partner takes the following resolution:

<i>Resolution

The partner approves the Merger whereby DanCo shall merge into the Company, its parent company holding the

entire present share capital of Danco, by way of a merger by absorption of DanCo and subsequent dissolution without
liquidation of DanCo as contemplated by the Merger Plan.

In accordance with Article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified the existence and validity,

under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the Merger and
hereby certifies that such acts and formalities have been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated

approximately at six thousand six hundred euros (€ 6.600,-).

The contribution of all the assets and liabilities of DanCo is being made within the provisions of Article 6 of the law

of December 19, 2008, which provides for a capital tax exemption.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil

status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille dix, le vingt-trois novembre,
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

FS Invest S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre de Commerce

et des sociétés de Luxembourg section B numéro 107.851 avec siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg,
agissant par son conseil de gérance ici représenté par Me Sabine HINZ, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration lui conférée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

- FS Invest S. à r.l est la seule et unique associée de «FS Invest II S. à r.l.», avec siège social au 2, rue du Fossé, L-1536

Luxembourg, constituée par acte du notaire Paul Bettingen, résidant à Niederanven, en date du 28 avril 2005, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 26 septembre 2005, numéro 944. Les statuts de la société
ont été modifiés plusieurs fois et la dernière fois par un acte du notaire Paul Bettingen, notaire prénommé, du 23 octobre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 avril 2008, numéro 839 (la «Société»);

125118

L

U X E M B O U R G

- le capital social de la Société est fixé à 1.546.018.200.- DKK (un milliard cinq cent quarante-six millions dix-huit mille

deux cents couronnes danoises) divisé en 7.730.091 (sept million sept cent trente mille quatre-vingt onze) parts sociales
de deux cents couronnes danoises (DKK 200.-) chacune.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>I. L’ordre du jour

Approbation de la fusion par laquelle ISS Equity A/S., une société anonyme de droit danois, ayant son siège social à

Bredgade 30, DK-1260 Copenhagen, Danemark, enregistrée auprès du registre du commerce et des société danois sous
le numéro CVR. 28697554 («DanCo» et ensemble avec la Société, les «Sociétés Fusionnantes»), sera fusionnée avec la
Société, son associé qui détient la totalité des actions de DanCo, par absorption de DanCo dans la Société et dissolution
sans liquidation de DanCo (la «Fusion»), tel que décrit en principe dans le projet de fusion déposé auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCSL») le 29 juillet 2010 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations le 3 août 2010 (le «Projet de Fusion»).

II. Le notaire instrumentant confirme et certifie par la présente que toutes les dispositions de la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915 (la «Loi») relatives aux fusions ont été respectées:

1. Le Projet de Fusion préparé conjointement par les Conseils d’Administration des Sociétés Fusionnantes a été publié

au mémorial C le 29 juillet 2010, donc au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire
de la Société.

2. Des rapports ont été signés par le Conseil de Gérance de la Société le 21 septembre 2010 et le Conseil d’Admi-

nistration de DanCo le 24 août 2010 décrivant les motifs de la Fusion, ses conséquences prévisibles sur les activités
respectives de chacune des Sociétés Fusionnantes, ainsi que tout autre impact juridique, économique et social de la Fusion.

3. Les documents respectifs requis par l’article 267 de la Loi, ont été déposés au siège social de la Société le 21

septembre 2010, comme justifié par une attestation préparée par le Conseil de Gérance présentée à l'assemblée générale,
donc au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale pour être consultés par l’associé de la Société.

4.  Le  notaire  instrumentaire  a  reçu  un  certificat  émis  par  l’autorité  danoise  compétente  certifiant  que  toutes  les

conditions posées par le droit danois pour la Fusion sont remplies, conformément à l’article 271 (2) de la Loi et à la
section 289 (1) de la loi danoise sur les sociétés.

Ayant constaté que les conditions de la fusion ont été remplies, l’associé unique prends la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé approuve la Fusion par absorption de DanCo par la Société, son associé qui détient la totalité des actions de

DanCo, et dissolution sans liquidation de DanCo, selon les principes tracés dans le Projet de Fusion.

Conformément à l’article 271 (2) de la Loi, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié, l’accomplissement et la

validité, en droit luxembourgeois, des actes juridiques et des formalités requises de la Société afin de réaliser la Fusion
et certifie par la présente que lesdits actes juridiques et formalités ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont

évalués à environ six mille six cents euros (€ 6.600,-).

L’apport de tous les actifs et les passifs de DanCo est réalisé dans le champ d’application de l’Article 6 la loi du 19

décembre 2008 qui prévoit une exonération des droits d’apport.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte authentique a été passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Signé: Sabine Hinz, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 novembre 2010. Relation: EAC/2010/14490. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010156682/133.
(100179611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

125119

L

U X E M B O U R G

Golding Mezzanine SICAV III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 117.519.

<i>Auszug aus dem Verwaltunqsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 14. Juni 2010

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Harald Strelen als Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV mit

Wirkung zum 14. Mai 2010 zur Kenntnis.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2010 wurde Herr Franz-Josef Glauben, geboren am 23.09.1965 in Wadern, Deutschland,

beruflich ansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, für die Restdauer des Mandates, bis zur ordentlichen Ge-
neralversammlung im Jahre 2012, als neues Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Des Weiteren wurde Herr Jan-Hendrik Bornemann, beruflich ansässig in Küterstraße 8-12, D-24103 Kiel, Deutschland,

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010155634/18.
(100178542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Golding Investments IV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 130.277.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 14. Juni 2010

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Harald Strelen als Mitglied des Verwaltungsrates der S.A. mit

Wirkung zum 14. Mai 2010 zur Kenntnis.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2010 wurde Herr Franz-Josef Glauben, geboren am 23.09.1965 in Wadern, Deutschland,

beruflich ansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, für die Restdauer des Mandats, bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung im Jahre 2013, als neues Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Des Weiteren wurde Herr Jan-Hendrik Bornemann, beruflich ansässig in Küterstraße 8-12, D-24103 Kiel, Deutschland,

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010155632/17.
(100178552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Golding Investments IV TF2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 149.046.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 14. Juni 2010

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Harald Strelen als Mitglied des Verwaltungsrates der S.A. mit

Wirkung zum 14. Mai 2010 zur Kenntnis.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2010 wurde Herr Franz-Josef Glauben, geboren am 23.09.1965 in Wadern, Deutschland,

beruflich ansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, für die Restdauer des Mandats, bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung im Jahre 2015, als neues Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Des Weiteren wurde Herr Jan-Hendrik Bornemann, beruflich ansässig in Küterstraße 8-12, D-24103 Kiel, Deutschland,

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010155633/17.
(100178560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

125120

L

U X E M B O U R G

Golding Investments III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 118.161.

<i>Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 14. Juni 2010

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Harald Strelen als Mitglied des Verwaltungsrates der S.A. mit

Wirkung zum 14. Mai 2010 zur Kenntnis.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2010 wurde Herr Franz-Josef Glauben, geboren am 23.09.1965 in Wadern, Deutschland,

beruflich ansässig in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, für die Restdauer des Mandats, bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung im Jahre 2013, als neues Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Des Weiteren wurde Herr Jan-Hendrik Bornemann, beruflich ansässig in Küterstraße 8-12, D-24103 Kiel, Deutschland,

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft ernannt.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010155631/17.
(100178550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

FCP OP Medical, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion de FCP OP Medical modifié au 15 Novembre 2010 a été déposée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2010155187/10.
(100178020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

GodmodeTrader.de Strategie I, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de GodmodeTrader.de Strategie I a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LRI Invest S.A.
Signature

Référence de publication: 2010155165/10.
(100178537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Eurizon Focus Capitale Protetto, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de EURIZON FOCUS CAPITALE PROTETTO (modifié/coordonné) a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURIZON CAPITAL S.A.
Jérome Debertolis
<i>Head of Legal &amp; Finance

Référence de publication: 2010154314/11.
(100177351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2010.

Cash Plus, Fonds Commun de Placement.

La partie spécifique du règlement de gestion de CASH PLUS modifié au 15 Novembre 2010 a été déposée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

125121

L

U X E M B O U R G

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2010152100/10.
(100173750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2010.

Haspa PB Strategie, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Haspa PB Strategie modifié au 03.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Signatures

Référence de publication: 2010149534/11.
(100171183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.

A-DGZ 13-Fonds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion de A-DGZ 13-FONDS a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Signatures

Référence de publication: 2010149484/10.
(100171187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.

Deka-WorldGarant 10/2011, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Deka-WorldGarant 10/2011 modifié au 01.11.2010 a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Signatures

Référence de publication: 2010149483/11.
(100171186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.

First Class, Fonds Commun de Placement,

(anc. Glogger Fonds).

Die Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements, in Kraft getreten am 25. Oktober 2010, für den Fonds First

Class (vormais Glogger Fonds) wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. November 2010.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2010147421/11.
(100169202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

NV Strategie Emerging, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 1. Oktober 2010, für den Fonds NV Strategie Emerging wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

125122

L

U X E M B O U R G

Luxemburg, den 8. November 2010.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2010147420/10.
(100169156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

NV Strategie, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 1. Oktober 2010, für den Fonds NV Strategie Fonds wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. November 2010.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2010147419/10.
(100169154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 115.812.

AMB Bonneuil Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.025,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 133.962.

AMB Le Havre Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.075,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 133.855.

AMB Port of Rouen Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.550,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 138.186.

AMB St Pathus Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.550,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 138.099.

JOINT MERGER PROPOSAL

AMONG:
AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Share capital: EUR 12,600
R.C.S. Luxembourg: B 115.812
(LGRH4 or the Absorbing Company)

AMB Bonneuil Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: at 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Share capital: EUR 37,025
R.C.S. Luxembourg: B 133.962 (BH)

125123

L

U X E M B O U R G

AMB Le Havre Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: at 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Share capital: EUR 37,075
R.C.S. Luxembourg: B 133.855 (LHH)

AMB Port of Rouen Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: at 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Share capital: EUR 49,550
R.C.S. Luxembourg: B 138.186 (PoRH)

AND

AMB St Pathus Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: at 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Share capital: EUR 49,550
R.C.S. Luxembourg: B 138.099 (StPH)

(BH, LHH, PoRH and StPH, together the Companies Ceasing To Exist or individually the Company Ceasing To Exist)

JOINT MERGER PROPOSAL

The merger contemplated in this joint merger proposal (the Joint Merger Proposal) is to be carried out by way of

absorption of the limited liability companies (Sociétés à responsabilité limitée) AMB Bonneuil Holding S.à r.l., AMB Le
Havre Holding S.à ri, AMB Port of Rouen Holding S.à r.l. and AMB St Pathus Holding S.à r.l. by their affiliate, the limited
liability company (Société à responsabilité limitée) AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.

The board of managers of LGRH4, BH, LHH, PoRH and StPH (together the Merging Companies, as further identified

above) have hereby resolved to draw up this Joint Merger Proposal in accordance with the provisions of Article 261 of
the Luxembourg Act of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, (the Law).

1. Description of the contemplated merger.
The board of managers of the Merging Companies propose to carry out a merger by absorption that will entail the

transfer of all assets and liabilities of the Companies Ceasing To Exist to the Absorbing Company in accordance with and
pursuant to the provisions of Article 274 of the Law (the Merger).

The Merging Companies belong to the same group of companies and the contemplated Merger is part of an internal

restructuring of the group aiming at realigning the activities and streamlining the group structure.

Both the Absorbing Company and the Companies Ceasing To Exist are fully owned by AMB Europe Luxembourg

Holding 2 S.à r.l., a Société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated and existing under the laws
of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 122.995
(ELH2). As a result, the Merger will not impact the consolidated assets of ELH2 or entail any dilution for ELH2.

The Merger will be carried out on the basis of the latest available interim accounts of the Merging Companies esta-

blished as per November 15, 2010 (the Interim Accounts).

The directors of the Merging Companies mutually undertake to take all required steps in order to carry out the Merger

in accordance with the terms and conditions detailed hereafter in this Joint Merger Proposal.

In accordance with Article 272 of the Law, the Merger will become effective inter partes when the concurring reso-

lutions of the Merging Companies shall have been adopted, i.e. on the date of the last general meeting of the shareholders
of the Merging Companies approving the proposed Merger (the Effective Date).

The Merger shall however only be effective towards third parties after the publication of the minutes of the general

meetings of shareholders of each of the Merging Companies (or of a certificate issued by a notary public) in accordance
with Article 9 and Article 273 (1) of the Law.

2. Information to be provided pursuant to Article 261 (2) of the Law.
a) Type of legal entity, name and registered office of the Merging Companies
i. The Absorbing Company

125124

L

U X E M B O U R G

The limited liability company (Société à responsabilité limitée) AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l. has its registered

office at 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of
Commerce and Companies of Luxembourg under number B 115.812.

ii. The Companies Ceasing To Exist
1) The limited liability company (Société à responsabilité limitée) AMB Bonneuil Holding S.à r.l. has its registered office

at 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce
and Companies of Luxembourg under number B 133.962;

2) The limited liability company (Société à responsabilité limitée) AMB Le Havre Holding S.à r.l. has its registered office

at 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce
and Companies of Luxembourg under number B 133.855;

3) The limited liability company (Société à responsabilité limitée) AMB Port of Rouen Holding S.à r.l. has its registered

office at 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of
Commerce and Companies of Luxembourg under number B 138.186; and

4) The limited liability company (Société à responsabilité limitée) AMB St Pathus Holding Holding S.à r.l. has its regis-

tered office at 1, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 138.099.

b) Share exchange ratio
The share exchange ratio is calculated on the basis of the par value of the Class A shares of the Absorbing Company

and the net assets value of each of the Companies Ceasing To Exist, with any difference between the par value of the
Class A shares to be issued to the shareholder(s) of the Company Ceasing To Exist and the net assets value of the
Company Ceasing to Exist as per its Interim Accounts being booked as a merger premium.

Given the fact that ELH2 is (or shall be before the Effective Date) the sole shareholder of all the Merging Companies,

there is no risk of creating a dilution that would be detrimental to any (former) shareholder of the Companies Ceasing
To Exist. Accordingly, the exchange ratio could be amended by the Merging Companies, in a way that they deem fit, at
the time of their resolving on the Merger.

i. The Absorbing Company
The subscribed share capital of the Absorbing Company is set at EUR 12,600 (twelve thousand six hundred euro)

consisting of 80 (eighty) Class A shares, 81 (eighty on) Class B shares, 81 (eighty one) Class C shares, 81 (eighty one)
Class D shares, 81 (eighty one) Class E shares and 100 (hundred) Class F shares. All shares are in registered form,
subscribed and fully paid-up and have a par value of EUR 25 (twenty five euro) each.

ii. The Companies Ceasing To Exist
1) The subscribed share capital of BH is set at EUR 37,025 (thirty seven thousand and twenty five euro) consisting of

1,481 (one thousand four hundred eighty one) ordinary shares. All shares are in registered form, subscribed and fully
paid-up. As per its Interim Accounts, BH's net assets value is EUR 199,842.06 (hundred ninety nine thousand eight hundred
forty two euro and six cent).

2) The subscribed share capital of LHH is set at EUR 37,075 (thirty seven thousand and twenty five euro) consisting

of 1,483 (one thousand four hundred eighty three) ordinary shares. All shares are in registered form, subscribed and fully
paid-up. As per its interim Accounts, LHH's net assets value is EUR 3,462,103.29 (three million four hundred sixty two
thousand hundred and three euro and twenty nine cent).

3) The subscribed share capital of PoRH is set at EUR 49,550 (forty nine thousand five hundred and fifty euro) consisting

of 1,982 (one thousand nine hundred eighty two) ordinary shares. All shares are in registered form, subscribed and fully
paid-up. As per its Interim Accounts, PoRH's net assets value is EUR 1,898,038.11 (one million eight hundred ninety eight
thousand thirty eigth euro and eleven cent).

4) The subscribed share capital of StPH is set at EUR 49,550 (forty nine thousand five hundred and fifty euro) consisting

of 1,982 (one thousand nine hundred eighty two) ordinary shares. All shares are in registered form, subscribed and fully
paid-up. As per its Interim Accounts, StPH's net assets value is EUR 557,227.89 (five hundred fifty seven thousand two
hundred twenty seven euro and eighty nine cent).

iii. Share consideration
In consideration for the transfer of all the assets and liabilities of the Companies Ceasing To Exist to the Absorbing

Company pursuant to the Merger, the latter will increase its share capital by an aggregate amount of EUR 6,117,175 (six
million hundred seventeen thousand hundred seventy five euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,600
(twelve thousand six hundred euro) to EUR 6,129,775 (six million hundred twenty nine thousand seven hundred seventy
five euro) by way of the issuance of an aggregate of 244,687 (two hundred forty four thousand six hundred eighty seven)
new Class A shares having a par value of EUR 25 (twenty five euro) each, of the same kind and carrying the same rights
and obligations as the existing Class A shares of the Company.

The newly issued Class A shares of the Absorbing Company will be allocated to ELH2 (or any shareholder of the

Companies Ceasing To Exist at the time of the Merger) on the basis of an exchange ratio of:

- 7,993 (seven thousand nine hundred ninety three) Class A share for all the shares in BH;

125125

L

U X E M B O U R G

- 138,484 (hundred thirty eight thousand four hundred eighty four) Class A share for all the shares in LHH;
- 75,921 (seventy five thousand nine hundred twenty one) Class A share for all the shares in PoRH; and
- 22,289 (twenty two thousand two hundred eighty nine) Class A share for all the shares in StPH.
The articles of association of the Absorbing Company dealing with its share capital and the shares in issuance will be

amended accordingly.

iv. Merger premium
On the basis of the above exchange ratio, an amount of EUR 36.35 (thirty six euro and thirty five cent) representing

the merger premium (i.e. the difference between the par value of the newly issued Class A shares of the Absorbing
Company and the net assets value of the Companies Ceasing To Exist as per the Interim Accounts) shall be recorded as
merger premium in the accounts of the Absorbing Company.

v. Cash payment (if any)
No cash payment will be granted to the shareholder(s) of the Companies Ceasing To Exist.
c) Terms for the delivery of the shares in the Absorbing Company
The newly issued shares will be registered in the share register of the Absorbing Company as of the Effective Date of

the Merger.

As a result of the Merger, the Companies Ceasing To Exist shall cease to exist and all their issued and outstanding

shares will be cancelled.

d) Date as of which the newly issued shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition

regarding such right

The newly issued shares will entitle its holder(s) to participate in the profits of the Absorbing Company as from the

Effective Date of the Merger and, from that date onwards, such holder(s) acquire(s) all rights attached to these shares,
including the right to dividends, or any other distribution, to be distributed out of the profit of the current accounting
period and/or out of the accumulated reserves and carried forward profits or otherwise. This right is not subject to any
special condition.

e) Date as of which the operations of the Company Ceasing To Exist shall be treated, for accounting purposes, as

being carried out on behalf of the Absorbing Company

For accounting purposes, the operations of the Companies Ceasing To Exist shall be treated as being carried out on

behalf of the Absorbing Company as from December 1, 2010.

f) Rights guaranteed by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to holders of securities other

than shares (or the measures it intends to take in their regard)

No guarantee or measures will be granted or taken by the Absorbing Company.
g) Special benefits granted to the experts referred to in Article 266 of the Law, to the members of the board of

managers of the Merging Companies and/or to any of the persons (if any) referred to in Article 261 (2) g) of the Law

Neither the experts referred to in article 266 of the Law (if any) nor the members of the board of managers of the

Merging Companies and/or any of the persons (if any) referred to in Article 261 (2) g) of the Law, shall be entitled to
receive any special benefits in connection with or as a result of the Merger.

3. Consequences of the Merger.
a) The Merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in Article 274 of the Law and in particular, as a result

of the Merger, the Companies Ceasing To Exist shall cease to exist and all their issued and outstanding shares shall be
cancelled.

b) Subject to the provisions of Article 274 (2) of the Law with respect to the enforceability vis-a-vis third parties, the

Absorbing Company will become the owner of the assets contributed by the Companies Ceasing To Exist as they exist
on the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Companies Ceasing To Exist.

c) All corporate documents of the Companies Ceasing To Exist shall be kept at the registered office of the Absorbing

Company for as long as prescribed by the Law.

d) The mandates of the members of the board of managers of the Companies Ceasing To Exist will be terminated on

the Effective Date of the Merger. Full discharge will be given to the members of the boards of managers for the perfor-
mance of their respective mandates.

e) The mandates of the members of the board of managers of the Absorbing Company will not be affected by the

Merger.

4. Additional provisions.
a) The cost of the Merger will be incurred by the Absorbing Company.
b) The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the Merger In accordance

with the legal and statutory requirements of both Merging Companies.

c) The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as

well as the transfer of all assets and liabilities of the Companies Ceasing To Exist to the Absorbing Company.

125126

L

U X E M B O U R G

d) The shareholder of the Merging Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered

office of the Merging Companies, at least one month before the date of the general meetings of the shareholder to be
convened to decide on the terms of the Merger:

i. the Joint Merger Proposal;
ii. the annual accounts and annual reports of the Merging Companies for the last three financial years, if any; and
iii. an interim balance sheet drawn up as per a date which must not be earlier than the first day of the third month

preceding the date of the publication of the Joint Merger Proposal in the Luxembourg Official Gazette, if the last annual
accounts of the Merging Companies relate to a year that ended more than six months before that date;

iv. the reports of the board of managers of the Merging Companies prepared in accordance with Article 265 of the

Law; and

v. as the case may be, the reports of the independent experts prepared in accordance with Article 266 of the Law.
e) A copy of the above mentioned documents will be granted free of charge upon request by a shareholder.
f) The present Joint Merger Proposal has been drawn up in Luxembourg on November 24, 2010, in three original

copies, in order to be registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to be published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, at least one month prior to the date of the general meetings
of the shareholder of each of the Merging Companies to be called to resolve on the Merger, in accordance with Article
262 of the Law.

Signature page to the Joint Merger Proposal between AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., AMB Bonneuil Holding

S.à r.l., AMB Le Havre Holding S.à r.l., AMB Port of Rouen Holding S.à r.l. and AMB St Pathus Holding S.à r.l.

<i>For AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager and attorney in fact
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs
For AMB Bonneuil Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager and attorney in fact
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

<i>For AMB Le Havre Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager and attorney in fact
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

<i>For AMB Port of Rouen Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager and attorney in fact
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

<i>For AMB St Pathus Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Manager and attorney in fact
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

Suit la traduction française du texte qui précède:

PROJET COMMUN DE FUSION

ENTRE:
AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Capital social: EUR 12,600
R.C.S. Luxembourg: B 115.812

125127

L

U X E M B O U R G

(LGRH4 ou la Société Absorbante)

AMB Bonneuil Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Capital social: EUR 37,025
R.C.S. Luxembourg: B 133.962 (BH)

AMB Le Havre Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Capital social: EUR 37,075
R.C.S. Luxembourg: B 133.855 (LHH)

AMB Port of Rouen Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Capital social: EUR 49,550
R.C.S. Luxembourg: B 138.186 (PoRH)

ET

AMB St Pathus Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg Capital social: EUR 49,550
R.C.S. Luxembourg: B 138.099 (StPH)

(BH, LHH, PoRH et StPH, ensemble les Sociétés Absorbées ou individuellement la Société Absorbée)

PROJET COMMUN DE FUSION

La fusion envisagée dans ce projet commun de fusion (le Project Commun de Fusion) serait amenée à être réalisée

par l'absorption des sociétés à responsabilité limitée AMB Bonneuil Holding S.à r.l., AMB Le Havre Holding S.à r.l., AMB
Port of Rouen Holding S.à r.l. et AMB St Pathus Holding S.à r.l. par leur société liée, la société à responsabilité limitée
AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.

Les conseils de gérance de LGRH4, BH, LHH, PoRH et StPH (ensemble les Sociétés qui Fusionnent, telles qu'identifiées

plus avant ci-dessus) ont décidé d'établir le présent Projet Commun de Fusion conformément aux dispositions de l'article
261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la Loi).

1. Description de la fusion envisagée.
Les conseils de gérance des Sociétés qui Fusionnent proposent de réaliser une fusion par absorption qui impliquera le

transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante en vertu de et
conformément aux dispositions de l'article 274 de la Loi (la Fusion).

Les Sociétés qui Fusionnent appartiennent au même groupe de sociétés et la fusion envisagée fait partie d'une res-

tructuration interne au groupe visant à réaligner les activités et à simplifier la structure du groupe.

La Société Absorbante ainsi que les Sociétés Absorbées sont entièrement détenues par AMB Europe Luxembourg

Holding 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante conformément au droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 122.995 (ELH2). Partant, la Fusion n'aura aucun impact sur les actifs consolidés de
ELH2 et n'entraînera pas de dilution pour cette dernière.

La Fusion sera réalisée sur la base des derniers comptes intérimaires des Sociétés qui Fusionnent établis en date du

15 novembre 2010 (les Comptes Intérimaires).

Les gérants des Sociétés qui Fusionnent s'engagent mutuellement à entreprendre toutes les actions nécessaires afin

de réaliser la Fusion conformément aux conditions détaillées ci-après dans le présent Projet Commun de Fusion.

Conformément à l'article 272 de la Loi, ta Fusion sortira ses effet entre les Sociétés qui Fusionnent lorsque les décisions

concordantes desdites sociétés auront été adoptées, c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale des action-
naires des Sociétés qui Fusionnent approuvant la Fusion proposée (la Date de Prise d'Effet).

125128

L

U X E M B O U R G

La Fusion sortira cependant uniquement ses effets vis-à-vis des tiers après la publication du procès-verbal des assem-

blées générales des actionnaires des Sociétés qui Fusionnent (ou d'un certificat établir par un notaire) conformément aux
articles 9 et 273 (1) de la Loi.

2. Informations fournies par l'article 261 (2) de la Loi.
a) Type de personne morale, dénomination sociale et siège social des Sociétés qui Fusionnent
i. La Société Absorbante
La société à responsabilité limitée AMB Le Grand Roissy Holding 4 a son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 115.812.

ii. Les Sociétés Absorbées
1) La société à responsabilité limitée AMB Bonneuil Holding a son siège social à 1, Ailée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 133.962;

2) La société à responsabilité limitée AMB Le Havre Holding a son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 133.855;

3) La société à responsabilité limitée AMB Port of Rouen Holding a son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 138.186; et

4) La société à responsabilité limitée AMB St Pathus Holding a son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 138.099.

b) Rapport d'échange des parts
Le rapport d'échange des parts est calculé sur la base du pair comptable des parts de classe A de la Société Absorbante

et ta valeur d'actifs nette de chacune des Sociétés qui Fusionnent, étant entendu que toute différence entre le montant
du pair comptable des parts de classe A à émettre à l'/aux actonnaire(s) d'une Société Absorbée et la valeur d'actifs nette
de cette dernière telle qu'elle ressort de ses Comptes Intérimaires sera comptabilisée comme une prime de fusion.

Etant donné le fait que ELH2 est (ou sera avant la Date de Prise d'Effet) le seul associé des Sociétés qui Fusionnent, il

n'y a pas de risque de dilution au détriment d'un autre associé (historique) des Sociétés Absorbées. Partant, le rapport
d'échange pourrait être modifié, comme elles l'estiment souhaitable, par les Sociétés qui Fusionnent à la date de prise de
décision quant à la Fusion.

i. La Société Absorbante
Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à EUR 12.600 (douze mille six cent euros) et se compose

de 80 (quatre-vingt) parts de classe A, 81 (quatre-vingt un) parts de classe B, 81 (quatre-vingt un) parts de classe C, 81
(quatre-vingt un) parts de classe D, 81 (quatre-vingt un) parts de classe E et 100 (cent) parts de classe F. Toutes ces parts
sont nominatives, entièrement souscrites et entièrement libérées et ont un pair comptable de EUR 25 (vingt-cinq euro)
chacune.

ii. Les Sociétés Absorbées
1) Le capital social souscrit de BH est fixé à EUR 37.025 (trente sept mille vingt-cinq euros) et se compose de 1.481

(mille quatre cent quatre-vingt un) parts ordinaires. Toutes ces parts sont nominatives, entièrement souscrites et entiè-
rement libérées. Sur la base de ses Comptes Intérimaires, BH a une valeur d'actifs nette de EUR 199.842,06 (cent nonante
neuf mille huit cent quarante deux euro et six cent).

2) Le capital social souscrit de LHH est fixé à EUR 37.075 (trente sept mille vingt-cinq euros) et se compose de 1.483

(mille  quatre  cent  quatre-vingt  trois)  parts  ordinaires.  Toutes  ces  parts  sont  nominatives,  entièrement  souscrites  et
entièrement libérées. Sur la base de ses Comptes Intérimaires, LHH a une valeur d'actifs nette de EUR 3.462.103,29 (trois
million quatre cent soixante deux mille cent trois euro et vingt-neuf cent).

3) Le capital social souscrit de PoRH est fixé à EUR 49.550 (quarante neuf mille cinq cent cinquante cinq euros) et se

compose de 1.982 (mille neuf cent quatre-vingt deux) parts ordinaires. Toutes ces parts sont nominatives, entièrement
souscrites et entièrement libérées. Sur la base de ses Comptes Intérimaires, PoRH a une valeur d'actifs nette de EUR
1.898.038,11 (un million huit cent nonante huit mille trente huit euro et onze cent).

4) Le capital social souscrit de StPH est fixé à EUR 49.550 (quarante neuf mille cinq cent cinquante cinq euros) et se

compose de 1.982 (mille neuf cent quatre-vingt deux) parts ordinaires. Toutes ces parts sont nominatives, entièrement
souscrites et entièrement libérées. Sur la base de ses Comptes Intérimaires, StPH a une valeur d'actifs nette de EUR
557.227,89 (cinq cent cinquante sept mille deux cent vingt-sept euro et quatre-vingt neuf cent).

iii. Contrepartie
En contrepartie de l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées, la Société Absorbante

suite à la Fusion, la Société Absorbante augmentera son capital social d'un montant global de EUR 6.117.175 (six million
cent dix-sept mille cent septante cinq euro) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.600 (douze mille six cent

125129

L

U X E M B O U R G

euro) à EUR 6.129.775 (six million cent vingt-neuf mille sept cent septante cinq euro) par l'émission de 244.687 (deux
cent quarante quatre mille six cent quatre-vingt sept) nouvelles parts de classe A ayant un pair comptable de EUR 25
(vingt cinq euro) chacune, de même nature et ayant les mêmes droits et obligations que les parts de classe A existantes
de la Société Absorbante.

Les nouvelles parts de la Société Absorbante seront attribuées à ELH2 (ou tout autre associé d'une Société Absorbée

à la date de la Fusion) sur la base d'un rapport d'échange de:

- 7.993 (sept mille neuf cent nonante trois) parts de classe A pour l'ensemble des parts émises par BH;
- 138.484 (cent trente huit mille quatre cent quatre-vingt quatre) parts de classe A pour l'ensemble des parts émises

par LHH;

- 75.921 (septante cinq mille neuf cent vingt et une) parts de classe A pour l'ensemble des parts émises par PoRH; et
- 22.289 (vingt-deux mille deux cent quatre-vingt neuf) parts de classe A pour l'ensemble des parts émises par StPH .
Les articles des statuts de la Société Absorbante relatifs à son capital social et au nombre de parts émises seront

modifiés en conséquence.

iv. Prime de fusion
Sur la base du rapport d'échange indiqué ci-dessus, un montant de EUR 36,35 (trente six euro et trente cinq cent)

représentant la prime de fusion (soit la différence entre te montant du pair comptables des nouvelles parts de classe A
émises par la Société Absorbante et la valeur d'actifs nette des Sociétés Absorbées selon les Comptes Intérimaires) sera
enregistré dans les comptes de la Société Absorbante en tant que prime de fusion attachée aux parts nouvellement émises.

v. Paiement en espèces (le cas échéant)
Aucun paiement en espèces ne sera accordé aux actionnaires des Sociétés Absorbées.
c) Modalités de remise des parts de la Société Absorbante
Les parts nouvellement émises seront enregistrées dans le registre des parts sociales de la Société Absorbante à

compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion.

En conséquence de la Fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister et toutes leurs parts émises seront annulées.
d) Date à partir de laquelle les parts nouvellement émises donneront droit de participer aux bénéfices et les modalités

particulières éventuelles relatives à ce droit

Les parts nouvellement émises permettront à leur(s) détenteur(s) de participer aux bénéfices de la Société Absorbante

à compter de la Date de Prise d'Effet de la Fusion et, à partir de cette date, ce(s) détenteur(s) acquière(ront) tous les
droits attachés à ces parts, en ce compris le droit aux dividendes ou à toute autre distribution future à distribuer à partir
des bénéfices de la période comptable en cours et/out des réserves accumulées et des profits reportés ou autrement.
Ce droit n'est soumis à aucune condition ni modalité particulière.

e) Date à laquelle les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées, à des fins comptables, comme étant

réalisées au nom de la Société Absorbante

Les opérations des Sociétés Absorbées seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées au nom de

la Société Absorbante à compter du 1 

er

 décembre 2010.

f) Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres ou

les mesures proposées à leur égard

Aucun droit spécial ni aucune mesure spécifique ne seront accordés par la Société Absorbante à quiconque.
g) Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 266 de la Loi, aux membres du conseil de gérance

et/ou des organes d'administration, de surveillance ou de contrôle des Sociétés qui Fusionnent

Ni les experts visés à l'article 266 de la Loi (le cas échéant), ni les membres des conseils de gérance, des organes

d'administration, de surveillance ou de contrôle des Sociétés qui Fusionnent ne seront autorisés à recevoir des avantages
particuliers en rapport avec ou par suite de la Fusion.

3. Conséquences de fa Fusion.
a) La Fusion entraînera de plein droit (ipso jure) toutes les conséquences détaillées à l'article 274 de la Loi et en

particulier, suite à la Fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister et toutes leurs parts émises seront annulées.

b) Sous réserve des dispositions de l'article 274 (2) de la Loi relativement à l'opposabilité aux tiers, la Société Absor-

bante deviendra propriétaire des actifs apportés par les Sociétés Absorbées tels qu'ils existent à la Date de Prise d'Effet
sans aucun droit de recours quel qu'il soit contre les Sociétés Absorbées.

c) Tous les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante aussi

longtemps que prescrit par la Loi.

d) Les mandats des membres du conseil de gérance des Sociétés Absorbées prendront fin à la Date de Prise d'Effet

de la Fusion. Pleine décharge sera accordée aux membres des conseils de gérance pour l'exécution de leurs mandats
respectifs.

e) Les mandats des membres du conseil de gérance de la Société Absorbante ne seront pas affectés par la Fusion.

125130

L

U X E M B O U R G

4. Dispositions supplémentaires.
a) Le coût de la Fusion sera supporté par la Société Absorbante.
b) Les soussignés s'engagent réciproquement à prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de réaliser la Fusion

conformément aux exigences légales et statutaires des Sociétés qui Fusionnent.

c) La Société Absorbante effectuera toutes les démarches nécessaires et requises à la réalisation de la Fusion ainsi que

le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante.

d) Chaque associé des Sociétés qui Fusionnent aura le droit, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale

des associés appelées à se prononcer sur le Project Commun de Fusion, de prendre connaissance des documents suivants
au siège social desdites sociétés:

i. le Projet Commun de Fusion;
ii. les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés qui Fusionnent;
iii. un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant

la date du Projet Commun de Fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est
antérieure de plus de six mois à cette date;

iv. les rapports des conseils de gérance des Sociétés qui Fusionnent mentionnés à l'article 265 de la Loi; et
v. le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 266.
e) Une copie des documents mentionnés ci-dessus sera délivrée sur demande à tout associé.
f) Le présent document a été établi le 24 novembre 2010 à Luxembourg, en trois originaux, aux fins d'être enregistré

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et d'être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations, un mois au moins avant la date des assemblées générales des associés de chacune des Sociétés qui Fusionnent
appelées à se prononcer sur les conditions de la Fusion, conformément à l'article 262 de la Loi.

Page de signature du Projet Commun de Fusion entre AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l., AMB Bonneuil Holding

S.à r.l., AMB Le Havre Holding S.à r.l., AMB Port of Rouen Holding S.à r.l. et AMB St Pathus Holding S.à r.l.

<i>Pour AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant et Mandataire spécial
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs
Pour AMB Bonneuil Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant et Mandataire spécial
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

<i>Pour AMB Le Havre Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant et Mandataire spécial
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

<i>Pour AMB Port of Rouen Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant et Mandataire spécial
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

<i>Pour AMB St Pathus Holding S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
<i>Gérant et Mandataire spécial
Paul van Baarle / Sophie Mellinger
<i>Administrateur / Fondée de Pouvoirs

Référence de publication: 2010156938/471.
(100180704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2010.

125131

L

U X E M B O U R G

amandea MK, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 20. November 2010, für den Fonds amandea MK wurde beim Handels-

und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. November 2010.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2010147411/10.
(100169139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Kikuoka Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5412 Canach, Scheierhaff.

R.C.S. Luxembourg B 28.646.

L'an deux mille dix, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est  réunie  une  assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  "KIKUOKA  LUXEM-

BOURG S.A.", ayant son siège social à L-5412 Canach, Scheierhaff, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg section B sous le numéro B 28.646, constituée suivant acte reçu le 31 juillet 1988 par-devant Maître Christine
DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 290 du 31 octobre 1988. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu
par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 février 2007 par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de
résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 898 du 16 mai 2007.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora GIBERT, juriste,

demeurant à Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que les 175.574 actions, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant;

<i>Ordre du tour:

1.-  Présentation  du  projet  de  fusion  par  absorption  entre  Kikuoka  Luxembourg  S.A.  et  Nouvelle  Immobilière  de

Warken S.A. ainsi que du rapport du Conseil d'Administration y afférent.

2.- Présentation du rapport de l'expert indépendant désigné sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport

d'échange proposé dans le cadre de la fusion par absorption de Nouvelle Immobilière de Warken S.A. par Kikuoka
Luxembourg S.A.

3.- Augmentation conséquente du capital social par l'émission de 4.324 actions nouvelles aux fins de rémunérer l'apport

de fusion et modification de l'article cinq des statuts.

4.- Décision de procéder à la fusion par absorption de Nouvelle Immobilière de Warken S.A. par Kikuoka Luxembourg

S.A.

5.- Décharge conférée aux organes sociaux ainsi qu'à l'expert indépendant désigné dans le cadre de la procédure de

fusion.

6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre Kikuoka Luxembourg S.A. (la "société absorbante")

et Nouvelle Immobilière de Warken S.A. (la "société absorbée") a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du Grand-Duché de Luxembourg numéro 2188 du 15 octobre 2010.

125132

L

U X E M B O U R G

Ce projet, arrêté par les conseils d'administration des deux sociétés concernées le 21 septembre 2010, prévoit l'ab-

sorption de Nouvelle Immobilière de Warken S.A. par Kikuoka Luxembourg S.A. avec prise d'effet de la fusion à la date
de ce jour (date effective), date à laquelle la société unique Kikuoka Luxembourg S.A. poursuivra seule les activités des
deux sociétés fusionnantes.

L'assemblée approuve en outre le rapport justificatif du conseil d'administration sur le projet de fusion prévu par

l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales. Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée approuve le rapport sur le projet de fusion prévu par l'article 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales

établi par l'expert Réviseur d'Entreprises indépendant G.S.L. Fiduciaire S. à R.L., ayant son siège social au 37, rue Romain
Fandel, L-4149 Esch-sur-Alzette désigné à cette fin par les conseils d'administrations de Kikuoka Luxembourg S.A. et de
Nouvelle Immobilière de Warken S.A. et par le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg le 09 novembre 2010.

Ce rapport conclut au caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange proposé dans le cadre de la fusion.
Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant

restera annexé au présent acte.

L'assemblée décide d'accepter de rémunérer l'apport de fusion par l'émission de 4.324 actions de la société absorbante

sans désignation de valeur nominale, ce qui correspond à 4,32 actions nouvelles de la société absorbante contre 1 action
existante de la société absorbée.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée, compte tenu de la décision qui précède, décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR

500.000,00 (cinq cent mille euros), et d'émettre 4.324 (quatre mille trois cent vingt-quatre) nouvelles actions, entièrement
libérées et jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, attribuées aux actionnaires de la société
absorbée au prorata de leur participation.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 22.066.000 (vingt-deux millions soixante-six mille euros) représenté par 179.898

(cent septante-neuf mille huit cent nonante-huit) actions sans désignation de valeur nominale".

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents susmentionnés et constatant que toutes les formalités légales ont

été accomplies, décide d'agréer le projet et de procéder à la fusion par absorption de Nouvelle Immobilière de Warken
S.A. par Kikuoka Luxembourg S.A., avec prise d'effet à la date de ce jour, les actionnaires de Nouvelle Immobilière de
Warken S.A. ayant préalablement aux présentes également marqué leur accord sur la fusion.

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée décide de donner décharge, pour autant que de besoin, aux organes sociaux en fonction au sein des

sociétés participant à la fusion pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour ainsi qu'à l'expert indépendant désigné par
les conseils d'administration des sociétés participant à la fusion en vue d'établir un rapport de contrôle relatif au projet
de fusion.

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément à l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, l'existence et la

légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Uhl, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 novembre 2010. LAC/2010/51952. Reçu soixante-quinze euros 75.-€

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

125133

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 NOV. 2010.

Référence de publication: 2010156945/98.
(100181791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Grellmann Fire Protection S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 16, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 142.401.

Im Jahre zweitausendzehn, am achtundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Anja HOLTZ, mit Amtssitz in Wiltz sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft "Brandschutz GRELLMANN GmbH", mit Sitz in D-50674 Köln, Moltkestrasse 48, eingetragen im

Handelsregister der Stadt Köln (Deutschland) unter dem Aktenzeichen HRB 21030, vertreten durch ihren einzigen und
einzelvertretungsberechtigten  Geschäftsführer,  Herrn  Manfred  Siebel,  Kaufmann,  wohnhaft  zu  Köln  Niehl  (D),
Nesselrodestraße 9

2.- Die Gesellschaft "Mano Invest s.àr.l." mit Sitz zu L-9674 Nocher-Route, 58, Nacherstrooss, eingetragen im Han-

delsregister Luxemburg unter der Nummer B 140433, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Norbert Maes,
Staatsbeamter im Ruhestand, wohnhaft zu L-9674 Nocher-Route, 58, Nacherstrooss. Die erschienenen Parteien bitten
den Notar folgendes zu beurkunden:

- die Gesellschaft "GRELLMANN FIRE PROTECTION S.àr.l." wurde durch eine Urkunde aufgenommen durch den

amtierenden Notar am 19. November 2008 gegründet;

- die Urkunde wurde im Gesetzblatt "Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" Nummer 2706 vom

06. November 2008 veröffentlicht;

- die Gesellschaft ist im Handelsregister unter der Nummer B 142.401 eingetragen;
- das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (12.500.-€) dargestellt durch hundert (100) Anteile

mit einem Nennwert von je hundertfünfundzwanzig Euro (125.-€);

- die erschienenen Parteien sind alleinige Anteilseigner der Gesellschaft "GRELLMANN FIRE PROTECTION S.àr.l.",

mit Sitz in L-9643 Büderscheid, 1, Weltzerstrooss.

- die Gesellschaft besitzt weder Grundstücke noch Anteile an Grundstücken.
Die erschienenen Parteien nehmen dann an der ordunungsgemäss einberufenen Gesellschafterversammlung teil und

bitten den Notar folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Anteilseigner beschliessen den Gesellschaftszweck zu erweitern. Der Artikel 2, Absatz 1 der Satzung lautet de-

mentsprechend wie folgt:

Art. 2. Absatz 1. Die Gesellschaft hat als Gegenstand die Planung, die Umsetzung, den An- und Verkauf, den Vertrieb,

die Vermietung, den Verleih, sowie die Instandsetzung und -haltung jeglicher Brandschutz- und Sicherheitsprodukte. Die
Gesellschaft kann ebenfalls den An-und Verkauf von Beschilderungen aller Art, von Gravuren auf oder in Metallen oder
sonstigen Materialien, von Souvenirartikeln und von Fotodrucken und geschenken tätigen."

<i>Zweiter Beschluss

Die Anteilseigner beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Büderscheid nach Wiltz, 16, rue des Tondeurs zu verlegen.

Der Artikel 5, Absatz 1, der Satzungen wird wie folgt abgeändert.

„ Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wiltz.(...)"
Die Tagesordnung ist abgeschlossen und die Sitzung wird aufgehoben.

<i>Kosten

Die Unkosten der vorstehenden Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf ungefähr 900.-€ abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.

Signé: M. Siebel, N. Maes, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 1er octobre 2010 - WIL/2010/832. Reçu soixante-quinze euros = 75 €.

<i>Le Receveur (signé): J. Pletschette.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr eirteilt um zu Verwaltungszwecken zu dienen.

Wiltz, den 5. Oktober 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010143632/49.
(100163706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

125134

L

U X E M B O U R G

EURO SPEED Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 70.932.

Les comptes annuels au 31/12/2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143613/10.
(100163698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

EURO SPEED Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 70.932.

Les comptes annuels au 31/12/2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143614/10.
(100163699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

EURO SPEED Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 70.932.

Les comptes annuels au 31/12/2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143615/10.
(100163701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

EURO SPEED Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 70.932.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143616/10.
(100163704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Whitehall French RE 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.922.225,93.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 138.808.

Constituée par-devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2008, acte publié au

Mémorial C no 1485 du 16 Juin 2008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Whitehall French RE 12 S.à.r.l.
Nicole Götz
<i>Manager

Référence de publication: 2010142385/15.
(100162179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2010.

125135

L

U X E M B O U R G

EURO SPEED Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 70.932.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143618/10.
(100163708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Exakt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-68, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 61.562.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143619/10.
(100163424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Fiduciaire DMD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 103.240.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010143620/10.
(100163433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Finb International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.058.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°58887 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010143621/12.
(100163799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Sofi S.C.A. Holding, Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 29.136.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2010142563/11.
(100162777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

125136


Document Outline

A-DGZ 13-Fonds

amandea MK

AMB Bonneuil Holding S.à r.l.

AMB Le Grand Roissy Holding 4 S.à r.l.

AMB Le Havre Holding S.à r.l.

AMB Port of Rouen Holding S. à r.l.

AMB St Pathus Holding S. à r.l.

Cash Plus

C.C.B. S.A.

Celesta S.A.

Deka-WorldGarant 10/2011

Eurizon Alternative Fund

Eurizon Focus Capitale Protetto

Eurizon Liquidity Fund

EURO SPEED Holding S.A.

EURO SPEED Holding S.A.

EURO SPEED Holding S.A.

EURO SPEED Holding S.A.

EURO SPEED Holding S.A.

Exakt S.A.

FCP OP Medical

Fiduciaire DMD S.à r.l.

Finb International S.A.

First Class

FS Invest II S.àr.l.

Glogger Fonds

GodmodeTrader.de Strategie I

Golding Investments III S.A.

Golding Investments IV S.A.

Golding Investments IV TF2 S.A.

Golding Mezzanine SICAV III

Golding Mezzanine SICAV IV

Grellmann Fire Protection S.àr.l.

Haspa PB Strategie

Hill International S.A.

Indra Holding Société Anonyme

Kikuoka Luxembourg S.A.

NV Strategie

NV Strategie Emerging

Selcius S.A.

Sireo Immobilienfonds No.6 Türkiye I S.à r.l.

Sofi S.C.A. Holding

Whitehall French RE 12 S.à r.l.