logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2557

24 novembre 2010

SOMMAIRE

Bocasi SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122723

Cable Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122731

Carbofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122726

Chelsea Invest Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . .

122727

Compagnie Financière de la Porte Neuve

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122727

Gelog A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122726

Gemstone Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

122726

Ginza Enterprises S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122726

Ginza Enterprises S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122727

Ginza Enterprises S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122727

Global Logistic Partners S.A.  . . . . . . . . . . . .

122731

GlobeOp Financial Services S.A. . . . . . . . . .

122736

Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxem-

burg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122736

Greenlark Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

122731

Immowald S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122736

ING REEIF Soparfi D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

122690

ING RPFFB Soparfi A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

122690

ING RPFFB Soparfi C S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

122690

ING RPFFB Soparfi Finco S.à r.l.  . . . . . . . .

122690

ING RPFI Soparfi A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

122691

ING RPFI Soparfi B S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

122702

ING RPFI Soparfi C S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

122702

Interassurances Pauly & Lamby et Associés

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122703

Invenergy Wind Europe Bulgaria S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122736

Inversiones Bren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122703

Inversiones Bren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122703

Inversiones Bren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122703

Inversiones Bren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122703

Investissimo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122704

Jacof S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122704

JAPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122704

Jean Charles Noel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

122704

JEANTY PARTNER Luxembourg S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122704

Jupiter International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

122705

KA Investments Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

122705

KA Investments Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

122705

Klingelnberg Luxemburg A.G. . . . . . . . . . . .

122705

LA Coussinerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122706

LA Coussinerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122706

Lagoas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122706

Landia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122722

Landia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122723

LCTS Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

122723

LDM Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122723

Nemab S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122706

Plus Russland Diskont-Beteiligung S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122691

122689

L

U X E M B O U R G

ING REEIF Soparfi D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 237.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.936.

Il est porté à la connaissance de tiers que le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant

de la société émargée, a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010.

Luxembourg, le 21 Octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139989/14.
(100160666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

ING RPFFB Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 71.013.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.522.

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant de la société émargée, a été transféré du

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

- M. Nicolas SCHREURS, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey

à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

- le siège social de la société ING RPFFB Soparfi B S.à r.l., associé de la société émargée, a été transféré du 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139990/18.
(100160749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

ING RPFFB Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 71.039.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.513.

Il est porté à la connaissance de tiers que le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant

de la société émargée, a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139991/14.
(100160751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

ING RPFFB Soparfi Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 95.511.

Il est porté à la connaissance de tiers que le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant

de la société émargée, a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

122690

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139992/14.
(100160752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

ING RPFI Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.350.025,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 72.289.

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant de la société émargée, a été transféré du

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

- M. Nicolas SCHREURS, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 40, avenue Monterey

à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

- le siège social de la société ING RPFI Soparfi B S.à r.l., associé de la société émargée, a été transféré du 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010.

Luxembourg, le 21 Octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139993/18.
(100160813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Plus Russland Diskont-Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.133.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzehn, am dreißigsten Tag des Monats September, vor Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz

in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1. Tecfocus, eine Gesellschaft errichtet gemäß dem Recht der Republik Zypern, mit Gesellschaftssitz Limassol, einge-

tragen im Handelsregister von Zypern unter der Nummer 270143 (Tecfocus),

vertreten durch Nicolas van Heule, Avocat, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, mittels einer privatrechtlich er-

teilten Vollmacht.

2. Plus Russland Holding GmbH, eine Gesellschaft errichtet gemäß dem Recht von Deutschland, mit Gesellschaftssitz

in Mülheim, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts von Duisburg unter der Nummer HRB 22321 (Plus Russland
Holding),

vertreten durch Herrn Uwe Klostermann, mit beruflicher Adresse in der Wissollstrasse 5 - 43, D-45478 Muelheim/

Ruhr, Deutschland handelnd als Geschäftsführer der Gesellschaft und auf Basis einer Vollmacht ausgestellt in Muelheim
an der Ruhr durch Herrn Markus Steinhoff, Geschäftsführer.

Diese Vollmachten, nachdem sie vom Bevollmächtigten der erscheinenden Parteien und dem unterzeichneten Notar

“ne varietur” unterzeichnet wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt.

Die erscheinenden Parteien, vertreten wie vorstehend bezeichnet, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die

Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”), die hiermit gegründet wird, wie
folgt zu dokumentieren:

I. Firma - Eingetragener Firmensitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Die Firma der Gesellschaft ist „Plus Russland Diskont-Beteiligung S.à r.l.“ (die Gesellschaft). Die Gesell-

schaft  ist  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (“société  à  responsabilité  limitée”),  die  der  Gesetzgebung  des
Großherzogtums Luxemburg unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in
der geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der gegenwärtigen Gründungssatzung (die Satzung).

122691

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Eingetragener Firmensitz.
2.1.Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann

durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter (i) innerhalb der Gemeinde und (ii) sofern die Gesellschafter gemäß den
Bedingungen handeln, die für Satzungsänderungen vorgesehen sind, an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten jeglicher Anteile in einer russischen Gesellschaft, deren Geschäftszweck

in der Entwicklung einer modernen Lebensmitteleinzelhandelsgesellschaft in der russischen Föderation, mit speziellem
Fokus auf eine Region von vierhundert (400) Kilometern um Moskau, wobei Konsens darüber besteht, dass die russische
Gesellschaft die operative Gesellschaft für ein russlandweites Vertriebsgeschäft sein soll. Der Gesellschaft soll es ferner
gestattet sein, Beteiligungen zu erwerben, in Luxemburg oder im Ausland, an jeglichen Gesellschaften oder Unternehmen
welcher Form auch immer und diese Beteiligungen und/oder Vermögen zu verwalten. Die Gesellschaft kann insbesondere
durch Zeichnung, Kauf und Tausch oder in jeder anderer Form Aktienkapital, Aktien und andere partizipatorische Effekte,
Obligationen, Anleihen, Einlagenzertifikate und andere Schuldinstrumente und im Allgemeinen jegliche Effekte und von
öffentlichen wie privaten juristischen Personen emittierte Finanzinstrumente kaufen. Sie kann an der Schaffung, Entwic-
klung, Verwaltung und Kontrolle jeder Gesellschaft und jeden Unternehmens teilnehmen. Sie soll ferner an der Gründung,
Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jeglicher Gesellschaft oder jeglichen Unternehmens teilnehmen können.

3.2. Die Gesellschaft soll in jeder Form außer im Wege öffentlichen Angebotes Darlehen aufnehmen können. Die

Gesellschaft, zur Vermeidung jeglichen Zweifels, darf keine regulierte Tätigkeit des Finanzsektors ausüben, ohne zuvor
die erforderliche Erlaubnis erhalten zu haben.

3.3. Die Gesellschaft darf alle Techniken und Instrumente benutzen, um sich gegen Kreditrisiken, Währungswechse-

lexponierung, Zinsratenrisiken und andere Risiken zu schützen.

3.4. Der Gesellschaft soll es gestattet sein, wirtschaftliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeiten und jegliche andere

Transaktionen hinsichtlich Immobilien oder beweglichen Vermögens durchzuführen, welche, direkt oder indirekt, dem
Gesellschaftszweck zugute kommen oder diesen betreffen.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft kann nicht aufgelöst werden wegen eines Sterbefalls, der Aufhebung von Bürgerrechten, Recht-

sunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder ähnlichen Vorkommnissen, die einen oder mehrere Gesellschafter betreffen.

II. Stammkapital - Anteile

Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) festgelegt und besteht aus fünfzigtau-

send (50.000) Anteilen in registrierter Form, mit einem Nennwert je Anteil von einem Euro (EUR 1), wobei alle Anteile
gezeichnet und voll eingezahlt sind.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann bei einem oder mehreren Anlässen durch einstimmigen Beschluss der

Gesellschafter in der Art und Weise, wie es für Satzungsänderungen vorgesehen ist, erhöht oder vermindert werden

Art. 6. Anteile.
6.1. Die Anteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Anteil an.
6.2. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
Wenn die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die Anteile dritten Parteien gegenüber frei übertragbar.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, unterliegt die Übertragung von Anteilen (unter Lebenden)

an dritte Parteien der vorherigen einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter.

Eine Anteilsübertragung bindet die Gesellschaft oder dritte Parteien nur nach einer Mitteilung an die Gesellschaft, oder

eine Billigung seitens der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

6.3. Am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Gesellschafter-

register aufbewahrt, das von jedem Gesellschafter, der dies verlangt, eingesehen werden kann. Jede Aktualisierung des
Gesellschafterregisters soll eine Mitteilungspflicht seitens der Gesellschaft begründen, welche innerhalb von acht (8) Tagen
nach Aktualisierung des Gesellschafterregisters jeden der Gesellschafter davon schriftlich oder mittels irgendeines ver-
gleichbaren anderen Kommunikationsmittels in Kenntnis setzen soll

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt sie hat dazu genügend verteilbare Rüc-

klagen oder wenn der Rückkauf von einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft herrührt.

III. Verwaltung - Vertretung

Art. 7. Ernennung und Entlassung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von einer Geschäftsführung geleitet, die aus mindestens einem (1) Klasse A Geschäftsführer

und mindestens einem (1) Klasse B Geschäftsführer besteht (die Geschäftsführung). Die Geschäftsführer werden durch

122692

L

U X E M B O U R G

einstimmigen Beschluss der Gesellschafter ernannt, welcher ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer brauchen keine
Gesellschafter zu sein.

7.2. Die Gesellschafter können die Geschäftsführer durch einen einstimmigen Beschluss gemäß Artkeil 10.2. (vii) der

Satzung jederzeit, mit oder ohne Grund, abberufen.

Art. 8. Die Geschäftsführung.
8.1. Befugnisse der Geschäftsführung
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz, die Satzung oder Beschlüsse der Gesellschafter den Ge-

sellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung, die alle Befugnisse haben soll,
um alle Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu bewilligen, die mit dem in Artikel 3 der Satzung dargestellten
Gesellschaftszweck übereinstimmen.

(ii) Besondere und begrenzte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten durch einen Beschluss der Ge-

schäftsführung, an einen (1) oder mehrere Vertreter erteilt werden.

8.2. Vorgehensweise
(i) Die Geschäftsführung soll auf Verlangen welcher zwei (2) Geschäftsführer auch immer oder des Klasse A Ge-

schäftsführers  an  dem  Ort  zusammentreten,  der  in  den  Einberufungsbekanntmachungen  angegeben  ist,  welcher  sich
normalerweise in Luxemburg befinden soll.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung jeder Sitzung der Geschäftsführung soll mindestens vierundzwanzig (24) Stunden

vor dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer ergehen, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art und Umstände
in der Einberufungsbekanntmachung für die Sitzung der Geschäftsführung anzugeben sind.

(iii) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung in einer Sitzung anwesend

oder vertreten sind und erklären, vollumfänglich über die Tagesordnung der Sitzung informiert worden zu sein. Es kann
von jedem Geschäftsführer auf die Bekanntmachung vor der Sitzung verzichtet werden. Separate schriftliche Bekannt-
machungen sollen für Sitzungen, die an Orten und zu Zeiten abgehalten werden, die in einem vorher von der Geschäfts-
führung verabschiedeten Anhang präzisiert wurden, nicht erforderlich sein.

(iv) Ein Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäfts-

führer schriftlich zu seinem Vertreter bestellt.

(v) Die Geschäftsführung kann nur rechtswirksam tagen und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder und

mindestens ein (1) Klasse A Geschäftsführer und ein (1) Klasse B Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse der Geschäftsführung werden in Protokollen aufgezeichnet, welche durch den Vorsitzenden der Sitzung oder,
wenn kein Vorsitzender ernannt wurde, durch alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterschrieben wer-
den.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jegliche andere Kommunikationsmittel

an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen, die es allen Personen, die an der Sitzung teilnehmen, ermöglichen,
einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel kommt einer per-
sönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gleich.

(vii) Umlaufbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer (die Geschäftsführerumlaufbeschlüsse) unterzeichnet wurden

sind gültig und bindend, als wären sie in einer Sitzung der Geschäftsführung erlassen worden, welche formgemäß einbe-
rufen und gehalten wurde und tragen das Datum der letzten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber dritten Parteien durch die gemeinsame Unterschrift eines

(1) Klasse A Geschäftsführers und eines (1) Klasse B Geschäftsführers gebunden.

(ii) Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber dritten Parteien durch die Unterschrift jeder Person ge-

bunden, der besondere Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten durch Beschluss der Geschäftsführung übertragen
worden sind.

Art. 9. Alleingeschäftsführer.
9.1. Wenn die Gesellschaft durch einen Alleingeschäftsführer geführt wird, sind alle Verweise in der Satzung auf die

Geschäftsführung oder die Geschäftsführer, soweit angemessen, als Verweise auf den Alleingeschäftsführer zu verstehen.

9.2. Die Gesellschaft ist gegenüber dritten Parteien durch die Unterschrift des Alleingeschäftsführers gebunden.
9.3. Die Gesellschaft ist gegenüber dritten Parteien auch durch die Unterschrift jeder Person gebunden, der besondere

Vollmachten durch den Alleingeschäftsführer übertragen worden sind.

IV. Gesellschafter

Art. 10. Hauptversammlungen der Gesellschafter und Gesellschafterumlaufbeschlüsse.
10.1 Befugnisse, Stimm- und Ernennungsrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden bei der Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder

im Wege von Gesellschafterumlaufbeschlüssen erlassen.

122693

L

U X E M B O U R G

(ii) Wenn Beschlüsse als Gesellschafterumlaufbeschlüsse gefasst werden sollen, wird der Text der Beschlüsse, gemäß

der Satzung, allen Gesellschaftern zugesendet. Gesellschafterumlaufbeschlüsse, die von allen Gesellschaftern unterzeich-
net wurden, sind gültig und bindend als wären sie in einer Hauptversammlung erlassen worden, welche ordnungsgemäß
einberufen und gehalten wurde und tragen das Datum der letzten Unterschrift.

(iii) Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine (1) Stimme.
(iv) Plus Russland Holding (wie oben definiert) soll auf der Grundlage dieser Satzung ermächtigt sein, der Hauptver-

sammlung  die  Ernennung  des  jeweiligen  Klasse  A  Geschäftsführers  der  Gesellschaft  vorzuschlagen,  wobei  Konsens
darüber besteht, dass Tecfocus sich verpflichtet, seine Zustimmung zu allen Beschlüssen zu geben, die in Verbindung mit
der Ernennung - auch im Fall eines Wechsels - des Klasse A Geschäftsführers notwendig sind.

10.2 Bekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Stimmverfahren
(i) Die Gesellschafter werden zu den Hauptversammlungen der Gesellschafter einberufen oder schriftlich befragt auf

Initiative eines oder mehrerer Geschäftsführer(s) oder eines oder mehrerer Gesellschafter(s) hin ungeachtet der Höhe
seines/ihres Anteils am Stammkapital der Gesellschaft.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung über jede Hauptversammlung wird allen Gesellschaftern mindestens vierzehn

(14) Tage vor dem Datum der Sitzung mitgeteilt, außer in einem Notfall, in welchem Fall die Art und Umstände in der
Bekanntmachung anzugeben sind.

(iii) Hauptversammlungen werden an dem in den Bekanntmachungen angegebenen Ort und zu der angegebenen Zeit

abgehalten, welche einstimmig von den Gesellschaftern festgelegt wurden.

(iv) Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und über die

Tagesordnung der Hauptversammlung informiert erachten, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Bekanntmachung
einberufen werden.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, Gesellschafter oder nicht, schriftlich eine Vollmacht erteilen, um

sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen.

(vi) Vorbehaltlich Artikel 10.2 (vii) unten oder strengerer Wahlmehrheitserfordernisse des Gesetzes und/oder der

Satzung, werden Beschlüsse, die bei den Hauptversammlungen oder durch Gesellschafterumlaufbeschlüsse gefasst werden
sollen, durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter gefasst. Jede Hauptversammlung (unabhängig ob
sie physisch abgehalten wird oder mittels Gesellschafterumlaufbeschluss) soll nur beschlussfähig sein wenn alle Gesell-
schafter, die 100% des Stammkapitals vertreten, anwesend sind, vertreten sind oder sonstwie an der Hauptversammlung
oder dem Gesellschafterumlaufbeschluss teilnehmen. Wenn diese Bedingung bei der ersten Hauptversammlung nicht
erfüllt wird und die Gesellschafter durch Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung berufen werden, werden die
Beschlüsse bei der zweiten Hauptversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ungeachtet des Proporzes
des vertretenen Stammkapitals gefasst. Zur Vermeidung jeglichen Zweifels soll der vorangehende Satz nicht Anwendung
finden auf einen zweiten Beschluss, sollte er im Wege eines Gesellschafterumlaufbeschlusses ergehen.

(vii) Ungeachtet jeglicher Vorschriften dieser Satzung, unterliegen die folgenden Angelegenheiten der Zuständigkeit

der Hauptversammlung und erfordern die vorherige einstimmige Zustimmung der Gesellschafter bei einer Hauptver-
sammlung oder im Rahmen von Gesellschafterzirkularbeschlüssen:

(1) jegliche Änderung der Satzung einschließlich der Veränderung der Höhe des Stammkapitals der Gesellschaft;
(2) ein Wechsel der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Gesellschaftereinlageverpflichtung gegenüber

der Gesellschaft;

(3) die Nominierung eines Geschäftsführers oder eines anderen Exekutivorgans der Gesellschaft, deren Entlastung,

die Festlegung seiner Vergütung und die Beendigung dessen Tätigkeit vor Ende seiner vorgesehenen Laufzeit;

(4) Regelungen über Prämien oder Vergütungen (z.B. für Geschäftsführer, Angestellte oder dritte Parteien) in Form

von Beteiligungen aller Art (z.B. als Beteiligung am Umsatz, am Ergebnis, an der Gesellschaft, an ihrem Wert oder der
jeweiligen betreffenden Steigerung);

(5) die Bestätigung der Jahres- und Finanzberichte; die Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung; die Bestellung

der Abschlussprüfer (inklusive des Liquidationsprüfers) und die Festlegung deren Vergütung

(6) die Aufstellung, Annahme und die Änderung von Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung;
(7) die Beschlussfassung über die Platzierung von Obligationen und anderen Wertpapieren durch die Gesellschaft;
(8) die Beschlussfassung über eine Umwandlung oder anderweitige Reorganisation der Gesellschaft (z.B. Verschmel-

zung, Ausgliederung, Aufspaltung usw.) oder die Auflösung der Gesellschaft; die Ernennung des Liquidators/der Liquida-
toren der Gesellschaft und die Bestätigung der Liquidationsbilanzen und der Liquidationsberichte;

(9) die Eröffnung von Zweigniederlassungen und eingetragenen Repräsentanzen der Gesellschaft;
(10) Anfragen für die Erbringung von Kapitaleinlagen oder anderen Finanzmitteln durch die Gesellschafter, falls nicht

in der genehmigten Jahresplanung vorgesehen;

(11) der Abschluss, die Beendigung oder die Änderung von Unternehmensverträgen (insbesondere Beherrschungs-,

Gewinnabführungs-, Betriebsführungs- oder vergleichbare Verträge) sowie Joint-Venture Verträgen;

(12) die Zustimmung zu Rechtsgeschäften und Maßnahmen, die gemäß dem Gesetz, der Satzung oder Gesellschafter-

beschlüssen oder anderer Vereinbarungen der Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen; und

122694

L

U X E M B O U R G

(13) die Beschlussfassung über sonstige Angelegenheiten, die gemäß den betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und/

oder der Satzung in die alleinige und ausschließliche Kompetenz der Gesellschafterversammlung fallen.

Art. 11. Alleingesellschafter.
11.1. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf eins (1) reduziert wird, übt der Alleingesellschafter alle Befugnisse aus,

die durch das Gesetz der Hauptversammlung zugeteilt sind.

11.2 Jeder Verweis in der Satzung auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Gesellschafterumlauf-

beschlüsse muss, soweit angemessen, als Verweis auf den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterumlaufbeschlüsse
gelesen werden.

11.3. Die Beschlüsse des Alleingesellschafters sind in den Protokollen verbrieft oder schriftlich niedergelegt.

V. Jahresberichte, Gewinnverteilung, Aufsicht

Art. 12. Geschäftsjahr und Bewilligung der Jahresberichte.
12.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember

eines jeden Jahres.

12.2. Jedes Jahr bereitet die Geschäftsführung die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten sowie die Inventarliste

vor, welche den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft auflistet zusammen mit einem Anhang, der alle ihre Verp-
flichtungen und etwaigen Verbindlichkeiten des/der Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter der Gesellschaft gegenüber
zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Inventarliste und die Bilanz am eingetragenen Firmensitz einsehen. Die Details

jeglicher weiterer Informationsrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Geschäftsordnung der Geschäftsfüh-
rung, welche durch die Gesellschafter gemäß 10.2 (vii) (6) angenommen wurde.

12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden bei der jährlichen Hauptversammlung oder durch Ge-

sellschafterumlaufbeschlüsse innerhalb von sechs (6) Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres bewilligt.

Art. 13. Externe Wirtschaftsprüfer (Réviseurs d'entreprises).
13.1. Die Geschäfte der Gesellschaft können von einem oder mehreren externen Wirtschaftsprüfern (réviseurs d'en-

treprises) überwacht werden.

13.2. Die Gesellschafter ernennen die externen Wirtschaftsprüfer, sofern vorhanden, und bestimmen ihre Zahl, Ent-

lohnung und die Dauer ihrer Amtszeit, welche nicht mehr als sechs (6) Jahre sein darf, bei gegebener Möglichkeit der
Wiederwahl.

Art. 14. Gewinnverteilung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Dieses Erfor-

dernis weicht, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

14.2. Die Gesellschafter bestimmen über die Zuteilung des Überschusses des jährlichen Nettogewinns. Sie können

über die Ausschüttung einer Dividende, die Übertragung des Überschusses zu einem Rücklagenkonto oder den Vortrag
gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen entscheiden.

14.3. Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;
(ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emissionsagios) zur

Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlwissentlich, dass der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit Ende
des letzten Geschäftsjahres für das die Abschlüsse approbiert wurden, sofern vorhanden, nicht übersteigen darf, erhöht
um die Gewinnvorträge und verteilbare Rücklagen und abzüglich der Verlustvorträge und Summen, die der gesetzlichen
Rücklage zugeteilt werden müssen;

(iii) die Hauptversammlung muss einstimmig die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten, innerhalb von zwei

(2) Monaten vom Zeitpunkt des Zwischenabschlusses an treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind angesichts der Aktiva der Gesellschaft nicht bedroht; und
(v) wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die verteilbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen,

müssen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter, welcher mit der Zustimmung aller Gesell-

schafter angenommen wurde, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die keine
Gesellschafter zu sein brauchen, um die Liquidation auszuführen and bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung.

15.2. Der Überschuss nach Veräußerung der Aktiva und Zahlung der Verbindlichkeiten wird den Gesellschaftern im

Verhältnis zu ihren jeweils gehaltenen Anteilen ausgezahlt.

122695

L

U X E M B O U R G

VI. Allgemeine Bestimmungen

16.1. Bekanntmachungen und Mitteilungen können gemacht werden oder es kann auf sie verzichtet werden, und Ge-

schäftsführer- und Gesellschafterumlaufbeschlüsse können schriftlich, durch Fax, Email oder jedes andere elektronische
Kommunikationsmittel nachgewiesen werden.

16.2. Vollmachten werden durch jedes der oben beschriebenen Mittel erteilt. Vollmachten im Zusammenhang mit

Sitzungen der Geschäftsführung können auch durch einen Geschäftsführer in Übereinklang mit solchen Bedingungen, die
von der Geschäftsführung akzeptiert werden, erteilt werden.

16.3. Unterschriften können handschriftlich oder in elektronischer Form erfolgen, vorausgesetzt sie erfüllen alle ge-

setzlichen  Voraussetzungen  um  mit  handschriftlichen  Unterschriften  als  gleichwertig  betrachtet  werden  zu  können.
Unterschriften der Geschäftsführerumlaufbeschlüsse, sowie durch die Geschäftsführung telefonisch oder im Wege einer
Videokonferenz ergehenden Beschlüsse oder Gesellschafterumlaufbeschlüsse, je nach Lage der Dinge, werden einem
Original oder mehreren Ausführungen desselben Dokuments angeheftet, wobei alle zusammen ein und dasselbe Doku-
ment darstellen.

16.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausschließlich durch diese Satzung geregelt werden, werden in Übereinklang mit

dem anwendbaren Gesetz und, vorbehaltlich nicht abbedingbarer Vorschriften des Gesetzes, in Übereinklang mit jeder
Übereinkunft bestimmt, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit getroffen haben. Die Satzung soll, im weitesten rechtlich
zulässigen Maße, im Lichte und in Übereinklang mit den Übereinkünften ausgelegt werden, die die Gesellschafter getroffen
haben (die Übereinkünfte), wobei Konsens darüber besteht, dass unter den Gesellschaftern letztere den Bestimmungen
dieser Satzung vorgehen sollen. Wenn einzelne Vorschriften dieser Satzung ungültig sind oder im Falle von Lücken in
dieser Satzung, soll die Gültigkeit der verbleibenden Vorschriften hiervon unberührt bleiben. Um die ungültige Vorschrift
zu ersetzen sollen sich Plus Russland Holding (wie oben definiert) und Tecfocus (wie oben definiert) bezüglich einer
Vorschrift einigen, die angesichts des Ziels und Zwecks dieser Übereinkünfte vernünftigerweise getroffen worden wäre,
wäre diese Angelegenheit von Anfang an berücksichtigt worden.

16.5. Im weitesten rechtlich zulässigen Maße werden alle Streitigkeiten, die sich aus und im Zusammenhang mit dieser

Satzung oder deren Gültigkeit ergeben, nach der Schieds- und Schlichtungsordnung des Internationalen Schiedsgerichts
der  Wirtschaftskammer  Österreich  in  Wien  (Wiener  Regeln)  von  einem  mit  drei  gemäß  diesen  Regeln  ernannten
Schiedsrichtern besetzten Schiedsrichtersenat ausschließlich und endgültig entschieden. Sitz des Schiedsgerichts ist Wien.
Die Sprache des schiedsrichterlichen Verfahrens ist deutsch. Die Parteien sind jedoch berechtigt, von ihnen zu Beweisz-
wecken vorzulegende Schriftstücke auch in englischer Sprache oder in englischer Übersetzung vorzulegen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr soll am Tag dieser Urkunde beginnen und am 31. Dezember 2010 enden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Plus Russland Holding (wie oben definiert), vertreten wie vorstehend angegeben, zeichnet fünfundzwanzigtausend-

fünfhundert (25.500) Anteile in registrierter Form mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), und willigt zu, diese
Anteile vollständig durch Bareinlage eines Betrags von fünfundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 25.500) zu bezahlen,

und
Tecfocus  (wie  oben  definiert),  vertreten  wie  vorstehend  angegeben,  zeichnet  vierundzwanzigtausendfünfhundert

(24.500) Anteile in registrierter Form mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), und willigt zu, diese Anteile
vollständig durch Bareinlage eines Betrags von vierundzwanzigtausendfünfhundert Euro (EUR 24.500) zu bezahlen.

Der Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) steht somit zur Verfügung der Gesellschaft, wie dem unterzeichneten

Notar bescheinigt wurde.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und Auslagen jeder Art, die von der Gesellschaft in Folge ihrer Gründung zu tragen

sind, werden auf ungefähr EUR 2.000.- geschätzt.

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter der Gesellschaft, die das gesamte gezeichnete

Stammkapital vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zum Klasse A Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Uwe Klostermann, Vorstandsvorsitzender, geboren am 6. August 1961 in Okel (jetzt Syke), Deutschland, mit

beruflicher Adresse in der Wissollstrasse 5 - 43, D-45478 Muelheim/Ruhr, Deutschland.

2. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Klasse B Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr Martinus C.J. Weijermans, geboren am 26. August 1970 in 's-Gravenhage, Niederlande, mit beruflicher Adresse

in der 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Gerald Welvaert, geboren am 15. Juli 1977 in Uccle, Belgien, mit beruflicher Adresse in der 46A, Avenue J. F.

Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

122696

L

U X E M B O U R G

3. Der Sitz der Gesellschaft ist 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der er-

scheinenden Parteien die gegenwärtige Urkunde auf Deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in englischer Sprache,
und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem deutschen und dem englischen Text die deutsche Fassung vorgeht.

WORÜBER, am oben genannten Tage diese Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der erscheinenden Parteien hat dieser sie zusammen mit dem unter-

zeichneten Notar unterzeichnet.

Es folgt die englische Übersetzung:

In the year two thousand and ten, on the thirtiest day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Tecfocus Investments Limited, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, having its regis-

tered office in Limassol, registered with the commercial register of Cyprus under number 270143 (Tecfocus),

here represented by Nicolas van Heule, Lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney given under private seal,

2. Plus Russland Holding GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office in

Mülheim, registered with the commercial register of the local court of Duisburg, under number HRB 22321 (Plus Russland
Holding),

here represented by Mr Uwe Klostermann, residing professionally at Wissollstrasse 5 - 43, D-45478 Muelheim/ Ruhr,

Germany, acting as manager of the Company and by virtue of a power of attorney given by Mr Markus Steinhoff, manager,
in Mülheim/Ruhr.

The powers of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary, to state as follows

the  articles  of  incorporation  of  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée),  which  is  hereby
incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Plus Russland Diskont-Beteiligung S.à r.l." (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by an unanimous resolution of the shareholders. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by an unanimous resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the holding of any and all shares in a Russian company whose business purpose

lies in the development of a modern food discount retail company in the Russian Federation, specifically in the Moscow
region, in an area of approximately four hundred (400) kilometres around Moscow, it being understood that this Russian
company shall be the operating company for a Russia wide retail business. The Company shall further be entitled to
acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and to manage
such participations and/or properties. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange
or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private
entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. For the avoidance of doubt, the Company

may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to protect itself against credit risks, currency exchange

exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

122697

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is fixed at fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by fifty thousand (50,000)

shares in registered form, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by an unanimous resolution

of the shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable among shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior unanimous approval by the shareholders.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Company law and may be examined by each shareholder who so requests. Each update of the shareholders' register
shall give rise to a notification duty of the Company, who shall within eight (8) days of the update of the shareholders'
register inform each of the shareholders thereof in writing or by any other equivalent means of communication.

6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one (1) class A manager and at least one (1) class

B manager (the Board). The managers are appointed by a unanimous resolution of the shareholders, which sets the term
of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by an unanimous resolution of the shareholders

in accordance with article 10.2. (vii) of the Articles.

Art. 8. Board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles or by the resolutions of the

shareholders shall fall within the competence of the Board, who shall have all powers to carry out and approve all acts
and operations consistent with the corporate object set forth in article 3 hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the

Board.

8.2. Procedure
(i) The Board shall meet upon the request of any two (2) managers or the class A manager, at the place indicated in

the convening notice which, in principle, shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice shall be required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full

knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager before a meeting. Separate
written notices shall not be required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting

of the Board.

(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members and at least one (1) class A manager and

one (1) class B manager is present or represented. The resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by
the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by such means shall be deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

122698

L

U X E M B O U R G

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), shall be valid and binding as

if passed at a Board meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager

and one (1) class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers

have been delegated by a resolution of the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
10.1. Powers, voting and nomination rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
(iv) Plus Russland Holding (as defined above) shall by virtue of these Articles be entitled to propose to the General

Meeting the nomination of the respective class A manager of the Company, it being understood that Tecfocus (as defined
above) undertakes to give its consent to all resolutions required in connection with the appointment -also in case of
change- of this class A manager.

10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

any of the shareholders irrespective of their shareholding in the share capital of the Company.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least fourteen (14) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings shall be held in Luxembourg at the time and place specified in the notices or at any other place

and time unanimously agreed upon by the shareholders.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Subject to article 10.2 (vii) below or save as to more stringent voting majority requirements set out in the Law

and/or the Articles, resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are
passed by the majority of votes cast of the shareholders. Any General Meeting (irrespective of whether physically or by
way of Shareholders' Circular Resolutions) shall only be quorate if all shareholders representing 100% of the share capital
are present or represented or otherwise participate in the General Meeting or a Shareholders' Circular Resolution. If
this condition is not reached at the first General Meeting and the shareholders are convened by registered letter to a
second General Meeting, the resolutions are adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast,
irrespective of the proportion of the share capital represented. For the avoidance of doubt, the preceding sentence shall
not apply to a second resolution held by way of a Shareholders' Circular Resolution.

(vii) Notwithstanding any provisions of these Articles, the following matters fall within the competence of the General

Meeting and shall require the prior approval of an unanimity of the shareholders at a General Meeting or by way of
Shareholders' Circular Resolutions:

(1) any amendment to the Articles including the altering of the amount of the Company's share capital;
(2) a change of the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company;
(3) nomination of a manager or other executive body of the Company, his/her/its discharge, the determination of his/

her/its compensation and the termination of his/her/its office before the end of the envisaged term;

122699

L

U X E M B O U R G

(4) rules concerning premiums or compensations (e.g. for managers, employees and other third parties) in the form

of  participation  of  any  kind  (e.g.  as  participation  in  turnover,  profit,  participation  in  the  company,  its  value,  or  their
respective increase);

(5) approval of annual accounts and financial reports; resolutions concerning the usage of financial statements; ap-

pointment of the annual auditors (including liquidation auditors) and determining their remuneration;

(6) setting-up, adoption and modification of rules of procedures for the Board;
(7) resolution to issue obligations or other securities by the Company;
(8) resolutions to change the corporate form of or otherwise reorganise the Company (e.g. by merger, demerger,

split up etc.) or the liquidation of the Company; appointment of the liquidator(s) of the Company and approval of the
liquidation balance sheets and liquidation reports;

(9) establishing of subsidiaries and registered branches of the Company;
(10) calls for contribution of capital or other funding by the shareholders unless foreseen in the approved annual

planning;

(11) conclusion, termination or alteration of affiliation agreements (particularly domination agreements, transfer of

profits agreements, management agreements or similar agreements) as well as joint-venture-agreements;

(12) approval of transactions and measures which according to the Law, the Articles or resolutions of the shareholders

or agreements require the approval of the General Meeting; and

(13) resolutions concerning other matters which according to the respective legal provisions and/or the Articles are

solely and exclusively within the competence of the meeting of the shareholders.

Art. 11. Sole shareholder.
11.1.When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

11.2.Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolu-

tions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

11.3.The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Every year the Board prepares the balance sheet and profit and loss account, as well as an inventory stating the

value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and any debts owed by the
manager(s) and shareholders to the Company.

12.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office. The details of any further

information rights of the shareholders shall be governed by rules of procedures for the Board adopted by the shareholders
in accordance with section 10.2.(vii)(6).

12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 13. External Auditors (réviseurs d'entreprises).
13.1. The Company's operations may be supervised by one or more external auditors (réviseurs d'entreprises).
13.2. The shareholders are entitled to appoint the external auditors, if any, and determine their number and remu-

neration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by the Law. This

requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the General Meeting must take the decision with unanimous consent to distribute interim dividends within two

(2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and

122700

L

U X E M B O U R G

(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of all

of the shareholders. The shareholders appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the
liquidation, and determine their number, powers and remuneration.

15.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

16.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax or by way of scans attached to e-mails.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the Law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time. To the widest extent legally permitted, the Articles shall be read and interpreted in light of and conformity with
agreements entered into by the shareholders (the Agreements), it being understood, that among the shareholders, the
latter shall pre-empt and override the provisions of these Articles. If individual provisions of these Articles are invalid or
in case of any gaps in these Articles, this shall not affect the validity of the remaining provisions. To replace the invalid
provision Plus Russland Holding (as defined above) and Tecfocus (as defined above) shall agree on a provision that meets
the objective and purpose of the invalid provision in light of the Agreements entered into by the shareholders. In the
event of gaps, Tecfocus and Plus Russland Holding (as defined above) shall agree on a provision, that in light of the objective
and purpose of the Agreements, reasonably would have been stipulated if such matter had been taken into consideration
from the outset.

16.5. To the widest extent legally permitted, any disputes arising under or in connection with the Articles or its validity

shall be exclusively and finally decided pursuant to the provisions of the Rules of Arbitration and Conciliation of the
International Arbitral Centre of the Austrian Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by an arbitral tribunal com-
prised of three (3) arbitrators appointed in accordance with these rules. The place of arbitration shall be Vienna. The
language of the arbitration proceedings shall be German. The parties shall however be entitled to also submit any docu-
ments required as evidence in English or in an English translation.

VIII. Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2010.

<i>Subscription and Payment

Plus Russland Holding (as defined above), represented as stated above, subscribes to twenty-five thousand five hundred

(25,500) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of twenty-five thousand five hundred euro (EUR 25,500),

and
Tecfocus (as defined above), represented as stated above, subscribes to twenty-four thousand five hundred (24,500)

shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash of twenty-four thousand five hundred euro (EUR 24,500).

The amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to

the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately EUR 2.000,-.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-

scribed capital, have passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:

122701

L

U X E M B O U R G

- Mr. Uwe Klostermann, CEO, born on August 6, 1961 in Okel (now Syke), Germany and professionally residing at

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Muelheim/Ruhr, Germany.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Martinus C.J. Weijermans, born on August 26, 1970 in 's-Gravenhage, The Netherlands and professionally residing

at 46 A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Gerald Welvaert, born on July 15, 1977 in Uccle, Belgium, and professionally residing at 46 A, Avenue J. F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

3.The registered office of the Company is set at 46 A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this

deed is drawn up in English, followed by a German version, and that in the case of divergences between the English text
and the German text, the German text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, who has signed it together with the undersigned

notary.

Gezeichnet: N. VAN HEULE, U. KLOSTERMANN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44296. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 19. Oktober 2010.

Référence de publication: 2010139205/599.
(100159259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

ING RPFI Soparfi B S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 225.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.145.

Il est porté à la connaissance de tiers que:
- le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant de la société émargée, a été transféré du

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

- le siège social de la société ING RPFI Soparfi C S.à r.l., associé de la société émargée, a été transféré du 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010.

Luxembourg, le 21 Octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139994/16.
(100160814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

ING RPFI Soparfi C S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 74.146.

Il est porté à la connaissance de tiers que le siège social de la société IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l., gérant

de la société émargée, a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, avec effet au 5 juillet 2010;

Luxembourg, le 21 Octobre 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139995/14.
(100160815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122702

L

U X E M B O U R G

Interassurances Pauly &amp; Lamby et Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.266.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010139996/9.
(100160545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Inversiones Bren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.601.

EXTRAIT

II résulte de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 septembre 2010 que:
- La société Réviconsult S.àr.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148

Luxembourg a été réélue au poste de Commissaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010140000/15.
(100160326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Inversiones Bren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.601.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Référence de publication: 2010140001/10.
(100160327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Inversiones Bren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.601.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Référence de publication: 2010140002/10.
(100160328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Inversiones Bren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.601.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

Référence de publication: 2010140003/10.
(100160329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122703

L

U X E M B O U R G

Investissimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 100.068.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010140004/9.
(100160800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Jacof S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.068.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2010.

Référence de publication: 2010140010/11.
(100160648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

JAPI, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 130.511.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2010.

Référence de publication: 2010140011/10.
(100160084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Jean Charles Noel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 332, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 45.707.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010140012/9.
(100160854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

JEANTY PARTNER Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 130.776.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 8 octobre 2010

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de 2, rue Dick, L-4220 Esch-sur-Alzette au 25, avenue de la Gare, L-4131

Esch-sur-Alzette avec effet immédiat.

Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 2010.

<i>Pour la société
Willi Charles Jeanty

Référence de publication: 2010140013/14.
(100160685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122704

L

U X E M B O U R G

Jupiter International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.498.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extra-Ordinaire du
19 octobre 2010 à 16h00
le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 60 Grand-Rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg,

Luxembourg

à effet du 20 octobre 2010.

Le 21 octobre 2010.

JUPITER INTERNATIONAL Sàrl
Gerardus H. M. OSSEVOORT
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2010140014/17.
(100160812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

KA Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 22.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KA INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2010140015/12.
(100160343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

KA Investments Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 22.114.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 26 mars 2010

Monsieur Carlo SCHLESSER, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant pro-

fessionnellement  au  412F,  route  d'Esch,  L-2086  Luxembourg,  est  nommé  Administrateur-Délégué  pour  une  période
statutaire de 4 ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Le 26 mars 2010.

Certifié sincère et conforme
KA INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2010140016/16.
(100160569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Klingelnberg Luxemburg A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 55.451.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2010.

Référence de publication: 2010140023/10.
(100160358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122705

L

U X E M B O U R G

LA Coussinerie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8154 Bridel, Ferme de Klingelbour.

R.C.S. Luxembourg B 16.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ELIOLUX S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010140029/11.
(100160047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

LA Coussinerie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8154 Bridel, Ferme de Klingelbour.

R.C.S. Luxembourg B 16.627.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ELIOLUX S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010140030/11.
(100160048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Lagoas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.658.

La soussignée,
TRUSTAUDIT S.à.R.L. (anciennement TRUSTAUDIT S.A.),
Dont le siège social est situé au 207, Route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, Immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le numéro B 73.125,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:
LAGOAS S.A.
ayant son siège social au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 97.658
Date effective: le 8 septembre 2010

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2010.

TRUSTAUDIT S.à.R.L
(anciennement TRUSTAUDIT S.A.)

Référence de publication: 2010140031/19.
(100160228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Nemab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.506,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.353.

In the year two thousand and ten, on the eight of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) NEINVER, S.A., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at Francisca Delgado

11, 5a planta, Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Spain and registered with the Mercantile Registry of Madrid
(Spain) under number 48331, in tome 5270, Section 8, folio 210, sheet number M-93606 (the "A Shareholder") here
represented by Mrs Judith STERN, professionally residing in Luxembourg, by virtue of one proxy given under private seal
dated Luxembourg, 8 

th

 October, 2010;

122706

L

U X E M B O U R G

2) MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having

its registered office at Wijnhaven 60, 2511 GA The Hague, registered with the chamber of commerce of The Hague under
number 27377056 (the "B Shareholder") here represented by Mr Johannes Gijsbertus Franciscus Eijkemans, manager
(“Bestuurder”) of the sole manager (“Bestuurder”) of the B Shareholder, MAB Development Group B.V., a company
incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Wijnhaven 60, 2511 GA The Hague,
registered with the chamber of commerce of The Hague under number 27104028, residing in Boulevard 42, 3707 BN
Zeist, The Netherlands, and by Mr Nicolaas Augustinus Franciscus Blüm, being the authorised agent (“Gevolmachtigde”)
of the sole manager (“Bestuurder”) of the B Shareholder, MAB Development Group B.V., residing in Van Reenenlaan 3,
3744 MD Baarn, The Netherlands.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

-The appearing parties are the shareholders of Nemab S.à.r.l.,a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume
Kroll  (Grand  Duchy  of  Luxembourg),  and  registered  with  the  Luxembourg  trade  and  companies  register  under  the
registration number B 153.353 (the "Company") incorporated by a deed of the undersigned notary, on May 21 

st

 , 2010,

as published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1488 dated July 20 

th

 , 2010.

The articles of incorporation of the Company have not been amended since the constitution of the Company.
- The agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company is worded as follows.

<i>Agenda:

1. Creation of the following three new classes of shares in the corporate capital of the Company:
- class C shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each;
- class D shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each;
- class E shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each;
2. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 6 (six Euro) by issuing:
- 2 (two) new class C shares (the “Class C Shares”) with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, numbered from

12,501 to 12,502;

- 2 (two) new class D shares (the “Class D Shares”) with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, numbered from

12,503 to 12,504; and

- 2 (two) new class E shares (the Class E Shares”) with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, numbered from

12,505 to 12,506.

so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,506.-(twelve

thousand five hundred and six Euro);

3. Subscription and payment of the new Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares and the related share

premium by the A Shareholder and the B Shareholder by:

(a.) contributions in kind consisting of:
- 30.000 (thirty thousand) corporate units with a nominal value of EUR 100.-(one hundred Euro) each, altogether

representing 100% of the issued corporate capital of MAB Roppenheim S.à.r.l., a company validly organised and existing
under the laws of France, having its registered office at 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France) and
registered with the RCS of Paris under the registration number 430 129 338 and with tax identification number FR33
430 129 338 (the “Roppenheim SPV"), valued at least at EUR 78,000.-(seventy eight thousand Euro);

- 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 16.-(sixteen Euro) each, altogether representing

100% of the issued corporate capital of Champs-Vernet S.à r.l., a company validly organised and existing under the laws
of France, having its registered office at 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France) and registered with the
RCS of Paris under the registration number 440 226 595 and with tax identification number FR62 440 226 595 (the
“Honfleur SPV") valued at least at EUR 4,000.-(four thousand Euro);

- 100 (one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 100.-(one hundred Euro) each, altogether repre-

senting 100% of the issued corporate capital of Bellegarde Village des Alpes S.à r.l., a company validly organised and existing
under the laws of France, having its registered office at 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France) and
registered with the RCS of Paris under the registration number 514 720 135 and with tax identification number FR54
514 720 135 (the “Bellegarde SPV") valued at least at EUR 9.880,46.-(nine thousand eight hundred eighty Euro and forty
six Cent);

- an existing/unquestioned claim against the Roppenheim SPV amounting to EUR 2,459,533.92 (two million four hun-

dred fifty-nine thousand five hundred thirty-three Euro and ninety-two Cent) held by the A Shareholder;

- an existing/unquestioned claim against the Roppenheim SPV amounting to EUR 2,459,533.92 (two million four hun-

dred fifty-nine thousand five hundred thirty-three Euro and ninety-two Cent) held by the B Shareholder;

122707

L

U X E M B O U R G

- an existing/unquestioned claim against the Honfleur SPV amounting to EUR 500,380.88 (five hundred thousand three

hundred eighty Euro and eighty-eight Cent) held by the A Shareholder;

- an existing/unquestioned claim against the Honfleur SPV amounting to EUR 500,380.88 (five hundred thousand three

hundred eighty Euro and eighty-eight Cent) held by the B Shareholder;

- an existing/unquestioned claim against the Bellegarde SPV amounting to EUR 426,427.11 (four hundred twenty-six

thousand four hundred twenty-seven Euro and eleven Cent) held by the A Shareholder; and

- an existing/unquestioned claim against the Bellegarde SPV amounting to EUR 426,427.11 (four hundred twenty-six

thousand four hundred twenty-seven Euro and eleven Cent) held by the B Shareholder;

(b.) the following contributions in cash:
- a contribution in cash of EUR 78,000.-(seventy-eight thousand Euro);
- a contribution in cash of EUR 4,000.-(four thousand Euro);
- a contribution in cash of EUR 9,880.46 (nine thousand eight hundred and eighty Euro and forty-six Cent);
4. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company.
5. Amendment of article 5.2 concerning the share premium account and insertion of new sub paragraphs 5.5, 5.6 and

5.7 in article 5 of the articles of incorporation.

6. Amendment of article 16 of the articles of incorporation concerning distribution rights.
7. Amendment of article 17 of the articles of incorporation concerning dissolution and liquidation.
8. Insertion of new definitions in the definition part of the articles of incorporation.
9. Miscellaneous.
The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, having recognised to be fully informed of the

foregoing agenda and having waived convening notices, then passes the following resolutions:

<i>First resolution

It is hereby resolved to create the following three new classes of shares in the corporate capital of the Company:
- class C shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each;
- class D shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each;
- class E shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each.

<i>Second resolution

It is hereby resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 6 (six Euro) by issuing:
- 2 (two) new class C shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, numbered from 12,501 to 12,502;
- 2 (two) new class D shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, numbered from 12,503 to 12,504; and
- 2 (two) new class E shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, numbered from 12,505 to 12,506,
so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred Euro) to EUR 12,506.-(twelve

thousand five hundred and six Euro).

<i>Subscriptions - Payments

(B.1) Thereupon the prenamed MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder of the Company, duly

represented as stated above, declared to subscribe 1 (one) new Class C Share with a nominal value of EUR 1.-(one Euro),
and to make a payment in full for such new Class C Share and the share premium by a contribution in kind consisting of
the following:

- 30.000 (thirty thousand) corporate units with a nominal value of EUR 100.-(one hundred Euro) each held by the B

Shareholder, altogether representing 100% of the issued corporate capital of the Roppenheim SPV (the "Contribution in
Kind 1").

- an existing/unquestioned claim held by the B Shareholder against the Roppenheim SPV amounting to EUR 2,459,533.92

(two million four hundred fifty-nine thousand five hundred thirty-three Euro and ninety-two Cent) (the "Contribution in
Kind 2").

Such total contribution of EUR 2,537,533.92 (two million five hundred thirty-seven thousand five hundred thirty-three

Euro and ninety-two Cent) is to be allocated as follows:

(i) The amount of EUR 1.-(one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
(ii) The amount of EUR 2,537,532.92 (two million five hundred thirtyseven thousand five hundred thirty-two Euro and

ninety-two Cent) is to be allocated to the share premium account of the Company.

It appears from the valuation report prepared by the management of the Company and presented to the notary that

the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind 1 at least at EUR 78,000.-(seventy-eight thousand
Euro) and the Contribution in Kind 2 at least at EUR 2,459,533.92 (two million four hundred fifty-nine thousand five
hundred thirty-three Euro and ninety-two Cent) which therefore is worth at least the nominal value of the single share
issued in consideration and connected share premium.

122708

L

U X E M B O U R G

(B.2) The prenamed MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder of the Company, duly represented

as stated above, furthermore declared to subscribe 1 (one) new Class D Share with a nominal value of EUR 1.-(one Euro),
and to make a payment in full for such new Class D Share and the share premium by a contribution in kind consisting of
the following:

- 500 (five hundred) corporate units with a nominal value of EUR 16.-(sixteen Euro) each held by the B Shareholder,

altogether representing 100% of the issued corporate capital of the Honfleur SPV(the "Contribution in Kind 3"); and

- an existing/unquestioned claim held by the B Shareholder against the Honfleur SPV amounting to EUR 500,380.88

(five hundred thousand three hundred eighty Euro and eighty-eight Cent) (the "Contribution in Kind 4").

Such total contribution of EUR 504,380.88 (five hundred four thousand three hundred eighty Euro and eighty-eight

Cent) is to be allocated as follows:

(i) The amount of EUR 1.-(one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
(ii) The amount of EUR 504,379.88 (five hundred four thousand three hundred seventy-nine Euro and eighty-eight

Cent) is to be allocated to the share premium account of the Company.

It appears from the valuation report prepared by the management of the Company and presented to the notary that

the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind 3 at least at EUR 4,000.-(four thousand Euro)
and the Contribution in Kind 4 at least at EUR 500,380.88 (five hundred thousand three hundred eighty Euro and eighty-
eight Cent) which therefore is worth at least the nominal value of the single share issued in consideration and connected
share premium.

(B.3) The prenamed MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder of the Company, duly represented

as stated above, furthermore declared to subscribe 1 (one) new Class E Share with a nominal value of EUR 1.-(one Euro),
and to make a payment in full for such new Class E Share and the share premium by a contribution in kind consisting of
the following:

- 100 (one hundred) corporate units with a nominal value of EUR 100.-(one hundred Euro) each held by the B Sha-

reholder, altogether representing 100% of the issued corporate capital of the Bellegarde SPV (the "Contribution in Kind
5"); and

- an existing/unquestioned claim held by the B Shareholder against the Bellegarde SPV amounting to EUR 426,427.11

(four hundred twenty-six thousand four hundred twenty-seven Euro and eleven Cent) (the "Contribution in Kind 6").

Such total contribution of EUR 436,307.57 (four hundred thirty-six thousand three hundred seven Euro and fifty-seven

Cent) is to be allocated as follows:

(i) The amount of EUR 1.-(one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
(ii) The amount of EUR 436,306.57 (four hundred thirty-six thousand three hundred six Euro and fifty-seven Cent) is

to be allocated to the share premium account of the Company.

It appears from the valuation report prepared by the management of the Company and presented to the notary that

the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind 5 at least at EUR 9.880,46.-(nine thousand eight
hundred and eighty Euro and forty six Cent) and the Contribution in Kind 6 at least at EUR 426,427.11 (four hundred
twenty-six thousand four hundred twenty-seven Euro and eleven Cent) which therefore is worth at least the nominal
value of the single share issued in consideration and connected share premium.

(A.1) Thereupon the prenamed NEINVER, S.A., A Shareholder of the Company, duly represented as stated above,

declared to subscribe 1 (one) new Class C Share with a nominal value of EUR 1.(one Euro), and to make a payment in
full for such new Class C Share and the share premium as follows:

- a contribution in cash of EUR 78,000.-(seventy-eight thousand Euro) (the "Contribution in Cash 1"); and
- a contribution in kind consisting of an existing/unquestioned claim held by the A Shareholder against the Roppenheim

SPV, amounting to EUR 2,459,533.92 (two million four hundred fifty-nine thousand five hundred thirty-three Euro and
ninety-two Cent) (the "Contribution in Kind 7").

Such total contribution of EUR 2,537,533.92 (two million five hundred thirty-seven thousand five hundred thirty-three

Euro and ninety-two Cent) is to be allocated as follows:

(i) The amount of EUR 1.-(one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
(ii) The amount of EUR 2,537,532.92 (two million five hundred thirtyseven thousand five hundred thirty-two Euro and

ninety-two Cent) is to be allocated to the share premium account of the Company.

It appears from the valuation report prepared by the management of the Company and presented to the notary that

the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind 7 at least at EUR 2,459,533.92 (two million four
hundred fifty-nine thousand five hundred thirty-three Euro and ninety-two Cent) which together with the Contribution
in Cash 1 of EUR 78,000.-(seventy-eight thousand Euro) therefore is worth at least the nominal value of the single share
issued in consideration and connected share premium.

(A.2) The prenamed NEINVER, S.A., A Shareholder of the Company, duly represented as stated above, furthermore

declared to subscribe 1 (one) new Class D Share with a nominal value of EUR 1.(one Euro), and to make a payment in
full for such new Class D Share and the share premium as follows:

- a contribution in cash of EUR 4,000.-(four thousand Euro) (the "Contribution in Cash 2"); and

122709

L

U X E M B O U R G

- a contribution in kind consisting of an existing/unquestioned claim held by the A Shareholder against the Honfleur

SPV, amounting to EUR 500,380.88 (five hundred thousand three hundred eighty Euro and eighty-eight Cent) (the "Con-
tribution in Kind 8").

Such total contribution of EUR 504,380.88 (five hundred four thousand three hundred eighty Euro and eighty-eight

Cent) is to be allocated as follows:

(i) The amount of EUR 1.-(one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
(ii) The amount of EUR 504,379.88 (five hundred four thousand three hundred seventy-nine Euro and eighty-eight

Cent) is to be allocated to the share premium account of the Company.

It appears from the valuation report prepared by the management of the Company and presented to the notary that

the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind 8 at least at EUR 500,380.88 (five hundred
thousand three hundred eighty Euro and eighty-eight Cent) which together with the Contribution in Cash 2 of EUR
4,000.-(four thousand Euro) therefore is worth at least the nominal value of the single share issued in consideration and
connected share premium.

(A.3) The prenamed NEINVER, S.A., A Shareholder of the Company, duly represented as stated above, furthermore

declared to subscribe 1 (one) new Class E Share with a nominal value of EUR 1.(one Euro), and to make a payment in
full for such new Class E Share and the share premium as follows:

-  a  contribution  in  cash  of  EUR  9,880.46  (nine  thousand  eight  hundred  and  eighty  Euro  and  forty  six  Cent)  (the

"Contribution in Cash 3"); and

- a contribution in kind consisting of an existing/unquestioned claim held by the A Shareholder against the Bellegarde

SPV amounting to EUR 426,427.11 (four hundred twenty-six thousand four hundred twenty-seven Euro and eleven Cent)
(the "Contribution in Kind 9").

Such total contribution of EUR 436,307.57 (four hundred thirty-six thousand three hundred seven Euro and fifty-seven

Cent) is to be allocated as follows:

(i) The amount of EUR 1.-(one Euro) is to be allocated to the nominal capital amount of the Company; and
(ii) The amount of EUR 436,306.57 (four hundred thirty-six thousand three hundred six Euro and fifty-seven Cent) is

to be allocated to the share premium account of the Company.

It appears from the valuation report prepared by the management of the Company and presented to the notary that

the management of the Company has evaluated the Contribution in Kind 9 at least at EUR 426,427.11 (four hundred
twenty-six thousand four hundred twentyseven Euro and eleven Cent) which together with the Contribution in Cash 3
of EUR 9,880.46 (nine thousand eight hundred and eighty Euro and forty-six Cent) therefore is worth at least the nominal
value of the single share issued in consideration and connected share premium.

The Contribution in Kind 1, the Contribution in Kind 2, the Contribution in Kind 3, the Contribution in Kind 4, the

Contribution in Kind 5, he Contribution in Kind 6, the Contribution in Kind 7, the Contribution in Kind 8 and the
Contribution in Kind 9 are together referred to as the Contributions in Kind.

The Contribution in Cash 1, the Contribution in Cash 2 and the Contribution in Cash 3 are together referred to as

the Contributions in Cash.

<i>Effective implementation of the aforementioned contributions

The A Shareholder and the B Shareholder declare that:
- they are the sole full owner of the contributions and possessing the power to dispose of them, they being legally and

conventionally freely transferable;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the contributions in order to duly carry

out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Valuation of the aforementioned contributions

It furthermore appears from a "Valuation certificate in view of a contribution in kind" signed by the members of the

board of managers of the Company on 8 October 2010 that the total value of the aforementioned Contributions in Kind
made to the Company amount to at least EUR 6,864,564.28 (six million eight hundred sixty-four thousand five hundred
sixty-four Euro and twenty-eight Cent).

The total Contributions in Cash amount to EUR 91.880,46 (ninety-one thousand eight hundred and eighty Euro and

forty-six Cent).

All contributions together amount to EUR 6,956,444.74 (six million nine hundred fifty-six thousand four hundred forty-

four Euro and seventy-four Cent). EUR 6.-(six Euro) of this total amount being recorded as corporate capital and the
remainder EUR 6,956,438.74 (six million nine hundred fifty-six thousand four hundred thirty-eight Euro and seventy-four
Cent) as share premium.

The proof of the existence, the value and the free transferability of the contributions have thus been given to the

Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company declares that it will accomplish all formalities

concerning the valid transfer to the Company of the aforementioned contributions.

122710

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

Thereupon, it is hereby resolved to accept the aforementioned subscriptions and contributions. As a result of the

above corporate capital increase, it is recorded that the shareholding in the Company is as follows:

- NEINVER, S.A., A Shareholder:
6,250 (six thousand two hundred and fifty) Class A Shares;
1 (one) Class C Share;
1 (one) Class D Share; and
1 (one) Class E Share.
- MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., B Shareholder:
6,250 (six thousand two hundred and fifty) Class B Shares;
1 (one) Class C Share;
1 (one) Class D Share; and
1 (one) Class E Share.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, it is hereby resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the

Company, which will from now on read as follows:

“ 5.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and six euro (EUR 12,506.-)

represented by (i.) six thousand two hundred fifty (6,250) class A shares (the “Class A Shares”, their holder being referred
to as the “Class A Shareholder”) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 1 to 6,250, (ii.) six
thousand two hundred fifty (6,250) class B shares (the “Class B Shares”, their holder being referred to as the “Class B
Shareholder” and together with the Class A Shareholder, jointly referred to asthe“Shareholders”) with a nominal value
of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 6,251 to 12,500, (iii.) two (2) class C shares (the “Class C Shares”) with
a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 12,501 to 12,502, (iv.) two (2) class D shares (the “Class
D Shares”) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 12,503 to 12,504, and (v.) two (2) class
E shares (the “Class E Shares”) with a nominal value of one Euro (EUR 1,00.-) each, numbered from 12,505 to 12,506.

The Class A Shares and the Class B Shares are together referred to as the"Ordinary Shares".”

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to replace sub paragraph 5.2 in article

5 of the articles of incorporation concerning the share premium account which shall read as follows:

5.2. In addition to the corporate capital, there shall be set up the following premium accounts: (i.) in respect of the

Ordinary Shares, the Ordinary Share Premium Account; (ii.) in respect of the Class C Shares, the Share Premium Account
C; (iii), in respect of the Class D Shares, the Share Premium Account D; and (iv.) in respect of the Class E Shares, the
Share Premium Account E. Any share premium paid into any of these share premium accounts shall not be repaid or
reimbursed (whether directly or in relation to a decrease of the share capital, the repurchase of own shares, the payment
of a dividend, the liquidation or any other transaction whatsoever resulting in a repayment or reimbursement of share
premium) to any Shareholder other than the holders of the shares pertaining to the class of shares linked to said share
premium account."

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to insert new sub paragraphs 5.5, 5.6

and 5.7 in article 5 of the articles of incorporation which shall read as follows:

5.5. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation

of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in such class(es), to the
fullest extent permitted by law.

5.6. The repurchase and cancellation of Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares will occur upon the sale of

the Assets C, Assets D or Assets E. Upon sale of any of the Assets C, Assets D or Assets E, the Company shall determine
the profit or loss attributable to each corresponding Class of Shares cancelled as if each Assets C, Assets D and Assets
E to which they refer were the sole investment held by the Company (the "Cancellation Value").

5.7. Upon the repurchase for subsequent cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value will

become due and payable by the Company."

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to amend article 16 of the articles of

incorporation concerning distribution rights which shall read as follows:

16.1. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and de-

preciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

122711

L

U X E M B O U R G

16.2 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted

and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

16.3. The general meeting of shareholders shall allocate the annual profit or loss (i.e. together the Ordinary Profits,

Profits C, Profits D and Profits E) as follows:

16.3.1 In addition to the legal reserve required by law, the Company has other reserves, one for each specific class of

shares, (namely (i) the Ordinary Profit Reserve, (ii) the Profit Reserve C, (iii) the Profit Reserve D and (iv) the Profit
Reserve E, each, a «Reserve»), the balance of which each corresponding class of Shareholders has exclusive entitlement
to.

16.3.2 Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Class of Shares for accounting

and tax purposes as if each share of the Roppenheim SPV, the Honfleur SPV and the Bellegarde SPV to which they refer
were the sole investment held by the Company (each, a «Profit and Loss Account»). All expenses and incomes connected
to a Class of Shares shall be credited to or debited from the corresponding Profit and Loss Account.

16.3.3 The balance of each Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve.
16.3.4 If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in

any financial year, the positive balances of the Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and insofar as is
possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Profit and Loss Account in proportion to the
percentage representing the positive balance of each Profit and Loss Account over the profit shown by the annual ac-
counts.

16.3.5 If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the

Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

16.3.6 As stipulated in article 5.2 above, there shall be a share premium account for the Ordinary Shares (namely the

Ordinary Share Premium Account), and a share premium account for each type of specific class of shares (namely the
Share Premium Account C, the Share Premium Account D and the Share Premium Account E (the «Specific Class Share
Premium Account»):

(a) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of each specific Class

of Shares (C,D,E) at the time of issuance of the shares belonging to each specific Class of Shares and share premium
account resulting from further contributions to be made by the holders of such specific Class of Shares is, or shall be, as
the case may be, allocated to the corresponding Specific Class Share Premium Account;

(b) The share premium account resulting from the contribution in kind or cash by the holders of the Ordinary Shares

at the time of issuance of the Ordinary Shares and share premium account resulting from further contributions to be
made by the holders of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Ordinary
Share Premium Account;

16.3.7 To the extent that funds are available for distribution both at the level of the Company and at the level of a

relevant Profit and Loss Account and out of the corresponding Specific Class Share Premium Account and to the extent
permitted by law and by these Articles, dividends may be paid out of such Specific Profit and Loss Account and out of
the corresponding Specific Class Share Premium Account only to the holders of the type of the specific Class of Shares
concerned. Dividends may be paid out of the Ordinary Share Profit and Loss Account only to the holders of Ordinary
Shares.

16.4 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

Any distribution shall always be done by virtue of a resolution of the general meeting, taken upon the proposal approved

by a separate meeting of shareholders of the same type as the particular Profit and Loss Account or share premium
account concerned.

16.5 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

Shareholders in accordance with the provisions of Article 13 above.

16.6 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the

Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that

(ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Share-

holders.”

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to amend article 17 of the articles of

incorporation concerning dissolution and liquidation which shall read as follows:

122712

L

U X E M B O U R G

17.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the Shareholders.

17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions and article 14.3.

17.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

17.4 The liquidation proceeds available for distribution shall be distributed in accordance with the following steps:
step a. From the balance remaining after payment of debts shall be distributed, as far as possible, the Ordinary Assets,

Assets C, Assets D and Assets E, (including any deriving proceeds), to the holders of Ordinary Shares, Class C Shares,
Class D Shares and Class E Shares respectively, in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares,
Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares respectively.

step b. From the balance remaining after step a shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in

proportion to, the Ordinary Share Premium Account, Share Premium Account C, Share Premium Account D and Share
Premium Account E to the holders of Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares respectively,
in proportion to the aggregate nominal amount of the Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares
respectively.

step c. From the balance remaining after step b shall be transferred, as far as possible an amount equalling and in

proportion to the Ordinary Profit Reserve, the Profit Reserve C, the Profit Reserve D and the Profit Reserve E to the
holders of Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares respectively, in proportion to the aggregate
nominal amount of the Ordinary Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares respectively.

step d. The positive balance remaining after step c shall be transferred to the shareholders in proportion to the

aggregate amount of their shareholdings."

<i>Eighth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to insert the following new definitions

in the definition part of the articles of incorporation:

“Assets C: means the Company's shareholding in the Roppenheim SPV;
Assets D: means the Company's shareholding in the Honfleur SPV;
Assets E: means the Company's shareholding in the Bellegrade SPV;
Bellegarde SPV: means Bellegarde Village des Alpes S.à r.l., a company validly organised and existing under the laws of

France, having its registered office at 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France) and registered with the RCS
of Paris under the registration number 514 720 135 and with tax identification number FR54 514 720;

Class of Shares: means together the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and

the Class E Shares;

Class A Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of association;
Class B Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of association;
Class C Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of association;
Class D Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of association;
Class E Shares: has the meaning ascribed to it under clause 5 of the present articles of association;
Class A Shareholder(s): means holder(s) of Class A Shares in the Company;
Class B Shareholder(s): means holder(s) of Class B Shares in the Company;
Class C Shareholder(s): means holder(s) of Class C Shares in the Company;
Class D Shareholder(s): means holder(s) of Class D Shares in the Company;
Class E Shareholder(s): means holder(s) of Class E Shares in the Company;
Honfleur SPV: means Champs-Vernet S.à r.l., a company validly organised and existing under the laws of France, having

its registered office at 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France) and registered with the RCS of Paris under
the registration number 440 226 595 and with tax identification number FR62 440 226 595;

Ordinary Assets: means any Company's shareholding other than the Company's shareholding in the SPVs;
Ordinary Profit Reserve: means the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Ordinary Sha-

reholders;

Ordinary Profits: refers to the annual accounts, deriving from the Ordinary Shares of the Company;
Ordinary Share Premium Account: means the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of

the Ordinary Shareholders;

Ordinary Shareholder(s): means holder(s) of Ordinary Shares in the Company;
Ordinary Shares: means together the Class A Shares and the Class B Shares;
Profit Reserve C: means the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class C Shareholders;

122713

L

U X E M B O U R G

Profit Reserve D: means the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class D Shareholders;
Profit Reserve E: means the profit reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class E Shareholders;
Profits  C:  means  the  profits,  as  appears  from  the  annual  accounts,  deriving  from  the  shares  held  by  the  Class  C

Shareholders corresponding to the Roppenheim SPV, netted with the taxes due by the Company (if any), with respect
to these profits;

Profits D: means  the  profits,  as appears  from  the annual  accounts,  deriving from  the shares held by  the  Class D

Shareholders in the Company corresponding to the Honfleur SPV, netted with the taxes due by the Company (if any),
with respect to these profits;

Profits E: means the profits, as appears from the annual accounts, deriving from the shares held by the Class E Share-

holders in the Company corresponding to the Bellegarde SPV, netted with the taxes due by the Company (if any), with
respect to these profits;

Roppenheim SPV: means MAB Roppenheim S.à r.l., a company validly organised and existing under the laws of France,

having its registered office at 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France) and registered with the RCS of Paris
under the registration number 430 129 338 and with tax identification number FR33 430 129 338;

Share Premium Account C: means the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class

C Shareholders;

Share Premium Account D: means the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class

D Shareholders;

Share Premium Account E: means the share premium reserve, maintained by the Company for the benefit of the Class

E Shareholders.”

<i>Ninth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders of the Company resolved to authorise and empower any manager

of the Company and/or any employee at Alter Domus, acting individually, with full power of substitution, to execute and
deliver, under his/her/its sole signature, on behalf of the Company, any documents necessary or useful in connection with
the filing and registration required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg regarding the above resolutions and,
in particular, to register the newly issued Class C Shares, the newly issued Class D Shares and the newly issued Class E
Shares in the register of the Company.

<i>Expenses

The expenses incurred in connection with the present deed are estimated to be approximately EUR 3,700 (three

thousand seven hundred Euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning.
The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the French version of the preceding text

L'an deux mille dix, le huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) NEIVER S.A., une société dûment constituée en Espagne, ayant son siège social à Francisca Delgado 11, 5a planta,

Arroyo de la Vega - Alcobendas, 28108 Madrid, Espagne et immatriculée au registre de commerce de Madrid (Espagne)
sous le numéro 48331, tome 5270, section 8, folio 210, page M-93606 (ci-après l'«Associé A»), ici représentée par Mme
Judith STERN, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé daté du
8 octobre 2010;

2) MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., une société dûment constituée aux Pays-Bas, ayant son siège social

à Wijnhaven 60, 2511 GA La Haye, immatriculée au registre de commerce de La Haye sous le numéro 27377056 (ci-
après l'«Associé B»), ici représentée par M. Johannes Gijsbertus Franciscus Eijkemans, étant le gérant (“Bestuurder”) du
gérant unique (“Bestuurder”) de l'Associé B, MAB Development Group B.V., une société dûment constituée aux Pays-
Bas, ayant son siège social à Wijnhaven 60, 2511 GA La Haye, immatriculée au registre de commerce de La Haye sous le
numéro 27104028, résidant à Boulevard 42, 3707 BN Zeist, Pays-Bas, et par M. Nicolaas Augustinus Franciscus Blüm,
étant le fondé de pouvoir (“Gevolmachtigde”) du gérant unique (“Bestuurder”) de l'Associé B, MAB Development Group
B.V. , résidant à Van Reenenlaan 3, 3744 MD Baarn, Pays-Bas.

122714

L

U X E M B O U R G

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne variatur» par les mandataires des comparantes et le notaire

instrumentant, annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités compétentes.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

- Les comparantes sont les associés (ci-après les «Associés») de la société Nemab S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, Grand-Duché
du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.353 (ci-
après la «Société») par acte du notaire instrumentaire du 21 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n°1488 le20juillet 2010.

Les statuts de la Société n'ont pas été amendé depuis la constitution de la Société.
- L'agenda de l'assemblée générale extraordinaire des associés est comme suit:

<i>Agenda

1. Création des trois classes d'actions suivantes dans le capital social de la Société:
- Parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale de EUR 1.(un euro) chacune;
- Parts sociales de catégorie D d'une valeur nominale de EUR 1.(un euro) chacune;
- Parts sociale de catégorie E d'une valeur nominale de EUR 1.(un euro) chacune;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 6 (six euros) par l'émission de:
- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie C (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie C») ayant une valeur

nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, numérotées de 12.501 à 12.502,

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie D (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie D») ayant une valeur

nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, numérotées de 12.503 à 12504 et

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie E (ci-après les «Parts sociales de Catégorie E») ayant une valeur

nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, numérotées de 12.505 à 12.506,

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500.-(douze mille cinq cent euros) à EUR 12.506.-(douze mille cinq

cent six euros).

3. Souscription et libération des nouvelles Parts Sociales de Catégorie C, des nouvelles Parts Sociales de Catégorie D

et  des  nouvelles  Parts  Sociales  de  Catégorie  E  et  de  la  prime  d'émission  y  afférente  par  l'Associé  A  et  l'Associé  B,
moyennant:

(a.) apports en nature de:
- 30.000 (trente mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.-(cent euros) chacune, l'ensemble représentant

100% du capital social émis de MAB Roppenheim S.à r.l., une société dûment constituée en France, ayant son siège social
à 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 129 338,
avec le numéro d'identification fiscale FR33 430 129 338 (la «Roppenheim SPV»), évaluées à au moins 78.000.-(soixante-
dix-huit mille euros);

- 500 (cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 16.(seize euros) chacune, l'ensemble représentant 100%

du capital social émis de Champs-Vernet S.à r.l., une société dûment constituée en France, ayant son siège social à 125,
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 226 595, avec le
numéro d'identification fiscale FR62 440 226 595 ( la «Honfleur SPV») évaluées à au moins 4.000.-(quatre mille euros);

- 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.(cent euros) chacune, l'ensemble représentant 100% du

capital social émis de Village des Alpes S.à r.l., une société dûment constituée en France, ayant son siège social à 125,
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 720 135, avec le
numéro d'identification fiscale FR54 514 720 135 ( la «Bellegarde SPV»), évaluées à au moins 9.880,46.-(neuf mille huit
cent quatre-vingt euros et quarante-six centimes);

-  une  créance  existante/non  contestée  à  l'encontre  de  la  Roppenheim  SPV  et  s'élevant  à  la  somme  de  EUR

2.459.533,92.-(deux million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes)
détenue par l'Associé A;

-  une  créance  existante/non  contestée  à  l'encontre  de  la  Roppenheim  SPV  et  s'élevant  à  la  somme  de  EUR

2.459.533,92.-(deux million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes)
détenue par l'Associé B;

- une créance existante/non contestée à l'encontre de la Honfleur SPV et s'élevant à la somme de EUR 500.380,88.-

(cinq cent mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt huit centimes) détenue par l'Associé A;

- une créance existante/non contestée à l'encontre de la Honfleur SPV et s'élevant à la somme de EUR 500.380,88.-

(cinq cent mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt huit centimes) détenue par l'Associé B;

- une créance existante/non contestée à l'encontre de la Bellegarde SPV et s'élevant à la somme de EUR 426.427,11.-

(quatre cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept euros et onze centimes) détenue par l'Associé A; et

- une créance existante/non contestée à l'encontre de la Bellegarde SPV et s'élevant à la somme de EUR 426.427,11.-

(quatre cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept euros et onze centimes) détenue par l'Associé B;

122715

L

U X E M B O U R G

(b) contributions suivantes en espèces:
- une contribution en espèces d'un montant de EUR 78.000.(soixante dix huit mille euros);
- une contribution en espèces d'un montant de EUR 4.000.(quatre mille euros) et
- une contribution en espèces d'un montant de EUR 9.880,46.(neuf mille huit cent quatre-vingt euros et quarante six

centimes);

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société;
5. Modification de l'article 5.2 concernant le compte de prime d'émission et insertion des nouveaux articles 5.5, 5.6

et 5.7 des statuts de la Société;

6. Modification de l'article 16 des statuts de la Société concernant les droits de distribution;
7. Modification de l'article 17 des statuts de la Société concernant la dissolution et la liquidation;
8. Insertion de nouvelles définitions dans la la liste des définitions des statuts de la Société;
9. Divers.
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société, après s'être déclarée parfaitement informée de l'ordre

du jour ci-avant exposé et après avoir renoncée aux formalités de convocation, a alors pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de procéder à la création des trois classes de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société:
- Parts sociales de classe C d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro) chacune;
- Parts sociales de classe D d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro) chacune;
- Parts sociales de classe E d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro) chacune.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 6.-(six euros) par l'émission de:
- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie C (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie C») ayant une valeur

nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, numérotées de 12.501 à 12.502;

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie D (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie D») ayant une valeur

nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, numérotées de 12.503 à 12504 et

- 2 (deux) nouvelles parts sociales de catégorie E (ci-après les «Parts Sociales de Catégorie E») ayant une valeur

nominale de EUR 1.-(un euro) chacune, numérotées de 12.505 à 12.506,

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500.-(douze mille cinq cent euros) à EUR 12.506.-(douze mille cinq

cent six euros).

<i>Souscriptions - Libération

(B.1) Ensuite la prémentionnée MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B de la Société, dûment re-

présentée comme précisé précédemment, déclare souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie C d'une valeur
nominale de EUR 1.-(un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en nature
consistant en:

- 30.000 (trente mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.-(cent euros) chacune, l'ensemble représentant

100% du capital social émis de la Roppenheim SPV (l'«Apport en Nature 1») et

-  une  créance  existante/non  contestée  à  l'encontre  de  la  Roppenheim  SPV  et  s'élevant  à  la  somme  de  EUR

2.459.533,92.-(deux million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes)
(l'«Apport en Nature 2»).

Cet apport d'un montant total de EUR 2.537.533,92.-(deux million cinq cent trente-sept mille cinq cent trente-trois

euros et quatre-vingtdouze centimes) doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.-(un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
(ii) Le montant de EUR 2.537.532,92.-(deux million cinq cent trente-sept mille cinq cent trente-deux euros et quatre-

vingt-douze centimes) doit être affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Il résulte d'un rapport d'évaluation préparé par la gérance de la Société et présenté au notaire que la gérance de la

Société a évalué l'Apport en Nature 1 à au moins EUR 78.000.-(soixante-dix-huit mille euros) et l'Apport en Nature 2 à
au moins EUR 2.459.533,92.-(deux million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-
douze centimes) valant ainsi au moins la valeur nominale de la part sociale émisse en question et de la prime d'émission
y afférente.

(B.2) La prémentionnée MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B de la Société, dûment représentée

comme précisé précédemment, déclare en outre souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie D d'une valeur
nominale de EUR 1.-(un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en nature
consistant en:

- 500 (cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 16.(seize euros) chacune, l'ensemble représentant 100%

du capital social émis de la Honfleur SPV (l'«Apport en Nature 3») et

122716

L

U X E M B O U R G

- une créance existante/non contestée à l'encontre de la Honfleur SPV et s'élevant à la somme de EUR 500.380,88.-

(cinq cent mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes) (l'«Apport en Nature 4»).

Cet apport de EUR 504.380,88.-(cinq cent quatre mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes)

doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.-(un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
(ii) Le montant de 504.379,88.-(cinq cent quatre mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes)

doit être affecté au compte prime d'émission de la Société.

Il résulte d'un rapport d'évaluation préparé par la gérance de la Société et présenté au notaire que la gérance de la

Société a évalué l'Apport en Nature 3 à au moins EUR 4.000.-(quatre mille euros) et l'Apport en Nature 4 à au moins
EUR 500.380,88.-(cinq cent mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes) valant ainsi au moins la valeur
nominale de la part sociale émisse en question et de la prime d'émission y afférente.

(B.3) La prémentionnée MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B de la Société, dûment représentée

comme précisé précédemment, déclare en outre souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie E d'une valeur
nominale de EUR 1.-(un euro) et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission par un apport en nature
consistant en:

- 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.(cent euros) chacune, l'ensemble représentant 100% du

capital social émis de la Bellegarde SPV (l'«Apport en Nature 5») et

- une créance existante/non contestée à l'encontre de la Bellegarde SPV et s'élevant à la somme de EUR 426.427,11.-

(quatre cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept euros et onze centimes) (l'«Apport en Nature 6»).

Cet apport de EUR 436.427,11.-(quatre cent trente-six mille quatre cent vingt-sept euros et onze centimes) doit être

affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.-(un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
(ii) Le montant de 436.426,11.-(quatre cent trente-six mille quatre cent vingt-six euros et onze centimes) doit être

affecté au compte prime d'émission de la Société.

Il résulte d'un rapport d'évaluation préparé par la gérance de la Société et présenté au notaire que la gérance de la

Société a évalué l'Apport en Nature 5 à au moins EUR 9.880,46.-(neuf mille huit cent quatre-vingt euros et quarte-six
centimes) et l'Apport en Nature 6 à au moins EUR 426.427,11.-(quatre cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept euros
et onze centimes) valant ainsi au moins la valeur nominale de la part sociale émisse en question et de la prime d'émission
y afférente.

(A.1) Ensuite la prémentionnée NEIVER S.A., Associé A de la Société, dûment représentée comme précisé précé-

demment, déclare souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro) et
déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission comme suit:

- par un apport en espèce de EUR 78.000.-(soixante-dix-huit mille euros) (l'«Apport en Espèce 1») et
- par un apport en nature consistant en une créance existante/non contestée à l'encontre de la Roppenheim SPV et

s'élevant à la somme de EUR 2.459.533,92.-(deux million quatre cent cinquante-neuf mille cinq cent trente-trois euros et
quatre-vingt-douze centimes) (l'«Apport en Nature 7»).

Cet apport d'un montant total de EUR 2.537.533,92.-(deux million cinq cent trente-sept mille cinq cent trente-trois

euros et quatre-vingtdouze centimes) doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.-(un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
(ii) Le montant de EUR 2.537.532,92.-(deux million cinq cent trente-sept mille cinq cent trente-deux euros et quatre-

vingt-douze centimes) doit être affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Il résulte du rapport d'évaluation préparé par la gérance de la Société et présenté au notaire que la gérance de la

Société a évalué l'Apport en Nature 7 à au moins EUR 2.459.533,92.-(deux million quatre cent cinquante-neuf mille cinq
cent trente-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) valant ainsi ensemble avec l'Apport en Espèce 1 de EUR 78.000.-
(soixante-dix-huit mille euros) au moins la valeur nominale de la part sociale émisse en question et de la prime d'émission
y afférente.

(A.2) La prémentionnée NEIVER S.A., Associé A de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment,

déclare en outre souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie D d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro) et
déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission comme suit:

- par un apport en espèce de EUR 4.000.-(quatre mille euros) (l'«Apport en Espèce 2») et
- par un apport en nature consistant en une créance existante/non contestée à l'encontre de la Honfleur SPV et s'élevant

à la somme de EUR 500.380,88.-(cinq cent mille trois cent quatre-vingt euros et quatrevingt-huit centimes) (l'«Apport
en Nature 8»).

Cet apport de EUR 504.380,88.-(cinq cent quatre mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-huit centimes)

doit être affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.-(un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
(ii) Le montant de 504.379,88.-(cinq cent quatre mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes)

doit être affecté au compte prime d'émission de la Société.

122717

L

U X E M B O U R G

Il résulte du rapport d'évaluation préparé par la gérance de la Société et présenté au notaire que la gérance de la

Société a évalué l'Apport en Nature 8 à au moins EUR 500.380,88.-(cinq cent mille trois cent quatre-vingt euros et quatre-
vingt-huit centimes) valant ainsi ensemble avec l'Apport en Espèce 2 de EUR 4.000.-(quatre mille euros) au moins la valeur
nominale de la part sociale émisse en question et de la prime d'émission y afférente.

(A.3) La prémentionnée NEIVER S.A., Associé A de la Société, dûment représentée comme précisé précédemment,

déclare en outre souscrire 1 (une) nouvelle Part Sociale de Catégorie E d'une valeur nominale de EUR 1.-(un euro)
chacune et déclare libérer ladite nouvelle part sociale et la prime d'émission comme suit:

- par un apport en espèce de EUR 9.880,46.-(neuf mille huit cent quatre-vingt euros et quarante-six centimes) (l'«Ap-

port en Espèce 3») et

- par un apport en nature consistant en une créance existante/non contestée à l'encontre de la Bellegarde SPV et

s'élevant à la somme de EUR 426.427,11.-(quatre cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept euros et onze centimes)
(l'«Apport en Nature 9»).

Cet apport de EUR 436.427,11.-(quatre cent trente-six mille quatre cent vingt-sept euros et onze centimes) doit être

affecté comme suit:

(i) Le montant de EUR 1.-(un euro) doit être affecté au capital social de la Société et
(ii) Le montant de 436.426,11.-(quatre cent trente-six mille quatre cent vingt-six euros et onze centimes) doit être

affecté au compte prime d'émission de la Société.

Il résulte du rapport d'évaluation préparé par la gérance de la Société et présenté au notaire que la gérance de la

Société a évalué l'Apport en Nature 9 à au moins EUR 426.427,11.-(quatre cent vingt-six mille quatre cent vingt-sept
euros et onze centimes) valant ainsi ensemble avec l'Apport en Espèce 3 de EUR 9.880,46.-(neuf mille huit cent quatre-
vingt euros et quarante-six centimes) au moins la valeur nominale de la part sociale émisse en question et de la prime
d'émission y afférente.

L'Apport en Nature 1, l'Apport en Nature 2, l'Apport en Nature 3, l'Apport en Nature 4, l'Apport en Nature 5,

l'Apport en Nature 6, l'Apport en Nature 7, l'Apport en Nature 8 et l'Apport en Nature 9 sont définis conjointement
ci-après en tant qu'«Apports en Nature».

L'Apport en  Espèce  1,  l'Apport  en Espèce 2  et  l'Apport  en  Espèce 3 sont  définis  conjointement  ci-après en  tant

qu'«Apports en Espèce».

Mise en oeuvre des apports susmentionnés
L'Associé A et l'Associé B déclarent:
- qu'ils sont les uniques et pleins propriétaires des apports et qu'ils ont le pouvoir d'en disposer librement et que les

apports sont légalement et contractuellement transférables librement;

- que toute formalité supplémentaire requise dans les pays de provenance des apports est actuellement remplie afin

d'assurer que le transfert soit dûment effectué et formalisé et qu'il dévient effectif en tout lieu et opposable envers toutes
les personnes tiers.

<i>Évaluation des apports prémentionnés

Il résulte d'un «Certificat d'évaluation en vue d'un apport en nature» signé par les membres du conseil des gérance de

la Société le 8 octobre 2010 que la valeur globale des prédits Apports en Nature faits à la Société équivaut au moins à
EUR 6.864.564,28.-(six million huit cent soixante-quatre mille cinq cent soixante quatre euros et vingt-huit centimes).

Les prédites Apports en Espèce s'élèvent ensemble au montant de EUR 91.880,46 (quatre-vingt et onze mille huit cent

quatre-vingt euros et quarante-six centimes).

L'ensemble des apports faits à la Sociétés vaut EUR 6.956.444,74 (six million neuf cent cinquante-six mille quatre cent

quarante-quatre euros et soixante-quatorze centimes), EUR 6.-(six euros) de ce montant total étant affectés au capital
social et les EUR 6.956.438,74 (six million neuf cent cinquante-six mille quatre cent trente-huit euros et soixante-quatorze
centimes) au compte prime d'émission.

Ainsi, la preuve de l'existence, de la valeur et du libre transfert des apports ont été fournis à la Société, ainsi qu'il en

a été justifié au notaire instrumentant.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société déclare que toutes les formalités concernant le transfert

des apports prémentionnés à la Société seront réalisées.

<i>Troisième résolution

Partant, il est décidé d'accepter les souscriptions et libérations dont il a été question ci-avant. En conséquence de la

présente augmentation de capital, il est constaté que les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- NEIVER S.A., Associé A:
6.250 (six mille deux cent cinquante) Parts Sociales de Catégorie A;
1 (une) Part Sociale de Catégorie C;
1 (une) Part Sociale de Catégorie D et
1 (une) Part Sociale de Catégorie E.

122718

L

U X E M B O U R G

- MAB DEVELOPMENT OUTLET CENTRE B.V., Associé B:
6.250 (six mille deux cent cinquante) Parts Sociales de Catégorie B;
1 (une) Part Sociale de Catégorie C;
1 (une) Part Sociale de Catégorie D et
1 (une) Part Sociale de Catégorie E.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises ci-avant, il est décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura

dorénavant la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent six euros (EUR 12.506.-) représenté par (i.) 6.250

(six mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A», dont le détenteur est
nommé «Associé A»), avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 1 à 6.250, (ii.) de 6.250
(six mille deux cent cinquante) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B», dont le détenteur est
nommé «Associé B»), avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 6.251 à 12.500, (iii.) de
deux (2) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C») avec une valeur nominale de un Euro ( EUR
1.-) chacune, numérotées de 12.501 à 12.502, (iv.) de deux (2) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de
Catégorie D») avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-) chacune, numérotées de 12.503 à 12.504 et (v.) de deux
(2) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E») avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1.-)
chacune, numérotées de 12.505 à 12.506.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société décide de modifier l'article 5.2 des statuts de la Société

concernant le compte de prime d'émission qui aura dorénavant la teneur suivante:

« 5.2. En plus du capital social, les comptes de prime d'émission suivants peuvent être établis: (i) concernant les Parts

Sociales Ordinaires, le Compte de la Prime d'Emission Ordinaire, (ii) concernant les Parts Sociales de Catégorie C, le
Compte de la Prime d'Emission C, (iii) concernant les Parts Sociales de Catégorie D, le Compte de la Prime d'Emission
D et (iv) concernant les Parts Sociales de Catégorie E, le Compte de la Prime d'Emission E. Toute prime d'émission versée
dans un de ces comptes de prime d'émission ne sera repayer ou remboursée (que ce soit directement ou dans le cadre
d'une diminution du capital social, rachat de parts sociales propres, payement de dividende, liquidation ou toute autre
opération aboutissant à un repaiement ou remboursement de prime d'émission) à un Associé autre qu'au détenteur des
parts sociales afférant à la Catégorie de Parts Sociales liée au compte de prime d'émission correspondant.»

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide d'ajouter les nouvelles sous-paragraphes 5.5, 5.6

et 5.7 dans l'article 5 des statuts qui auront la teneur suivante:

« 5.5. Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales y compris par l'annulation de

l'ensemble d'une ou de plusieurs catégories entières de parts sociales par le rachat ou l'annulation de toutes les parts
sociales émises dans cette/ces catégorie(s).

5.6. Le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D ou des Parts Sociales

de Catégorie E aura lieu en cas de la vente de l'Actif C, l'Actif D ou l'Actif E. En cas de la vente de l'Actif C, l'Actif D ou
l'Actif E, la Société déterminera le profit ou la perte attribuable à chaque Catégorie de Parts Sociales correspondante
annulée comme si l'Actif C, l'Actif D ou l'Actif E auquel elles se réfèrent avait été le seul investissement détenu par la
Société («Valeur d'Annulation»).

5.7. Après le rachat et l'annulation subséquente des parts sociales de la Catégorie de Parts Sociales concernée, la Valeur

d'Annulation sera exigible et due par la Société.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société

concernant le droit de distribution qui aura dorénavant la teneur suivante:

« 16.1. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

16.2 Du bénéfice net déterminé conformément aux dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront déduis

et alloués à un fond de réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque le montant du fond de réserve
légal aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

16.3 L'assemblée générale des associés allouera les bénéfices ou les pertes annuels (i.e. l'ensemble des Profits Ordi-

naires, Profits C, Profits D et Profits E) comme suit:

16.3.1 En plus de la réserve légale requise par la Loi, la Société a d'autres réserves, une pour chaque Catégorie de

Parts Sociales spécifique, (à savoir (i) la Réserve du Profit Ordinaire, (ii) la Réserve du Profit C, (iii) la Réserve du Profit
D et (iv) la Réserve du Profit E, chacune une «Réserve ), pour lesquelles chaque catégorie d'Associé dispose d'un droit
exclusif sur le solde correspondant.

122719

L

U X E M B O U R G

16.3.2 Chaque année, la Société doit déterminer comptablement et fiscalement les profits et pertes attribuables à

chaque Catégorie de Parts Sociales, comme si chaque part de la Roppenheim SPV, la Honfleur SPV et la Bellegrade SPV
à laquelle elle se réfère, était le seul investissement détenu par la Société (chacun un "Compte de Résultats"). Toutes les
dépenses et revenus liés à une Catégorie de Parts Sociales doivent être crédités ou débités du Compte de Résultats
correspondant.

16.3.3 Le solde de chaque Compte de Résultats devra ainsi être alloué à la Réserve correspondante.
16.3.4. Si et pour autant que les réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par

la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats doivent être utilisés pour ce but. Si
possible, pour autant que ce le soit, telle réserve doit être crée ou augmentée aux comptes de chaque Compte de Résultats
en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats par rapport aux profits
montrés par les comptes annuels.

16.3.5. Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté

au(x) Compte(s) de Résultats en vertu duquel/desquels la réserve légale a été formée ou augmentée.

16.3.6 Selon l'article 5.2 ci-dessus, il y aura un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales Ordinaires (à savoir

le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires) et un compte de prime d'émission pour chaque Catégorie
de Parts Sociales spécifiques (à savoir le Compte de Prime d'Emission C, le Compte de Prime d'Emission et, le Compte
de Prime d'Emission E) (le «Compte de Prime d'Emission de Catégories de Parts Sociales Spécifiques»):

a) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs de chaque spécifique

Catégorie de Parts Sociales (C, D, E) au moment de l'émission des parts sociales appartenant à chaque Catégorie de Parts
Sociales et le compte de prime d'émission résultant de tout apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Catégories
de Parts Sociales est ou doit être, selon le cas, alloué au compte de prime d'émission correspondant à ladite Catégorie
de Parts Sociales;

b) le compte de prime d'émission résultant d'un apport en nature ou en espèce par les détenteurs des Parts Sociales

Ordinaires au moment de l'émission des Parts Sociales Ordinaires et le compte de prime d'émission résultant de tout
apport ultérieur à être fait par les détenteurs de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au
Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires.

16.3.7. Dans la mesure où des fonds sont disponibles pour distribution aussi bien au niveau de la Société qu'au niveau

du spécifique Compte de Résultat et d'un Compte de Prime d'Emission de Catégorie de Parts Sociales Spécifique, dans
la mesure autorisée par la loi et ces Statuts, des dividendes peuvent être payés d'un Compte des Résultats et du Compte
de Prime d'Emission de Catégorie de Parts Sociales Spécifique correspondant, seulement aux détenteurs de parts sociales
de cette Catégorie de Parts Sociales spécifique. Des dividendes ne peuvent être payés du Compte de Résultats appartenant
aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires qu'aux propriétaires de Parts Sociales Ordinaires.

16.4 Dans la mesure ou des fonds sont disponibles pour distribution aussi bien au niveau de la Société et dans la mesure

autorisée par la loi et ces Statuts, le Conseil de Gérance peut proposer que les fonds disponibles pour paiement soient
distribués.

Les  distributions  doivent  toujours  être  faites  en  vertu  d'une  résolution  de  l'assemblée  générale  des  associés,  sur

proposition approuvée par une réunion séparée des associés détenant le même Compte de Résultats ou le même Compte
de Prime d'Emission concerné.

16.5 La décision de distribuer des fonds et la détermination de leur montant sera prise par les Associés conformément

aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.

16.6 Nonobstant les stipulations qui précèdent, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intér-

imaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si
applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la loi ou selon ces
Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront
remboursées par l'Associé(s).»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société

concernant la dissolution et la liquidation qui aura dorénavant la teneur suivante:

« 17.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite

de l'un de ses Associés.

17.2 La liquidation de la Société sera décidée par l'assemblée générale des Associés en conformité avec les dispositions

légales applicables et l'article 14.3 ci-dessus.

17.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.4 Le boni de liquidation disponible pour la distribution sera réparti conformément aux étapes suivantes:

122720

L

U X E M B O U R G

étape  a.  Après  le  paiement  des  dettes,  à  partir  du  solde  restant  seront  distribués,  autant  que  possible,  les  Actifs

Ordinaires, les Actifs C, Actifs D et Actifs E, (y compris tout montant dérivé) aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires,
des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D et des Parts Sociales de Catégorie E respectivement,
proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts
Sociales de Catégorie D et des Parts Sociales de Catégorie E respectivement.

étape b. A partir du solde restant après l'étape a, seront transférés, autant que possible, un montant égal et propor-

tionnel au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires, au Compte de Prime d'Emission C, au Compte de
Prime d'Emission D et au Compte de Prime d'Emission E aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales
de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D et des Parts Sociales de Catégorie E respectivement, proportionnel-
lement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de
Catégorie D et des Parts Sociales de Catégorie E respectivement.

étape c. A partir du solde restant après l'étape b, sera transféré, autant que possible, un montant égal et proportionnel

à la Réserve de Profit Ordinaire, la Réserve de Profit C, la Réserve de Profit D et la Réserve de Profit E aux détenteurs
des Parts Sociales Ordinaires, des Parts Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D et des Parts Sociales
de Catégorie E respectivement, proportionnellement au montant nominal total des Parts Sociales Ordinaires, des Parts
Sociales de Catégorie C, des Parts Sociales de Catégorie D et des Parts Sociales de Catégorie E respectivement.

étape d. Le solde positif restant après l'étape c sera transféré aux associés proportionnellement au montant total de

leurs participations.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société décide d'insérer les nouvelles définitions suivantes dans

la liste des définitions des Statuts:

«Actifs C: signifie la participation de la Société dans Roppenheim SPV;
Actifs D: signifie la participation de la Société dans Honfleur SPV;
Actifs E: signifie la participation de la Société dans Bellegrade SPV;
Actifs Ordinaires: signifie toute participation de la Société autre que la participation de la Société dans les SPVs;
Associé(s) Ordinaire(s): signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires dans la Société;
Associé(s) A: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie A dans la Société;
Associé(s) B: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie B dans la Société;
Associé(s) C: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie C dans la Société;
Associé(s) D: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie D dans la Société;
Associé(s) E: signifie le(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie E dans la Société;
Bellegrade SPV: signifie Village des Alpes S.à r.l., une société dûment constituée en France, ayant son siège social à 125,

avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 720 135, avec le
numéro d'identification fiscale FR54 514 720 135;

Catégories de Parts Sociales: signifie les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts

Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D et les Parts Sociales de Catégorie E;

Compte de Prime d'Emission Ordinaire: signifie la réserve de prime d'émission maintenue par la Société au profit des

Associés Ordinaires;

Compte de Prime d'Emission C: signifie la réserve de prime d'émission maintenue par la Société au profit des Associés

C;

Compte de Prime d'Emission D: signifie la réserve de prime d'émission maintenue par la Société au profit des Associés

D;

Compte de Prime d'Emission E: signifie la réserve de prime d'émission, maintenue par la Société au profit des Associés

E;

Honfleur SPV: signifie Champs-Vernet S.à r.l., une société dûment constituée en France, ayant son siège social à 125,

avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 226 595, avec le
numéro d'identification fiscale FR62 440 226 595;

Parts Sociales Ordinaires: signifie les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B ensembles;
Parts Sociales de Catégorie A: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents Statuts;
Parts Sociales de Catégorie B: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents Statuts;
Parts Sociales de Catégorie C: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents Statuts;
Parts Sociales de Catégorie D: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents Statuts;
Parts Sociales de Catégorie E: a le sens énoncé sous la clause 5 des présents Statuts;
Profits C: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les comptes annuels, dérivant des parts sociales correspondant

au Roppenheim SPV, libres des impôts dus par la Société (s'il y en a), en rapport avec ses profits;

122721

L

U X E M B O U R G

Profits D: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les comptes annuels, dérivant des parts sociales correspondant

au Honfleur SPV, libres des impôts dus par la Société (s'il y en a), en rapport avec ses profits;

Profits E: signifie les profits, tels qu'ils apparaissent sur les comptes annuels, dérivant des parts sociales correspondant

au Bellegrade SPV, libres des impôts dus par la Société (s'il y en a), en rapport avec ses profits;

Profits  Ordinaires:  signifie  les  profits,  tels  qu'ils  apparaissent  sur  les  comptes  annuels,  dérivant  des  Parts  Sociales

Ordinaires de la Société;

Réserve du Profit C: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés C;
Réserve du Profit D: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés D;
Réserve du Profit E: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés E;
Réserve du Profit Ordinaire: signifie la réserve du profit, maintenue par la Société au profit des Associés Ordinaires;
Roppenheim SPV: signifie MAB Roppenheim S.à r.l., une société dûment constituée en France, ayant son siège social

à 125, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 129 338,
avec le numéro d'identification fiscale FR33 430 129 338.»

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide d'autoriser chacun des gérants de la Société et/

ou employée de Alter Domus, agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution à signer et émettre par sa
seule signature au nom de la société tout document nécessaire ou utile en relation avec l'inscription requise par la loi du
Grand-Duché de Luxembourg au sujet des résolutions ci-dessus et, plus particulièrement, d'inscrire les Parts Sociales de
Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D et les Parts Sociales de Catégorie E nouvellement émises dans le registre
de la Société.

<i>Coûts

Les frais, occasionnés par le présent acte sont approximativement estimés à la somme de EUR 3.700 (trois mille sept

cents Euros).

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-ville, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte

original.

Signé: S. Judit, J. G. F. Eijkemans, N. A. F. Blüm et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44893. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139182/891.
(100159301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2010.

Landia Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.775.

Rectificatif comptes au 31 août 2009 enregistrés et déposés le 20 novembre 2009.
Réf L090178686.04
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LANDIA INVEST S.A.

Référence de publication: 2010140032/11.
(100160505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122722

L

U X E M B O U R G

Landia Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.775.

Rectificatif comptes au 31 août 2008 enregistrés et déposé le 20 novembre 2009.
Réf L090178688.04
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LANDIA INVEST S.A.

Référence de publication: 2010140033/11.
(100160506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

LCTS Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 113.317.

1. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de ses mandats d’administrateur et de présidente du conseil d’adminis-

tration.

2. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d’administrateur.
3. M. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat d’administrateur.
4. La société à responsabilité limité COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LCTS INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010140034/16.
(100160394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

LDM Participations, Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 138.563.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010140035/14.
(100160503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Bocasi SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8260 Mamer, 55, rue de Dangé Saint Romain.

R.C.S. Luxembourg E 4.353.

STATUTS

L'an deux mil dix, le huit octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Ernest SIMON, ingénieur, né à Luxembourg, le 12 juin 1942, demeurant à L-8260 Mamer, 55, rue de

Dangé Saint Romain;

2.- Madame Heddy MEYERS, sans état particulier, née à Mamer, le 17 février 1950, demeurant à L-8260 Mamer, 55,

rue de Dangé Saint Romain;

122723

L

U X E M B O U R G

3.- Monsieur Bob SIMON, économiste, né à Luxembourg, le 22 août 1974, demeurant à L-8063 Bertrange, 17, rue

Batty Weber;

4.- Madame Carole SIMON, sans état particulier, née à Luxembourg, le 2 mars 1978, épouse de Monsieur Carlo Finzi,

demeurant à Bertrange, 55, rue Batty Weber.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile

immobilière qu'ils déclarent constituer par les présentes:

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu'elle pourrait acquérir.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses associés.
La société pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant

en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation, en dehors de toute opération commerciale.

Art. 2. La société prend la dénomination de "BOCASI SCI".

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis

en assemblée générale.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-), représenté par cent (100) parts

de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- par Monsieur Ernest SIMON, ingénieur, né à Luxembourg, le 12 juin 1942, demeurant
à L-8260 Mamer, 55, rue de Dangé Saint Romain, quarante-neuf parts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2.- par Madame Heddy MEYERS, sans état particulier, née à Mamer, le 17 février 1950, demeurant
à L-8260 Mamer, 55, rue de Dangé Saint Romain, quarante-neuf parts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

3.- par Monsieur Bob SIMON, économiste, né à Luxembourg, le 22 août 1974, demeurant
à L-8063 Bertrange, 17, rue Batty Weber, une part, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4.- par Madame Carole SIMON, sans état particulier, née à Luxembourg, le 2 mars 1978,
épouse de Monsieur Carlo Finzi, demeurant à Bertrange, 55, rue Batty Weber, une part, . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille

cinq cents euros (€ 2.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code

Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'après l'agrément donné en assemblée générale par tous les

associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code

civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs associés mais continuera entre le ou les survivants

et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera

entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui

fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

122724

L

U X E M B O U R G

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2010.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation. Les

associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable, mais
ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen
de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet
de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés sauf dispositions légales

ou statutaires contraires.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient

au nu-propriétaire.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.
Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation se fera par les soins du ou des associés-gérants ou

de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une société
ou toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à raison de sa constitution,

sont estimés à environ neuf cents euros (EUR 900.-).

<i>Déclaration

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ayant servi à la libération
du capital social n'ont pas provenu d'activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la venté de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou d'actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme),
respectivement que la société ne se livre pas à des activités ci-dessus émargées.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:

1.- Le nombre des associés-gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé associé-gérant, pour une durée indéterminée: Monsieur Ernest SIMON, prénommé.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'associé-gérant.
4.- L'adresse du siège de la société est fixé à L-8260 Mamer, 55, rue de Dangé Saint Romain.

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.

122725

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ernest SIMON, Heddy MEYERS, Bob SIMON, Carole SIMON, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 octobre 2010. Relation: LAC/2010/44671. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 octobre 2010.

T. METZLER.

Référence de publication: 2010139346/127.
(100158415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Carbofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 47.207.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 07 juillet 2010:

1) L’Assemblée décide de renouveler le mandat de l’administrateur, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui

se tiendra en 2016:

- Monsieur Daniele Severoni, demeurant au 7, Via del Sole, CH-6943 Vezia;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CARBOFIN S.A.

Référence de publication: 2010139847/13.
(100160851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Gelog A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.

R.C.S. Luxembourg B 91.921.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010139949/9.
(100160076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Ginza Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.307.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2010139953/12.
(100160457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Gemstone Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.273.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010139950/9.
(100160324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122726

L

U X E M B O U R G

Chelsea Invest Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 89.387.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 septembre

2010 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le
dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
a été ordonné.

Luxembourg, le 20 septembre 2010.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CHELSEA INVEST HOLDING (en liquidation)
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010139853/16.
(100160519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Ginza Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.307.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2010139954/12.
(100160458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Ginza Enterprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 100.307.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2010139955/12.
(100160459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Compagnie Financière de la Porte Neuve S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.480.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth of September,
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of shareholders of Compagnie Financière de la Porte Neuve S.A., a société anonyme

having its registered office in L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, recorded with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 123.480, incorporated under the denomination Royale Neuve IV S.à r.l. pursuant
to a notarial deed dated 28 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
364 of 13 March 2007.

The articles of incorporation of the company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated

18 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 343 of 16 February 2010
(hereafter the "Company").

122727

L

U X E M B O U R G

The meeting is opened at 11.30 a.m. with Mr François Mayet, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Dominique Pacci, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Emmanuel Lebeau, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decrease of the share capital of the Company in order to bring it from its current amount of EUR 2,698,220 (two

million six hundred ninety-eight thousand two hundred and twenty euro) to EUR 2,218,220 (two million two hundred
eighteen thousand two hundred and twenty euro) by the cancellation of 480,000 (four hundred eighty thousand) Preferred
Shares ("Preferred Shares") owned by the Company.

2. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows: "The capital of

the Company is set at two million two hundred eighteen thousand two hundred and twenty euro (EUR 2,218,220) divided
into two million two hundred eighteen thousand two hundred twenty (2,218,220) shares with a nominal value of one
euro (EUR 1) each, all of which are fully paid up.

The share premium allocated to a share premium account is freely distributable.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws. Each share entitles to one vote and carries the right to dividend subject to the
available amounts for distribution. The shares are freely transferable."

3. Cancellation of the "Ordinary Shares" and the "Preferred Shares".
4. Deletion of article 7 "Ordinary Shares", article 8 "Preferred Shares" and amendment of the last paragraph of article

32 as follows: "After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation,
the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s)."

5. Renumbering of articles 9 to 34.
II.- That the represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder
and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III.- That the whole share capital being represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the

represented shareholder declaring that he had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

The general meeting then takes the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting decides to decrease the share capital of the Company in order to bring it from its current amount

of two million six hundred ninety-eight thousand two hundred and twenty euro (EUR 2,698,220) to two million two
hundred eighteen thousand two hundred and twenty euro (EUR 2,218,220) by the cancellation of 480,000 (four hundred
eighty thousand) Preferred Shares ("Preferred Shares") owned by the Company.

<i>Second resolution:

The general meeting decides to cancel the reference made to "Ordinary Shares" and "Preferred Shares" and to replace

them by "shares".

<i>Third resolution:

As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend article 5 of the articles of incor-

poration of the Company which will henceforth be read as follows:

"The capital of the Company is set at two million two hundred eighteen thousand two hundred and twenty euro (EUR

2,218,220) divided into two million two hundred eighteen thousand two hundred twenty (2,218,220) shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, all of which are fully paid up.

The share premium allocated to a share premium account is freely distributable.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws. Each share entitles to one vote and carries the right to dividend subject to the
available amounts for distribution. The shares are freely transferable."

122728

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution:

The general meeting decides to delete article 7 "Ordinary Shares", article 8 "Preferred Shares" and to amendment of

the last paragraph of article 32 as follows:

"After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s)."

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the deletion of articles 7 and 8, the general meeting decides to renumber the current articles 9

to 34 which will henceforth be numbered from 7 to 32.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800).

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, at the registered office of the Company, on the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the appearers, the said appearers signed together with the notary this original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille dix, le trente septembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Compagnie Financière de la Porte Neuve

S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 123.480, constituée sous la dénomination Royale Neuve IV S.à r.l. suivant
acte notarié en date du 28 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 364 du
13 mars 2007 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 18 décembre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 16 février 2010 (ci-après la "Société").

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur François Mayet, employé privé, 10, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Lebeau, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société pour le ramener de son montant actuel de EUR 2.698.220 (deux millions

six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt euros) à EUR 2.218.220 (deux millions deux cent dix-huit mille deux
cent vingt euros) par annulation des 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) Actions Préférentielles ("Actions Préféren-
tielles") rachetées par la Société.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante: "Le capital de la Société est

fixé à deux millions deux cent dix huit mille deux cent vingt euros (EUR 2.218.220) représenté par deux millions deux
cent dix huit mille deux cent vingt (2.218.220) actions ayant une valeur nominale de EUR 1 chacune, toutes entièrement
libérées.

La prime d'émission allouée à un compte de prime d'émission est librement distribuable.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois. Chaque

action donne droit à une voix et confère le droit aux dividendes en fonction des sommes mises en distribution. Les actions
sont librement cessibles."

3. Suppression des catégories: "Actions Ordinaires" et "Actions Préférentielles".
4. Suppression de l'article 7 "Actions Ordinaires" et de l'article 8 "Actions Préférentielles" et modification du dernier

alinéa de l'article 32 des statuts comme suit: "Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, y compris
tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti entre les actionnaires."

5. Renumérotation des articles 9 à 34.

122729

L

U X E M B O U R G

II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d'usage, l'actionnaire représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société pour le ramener de son montant actuel de deux

millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent vingt euros (EUR 2.698.220) à deux millions deux cent dix-huit mille
deux cent vingt euros (EUR 2.218.220) par annulation de quatre cent quatre-vingt mille (480.000) Actions Préférentielles
("Actions Préférentielles") détenues par la Société.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer les références aux "Actions Ordinaires" et "Actions Préférentielles" et de

les replacer par "actions".

<i>Troisième résolution:

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

"Le capital de la Société est fixé à deux millions deux cent dix huit mille deux cent vingt euros (EUR 2.218.220)

représenté par deux millions deux cent dix huit mille deux cent vingt (2.218.220) actions ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement libérées.

La prime d'émission allouée à un compte de prime d'émission est librement distribuable.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois. Chaque

action donne droit à une voix et confère le droit aux dividendes en fonction des sommes mises en distribution. Les actions
sont librement cessibles."

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 7 "Actions Ordinaires" et l'article 8 "Actions Préférentielles" et de

modifier le dernier alinéa de l'article 32 des statuts comme suit:

"Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, y compris tous les frais de liquidation, le boni net de

liquidation sera réparti entre les actionnaires."

<i>Cinquième résolution:

En conséquence de la suppression des articles 7 et 8, l'assemblée générale décide de renuméroter les articles 9 à 34

qui seront désormais numérotés de 7 à 32.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille huit cents euros (EUR 1.800).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. MAYET, D. PACCI, E. LEBEAU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

ier

 octobre 2010. LAC/2010/42968 Reçu soixante quinze euros €75,-

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

122730

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 octobre 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010139353/178.
(100158496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2010.

Greenlark Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 139.150.

EXTRAIT

Il est à noter que le siège social de l'associé unique, Sandlark Investments Holdings S.à r.l a été transféré au 35, Avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010139946/14.
(100160859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Global Logistic Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 85.342.

Il résulte des résolutions prises par les Actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 octobre

2010 que:

- Monsieur Frantz WALLENBORN, né le 15/02/1962 à Luxembourg, demeurant à L-8606 Bettborn, 31, rue Principale,

est nommé Administrateur-délégué soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Monsieur Frantz WALLENBORN est habilité à engager la société par sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 20 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139956/14.
(100160081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Cable Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.941.

In the year two thousand and ten, on the eighth day of October;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

CAYMAN CABLE HOLDING, L.P., with registered office at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, (the “Shareholder”),

here represented by M 

e

 Basile FÉMELAT, Esq., attorney at law by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The prenamed party is the sole shareholder of “Cable Holding S.A.”, a public limited company, having its registered

office at 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, registered at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg
section B number 91.941, incorporated pursuant to a deed of M 

e

 Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, on

January 21, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 361 of April 3, 2003 (the
“Company”).

The articles of association were amended a last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 31, 2010,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1003 of May 12, 2010.

WHEREAS, the issued share capital of the Company is currently set at two hundred and thirty two thousand seven

hundred euros (EUR 232,700.-) represented by:

- thirty-two thousand seven hundred (32,700) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);

122731

L

U X E M B O U R G

- one hundred thousand (100,000) redeemable preference shares of class D (the “D Participating Preference Shares”);

and

- one hundred thousand (100,000) redeemable preference shares of class E (the “E Participating Preference Shares”),
each share having a par value of one euro (EUR 1.-) duly subscribed for and fully paid up (collectively, the “Shares”

and each individually a “Share”).

The prenamed party is the sole owner of all the Shares.
The prenamed party requests the undersigned notary to draw up as follows:
That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to cancel all of the one hundred thousand (100,000) D Participating Preference Shares of the Company

following their repurchase to the Shareholder and to reduce the issued share capital of the Company by an amount of
one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) so as to bring it from its present amount of two hundred and thirty two
thousand seven hundred euros (EUR 232,700.-) to an amount of one hundred and thirty two thousand seven hundred
euros (EUR 132,700.-), in accordance with the provisions of the Company’s articles of association. The reimbursement
of the repurchased shares will be settled, in accordance with the provisions of Article 5.4 of the Company’s articles of
association, by a total amount of four hundred nine million three hundred nine thousand two hundred and ten euros
(409,309,210) divided into: (i) a cash payment by the Company for a net amount of thirty two million nine hundred sixty
nine thousand two hundred twenty one euros (EUR 32,969,221) (corresponding to a gross amount four hundred one
million seven hundred fifteen thousand eight hundred forty two euros (EUR 401,715,842) minus the prepaid amount of
three hundred sixty eight million seven hundred forty six thousand six hundred twenty one euros (EUR 368,746,621)
already transferred by the Company to the Shareholder pursuant to a redemption agreement dated October 4, 2010)
to any bank account and/or directly to the benefit of any other beneficiary on behalf of, and as expressly notified by the
Shareholder, and (ii) the transfer of 279,209 KDGH shares by the Company to the Shareholder and/or directly to the
benefit of any other beneficiary on behalf of, and as expressly notified by the Shareholder, such shares corresponding to
a value of seven million five hundred ninety three thousand three hundred sixty eight (EUR 7,593,368).

2. Decision to amend Article 5.1, Article 5.4.1, Article 9.10 and Article 21.2 of the Company’s articles of association

in order to reflect the aforementioned capital reduction.

3. Powers to be granted to the directors of the Company in order to implement the aforementioned resolutions.
After this had been set forth, the prenamed party now requests the undersigned notary to record the following

resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company resolves to cancel all of the one hundred thousand (100,000) D Participating

Preference Shares of the Company following their repurchase to the Shareholder and to reduce the issued share capital
of the Company by an amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000.-) so as to bring it from its present amount
of two hundred and thirty-two thousand seven hundred euros (EUR 232,700.-) to an amount of one hundred and thirty-
two thousand seven hundred euros (EUR 132,700.-), in accordance with the provisions of the Company’s articles of
association. The reimbursement of the repurchased shares will be settled, in accordance with the provisions of Article
5.4 of the Company’s articles of association, by a total amount of four hundred nine million three hundred nine thousand
two hundred and ten euros (EUR 409,309,210.-) divided into: (i) a cash payment by the Company for a net amount of
thirty-two million nine hundred sixty-nine thousand two hundred twenty-one euros (EUR 32,969,221.-) (corresponding
to  a  gross  amount  four  hundred  one  million  seven  hundred  fifteen  thousand  eight  hundred  forty-two  euros  (EUR
401,715,842.-) minus the prepaid amount of three hundred sixty-eight million seven hundred forty-six thousand six hun-
dred  twenty-one  euros  (EUR  368,746,621.-)  already  transferred  by  the  Company  to  the  Shareholder  pursuant  to  a
redemption agreement dated October 4, 2010) to any bank account and/or directly to the benefit of any other beneficiary
on behalf of, and as expressly notified by the Shareholder, and (ii) the transfer of 279,209 KDGH shares by the Company
to the Shareholder and/or directly to the benefit of any other beneficiary on behalf of, and as expressly notified by the
Shareholder, such shares corresponding to a value of seven million five hundred ninety-three thousand three hundred
sixty-eight (EUR 7,593,368.-).

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to amend Article 5.1, Article 5.4.1, Article 9.10 and Article 21.2 of the

Company’s articles of association in order to reflect the foregoing resolutions, so as to be read as follows:

“Art. 5.1. The company’s share capital is set at one hundred and thirty-two thousand seven hundred euros (EUR

132,700.-) represented by:

- thirty-two thousand seven hundred (32,700) ordinary shares (the “Ordinary Shares”); and
- one hundred thousand (100,000) redeemable preference shares of class E (the “E Participating Preference Shares”),
each share having a par value of one euro (EUR 1.- ).”

122732

L

U X E M B O U R G

“Art. 5.4.1. Repurchases may only be made in the alphabetical order and within the following periods:
(1) the E Participating Preference Shares may only be repurchased between October 9, 2010 and December 31 

st

 ,

2014;

(in each case, the “Initial Repurchase Period”); and
(2) thereafter, every second anniversary year of the Initial Repurchase Period in respect of each class of shares (the

“Subsequent Repurchase Periods” and together with the Initial Repurchase Period, the “Relevant Repurchase Periods”
in respect of each class of shares);

provided that in case a class of shares has been repurchased, (i) the starting date of the Relevant Repurchase Period

for the next class of shares to be repurchased is anticipated to the first business day after the Repurchase Date (as defined
below) in respect of the repurchased shares, while the closing date of that Relevant Repurchase Period remains December
31 

st

 of the following year, and (ii) each Subsequent Repurchase Periods for all remaining classes of shares is anticipated

by one (1) year per repurchased class of shares.”

“Art. 9.10. The shares give their holders the right to the following distribution entitlements:
a) The E Participating Preference Shares shall be entitled, on a preferential basis, to the Repurchase Value if a repurchase

occurs within a Relevant Repurchase Period with respect to such class of shares.

b) The Ordinary Shares shall be entitled to an exclusive cumulative dividend amounting to zero point zero one percent

(0.01%) of the net annual profit of the company (the “Ordinary Dividend”).

c) Without prejudice to 5.4.2 above, the E Participating Preference Shares shall be entitled to receive any residual

profits remaining in the company after the payment or provisioning of the Ordinary Dividend.”

“Art. 21.2. Any liquidation surplus shall be distributed on a pro-rata basis, pari passu to the holders of the shares then

outstanding at the time of the liquidation."

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant the broadest powers to any directors of the Company, to

implement the aforementioned resolutions and to sign and execute on behalf of the Company any agreement and docu-
ment and generally to do anything necessary or useful in connection with the aforementioned capital reduction.

<i>Valuation and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at one thousand four hundred Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with Us the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille dix, le huitième jour d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

CAYMAN CABLE HOLDING, L.P., ayant son siège social au PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street,

George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans, (l’ "Actionnaire"),

ici représentée par Maître Basile FÉMELAT, attorney at law, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La prédite partie est l’actionnaire unique de “Cable Holding S.A.”, une société anonyme, ayant son siège social au 31,

Grand Rue, L-1661 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le
numéro 91.941, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date
du 21 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 361 du 3 avril 2003 (la "Société").

Les statuts ont été modifiés une dernière fois par un acte du notaire instrumentant, en date du 31 mars 2010, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1003 du 12 mai 2010.

122733

L

U X E M B O U R G

ATTENDU QUE, le capital émis de la Société est actuellement fixé à deux cent trente deux mille sept cent euros (EUR

232.700,-) représenté par:

- trente-deux mille sept cents (32.700) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires");
- cent mille (100.000) actions participatives privilégiées rachetables de classe D (les "Actions Participatives Privilégiées

D"); et

- cent mille (100.000) actions participatives privilégiées rachetables de classe E (les "Actions Participatives Privilégiées

E");

chaque action ayant une valeur nominale d’un euro (1,- EUR), dûment souscrites et libérées (collectivement les "Ac-

tions" et individuellement chacune une "Action").

La partie susnommée est l’actionnaire unique de toutes les Actions.
La partie susnommée demande au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. décision d’annuler les cent mille (100.000) Actions Participatives Privilégiées D suite à leur rachat à l’Actionnaire

par la Société et de réduire le capital social émis de la Société d’un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) de
manière à l’apporter de son montant actuel de deux cent trente deux mille sept cent euros (EUR 232.700,-) à la somme
de cent trente deux mille sept cent euros (EUR 132.700,-), en conformité avec les dispositions des statuts de la Société.
Le remboursement des actions rachetées sera effectué en conformité avec les dispositions de l’article 5.4 des statuts de
la Société pour un montant total de quatre cent neuf millions trois cent neuf mille deux cent dix euros (EUR 409,309,210)
divisé en : (i) un payement en liquide par la société d’un montant net de trente deux million neuf cent soixante neuf mille
deux cent vingt et un euros (EUR 32,969,221) (correspondant à un montant brut de quatre cent un million sept cent
quinze mille huit cent quarante deux euros (EUR 401,715,842) moins l’avance de trois cent soixante huit millions sept
cent quarante six mille six cent vingt et un euros (EUR 368,746,621) déjà payée par la Société à l’actionnaire en vertu
d’un contrat d’annulation daté du 4 octobre 2010) sur n’importe quel compte bancaire et/ou directement au bénéfice
d’un autre bénéficiaire au nom de et tel qu’expressément notifié par l’Actionnaire, et (ii) le transfert de 279,209 actions
KDGH, correspondant à un montant de sept million cinq cente quatre vingt treize mille trois cent soixante huit euros
(EUR 7,593,368), par la société à l’Actionnaire et/ou directement au bénéfice d’un autre bénéficiaire au nom de et tel
qu’expressément notifié par l’Actionnaire.

2. Décision de modifier l’Article 5.1, l’Article 5.4.1, l’Article 9.10 et l’Article 21.2 des statuts de la Société pour refléter

la réduction de capital susmentionnée.

3. Pouvoirs à êtres accordés aux administrateurs de la Société aux fin de mettre en oeuvre les résolutions susmen-

tionnées.

Après avoir établi ceci, la partie susnommée demande maintenant au notaire instrumentant d’acter les décisions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique de la Société décide d’annuler les cent mille (100.000) Actions Participatives Privilégiées D suite

à leur rachat à l’Actionnaire par la Société et de réduire le capital social émis de la Société d’un montant de cent mille
euros (EUR 100.000,-) de manière à l’apporter de son montant actuel de deux cent trente-deux mille sept cents euros
(EUR 232.700,-) à la somme de cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 132.700,-), en conformité avec les dispo-
sitions des statuts de la Société. Le remboursement des actions rachetées sera effectué en conformité avec les dispositions
de l’article 5.4 des statuts de la Société pour un montant total de quatre cent neuf millions trois cent neuf mille deux cent
dix euros (EUR 409.309.210,-) divisé en: (i) un payement en liquide par la société d’un montant net de trente-deux millions
neuf cent soixante-neuf mille deux cent vingt et un euros (EUR 32.969.221,-) (correspondant à un montant brut de quatre
cent un millions sept cent quinze mille huit cent quarante-deux euros (EUR 401.715.842,-) moins l’avance de trois cent
soixante-huit millions sept cent quarante-six mille six cent vingt et un euros (EUR 368.746.621,-) déjà payée par la Société
à l’actionnaire en vertu d’un contrat d’annulation daté du 4 octobre 2010) sur n’importe quel compte bancaire et/ou
directement au bénéfice d’un autre bénéficiaire au nom de et tel qu’expressément notifié par l’Actionnaire, et (ii) le
transfert de 279.209 actions KDGH, correspondant à un montant de sept millions cinq cent quatre-vingt-treize mille trois
cent soixante-huit euros (EUR 7.593.368,-), par la société à l’Actionnaire et/ou directement au bénéfice d’un autre bé-
néficiaire au nom de et tel qu’expressément notifié par l’Actionnaire.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’Article 5.1, l’Article 5.4.1, l’Article 9.10 et l’Article 21.2 des statuts de la

Société afin de refléter les décisions susmentionnées, pour qu’ils aient la teneur suivante

"Art. 5.1. Le capital social de la société est fixé à cent trente-deux mille sept cents euros (EUR 132.700,-) représenté

par:

- trente-deux mille sept cents (32.700) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires"); et

122734

L

U X E M B O U R G

- cent mille (100.000) actions participatives privilégiées rachetables de classe E (les "Actions Participatives Privilégiées

E");

chaque action ayant une valeur nominale d’un euro (1,- EUR)."

"Art. 5.4.1. Les rachats peuvent uniquement se faire selon l’ordre alphabétique et au cours des périodes suivantes:
(1) les Actions Participatives Privilégiées E peuvent uniquement être rachetées entre le 8 octobre 2010 et le 31 dé-

cembre 2014;

(dans chaque cas, la "Période de Rachat Initiale"); et
(2) après, à chaque seconde année anniversaire de la Période de Rachat Initiale respective pour chaque classe d’actions

(les "Périodes de Rachat Subséquentes" et ensemble avec la Période de Rachat Initiale, les "Périodes de Rachat Pertinentes"
pour chaque classe d’actions);

à condition que, en cas de rachat d’une classe d’actions, (i) la date de début de la Période de Rachat Pertinente pour

la prochaine classe d’actions à racheter soit anticipée au premier jour ouvrable après la Date de Rachat (telle que définie
ci-dessous) des actions rachetées en question, tandis que le date de clôture de cette Période de Rachat Pertinente reste
le  31  décembre  de  l’année  suivante,  et  (ii)  chaque  Période  de  Rachat  Subséquente  pour  toutes  les  classes  d’actions
restantes est anticipée d’un (1) an par classe d’actions rachetée."

Art. 9.10. Les actions donnent à leurs détenteurs le droit aux distributions suivantes:
a) Les Actions Participatives Privilégiées E auront droit, sur une base préférentielle, à la Valeur de Rachat si un rachat

a lieu durant une Période de Rachat Pertinente en ce qui concerne telle classe d’actions.

b) Les Parts Ordinaires auront droit à un dividende cumulatif exclusif équivalent à zéro virgule zéro un pourcent (0,01%)

du bénéfice net annuel de la société (le "Dividende Ordinaire").

c) Sous réserve du 5.4.2 ci-dessus, les Actions Participatives Privilégiées E auront droit à tout bénéfice résiduel de-

meurant dans la société après paiement ou provisionnement du Dividende Ordinaire."

"Art. 21.2. Tout boni de liquidation sera distribué au prorata pari passu aux détenteurs des actions en circulation au

moment de la liquidation."

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique de la Société décide de conférer les pouvoirs les plus étendus à deux administrateurs de la Société,

agissant conjointement, afin de mettre en oeuvre les résolutions susvisées et de signer et exécuter au nom de la Société
tout contrat ou document et, de manière générale, d’entreprendre toutes actions nécessaires ou utiles en relation avec
la réduction de capital susmentionnée.

<i>Évaluation et dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou frais de quelque nature que ce soit en raison du présent acte sont évalués à

mille quatre cents euros.

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, l’assemblée est ajournée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie
comparante, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera
foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. FÉMELAT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 octobre 2010 LAC/2010/44631 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139832/236.
(100160718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

122735

L

U X E M B O U R G

Invenergy Wind Europe Bulgaria S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.490.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associées en date du 16 juin 2010

1) La société anonyme BDO Tax &amp; Accounting (anciennement BDO Compagnie Fiduciaire SA) a été révoquée de son

mandat de liquidateur.

2) La société anonyme LUXGLOBAL TRUST SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 149355, avec siège social à L-1150

Luxembourg, 291, route d'Arlon, a été nommée comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les
articles 144 à 148 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Invenergy Wind Europe Bulgaria S.à r.l. (en liquidation)
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010139973/18.
(100160502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 74.304.

Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Référence de publication: 2010139945/10.
(100160480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 29.865.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010139957/10.
(100160035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Immowald S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 12, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 88.151.

EXTRAIT

II résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 20 septembre

2010 que:

- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, a

été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

- Monsieur Thierry LEG, né le 07/09/1960 à Thionville, demeurant 54, avenue Merlin à F-57100 Thionville, a été désigné

représentant permanent de la société LEGLUX S.à r.l., pour toute la durée de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 20 septembre 2010.

Référence de publication: 2010139980/18.
(100160079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

122736


Document Outline

Bocasi SCI

Cable Holding S.A.

Carbofin S.A.

Chelsea Invest Holding

Compagnie Financière de la Porte Neuve S.A.

Gelog A.G.

Gemstone Holding S.A.

Ginza Enterprises S.A.

Ginza Enterprises S.A.

Ginza Enterprises S.A.

Global Logistic Partners S.A.

GlobeOp Financial Services S.A.

Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A.

Greenlark Property S.à r.l.

Immowald S.A.

ING REEIF Soparfi D S.à r.l.

ING RPFFB Soparfi A S.à r.l.

ING RPFFB Soparfi C S.à r.l.

ING RPFFB Soparfi Finco S.à r.l.

ING RPFI Soparfi A S.à r.l.

ING RPFI Soparfi B S.àr.l.

ING RPFI Soparfi C S.àr.l.

Interassurances Pauly &amp; Lamby et Associés S.à r.l.

Invenergy Wind Europe Bulgaria S.à r.l.

Inversiones Bren S.A.

Inversiones Bren S.A.

Inversiones Bren S.A.

Inversiones Bren S.A.

Investissimo S.A.

Jacof S.àr.l.

JAPI

Jean Charles Noel S.à r.l.

JEANTY PARTNER Luxembourg S.àr.l.

Jupiter International S.à r.l.

KA Investments Holding S.A.

KA Investments Holding S.A.

Klingelnberg Luxemburg A.G.

LA Coussinerie

LA Coussinerie

Lagoas S.A.

Landia Invest S.A.

Landia Invest S.A.

LCTS Investments S.A.

LDM Participations

Nemab S.à r.l.

Plus Russland Diskont-Beteiligung S.à r.l.