logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2300

27 octobre 2010

SOMMAIRE

Adriel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110391

Balzak s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110392

Baptista S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110385

Barn Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

110386

Belgard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110386

Bijouterie Huberty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

110386

Bodhi Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110387

Bucomi SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110387

Bucomi SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110387

Bucomi SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110387

Bucomi SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110388

Cabrilla S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110389

Camosc Charter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110389

Capital Investment Management Compa-

ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110389

CFL-Evasion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110390

Chausseur Robert S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

110390

Chausseur Robert S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

110390

Ciancone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110389

Claire Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

110387

Clervaux Participations S.A.  . . . . . . . . . . . .

110391

CM & Partners Investments S.A.  . . . . . . . .

110391

Coficom Expertise S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

110388

Coralia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110392

Cristo Rei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110392

Crossways S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110354

Delamare Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . .

110393

Delphirica Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .

110393

Destet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110393

Dharma Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

110394

Dialogue S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110394

Diamco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110395

Diamco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110395

Eko-Park International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

110395

Enop 1 A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110376

Enop 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110376

ENRC Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

110395

Equity Trust Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

110388

Exorsa, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110396

Fiduciaire F. Winandy & Associés S.A.  . . .

110396

Fortrust Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110396

Geldilux-TS-2010 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110354

Gold-Rush S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110397

Groengrond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110397

GSLP International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

110398

Harlow Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . .

110398

Immo ABS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110395

Immobilière Diederich S.A.  . . . . . . . . . . . . .

110398

Immobilière Wolz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

110399

Integreat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110399

Inter Ikea Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

110400

Inter Ikea Finance S.A. Holding  . . . . . . . . .

110400

Jan Navigation A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110400

Jenebe International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

110399

Jenebe International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

110400

Linamar Financial Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110365

Metallum Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110390

Newell Luxembourg Finance S.à r.l.  . . . . .

110400

Odyssey Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110398

Oriel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110399

Pamplona PE Holdco 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . .

110394

Providence Education S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

110397

R.G.R.B. International S.A. . . . . . . . . . . . . . .

110386

Valbonne II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110391

110353

L

U X E M B O U R G

Crossways S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 124.745.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/09/10.

<i>Pour: CROSSWAYS SA
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Fanny Marx / Antonio Intini

Référence de publication: 2010125722/15.
(100142576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

Geldilux-TS-2010 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 155.505.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the seventeenth day of September.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, siding in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Stichting Rebna, a foundation (stichting) established under the laws of The Netherlands, having its statutory seat (sta-

tutaire zetel) in The Netherlands at Dam 7, 1012 JS Amsterdam, registered with the Trade Register of the Chamber of
Commerce of Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) under number 34306791,

here represented by Ms. Monique GOERES, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following

articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.

By-Laws:

Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration.

1. Form, Corporate name.
1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") go-

verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies as amended (the "1915 Law") and by the present articles (the "Articles"). The Company shall be subject to
the law dated 22 March 2004 on securitisation as amended (the "Securitisation Law").

1.2 The Company exists under the name of "Geldilux-TS-2010 S.A.".

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") or in case of plurality of shareholders by means of a
resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments
to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole

Director") is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole
Director.

110354

L

U X E M B O U R G

3. Object.
3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several

securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.

3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through

another entity, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the
activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the
issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired
or assumed by the Company.

3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:
(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense

of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;

(b) sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of its assets in such manner and for such compensation as the

Board of Directors, the Sole Director or any person appointed for such purpose shall approve at such time;

(c) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial ins-

truments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security
rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;

(d) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;
(e) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options)

and any similar transactions;

(f) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities

the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and

(g) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund

the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company
acts  as  acquisition  entity), to comply  with  any  payment  or  other obligation it  has  under  any  of its securities  or  any
agreement entered into within the context of its activities.

3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are

directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development.

4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital

5. Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (€ 31,000), divided into thirty-one thousand

(31,000) registered shares with a par value of one Euro (€ 1) each, fully paid up (by 100 %).

6. Form of the shares. The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.

7. Payment of shares. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and

upon conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount
called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.

8. Modification of capital.
8.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

8.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

Chapter III. - Bonds, Notes and Other debt instruments

9. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or

bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or con-
verted into bearer form.

Chapter IV. - Directors, Board of Directors, Independent auditors

10. Board of directors or Sole Director.
10.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least

three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.

10.2 In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders,

it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors
consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the shareholders
noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of
the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a

110355

L

U X E M B O U R G

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal
entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

10.3 The  Directors  or the Sole  Director are  appointed by the general  meeting of shareholders  for a period not

exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of
shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without
mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

10.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next
general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

11. Meetings of the Board of Directors.
11.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman

may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced
by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

11.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the

Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

11.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented

by proxies.

11.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his

proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later
stage.

11.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman

has a casting vote.

11.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating

Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the

Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by
fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings,
duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

11.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event

such vote is confirmed in writing.

11.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts

shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

12. General powers of the Board of Directors / Sole Director.
12.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of adminis-

tration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

12.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the

Company in accordance with the Securitisation Law.

13. Delegation of powers.
13.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs

of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members
of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under
such terms and with such powers as the Board shall determine.

13.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons

who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

14. Representation of the Company. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a

Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the signatures of
any two Directors together or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by
any two Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

15. Approved statutory auditor(s).
15.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises

agréé(s)) appointed by the Board of Directors or by the Sole Director.

15.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with

the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

15.3 The registered statutory auditor(s) is/are re-eligible.

110356

L

U X E M B O U R G

16. Conflict of interests.
16.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has an interest in, or is a Director,
associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 16.3 is complied with.

16.2 Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3 In the event that any Director of the Company may have any opposing interest in any transaction of the Company,

such Director shall make known to the Board of Directors such opposing interest and shall not consider or vote upon
any such transaction, and such transaction, and such Director's interest therein, shall be reported to the next following
general meeting of the shareholders of the Company.

16.4 If there is only one Director, by derogation to paragraph 16.3, the minutes shall only mention the operations

intervened between the Company and its Sole Director having an interest opposing with that of the Company.

16.5 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors or

of the Sole Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.

Chapter V. - General meeting of shareholders

17. Powers of the Sole Shareholder / General meeting of shareholders.
17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be

held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.

17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting

of shareholders and shall take the decision in writing.

17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of

shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

17.4 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by

registered letter at least fifteen days before the meeting. In the event that all the shareholders are present or represented
and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements
and formalities of publication.

17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive

or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three
(3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to shall be taken into account.

17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by teleconference or by way of telecommunications

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of
communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the de-
liberations are transmitted on a continuous basis.

17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of

shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.

17.9 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles
or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds of the votes cast of the shareholders
present or represented.

17.10 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal
requirement.

18. Place and Date of the annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders is held

in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the last Wednesday
of June at 15.00 o’clock, and for the first time in 2011. If such day is a public holiday, the annual general meeting of
shareholders will be held on the next following business day.

19. Other general meetings. Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened

at the request of the shareholders which together represent one fifth of the capital of the Company.

110357

L

U X E M B O U R G

20. Votes. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general

meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

Chapter VI. - Business year, Distribution of profits

21. Business year.
21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2010.

21.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It

shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the
annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such
documents.

22. Distribution of profits.
22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This

allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the
Company.

22.2  After  allocation  to  the  legal  reserve,  the  general  meeting  of  shareholders  determines  the  appropriation  and

distribution of net profits.

22.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms

prescribed by law.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

23. Dissolution, Liquidation.
23.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum

as for the amendment of the Articles.

23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by

the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.

23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors or

the Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.

Chapter VIII. - Applicable law

24. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law

and the Securitisation Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for thirty-one thousand (31,000)

shares as follows:

Stichting Rebna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares
Total: thirty-one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) is forthwith at the

free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand Euro (€ 1,000.-).

<i>First resolutions of the Sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting Rebna, considering itself as

duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolve7d to the meeting
of the shareholders passed the following resolutions:

1. The Company’s address is fixed at 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general

meeting of shareholders to be held in 2011:

(a) Mrs. Candice De Boni, senior manager, born on 31 December 1973 in Strasbourg (France) with professional address

at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

110358

L

U X E M B O U R G

(b) Mrs. Laetitia Antoine, senior manager, born on 30 March 1973 in Woippy (France) with professional address at

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg; and

(c) Mr. Jean-Robert Bartolini, senior vice president, born on 10 November 1962 in Differdange (Luxembourg) with

professional address at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with us, the notary,

the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundzehn, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).

ERSCHIEN:

Stichting Rebna, eine Stiftung (stichting) nach dem Recht der Niederlande mit Geschäftssitz (statutaire zetel) in Dam

7, 1012 JS Amsterdam, Niederlande, eingetragen bei der Handelskammer in Amsterdam (Handelsregister van de Kamer
van Koophandel voor Amsterdam) unter der Nummer 34306791,

hier vertreten durch Fräulein Monique GOERES, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftli-

chen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde
beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht wird.

Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer

Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu gründen wünscht.

Satzung:

Kapitel I. - Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Gesellschaftszweck

1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in
seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz
vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").

1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Namen "Geldilux-TS-2010 S.A.".

2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).
2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär"), beziehungsweise

im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden
Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb des Großher-
zogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft

(der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der
sich der Sitz der Gesellschaft befindet.

2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorste-

hen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem
Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände
vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt,
die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins
Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.

3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende

und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbergesellschaft und/oder Emittent zu fungieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere

Gesellschaft Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten
Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die
Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere

110359

L

U X E M B O U R G

Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen
oder übernommenen Risiken abhängt.

3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:
(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital-oder Personengesellschaften

begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwer-
ben;

(b) ihre Vermögenswerte in einer Weise und zu einem Gegenwert verkaufen, übertragen, abtreten oder belasten oder

anderweitig darüber verfügen, wie von dem Verwaltungsrat, dem alleinigen Verwaltungsrat oder einer anderen mit dieser
Aufgabe betrauten Person zu dem betreffenden Zeitpunkt genehmigt;

(c) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente

verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an
den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfand-
rechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;

(d) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte

abschließen;

(e) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen

abschließen und durchführen;

(f) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte

ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt
und

(g)  als  Kreditnehmer  Darlehensvereinbarungen  im  Rahmen  des  Verbriefungsgesetzes  eingehen,  insbesondere  zum

Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner,
sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr
aufgrund der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit
ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat.

3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,

die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

4. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Kapitel II. - Kapital

5. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (€ 31.000,-), eingeteilt in einund-

dreißigtausend (31.000) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (€ 1,-) und ist vollständig einbezahlt
(100%).

6. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Bestimmun-

gen.

7. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren,

können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwal-
tungsrat jeweils von Zeit zu Zeit festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen
und nicht voll eingezahlten Anteile zu gleichen Teilen eingefordert.

8. Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen.
8.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt

werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen muss.

8.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.

Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel

9. Namens- oder Inhaberpapieren. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als

Namens-oder Inhaberpapiere in Zertifikatsform begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel, die
als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.

Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

10. Verwaltungsrat oder alleiniger Verwaltungsrat.
10.1 Im Falle vom Vorhandensein einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen

Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein
"Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.

10.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der

Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen
Verwaltungsrat zu führen, bestehend entweder aus einem einzigen Verwaltungsratsmitglied, genannt der alleinige Ver-

110360

L

U X E M B O U R G

waltungsrat, bis zum Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die das Bestehen von mehr als einem
Aktionär feststellt oder bestehend aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied
des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der
diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen
Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.

10.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Akti-

onäre für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren bestellt und können wiedergewählt werden. Sie können jederzeit
durch einen Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nach-
folger ernannt worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt dieses als
für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.

10.4  Wird  ein  Platz  im  Verwaltungsrat  wegen  Todes  oder  Ausscheidens  eines  Verwaltungsratsmitglieds  oder  aus

anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Mehrheit
der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Platz besetzt, bis die nächste Hauptversammlung statt-
findet, die zur Ratifizierung dieser Wahl aufgefordert werden wird.

11. Sitzungen des Verwaltungsrats.
11.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann

von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann,
wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden
Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.

11.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied

einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Ein-
haltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.

11.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner

Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.

11.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes

Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes
Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

11.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei

Abstimmungen ist im Fall von Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

11.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder per Telefonkonferenz ist erlaubt, vorausgesetzt, dass jedes teilnehmende

Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Technologie verwendenden
Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per Videokonferenz oder
Telefon abzustimmen.

11.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Un-

terschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaires). Die Zustimmung kann in
einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem
Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwal-
tungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.

11.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon,

wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.

11.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmit-

gliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.

12. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats / des alleinigen Verwaltungsrats.
12.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme

von Verwaltungs-und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts
wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des
Verwaltungsrats.

12.2  Der  Verwaltungsrat  oder  der  alleinigen  Verwaltungsrat  der  Gesellschaft  ist  berechtigt,  Vermögenswerte  der

Gesellschaft im Einklang mit dem Verbriefungsgesetz zu übertragen, abzutreten und darüber zu verfügen.

13. Übertragung von Befugnissen.
13.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der

Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft
handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat fest.

13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinigen Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch

an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte
und Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.

110361

L

U X E M B O U R G

14. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen

Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmit-
gliedern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift der
Person, die eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Verwaltungsrat
übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.

15. Eingetragene(r) unabhängige(r) Wirtschaftsprüfer.
15.1  Die  Jahresabschlüsse  der  Gesellschaft  werden  von  einem  oder  mehreren  eingetragenen  unabhängigen  Wirt-

schaftprüfern (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, die vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Verwaltungsrat
ernannt werden.

15.2 Die/der unabhängige(n) eingetragene(n) Wirtschaftsprüfer sind/ist auf unbestimmte Zeit aus den bei der Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfern ernannt.

15.3 Die/der unabhängige(n) eingetragene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.

16. Interessenkonflikte.
16.1 Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht

dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Angestellte oder Handlungs-
bevollmächtigte der Gesellschaft ein Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Verwaltungsratsmit-
glieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der anderen Gesellschaft oder Firma sind, sofern die
Bestimmungen der Ziffer 16.3 beachtet werden.

16.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, Angestellter oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher als Verwal-

tungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die
Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, ist nicht allein aufgrund dieser Verbindung
mit der anderen Gesellschaft oder Firma gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäfts-
beziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder damit zusammenhängende Handlungen auszuführen.

16.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein entgegenstehendes Interesse an einem Rechtsgeschäft

der Gesellschaft hat oder verfolgt, teilt das Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegenstehende Inte-
resse  mit  und  nimmt  im  Hinblick  auf  dieses  Rechtsgeschäft  nicht  an  Beratungen  oder  Abstimmungen  teil.  Von  dem
Rechtsgeschäft sowie dem Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, wird bei der nächstfolgenden Hauptversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft berichtet.

16.4 Bei Vorhandensein nur eines Verwaltungsratsmitglieds, soll das Protokoll, unter Abänderung des Artikels 16.3,

nur den Ablauf zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsrat, der ein Interesse hat, welches dem der
Gesellschaft entgegensteht, aufführen.

16.5 Die Regelungen der vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn die Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des al-

leinigen Verwaltungsrats laufende Geschäftstätigkeiten zu üblichen Konditionen betreffen.

Kapitel V. - Hauptversammlung

17. Befugnisse des Alleinaktionärs / der Hauptversammlung.
17.1 Die Gesellschaft kann durch einen Alleinaktionär gegründet werden, oder können alle Anteile der Gesellschaft

von  einer  einzelnen  Person  gehalten  werden.  Tod  oder  Auflösung  des  Alleinaktionärs  führt  nicht  zur  Auflösung  der
Gesellschaft.

17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser Alleinaktionär sämtliche Befugnisse, die der Hauptversamm-

lung zustehen erhalten und Beschlüsse schriftlich fassen.

17.3 Im Falle, dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Akti-

onäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung
von Angelegenheiten der Gesellschaft.

17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwal-

tungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungs-
mitteilung  per  Einschreiben  erfolgen.  Sofern  sämtliche  Aktionäre  während  der  Hauptversammlung  anwesend  oder
ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden,
können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung
der Tagesordnung verzichten.

17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder

durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss,
und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu
lassen.

17.6  Die  Aktionäre  sind  berechtigt,  mittels  eines  Abstimmungsformulars,  das  eine  Zustimmung,  Ablehnung  oder

Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der
Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird,
eingegangen sind, sollen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt werden.

110362

L

U X E M B O U R G

17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Telekonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie iden-

tifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und
Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht ge-
eignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
fortwährend zu übertragen sind.

17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß

einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, ungeachtet des Anteils des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.

17.9 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirk-

sam  beraten,  wenn  mindestens  die  Hälfte  des  Kapitals  vertreten  ist  und  die  geplante  Satzungsänderung  sich  der
Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Ver-
sammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen
werden. In der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der
vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versamm-
lung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer
Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.

17.10 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten

der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfor-
dernisse beschlossen werden.

18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am letzten Mittwoch im Juni

um 15.00 Uhr, erstmalig im Jahr 2011, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmitteilung
näher angegeben wird. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird die Jahreshauptversammlung am ersten
darauffolgenden Geschäftstag abgehalten.

19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine

Hauptversammlung ist auf Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Fünftel des Kapitals der Gesellschaft
vertreten.

20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jah-

reshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats

Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft
beginnt und am 31. Dezember 2010 endet.

21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung er-

stellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der
Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorge-
legten Unterlagen erstellen.

22. Gewinnausschüttung.
22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5%) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine

solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens
ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Ver-

wendung und Ausschüttung der Nettogewinne.

22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen

Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.

Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation

23. Auflösung, Liquidation.
23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, für den die selben Anforderungen

an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung der Satzung.

23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär

oder von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.

23.3 Wenn keine Liquidatoren vom Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Verwal-

tungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).

110363

L

U X E M B O U R G

Kapitel VIII. - Geltendes Recht

24. Geltendes Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des

Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

<i>Zeichnung und Zahlung

Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei einunddreißigtausend (31.000) Anteile wie nach-

stehend angegeben gezeichnet:

Stichting Rebna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Anteile
Insgesamt: einunddreißigtausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Anteile

Diese Anteile sind sämtlich voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (€ 31.000,-) der Ge-

sellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von

1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

<i>Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer

Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ungefähr eintausend Euro (€
1.000,-) geschätzt.

<i>Erste Beschlüsse des Alleinaktionärs

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting Rebna, die die Versammlung

als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse
der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Als Anschrift der Gesellschaft wird 43, boulevard du Prince Henri, L1724 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

vorgesehen.

2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre

2011 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:

(a) Frau Candice De Boni, Geschäftsführerin, geboren am 31. Dezember 1973 in Strasburg (Frankreich), geschäftsan-

sässig in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

(b) Frau Laetitia Antoine, Geschäftsführerin, geboren am 30. März 1973 in Woippy (Frankreich), geschäftsansässig in

412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und

(c) Herr Jean-Robert Bartolini, senior vice president, geboren am 10. November 1962 in Differdange (Luxemburg),

geschäftsansässig in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, aktiert hiermit, dass auf Anfrage der oben

genannten  erschienenen  Person,  die  vorliegende  Ausfertigung  in  Englisch  verfasst  ist,  welcher  eine  deutsche  Fassung
beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, wird der englische Text maßgebend sein.

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg

errichtet.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam

mit dem Notar diese Originalurkunde.

Signé: M. GOERES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2010. LAC/2010/40808. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 20 septembre 2010.

Référence de publication: 2010125256/579.
(100142966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

110364

L

U X E M B O U R G

Linamar Financial Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.502.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the tenth day of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

THERE APPEARED:

Linamar Corporation, a public company incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered

office set at 287 Speedvale Ave. W. Guelph, Ontario, Canada N1H 1C5, registered with the Ontario, Canada Trade
Register under number 175-8459.

Represented by Mr. Matthieu Groetzinger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organize as shareholder.

Title I. Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name.
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of “Linamar

Financial Sàrl”, governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such an entity
(hereinafter referred to as the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

 of August 1915, on commercial com-

panies, as amended (hereinafter referred to as the “Law”).

Art. 2. Object.
2.1 The object of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in

Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The Company may also pursue marketing and selling activities directly
or through branches established abroad and/or offices located abroad. The Company may in particular acquire by sub-
scription,  purchase,  exchange  or  in  any  other  manner  any  stock,  shares  and  other  participation  securities,  bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may also contract loans
and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation
or to any other companies of the group. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to
secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company of the group. The
Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets. The Company
may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance, licence and sub-licence and dispose of patents, licences,
and all other intangible property, as well as rights deriving there from or supplementing them. In addition, the Company
may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of
moveable property.

2.3 In general, the Company may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities

or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in

the manner required for the amendment of these articles of association.

3.3 The life of the Company does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar

event affecting, one or several shareholders.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the

municipality of Luxembourg by decision of the board of managers of the Company. It may further be transferred to any
other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of the shareholders
adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

4.2 The Company may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision

of the board of managers.

110365

L

U X E M B O U R G

4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would

interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office; the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal cir-
cumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. Capital - Shares.
5.1 The Company's corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-), represented by two (2)

classes of shares as follows: twenty thousand (20,000) ordinary shares (hereinafter referred to as the “Ordinary Shares”)
and zero (0) mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend shares (hereinafter referred to as the “Man-
datory Redeemable Preferred Shares”, and together with the Ordinary Shares shall be referred to as the “Shares”), with
a par value of USD 1.- (one US Dollar) each. The respective rights and obligations attached to each class of Shares are
set forth below. All Shares will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and
class to which they belong.

5.2 All the Shares are fully paid up.
5.3 In addition to the contributions to the Company in the form of corporate capital as set forth in the above section

5.1, new shareholders or existing shareholders may subscribe to shares by payments made to the corporate capital and
as the case may be also through payments made to the share premium account linked to the newly issued shares.

5.4 The shareholder owning Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share

premium paid for the subscription of Ordinary Shares. The shareholder owning Mandatory Redeemable Preferred Shares
will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium paid for the subscription of Mandatory
Redeemable Preferred Shares.

5.5 Share premium paid on Ordinary Shares or Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in specific

share premium accounts, as follows:

- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an ordinary shares’ share premium account (hereinafter

referred to as the “Ordinary Shares’ Share Premium Account”) and such share premium shall remain attached to the
Ordinary Shares upon which the share premium was paid;

- any share premium paid on Mandatory Redeemable Preferred Shares shall be booked in a mandatory redeemable

preferred shares’ share premium account (hereinafter referred to as the “Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Share
Premium Account”) and such share premium shall remain attached to the Mandatory Redeemable Preferred Shares upon
which the share premium was paid;

5.6 All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of redeemable shares within the meaning of

Article 49-8 of the Law. Without prejudice to the conditions set forth in Article 49-8 of the Law (including, without
limitation, the fact that the redemption of the Mandatory Redeemable Preferred Shares can only be made by means of
sums available for distribution pursuant to Article 72-1 of the Law) (distributable funds, inclusive of the extraordinary
reserve established with funds received by the Corporation as an issue premium) or proceeds of a new issue made for
the redemption purpose), Mandatory Redeemable Preferred Shares will be redeemed pursuant to the following terms
and conditions:

(i) if the Mandatory Redeemable Preferred Shares are neither converted or retracted, the Company shall redeem all

Mandatory Redeemable Preferred Shares then in issue upon expiry of a thirteen (13) years period from the date on which
the relevant Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued (hereinafter referred to as the “Final Mandatory Re-
demption Date”);

(ii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holder of Mandatory

Redeemable Preferred Shares is entitled to request (in one or several occasions) in writing the Company to redeem all
or part of its Mandatory Redeemable Preferred Shares; and

(iii) the holder of any Mandatory Redeemable Preferred Shares, that has been redeemed, is entitled to receive a

payment in cash or in kind per redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares (hereinafter referred to as “the
redemption price”) equal to:

1. the par value of the redeemed shares; plus
2. all and any accrued and unpaid dividends that the holder of redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares is

entitled to receive at the time of the redemption; plus

3. an amount corresponding to a portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Share Premium Account

equal to the balance of the Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Share Premium Account divided by the number of
outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares prior to the redemption; plus

4. an amount corresponding to the portion of the Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account (as such

expression is defined in article 5.10 below) divided by the number of outstanding Mandatory Redeemable Preferred Shares
prior to the redemption.

Redeemed Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after redemption.

110366

L

U X E M B O U R G

5.7 All Mandatory Redeemable Preferred Shares are issued in the form of shares convertible into Ordinary Shares.

Mandatory Redeemable Preferred Shares may be converted into Ordinary Shares pursuant to the following terms and
conditions:

(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares may

at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert in Ordinary Shares all or part
of the Mandatory Redeemable Preferred Shares;

(ii) the Mandatory Redeemable Preferred Shares will be converted into a fixed number of Ordinary Shares equal to

the respective Mandatory Redeemable Preferred Shares par value, accrued and unpaid dividends, attached Mandatory
Redeemable Share Premium Account and Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. No decimal of
Shares will be available. The board of managers of the Company may (in case of decimals) either round up or round down
to the closest appropriate number of Ordinary Shares.

Converted Mandatory Redeemable Preferred Shares will be cancelled forthwith after conversion.
5.8 The holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will be entitled to an annual cumulative dividend equal to

1% of the par value of the Mandatory Redeemable Preferred Shares and attached share premium (if any) and a variable
rate that tracks the entitlement of the interest income and other profits of any assets of the Company, less the fixed rate
and the applicable margin.

5.9 The holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will only be entitled to dividend payments provided that

the Company has sufficient liquid assets available, after each dividend payment is made to cover its current expenses
immediately after the payment of the dividend and one of the following three (3) events has occurred:

(i) the distribution of a dividend payment is approved; or
(ii) Mandatory Redeemable Preferred Shares are redeemed by the Corporation or retracted by the holder of Man-

datory Redeemable Preferred Shares; or

(iii) the Company is wound-up.
5.10 Should the profits be sufficient to distribute a dividend, in whole or in part, and the shareholder, or in case of

plurality of shareholders, the general meeting of shareholders, decides to make no distribution resolution with respect
to such dividend, the amount of the dividend that should have been distributed to the holder of the Mandatory Redeemable
Preferred Shares shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a Mandatory Redeemable Preferred
Shares reserve account (hereinafter referred to as the “Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account”).

5.11 In case of dissolution of the Corporation, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares will rank junior

to all other debts incurred by the Company but will rank senior to the holder of Ordinary Shares as set forth in article
18 below.

Art. 6. Increase and Reduction of corporate capital.
The corporate capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the

general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

Art. 7. Transfer of shares.
7.1 Shares are freely transferable among shareholders.
7.2 In case of a sole shareholder, the shares are freely transferable to non-shareholders. In case of plurality of share-

holders,  Shares  may  be  transferred  to  non-shareholders,  within  the  limits  of  the  Law.  Indeed,  shares  may  not  be
transferred inter vivo to non-shareholders, unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate
capital shall have agreed thereto in a general meeting.

7.3 The transfer of Shares will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or

acceptance by the Company, as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The Company may purchase its own Shares.

Art. 8. Form of shares - Shareholders’ register.
8.1 Shares are in registered form.
8.2 A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Law and may be examined by the shareholders if they require.

8.3 The ownership of the Shares will result from the inscription in the shareholders’ register.

Title III. Administration - Management - Representation

Art. 9. Board of managers.
9.1 The Company shall be managed by a board of managers composed, at least, of two managers, who do not need

to be shareholders and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders. The board
of managers shall be composed of two classes of managers (A and B). Class A shall be composed of one (1) manager at
least. Class B shall be composed of one (1) manager at least.

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers, compensation and duration of their mandates reserved the faculty attributed to the board

110367

L

U X E M B O U R G

of managers to proceed by way of cooptation in order to replace resigning or deceased board members. The managers
shall hold office until their successors are appointed.

Art. 10. Power of the board of managers.
10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the general meeting of

shareholders fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve
all acts and operations consistent with the object of the Company.

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent’s responsibilities and remunerations (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure.
11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Company’s interest so requires or upon call of

any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose
from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two (2) working

days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by cable, telegram or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such
notice is required if all the managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have
been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or

telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting, this
manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board
meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram or telefax, or by email.

11.4 The board of managers can validly deliberate and act only if at least one manager class A and one manager class

B are present or represented. Decisions shall be taken by a majority vote composed at least by one vote of each class of
managers present or represented at such meeting.

11.5 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.

11.6 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the chairman pro tempore, by the secretary or by
two managers.

Art. 12. Representation.
The Company shall be bound by the joint signature of one manager class A and one manager class B in any case and

for any amount or by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been
delegated by the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers.
In the execution of their mandates, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Com-

pany. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Title IV. General meetings of shareholders

Art. 14. Powers and Voting rights.
14.1 Resolutions at a meeting of shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting.
14.2 The corporate capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the

shareholders. The shareholders may change the nationality of the Company by a unanimous vote. A meeting of share-
holders may be held without prior notice or publication if they state that they have been informed of the agenda of the
meeting.

14.3 Each Share entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meeting of shareholders.
14.4 The Company will recognize only one holder per Share.
14.5 The shareholders exercise all the powers allocated to the general meeting of the shareholders pursuant to the

Law.

14.6 The decisions of the shareholders are recorded in minutes or drawn-up in writing.

110368

L

U X E M B O U R G

14.7 Also, contracts entered into between the shareholders and the Company, represented by the shareholders, are

recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations
entered into under normal conditions.

Art. 15. Annual general meeting.
An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six months after

the closing of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice of the annual general meeting.

Art. 16. Accounting year.
The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-

first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the incorporation of
the Company and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand and ten.

Art. 17. Annual accounts and Allocation of profits.
17.1 The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each accounting year and will be at

the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

17.2 Out of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve account.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve has reached an amount to ten per cent (10%) of the
corporate capital of the Company.

This allocation should again become compulsory if the legal reserve falls below ten (10%) per cent of the corporate

capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of managers, will determine the allocation

of the annual net profits.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit, including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the board of managers of the Company, and
4. The payment is made only when the rights of the significant creditors of the Company are not threatened.

Title V. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders in charge of such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the

general meeting of shareholders.

18.3 The power of the board of managers will end upon the appointment of the liquidator(s). After the payment of all

debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the remaining available amount will be paid
first in priority to the holder of Mandatory Redeemable Preferred Shares according to the par value of such shares
increased by any accrued but unpaid dividends, any Mandatory Redeemable Preferred Shares’ Share Premium Account
and Mandatory Redeemable Preferred Shares Reserve Account. Holder of Ordinary Shares will then be entitled to the
remaining available amount (if any) on a pro rata basis, according to the number of shares held in the Company’s capital
by the holder of such shares.

Art. 19. General provision.
All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, repre-

sented as stated here above, declare to subscribe for twenty thousand (20,000) shares and to have fully paid up in cash
these shares for an amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-).

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the Law have been fulfilled.

<i>Statement

The undersigned notary herewith declares having checked the existence of the conditions listed in article 183 of the

Law and expressly states that they have been fulfilled.

110369

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the shareholder

The prenamed shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at L-2310 Luxembourg, 16 Avenue Pasteur, Grand-Duchy of Luxem-

bourg.

2. The number of manager class A is fixed at one (1). The following person is appointed as manager class A:
- Mr. Edward Alfred Mahood, born on May 8, 1963, in ST. Catharines (Canada), residing at 287 Speedvale Ave.w

Guelph, Ontario Canada, N1H1C5.

The number of manager class B is fixed at two (2). The following persons are appointed as managers class B:
- Mr. Emmanuel Réveillaud, born on October 10, 1971 in La Rochelle (France), residing at L-2132 Luxembourg, 20

Avenue Marie-Thérèse; and

- Mr. Tamas Horvath, born on November 5, 1977 in Pécs (Hungary), residing at L-2310 Luxembourg, 16, Avenue

Pasteur.

3. The managers shall be appointed for an unlimited period which shall end either by their resignation or their revo-

cation by the general meeting of the shareholders.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le dix septembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire du présent acte,

A COMPARU:

Linamar Corporation, une société anonyme, constituée et organisée selon les lois du Canada, ayant un siège social au

287 Speedvale avenue W. Guelph, Ontario, Canada N1H 1C5, inscrite au registre du commerce d’ Ontario, Canada, sous
le numéro 175-8459,

Ici représentée par Monsieur Matthieu Groetzinger, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante

et par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle

entend constituer en tant qu’associé.

Title I 

er

 . Nom - Durée - Siège social - Objet

Art. 1 

er

 . Nom.

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination “ Linamar Financial Sàrl”, qui sera régie par les

présents statuts et les lois luxembourgeoises relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du
10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la disposition de participations au Luxembourg

ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des activités de marketing et de
vente directement ou par l’intermédiaire de succursales situées à l’étranger et/ou de bureaux situés à l’étranger. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions
simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus
généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques quelconques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par

voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de
participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à
d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, ainsi qu’à toutes autres sociétés du groupe. Elle pourra

110370

L

U X E M B O U R G

aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer
d'autres types de garanties sur l’ensemble ou une partie de ses actifs. La Société pourra détenir des participations dans
des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien matériel,
ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des
propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines

de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans

les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre évènement

similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxem-

bourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Grand- Duché de Luxembourg qu’à l’étranger,

par décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, actuels ou imminents,

qui pourraient compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
de ce siège avec l'étranger, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille US Dollars (20.000 US Dollars) représenté par deux (2) catégories de parts

comme suit: vingt mille (20.000.-) parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») et zéro (0) part privilégiée obligatoirement
rachetable à dividende fixe et variable (les «Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables», et collectivement avec les
Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de un US Dollars (1.00.- US Dollars) chacune. Les obli-
gations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts sont émises
sous la forme nominative et assorties de droits de vote quelque soit leur nature et la catégorie à laquelle elles appar-
tiennent.

5.2 Toutes les Parts ont été entièrement libérées.
5.3 En plus des apports faits à la Société sous forme de capital social tel que décrit à l’article 5.1, de nouveaux associés

ou les associés existants peuvent souscrire à des Parts par un paiement au capital social et le cas échéant par des paiements
faits au compte prime d’émission lié aux parts nouvellement émises.

5.4 L’associé qui détient des Parts Ordinaires bénéficiera exclusivement de tous les droits attachés à la prime d’émission

payée lors de la souscription des Parts Ordinaires. L’associé détenant des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables
bénéficiera exclusivement de tous les droits attachés à la prime d’émission payée lors de la souscription des Parts Privi-
légiées Obligatoirement Rachetables.

5.5 La prime d’émission payée pour des Parts Ordinaires ou des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables devra

être comptabilisée dans des comptes prime d’émission distincts, comme suit:

- toute prime d’émission payée pour des Parts Ordinaires devra être comptabilisée dans un compte prime d’émission

des parts sociales ordinaires (le «Compte Prime d’Emission Parts Ordinaires») et restera attachée aux Parts Ordinaires
pour lesquelles la prime d’émission a été payée; et

- toute prime d’émission payée pour Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables devra être comptabilisée dans un

compte prime d’émission Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables (le «Compte Prime d’Emission Parts Privilégiées
Obligatoirement Rachetables») et restera attachée aux Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables pour lesquelles la
prime d’émission a été payée;

5.6 Toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts rachetables au sens

de l’Article 49-8 de la Loi. Sans préjudice des conditions requises à l’Article 49-8 de la Loi (incluant, sans limite, le fait que
le rachat des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables peut uniquement être effectué au moyen de sommes dispo-
nibles à la distribution conformément à l’Article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris toute réserve extraordinaire
constituée par des fonds reçus par la Société à titre de prime d’émission) ou bénéfices issus d’une nouvelle émission à

110371

L

U X E M B O U R G

laquelle il est procédé à des fins de rachat), les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront rachetées confor-
mément aux conditions et modalités suivantes:

(i) en toutes circonstances, la Société rachètera toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables alors émises

à l’expiration d’un délai de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables
ont été émises (ci-après la «Date Finale de Rachat Obligatoire»);

(ii) nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, et à tout moment avant cette date, le détenteur de Parts Privi-

légiées Obligatoirement Rachetables peut demander (à une ou plusieurs occasions) par écrit à la Société le rachat de
certaines ou de toutes ses Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables; et

(iii) le détenteur de toutes Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables rachetées recevra un paiement en numéraire

ou en nature par Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables (le «prix de rachat») égal à:

1. la valeur nominale des parts rachetées; plus
2. tout dividende cumulé mais non payé auquel le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables rache-

tées est autorisé à recevoir au moment du rachat; plus

3. un montant correspondant à une partie du Compte Prime d’Emission des Parts Privilégiées Obligatoirement Ra-

chetables égal au montant du Compte Prime d’Emission des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables divisé par le
nombre de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables émises préalablement au rachat; plus

4. un montant correspondant à une partie du Compte de Réserve Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables (tel

que  défini  à  l’article  5.10  ci-dessous)  divisé  par  le  nombre  de  Parts  Privilégiées  Obligatoirement  Rachetables  émises
préalablement au rachat.

Les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront annulées immédiatement à l’issue de leur rachat.
5.7 Toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont émises sous la forme de parts convertibles en Parts

Ordinaires. Les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront converties en Parts Ordinaires conformément aux
conditions et modalités suivantes:

(i) nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables

peut à tout moment avant cette date, demander (à une ou plusieurs occasions) par écrit la conversion de certaines ou
de toutes ses Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables en Parts Ordinaires; et

(ii) les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables pourront être converties en un nombre déterminé de Parts

Ordinaires égal à la valeur nominale des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables converties, au dividende accumulé
et non payé, au Compte Prime d’Emission des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables attaché ainsi qu’au Compte
de Réserve Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables. Aucune décimale de Parts ne sera possible. Le conseil de
gérance de la Société pourra (en cas de décimal) soit arrondir à la valeur supérieure ou inférieure au plus près du nombre
de Parts Ordinaires approprié.

Les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables seront annulées immédiatement à l’issue de leur conversion.
5.8 Le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables bénéficiera d’un dividende annuel cumulatif égal à

1% de la valeur nominale des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables et de la prime d’émission attachée le cas
échéant et d’un taux variable qui suivra le revenu d’intérêt ainsi que les revenus des autres actifs de la Société, moins le
taux fixe et la marge applicable.

5.9 Le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables aura uniquement droit à un paiement de dividendes

à condition que la Société dispose d’actifs liquides suffisants pour qu’à l’issue de chaque paiement de dividendes elle puisse
couvrir ses frais courants immédiatement après le paiement du dividende et qu’en outre un des trois événements suivants
ait eu lieu:

(i) la distribution d’un dividende est approuvée; ou
(ii) les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sont rachetées par la Société ou leur détenteur; ou
(iii) la Société est dissoute.
5.10 Les bénéfices doivent être suffisants pour distribuer un dividende, en tout ou partie, et l’associé, ou en cas de

pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés ne prend aucune décision de distribuer un tel dividende, le montant
du dividende qui aurait dû être payé au détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera automatiquement
alloué à une réserve distribuable comptabilisée dans un compte de réserve parts privilégiées obligatoirement rachetables
le «Compte de Réserve Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables»).

5.11 En cas de dissolution de la Société, le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables sera subordonné

aux dettes encourues par la Société mais sera prioritaire par rapport au détenteur de Parts Ordinaires tel que défini à
l’article 18 ci-dessous.

Art. 6. Augmentation et Réduction du capital.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision des associés prise

dans les conditions prévues pour la modification des présents statuts.

Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Les Parts sont librement cessibles entre associés.

110372

L

U X E M B O U R G

7.2 En cas d’associé unique les Parts sont librement cessibles à des non-associés. En cas de pluralité d’associés les Parts

peuvent être transférées à des non-associés, dans les limites prévues par la Loi. En effet, aucune cession de Parts entre
vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué sans l’agrément préalable donné en assemblée générale des associés
représentant au moins trois quart du capital social.

7.3 Le transfert de Parts ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à une notification à la Société ou à

l'acceptation par la Société telle que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La société pourra acquérir ses propres Parts.

Art. 8. Forme des parts sociales registre des associés.
8.1 Les Parts sont émises uniquement sous forme nominative.
8.2 Un registre d’associés sera tenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par

les associés s’ils en font la demande.

8.3 La propriété des Parts résultera de l'inscription dans le registre d’associés de la Société.

Titre III. Administration gérance représentation

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de deux (2) gérants, qui n’ont pas besoin d’être

des associés et qui seront nommés par résolution de l’assemblée générale des associés. Le conseil de gérance est composé
de deux catégories de gérants (A et B). La catégorie A devra être composée de un (1) gérant au moins. La catégorie B
devra être composée d’au moins un (1) gérant.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée générale des associés, qui déter-

mine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au
conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les
gérants sont maintenus en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance.
10.1 Tous les pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à la décision des associés,

relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et
effectuer les opérations conformément à l'objet social de la Société.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches

spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si
c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 11. Procédure.
11.1  Le  conseil  de  gérance  se  réunira  à  Luxembourg  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  Société  le  requiert  ou  sur

convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance
pourra choisir en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui
sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue du

conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires
en cause, lequel sera dans ce cas décrit dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit,
par câble, par télégramme, par téléfax ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour
les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le
conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la
réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3  Tout  gérant  pourra  assister  à  toute  réunion  du  conseil  de  gérance  en  désignant  par  écrit  ou  par  câble,  par

télégramme ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du
conseil de gérance, ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un gérant, pour l'assister
dans la tenue de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble,
télégramme, téléfax ou par e-mail.

11.4 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si au moins un gérant de la catégorie A et un

gérant de la catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants
présents ou représentés comprenant au moins le vote d’un gérant de chaque catégorie.

11.5 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées

lors d'une réunion du conseil de gérance. De telles signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs
copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des telefax.

11.6 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le président ou en son

absence par le président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, le président pro tempore, le secrétaire ou par deux gérants.

110373

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Représentation.
La Société est engagée par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B dans tous les cas et pour tout montant,

ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le
conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants.
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et Droits de votes.
14.1 Les décisions de l’assemblée générale des associés seront prises à la majorité simple des voix des associés présents

et votants.

14.2 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l’assemblée

générale des associés. L’assemblée générale des associés pourra changer la nationalité de la Société par un vote unanime.
Une assemblée générale des associés pourra se tenir sans convocation ou publication préalable s’ils déclarent qu'ils ont
été informés de l'ordre du jour de l'assemblée.

14.3 Chaque Part donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.
14.4 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par Part.
14.5 L’assemblée générale des associés exerce tous les pouvoirs dévolus par la Loi à l’assemblée générale des action-

naires.

14.6 Les décisions de l’assemblée générale des associés sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.
14.7 De plus, les contrats passés entre les associés et la Société représentée par les associés seront établis sous la

forme de minutes ou dressés par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes
prises dans des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle.
Une assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels se tiendra dans les six mois de la clôture

de l'exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de l’assemblée générale
annuelle.

Art. 16. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre, à l'exception du

premier exercice social qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente-et-un décembre deux
mille dix.

Art. 17. Comptes annuels et Allocation des bénéfices.
17.1 Les comptes annuels sont établis par le conseil de gérance de la Société à la fin de chaque exercice et seront mis

à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve légale. Cette affectation

cessera d’être requise dès que le montant de la réserve légale s’élèvera à dix pourcent (10%) du capital social de la Société.

Cette affectation devra être de nouveau requise si la réserve légale descend en deçà de dix pourcent (10%) du capital

social de la Société.

L’assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l’affectation des bénéfices

nets annuels.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance de la Société,
2. Ces comptes montrent un bénéfice incluant les bénéfices reportés suffisant pour payer le dividende intérimaire

envisagé,

3. La décision de payer un dividende intérimaire est prise par une décision du conseil de gérance, et
4. Le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de

la Société ne sont pas menacés.

Titre V. Dissolution et Liquidation

Art. 18. Dissolution et Liquidation.
18.1 Dans le cas, d’une dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront

être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des associés, décidant une telle dissolution,
et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

110374

L

U X E M B O U R G

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de

l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs du conseil de gérance de la Société cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le

paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cet effet, le montant
restant sera payé en priorité au détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables en fonction de la valeur
nominale de ces parts augmentées par les dividendes cumulés mais non payés, le Compte Prime d’Emission des Parts
Privilégiées Obligatoirement Rachetables attaché ainsi que le Compte de Réserve des Parts Privilégiées Obligatoirement
Rachetables. Le détenteur de Parts Ordinaires sera autorisé à recevoir le cas échéant le montant restant au pro rata eu
égard au nombre de parts qu’il détient dans le capital social de la Société.

Art. 19. Dispositions générales.
Tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents statuts sera régi par la Loi.

<i>Souscription et Libération

La comparante, ici représentée comme indiqué ci-dessus, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré souscrire

à vingt mille (20,000) parts sociales ordinaires et a déclaré les avoir libérées en espèces pour un montant de vingt mille
US Dollars (USD 20,000.-).

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article

183 de la Loi, ont été respectées.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l’article 183 de la Loi se trouvent ac-

complies et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR

1.500.-).

<i>Résolutions de l’ associé

Et aussitôt, l’associé représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé à L-2310 Luxembourg, 16 avenue Pasteur, Grand-Duché du Luxembourg.
2) Le nombre de gérant de catégorie A est fixé à un (1). La personne suivante est nommée gérant catégorie A:
- Monsieur Edward Alfred Mahood, né le 8 mai 1963, à ST. Catharines (Canada), domicilié à 287 Speedvale Ave.w

Guelph, Ontario Canada, N1H1C5.

Le nombre de gérants catégorie B est fixé à deux (2). Les personnes suivantes sont nommées gérant catégorie B de

la Société:

- Monsieur Emmanuel Réveillaud, né le 10 octobre 1971, à La Rochelle, demeurant au 20 avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg;

- Monsieur Tamas Horvath, né le 5 novembre 1977, à Pécs (Hongrie), domicilié à L-2310 Luxembourg, 16 avenue

Pasteur.

3) Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée et leur mandat prendra fin soit par leur démission soit par

leur révocation par l’assemblée générale des associés.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu du comparant, connu du notaire par son prénom, nom, état

civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: M. GROETZINGER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 septembre 2010. Relation: LAC/2010/40192. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010125323/602.
(100142846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

110375

L

U X E M B O U R G

Enop 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Enop 1 A.G.).

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 76.809.

In the year two thousand and ten, on the twenty-eighth day of July.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg);
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company ("société anonyme") “ENOP 1 A.G.”,

with registered office at L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall, (R.C.S. Luxembourg section B number 76.809),
incorporated by deed of the undersigned notary on July 6 

th

 , 2000, published in the Mémorial C number 853 on November

22 

nd

 ,2000,

whose articles of incorporation have been modified pursuant a deed of the undersigned notary on October 19 

th

 ,

2000, published in the Mémorial C number 302 of April 25 

th

 , 2001

The meeting is presided by Mr Joachim Albert WÖRZ, Businessman, residing at L-2311 Luxembourg, 47, avenue

Pasteur

The chairman appoints as secretary Mr Frank WALENTA, Director, residing professionally at L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank NIMAX, Tax Advisor, residing at L-9068 Ettelbruck, 21B, Cité Patton
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the legal form of the company from a stock company, ("société anonyme"), into a limited liability company,

("société à responsabilité limitée"), without changing the purpose of the company.

2.- Change the name of the company into ENOP 1 S.à r.l.
3.- Dismissal of all members of the board of directors and the statutory auditor with effect of the day of the General

Meeting.

4.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the legal form of the company from a stock company, ("société anonyme"), into a

limited liability company, ("société à responsabilité limitée"), and to convert the existing 1.500 (one thousand five hundred)
shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) into 1,500 (one thousand five hundred) sharequotas with a
par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

By this transformation of the stock company into a limited liability company, no new company is created; the limited

liability company is the continuation of the stock company such as it existed until now, with the same legal personality
and without any change intervening so much in the assets than in the liabilities of this company.

<i>Second resolution

The meeting decides to change the name of the company into “ENOP 1 S.à r.l.”.

<i>Third resolution

The meeting decides to dismiss all the directors and the statutory auditor with effect of the date hereof and to give

them full and entire discharge for the execution of their mandate.

110376

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The meeting decides to proceed to a complete restatement of the articles of association, in order to reflect such

action, and to give them the following wording:

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “ENOP 1 S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the purchase, sale and management of real estate.
3.2. The Company may also act as an intermediary of real estate entities, and carry out any transactions which lead

directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any form in any company, and manage, control and develop its
portfolio. The Company will take all measures to promote its interests and engage in any commercial, industrial or financial
transactions in relation to its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-), represented by 1,500 (one

thousand five hundred) sharequotas with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

110377

L

U X E M B O U R G

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

110378

L

U X E M B O U R G

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. External Auditors (réviseurs d’entreprises).
14.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs

d’entreprises).

14.2. The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the

term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the shareholders must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and
(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

110379

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to appoint as managers of the company, for an unlimited period,
a.- Mr Joachim Albert WÖRZ, Businessman, residing at L-2311 Luxembourg, 47, avenue Pasteur and
b.- Mr Frank NIMAX, Tax Advisor, residing at L-9068 Ettelbruck, 21B, Cité Patton
The company will be validly bound in any circumstances by the joint signature of the managers.

<i>Sixth resolution

The meeting ACKNOWLEDGES that 1,500 (one thousand five hundred) sharequotas with a par value of one thousand

Euro (EUR 1,000.-) each which are allocated as follows:

1,126 (one thousand one hundred twenty-six) sharequotas to MONTANA PROPERTIES S.A. with registered office

at L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall, (R.C.S. Luxembourg section B number 70.402) and 374 (three hundred
seventy-four) sharequotas to MARTLEY ENOP 1 S.à r.l., having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon
Thyes (RCS Luxembourg B.120.809)

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 1,500.-..

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille dix le vingt-huitième jour du mois de juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ENOP 1 A.G.”, avec siège

social à L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.809), constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 853 du 22 novembre 2000,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire instrumentant, en date 19 octobre 2000, publié au

Mémorial C numéro 302 du 25 avril 2001

110380

L

U X E M B O U R G

L'assemblée est présidée par Monsieur Joachim Albert WÖRZ, homme d’affaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

47, avenue Pasteur

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank WALENTA, Directeur, demeurant professionnellement à

L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank NIMAX, conseil fiscal demeurant à L-9068 Ettelbruck, 21B,

Cité Patton

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la Société de sa forme actuelle de société anonyme en société à responsabilité limitée, sans

changement de l’objet social.

2.- Modification de la dénomination en “ENOP 1 S.à r.l.”.
3.- Démission de tous les membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes de la société avec effet

à la date de l’assemblée générale.

4.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité

limitée et de transformer les 1.500 (mille cinq cents) actions avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR)
chacune en 1.500 (mille cinq cents) parts sociales avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Par cette transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n'est créée;

la société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la
même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en “ENOP 1 S.à r.l.”.

<i>Troisième résolution

L'assemblée révoque tous les administrateurs et le commissaire aux comptes de la société et de leur accorder décharge

pour l'exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts afin de leur

donner la teneur suivante:

STATUTS

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "ENOP 1 SARL" (la Société). La Société est une société à respon-

sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-

110381

L

U X E M B O U R G

traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet social de la Société consiste en l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers.
3.2. La Société peut également agir comme intermédiaire dans des sociétés d’immobilier, et réaliser toutes transactions

qui mènent directement ou indirectement à la prise de participations sous n’importe quelle forme dans toute société, et
gérer, contrôler, et développer son portefeuille. La Société peut prendre toutes les mesures pour promouvoir ses intérêts
et faire toutes sortes d’opérations commerciales, industrielles, financières, en relation avec son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), représenté par 1.500 (mille cinq

cents) parts sociales avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation

110382

L

U X E M B O U R G

à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés

sont  convoqués  par  lettre  recommandée  à  une  seconde  Assemblée  Générale  ou  consultés  une  seconde  fois,  et  les
décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

110383

L

U X E M B O U R G

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le associés dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,

les associés doivent reverser l’excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

110384

L

U X E M B O U R G

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer, comme gérants de la société, pour une durée indéterminée,
a.- Monsieur Joachim Albert WÖRZ, homme d’affaires, demeurant au 47, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg; et
b.- Monsieur Frank NIMAX, conseil fiscal, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 21B, Cité Patton
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des gérants.

<i>Sixième résolution

L'assemblée constate que les 1.500 (mille cinq cents) parts sociales avec une valeur nominale de mille euros (1.000,-

EUR) chacune sont toutes détenues sont toutes détenues comme suit:

- 1.126 (mille cent vingt-six) parts sociales par MONTANA PROPERTIES S.A., ayant son siège social à L-5365 Munsbach,

1, Parc d'Activité Syrdall (RCS Luxembourg B.70.402)

- 374 (trois cent soixante-quatorze) parts sociales par MARTLEY ENOP 1 S.à r.l., ayant son siège social à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes (RCS Luxembourg B.120.809)

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.500,- EUR

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Joachim Albert WÖRZ, Frank WALENTA, Frank NIMAX, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 06 août 2010. Relation GRE/2010/2737. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR COPIE CONFORME.

Junglinster, le 21 septembre 2010.

Référence de publication: 2010125937/513.
(100143061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Baptista S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 6, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 108.952.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125574/10.
(100141755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110385

L

U X E M B O U R G

Barn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 134.959.

Par le présent avis, le gérant informe les tiers que l'adresse du siège social de "Mars Properties S.à r.l." (associé unique

de La Société) est désormais domicilié au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2010.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2010125575/14.
(100141807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Belgard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 34.407.

<i>Rectificatif du bilan au 31 décembre 2009, déposé le 02 septembre 2010 sous la référence L100134950 04

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 septembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010125576/11.
(100142054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

R.G.R.B. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 17.218.

Par décision du conseil d'administration tenu le 20 septembre 2010 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter, avec effet immédiat, la démission de:
Madame Elisiana PEDONE, résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg

de sa fonction d'administrateur

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat
Monsieur Andrea CASTALDO résidant professionnellement au 19/21 Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg
son mandat ayant pour échéance l'assemblée générale le statuant sur l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010126088/19.
(100143669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Bijouterie Huberty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 28.557.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010125578/10.
(100141734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110386

L

U X E M B O U R G

Bodhi Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 26.510.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WILSON ASSOCIATES
Signature

Référence de publication: 2010125579/11.
(100141860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Bucomi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 41, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 104.702.

Les comptes annuels au 31.12.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125580/10.
(100142022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Bucomi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 41, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 104.702.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125581/10.
(100142023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Claire Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 151.898.

Il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Claire Management du 3 septembre

2010 que le siège social de la société Claire Management a changé d'adresse. L'ancienne adresse était 94, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg. La nouvelle adresse est 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010125601/13.
(100141866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Bucomi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 104.702.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125583/10.
(100142029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110387

L

U X E M B O U R G

Bucomi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 41, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 104.702.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125584/10.
(100142037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Equity Trust Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.730.450,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.519.

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la société Equity Trust Holdings S.à r.l. en date du 8 septembre

2010 que les actionnaires ont pris en autres les décisions suivantes

1. Réélection des gérants jusqu'à l'assemblée Générale qui se tiendra en 2011 et qui approuvera les états financiers

2010:

- Nicholas Hayes, né le 14 septembre 1954 à Westcliff, Grande Bretagne, résidant à 6, St Andrew Street, GB-EC4A

3AE, Londres, Grande-Bretagne

- Floris van der Rhee, né le 22 juin 1954 à Vlaardingen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle à à 3105 Strawinskylaan,

1077 ZX, Amsterdam, Pays-Bas;

- Frederik van Tuyll van Serooskerken, né le 12 mai 1967 à Eindhoven, Pays-Bas avec adresse professionnelle à 31/F,

The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong;

- John Jaakke, né le 3 juillet 1954 à Hilversum, Pays-Bas résidant à 10, A.L.G. Bosboom Toussaintlaan, NL-1401 CC

Bussum, Pays-Bas;

- Rijnhard Willem Ferdinand van Tets, né le 7 avril 1947 à 's-Gravenhage, Pays-Bas avec adresse professionnelle 528-

HS, Keizersgracht, NL-1017 EK Amsterdam, Pays-Bas;

- Charles Green, né le 31 mars 1964 à Gosport avec adresse professionnelle à 6, St Andrew Street, GB- EC4A 3AE

Londres, Royaume-Uni;

- Peter Woodthorpe, né le 9 juillet 1953 à Watford, Royaume-Uni résidant à Urbn. La Pepina Bahia De Banus 14,

Nueva Andalucia Marbella, Malaga, Espagne;

- Nils Ian Stoesser, né le 6 juillet 1974 à Stuttgart, Allemagne, avec adresse professionnelle à 20, Old Bailey Street,

EC4M 7LN, Londres, Royaume-Uni..

2. Réélection du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers S.à rl., Réviseur d'entreprises, 400 Route d'Esch,

L-1014 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée Générale qui se tiendra en 2011 et qui approuvera les états financiers 2010

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Equity Trust Holdings S.à r.l.
Nicholas Hayes
<i>Manager

Référence de publication: 2010126849/34.
(100143115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Coficom Expertise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 122.580.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125588/10.
(100142081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110388

L

U X E M B O U R G

Cabrilla S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.279.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010125592/10.
(100141801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Camosc Charter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 64.147.

Par la présente, j'ai le regret de vous présenter ma démission en ma qualité d'Administrateur au sein de la société

CAMOSC CHARTER S.A. avec immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

R. Van Herck.

Référence de publication: 2010125593/11.
(100141681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Capital Investment Management Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 36.777.

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire en date du 26 mars 2010

En date du 26 mars 2010, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 15 décembre 2009, de Madame Sandrine Leclercq, en qualité d'Administrateur
- de coopter, avec effet au 15 décembre 2009, Madame France Colas, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité

d'Administrateur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, en remplacement de Madame Sandrine Leclercq,
démissionnaire

Luxembourg, le 2 août 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010125594/17.
(100141672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Ciancone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 123.604.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 9

<i>septembre 2010

Monsieur DONATI Régis, Monsieur REGGIORI Robert et Monsieur MARIANI Daniele sont renommés administra-

teurs.

Monsieur KARA Mohammed est renommé commissaire aux comptes.
Monsieur REGGIORI Robert est nommé Président du Conseil d'administration.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme
CIANCONE S.A.
Régis DONATI
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010125600/18.
(100141626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110389

L

U X E M B O U R G

CFL-Evasion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 63.548.

Les comptes annuels au 31.12.09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125597/10.
(100141964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Chausseur Robert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 51, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 67.829.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125598/10.
(100142032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Metallum Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.635.

ERRATUM

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société à anonyme "Metallum Holding S.A.", établie et ayant son

siège social au "Le Dôme Espace Petrusse", 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, reçu par Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 30 janvier 2009, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3
février 2009, EAC/2009/1176, déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés le 12 mars 2009, référence:
L090039721.05, publié au Mémorial C numéro 676 du 27 mars 2009, que le code postal du siège sociale a été erronément
indiquée.

Il y a donc lieu de rectifier et de lire dans la version anglaise et la version française le code postal du siège social comme

suivant: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, "Le Dôme Espace Petrusse".

Enregistré à Esch/AI. A.C., le 17 SEPT. 2010. Relation: EAC/2010/11120. Reçu douze euros 12,00€.

<i>Le Receveur (signé)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 17 septembre 2010.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010126045/22.
(100143104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Chausseur Robert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 51, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 67.829.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125599/10.
(100142034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110390

L

U X E M B O U R G

Clervaux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 72.188.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 septembre 2010 que:
Les mandats des trois administrateurs:
- Roger GREDEN, né le 28.10.1953 à Arlon (Belgique), demeurant à L-2273 Luxembourg, 4a, rue de l'Ouest;
- Pierre-Paul BOEGEN, né le 20.10.1948 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Viville, 65, rue de Freylange;
- Nelly NOEL, née le 26.10.1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-2440 Luxembourg, 121, rue de Rollingergrund;
et le mandat du commissaire aux comptes FIDU-CONCEPT SARL, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36,

avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 38.136,

ont été reconduits pour une période de six ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2010125602/18.
(100141564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

CM &amp; Partners Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 85.191.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 15 juillet 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- CM &amp; PARTNERS INVESTMENTS S.A., dont le siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, a été dénoncé

en date du 5 mai 2004 (RCS B 85.191);

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010125603/17.
(100142000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Adriel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 147.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010125826/9.
(100143793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Valbonne II, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.583.

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 6 avril 2010 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats de:
Pierre-Alain Eggly, 1 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Philippe Bertherat, 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73
Claude Demole, 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73

110391

L

U X E M B O U R G

Michèle Berger, 3 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2011.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé Deloitte S.A. pour une période d’une année

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2011.

Le Conseil d’Administration du 22 avril 2010 a noté la démission de M. Claude Demole au poste d’Administrateur à

partir du 14 mai 2010.

Référence de publication: 2010126158/19.
(100143776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Coralia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 93.433.

Par la présente, nous sommes au regret de vous annoncer notre démission de notre fonction de Commissaire aux

comptes au sein de votre société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2010.

FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A.
Société Anonyme
Thierry JACOB / François WINANDY

Référence de publication: 2010125604/14.
(100141934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Cristo Rei, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 19, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 117.984.

<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 septembre 2010

Il résulte de la liste de présence que l'associé unique:
Madame JERONIMO DAS MERCES Maria De Lurdes, née le 29/04/1958 et demeurant au 36 rue de Remich L-5250

SANDWEILER

Est présente et, représente l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité des voix la décision suivante:
Madame JERONIMO DAS MERCES Maria De Lurdes est nommée gérante technique en remplacement de Madame

DA SILVA SOUSA Silvia, démissionnaire

La société est engagée en toutes circonstances par la signature unique de la gérante unique.

DA SILVA SOUSA Silvia.

Référence de publication: 2010125605/16.
(100141641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Balzak s.a., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 148.715.

<i>Extrait des délibérations portant publication de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg ville en

<i>date du 10 septembre 2010

<i>Décisions:

Il est porté à la connaissance de tous et il est décidé à l'unanimité:

<i>Première résolution

Démission de Monsieur MIGNE Steve, administrateur de société, né le 2 mai 1974 à Charleroi en Belgique et demeurant

au 55, rue de la Raguette à B-6280 Gerpinnes en temps qu'administrateur et administrateur délégué.

<i>Deuxième résolution

Nomination de Monsieur Franck Manco, consultant, née le 30 octobre 1968 à Charleroi en Belgique et demeurant 1

Haie du Moulin à B-1470 Genappe en Belgique, au poste d'administrateur à partir de ce jour et pour une durée expirant
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

110392

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Nomination de Monsieur Franck Manco, pré-qualifié, au poste d'administrateur délégué à partir de ce jour et pour

une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010126296/24.
(100143696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Delamare Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 2.829.580.600,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 119.857.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution écrite tenue en date du 8 septembre 2010 par l'associé de la Société, que M. Chris Nicholas,

né le 27 février 1977 à Hull (Royaume-Uni) avec adresse professionnelle au Tesco-Global Aruhazak Zrt Kinizsi ut 1-3
2040 Budaors, HONGRIE, a été nommé gérant de type B en remplacement du gérant démissionnaire Mme Erzsebet Antal
avec effet au 27 août 2010 pour une durée indéterminée

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 16 septembre 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2010125607/18.
(100142092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Delphirica Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 80.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010125610/10.
(100141772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Destet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 96.482.

Par la présente, nous sommes au regret de vous annoncer notre démission de notre fonction de Commissaire aux

comptes au sein de votre société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2010.

FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A.
Société Anonyme
Thierry JACOB / François WINANDY

Référence de publication: 2010125611/14.
(100141936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110393

L

U X E M B O U R G

Dharma Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 73.992.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 août 2010 que l'adresse des

Administrateurs a changé de la façon suivante:

- Monsieur François WlNANDY, est domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
- Monsieur Thierry JACOB, est domicilié professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
- Madame Mireille GEHLEN, est domiciliée professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010125612/16.
(100141943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Pamplona PE Holdco 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.106.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société tenue au siège social de

<i>la Société le 17 août 2010.

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue au siège social de la Société le 17 août 2010, il

a été décidé de:

1. réélire, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en l'année 2011 pour statuer sur l'approbation

des comptes annuels au 30 septembre 2010, les administrateurs de la Société, à savoir:

- Mr. Vincent GOY, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
- Mr. Raphaël PONCELET, résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lusembourg;
- Mr. Pavel NAZARIAN, demeurant au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. nommer KPMG Audit (anciennement "KPMG Audit S.à r.l."), société à responsabilité limitée dont le siège social est

situé au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 103.590, en tant que réviseur d'entreprises de la Société jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires
devant se tenir en l'année 2011 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 30 septembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010126426/24.
(100143161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Dialogue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 139.555.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 septembre 2010

La nouveau siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60 Grand-Rue.

Luxembourg, le 07.09.2010.

Pour extrait sincère et conforme
DIALOGUE S.A.
Alexis DE BERNARDI / Mohammed KARA
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010125613/14.
(100141670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110394

L

U X E M B O U R G

Diamco, Société Anonyme,

(anc. Diamco S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.233.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 11 août 2010.

<i>Pour la société
Anja HOLTZ
<i>Le notaire

Référence de publication: 2010125614/14.
(100141603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Eko-Park International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.791.600,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.107.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 19 avril 2010

En date du 19 avril 2010, l'associé unique a décidé de ne pas renouveler le mandat de L'Alliance Révision SARL, avec

siège social au 54 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 46 498 , en tant que réviseur d'entreprise de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010125617/16.
(100141696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Immo ABS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 167, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 102.886.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010125631/10.
(100141728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

ENRC Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 122.762.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en

date du 23 août 2010 que:

- Maître Charles DURO, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été élu aux fonctions de

gérant de catégorie B pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur David HILL démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125620/14.
(100141803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110395

L

U X E M B O U R G

Exorsa, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1710 Luxembourg, 13, rue Paul Henkes.

R.C.S. Luxembourg B 100.111.

<i>Extrait de la Résolution écrite du Gérant unique prise à Luxembourg en date du 23 août 2010

En date du 23 août 2010, le gérant unique de la société EXORSA S.à.r.l., a pris la résolution suivante:
Le siège social de la Société est transféré au 13, rue Paul Henkes, L-1710 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2010.

EXORSA S.À R.L.
Massimo Sabbatucci
<i>Le gérant

Référence de publication: 2010125623/16.
(100141743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Fortrust Global, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 152.196.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 01

juillet 2010, que

L'assemblée a décidé d'augmenter le nombre des membres du Conseil d'Administration de cinq à six et a appelé à la

fonction d'administrateur, Monsieur Philippe Dauvergne, dirigeant de sociétés, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-Roses
(France), demeurant au no. 19, rue Jean-François Gangler, L-1613 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée
générale annuelle de l'an 2015.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à la suite de l'assemblée générale extraor-

dinaire du 1 

er

 juillet 2010 que Monsieur Philippe Dauvergne, dirigeant de sociétés, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-

Roses  (France),  demeurant  au  no.  19,  rue  Jean-François  Gangler,  L-1613  Luxembourg  a  été  nommé  administrateur-
délégué. Il sera chargé de la gestion journalière de la société et il pourra engager la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juillet 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2010126858/24.
(100143662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 67.905.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg ce 30 mars 2010 que:
- Monsieur Carlo SCHLESSER, demeurant professionnellement 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
- Monsieur Serge KRANCENBLUM, demeurant professionnellement 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
- Monsieur François WlNANDY, demeurant professionnellement 412 F, route -d'Esch, L-2086 Luxembourg
- Madame Mireille GEHLEN, demeurant professionnellement 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31

décembre 2010.

110396

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010125626/18.
(100141947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Gold-Rush S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 52.687.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 20 avril 2010

<i>Sixième résolution

A l'unanimité, l'assemblée des actionnaires décide de reconduire les administrateurs dans leur fonction pour une durée

de trois ans. Le mandat des administrateurs expirera à la date de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2013.

L'assemblée  des  actionnaires  décide  à  l'unanimité  de  reconduire  Mme  Marina  Tosin,  administratrice  demeurant  à

Bassano Del Grappa (Italie), dans ses fonctions de présidente de la société pour une durée de trois ans.

Le mandat de Mme Marina Tosin en tant que présidente et en tant qu'administratrice expirera à la date de l'assemblée

générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Référence de publication: 2010125627/16.
(100142014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Providence Education S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.046.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique tenu en date du 19 Août 2010 que les démissions de M. Raymond M.

Mathieu et de M. John D. Woodworth en tant que gérants sont acceptées avec effet au 30 Août 2010.

M. George Richard Cobleigh ayant son adresse professionnelle au 50, Kennedy Plaza, Providence, 02903 Rhode Island,

et M. Michael Kidd ayant son adresse professionnelle au C/o ATEAC 46 a, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg sont
élus nouveaux gérants, avec effet au 30 Août 2010.

Par conséquent, le Conseil de Gérance de la société est composé comme suit:
- M. George Richard Cobleigh
- M. Michael Kidd
- M. Sinisa Krnic
- M. Claude Larbière

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Emilie Dougnac.

Référence de publication: 2010126240/20.
(100142463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2010.

Groengrond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 39.474.

<i>Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 14 septembre 2010

Le siège social de la société est transféré du 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,

L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

Patrick ROCHAS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010125628/12.
(100141571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110397

L

U X E M B O U R G

GSLP International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 26.363.

<i>Beschluss der Geschäftsleitung vom 26. April 2010

Zum Abschlussprüfer 2010 wird die Gesellschaft MAZARS, mit Sitz in L-2530 Luxemburg 10A, rue Henri M. Schnadt

ernannt. Das Amt endet auf der in 2011 stattfindenden Gesellschafterversammlung.

Luxemburg, den 3. September 2010.

MAZARS
Unterschrift

Référence de publication: 2010125629/13.
(100141604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Harlow Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 144.179.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Harlow Investissements S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010125630/13.
(100141870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Odyssey Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 50.331.

<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11/06/2010

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 11 juin 2010

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Gregory Conley, domicilié à 1153 Bergen Parkway M-184 - 80439

Evergreen - Colorado - USA, à la fonction d'Administrateur pour une durée de 4 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale
de 2014.

Luxembourg, le 11 Juin 2010.

Certifié conforme
Antoine Duchateau / Charlie Barrass / Sandrine Sancan
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Référence de publication: 2010125655/16.
(100141663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Immobilière Diederich S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 3, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 97.095.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/09/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010125633/10.
(100141708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110398

L

U X E M B O U R G

Oriel S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 50.771.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 13 septembre 2010

- Monsieur Alain Geurts, Administrateur, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République Démocratique du Congo),

demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Ad-
ministration, en remplacement de Monsieur Christophe Blondeau démissionnaire. Il occupera cette fonction pendant
toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.

Pour extrait conforme
<i>Pour ORIEL S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010125659/16.
(100141892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Immobilière Wolz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 99.316.

Le soussigné Monsieur Marco Lauer, médecin généraliste, né le 30.07.1945 à HOSINGEN et demeurant à L-9575

WILTZ, 1, place des Tilleuls,

agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE WOLZ S.à r.l., avec siège

social au 30, rue des Tondeurs, L-9570 Wiltz, RCS Luxembourg B numéro 99.316 (la "Société"), suite au décès de l'associé
unique et gérant unique de la Société savoir son épouse Madame Viviane Heiderscheid, décédée le 29 août 2010 avec
laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle,

décide de nommer Monsieur Jacques Lauer, Directeur (profession), né le 15 juin 1982 à Wiltz et demeurant à L-9572

Weidingen, 1, rue des Vieilles Tanneries, en qualité de nouveau gérant unique de la Société.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Fait à Wiltz, le 3 septembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010125634/17.
(100141932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Integreat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 66.821.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010125636/10.
(100141722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Jenebe International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 80.602.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125637/10.
(100141736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

110399

L

U X E M B O U R G

Newell Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 465.550,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 112.715.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 31 août 2010

Il résulte desdites résolutions que la Société a décidé:
- de révoquer Monsieur Jérôme MIARA en tant que gérant de la Société avec effet le 31 août 2010; et
- de nommer Monsieur Troy A. BRINKMEIER, demeurant à 6153 South Stone Church Road, Pearl City, IL 61062,

Etats-Unis en tant que gérant de la Société avec effet au 31 août 2010 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 31 août 2010.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010125651/17.
(100141961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Jenebe International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 80.602.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010125638/10.
(100141748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Jan Navigation A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 81.742.

Le bilan au 31 décembre 2009 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

JAN NAVIGATION A.G.
Signatures
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010125639/13.
(100141686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Inter Ikea Finance S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Inter Ikea Finance S.A. Holding).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 11.539.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PDR S.A.
FIDALUX S.A.
Signature
<i>Le domicilataire

Référence de publication: 2010125663/13.
(100141674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

110400


Document Outline

Adriel S.à r.l.

Balzak s.a.

Baptista S.à r.l.

Barn Properties S.à r.l.

Belgard S.A.

Bijouterie Huberty S.à r.l.

Bodhi Holdings S.A.

Bucomi SA

Bucomi SA

Bucomi SA

Bucomi SA

Cabrilla S.A.

Camosc Charter S.A.

Capital Investment Management Company

CFL-Evasion S.A.

Chausseur Robert S.A.

Chausseur Robert S.A.

Ciancone S.A.

Claire Management S.A.

Clervaux Participations S.A.

CM &amp; Partners Investments S.A.

Coficom Expertise S.à r.l.

Coralia S.A.

Cristo Rei

Crossways S.A.

Delamare Luxembourg S. à r.l.

Delphirica Investments S.à r.l.

Destet S.A.

Dharma Investment S.A.

Dialogue S.A.

Diamco

Diamco S.A.

Eko-Park International S.à r.l.

Enop 1 A.G.

Enop 1 S.à r.l.

ENRC Investments S.à r.l.

Equity Trust Holdings S.à r.l.

Exorsa, S.à r.l.

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A.

Fortrust Global

Geldilux-TS-2010 S.A.

Gold-Rush S.A.

Groengrond S.A.

GSLP International S.à r.l.

Harlow Investissements S.A.

Immo ABS S.à r.l.

Immobilière Diederich S.A.

Immobilière Wolz S.à r.l.

Integreat S.A.

Inter Ikea Finance S.A.

Inter Ikea Finance S.A. Holding

Jan Navigation A.G.

Jenebe International S.à r.l.

Jenebe International S.à r.l.

Linamar Financial Sàrl

Metallum Holding S.A.

Newell Luxembourg Finance S.à r.l.

Odyssey Group S.A.

Oriel S.A.

Pamplona PE Holdco 4 S.A.

Providence Education S.àr.l.

R.G.R.B. International S.A.

Valbonne II