This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2272
25 octobre 2010
SOMMAIRE
3D Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109017
A.L.D. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
109019
Alpha Personnel System S.A. . . . . . . . . . . .
109019
Am Haferstück S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109019
Apaj Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109020
Assay Finances S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109020
as you like it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109018
as you like it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109018
BCM (Luxembourg) SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
109019
Best Buy International Finance S.à r.l. . . .
109020
Boesen Ihr Gärtner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109021
B.V.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109021
Cerlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109022
CHARON HOLDING Société Anonyme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109022
Chephar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109015
Citibank International plc (Luxembourg
Branch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109021
C.M.W. Canadian Mineral Water Develop-
ment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109014
Credit Suisse - Zweigniederlassung Luxem-
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109022
Duro-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109010
Edita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109013
Enel Finance International S.A. . . . . . . . . . .
109023
Fahri-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109023
F&C Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109023
Fredcat Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109017
GSLP I Onshore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109012
"Jardinage de la Moselle S.à r.l." . . . . . . . . .
109018
Lancelot Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109018
Pelvis S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109014
Polygraphic Communication S.A. . . . . . . . .
109013
Proteus Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109021
SA Paul Zanzen (Succursale de Luxem-
bourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109016
SA Paul Zanzen (Succursale de Luxem-
bourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109015
Sinopia Multi Index Fund . . . . . . . . . . . . . . .
109016
Sunningdale Properties II S.A. . . . . . . . . . . .
109010
SunRelaX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109015
Thistle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109010
Threadneedle Asset Management Hol-
dings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109010
Tobacco World S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109011
Tradinggate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109016
Trilantic Capital Partners IV (Europe) In-
vestors S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109010
Urals Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
109011
Voltige Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109012
Wildhog Industries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
109012
Willemoes Invest Holding S.à r.l. . . . . . . . .
109016
Yago Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
109014
Ydulux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109017
Yellow Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109014
109009
L
U X E M B O U R G
Sunningdale Properties II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 79.197.
En date du 3 juin 2010, l’assemblée générale a décidé de nommer comme commissaire G.T Experts Comptables S.à
r.l avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg en remplacement de Monsieur Jean Thyssen démissionnaire
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sunningdale Properties II S.A.
Référence de publication: 2010124297/12.
(100141352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 143.975.
Maître Pierre METZLER, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a
démissionné de ses fonctions de gérant de la société THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS S.à.r.l.,
société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.975, avec effet au 14 septembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010124305/12.
(100141318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Trilantic Capital Partners IV (Europe) Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 123.633.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2010.
Référence de publication: 2010124306/10.
(100141336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Thistle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2010.
Référence de publication: 2010124311/10.
(100141489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Duro-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.
R.C.S. Luxembourg B 99.581.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 17 septembre 2010i>
Il résulte des résolutions prise lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DURO-LUX S.A. en
date du 17 septembre 2010:
- Le non renouvellement du mandat de Monsieur Gian Marco TOFFOLO demeurant 8295 KEISPELT, 80A rue de
Kehlen (Luxembourg), en tant qu'administrateur de la société étant venu à échéance lors de l'assemblée de 2009
- Le non renouvellement du mandat de Madame Anne-Marie DAXHELET demeurant 4577 MODAVE, 2 rue de Camp
Romain (Belgique), en tant qu'administrateur de la société étant venu à échéance lors de l'assemblée de 2009
109010
L
U X E M B O U R G
- Le non renouvellement du mandat de Monsieur Adriano VIDONI demeurant 4040 HERSTAL, 69 rue du Pied des
Vignes (Belgique), en tant qu'administrateur de la société étant venu à échéance lors de l'assemblée de 2009
- Le non renouvellement du mandat de Monsieur Adam OZGA demeurant 22600 TOMASZOW LUBELSKI, 7 Wojska
Polskiego (Pologne), en tant qu'administrateur de la société étant venu à échéance lors de l'assemblée de 2009
- Le non renouvellement du mandat de Madame Sonia VIDONI demeurant 4020 WANDRE, 543 rue de Visé (Belgique),
en tant qu'administrateur de la société étant venu à échéance lors de l'assemblée de 2009.
- La nomination de Monsieur Patrick Joseph DODION, ouvrier, né à Lantremange (Belgique), le 30 janvier 1964,
demeurant à 4000 LIEGE, 3 rue Matrognard (Belgique) en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2015
- La nomination de Monsieur Frédéric Alexis THOLET, ouvrier, né à Rocourt (Belgique), le 27 janvier 1970, demeurant
à 4000 LIEGE, 25 rue Dossin (Belgique) en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2015
- La nomination de Monsieur Houcine EL KAROUNI, directeur, né à Ougrée (Belgique), le 21 novembre 1965, de-
meurant à 4000 LIEGE, 35 Montagne de Bueren (Belgique) en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2015
- Le renouvellement jusqu'à l'assemblée générale de 2015 du mandat du commissaire aux comptes Fiduciaire EURO
CONSEIL ENTREPRISE S.A., rue de l'Industrie, coin des Artisans, 3895 FOETZ (Luxembourg) inscrite au RC n° B90331
qui est venu à échéance lors de l'assemblée générale de 2009
- Le non renouvellement du mandat de Monsieur Adriano VIDONI prénommé, en tant qu'administrateur-délégué de
la société étant venu à échéance lors de l'assemblée de 2009
- La nomination de Monsieur Houcine EL KAROUNI, prénommé, en tant que nouvel administrateur-délégué jusqu'à
l'assemblée générale de 2015
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2010124704/34.
(100142149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Tobacco World S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 33, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 125.892.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 septembre 2010.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2010124313/11.
(100140952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Urals Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 85.573.
EXTRAIT
En date du 19 juillet 2010, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Frank Walenta, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Ivo Hemelraad, avec adresse professionnelle au "15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg", est élu
nouveau gérant de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Le siège social de la société est transféré du "12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg" au "15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg".
Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2010124318/17.
(100141060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
109011
L
U X E M B O U R G
GSLP I Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.795.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 16 septembre 2010, a décidé d'accepter:
- la démission de Christophe Cahuzac en qualité de gérant de la Société avec effet au 2 août 2010.
- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A de la
Société de Nicole Götz, née à Brackenheim (Allemagne) le 4 Juin 1967, et ayant son adresse professionnelle au 2, rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg.
- La nomination avec effet au 2 août 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe B de la
Société, de Véronique Menard, née à Le Loroux-Bottereau (France) le 2 octobre 1973, et résidant professionnellement
au 133 Peterborough Court, Fleet Street, GB - EC4A 2BB London, Royaume-Uni.
Le Conseil de Gérance sera, à partir du 2 août 2010, composé comme suit:
- Nicole GÖTZ, gérant A
- Maxime NINO, gérant A
- Michael FURTH, gérant B
- Eric GOLDSTEIN, gérant B
- Véronique MENARD, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010124966/26.
(100141217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Voltige Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 56.599.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2000 que Monsieur Philippe MANTZ n’est plus gérant
de la Société et a été nommé gérant unique de la société VOLTIGE LUXEMBOURG, et ce, pour une durée indéterminée,
Monsieur Pierre Bouget.
Monsieur Pierre BOUGET, est dorénavant domicilié au 169, rue du Pont à Mousson F-57950 Montigny Les Metz.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010124320/12.
(100141347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Wildhog Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8267 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 126.655.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 septembre 2010.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2010124323/11.
(100141007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
109012
L
U X E M B O U R G
Polygraphic Communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 40.320.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue à L-4050 Esch-sur-AIzette 44, rue du Canal le 7 juin 2010 ài>
<i>14.30 heuresi>
<i>Résolutioni>
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
De renommer:
1) à la fonction d'administrateur pour une période de deux ans:
- Madame Danièle Fonck, née le 31 janvier 1953 à Luxembourg et domiciliée à L-2222 Luxembourg, 326, rue de
Neudorf,
- Madame Patricia Kayser, née 11 mai 1985 à Luxembourg et domiciliée à L-4602 Niederkorn, 115, avenue de la Liberté,
- Monsieur Alvin Sold, né le 26 juin 1943 à Luxembourg et domicilié à L-4350 Esch-sur-AIzette, 35, rue Würth Paquet,
- Maître Nicolas Decker, né le 22 avril 1946 à Luxembourg et domicilié à L-2013 Luxembourg, 16, avenue Marie-
Thérèse,
- et Monsieur Roland Kayser, né le 21 septembre 1956 à Luxembourg et domicilié à L-4602 Niederkorn, 115, avenue
de la Liberté.
2) à la fonction d'administrateur délégué pour une période de deux ans Monsieur Alvin Sold, né le 26 juin 1943 à
Luxembourg et domicilié à L-4350 Esch-sur-AIzette, 35, rue Würth Paquet,
3) aux fonctions de Réviseur d'entreprises, la société PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., ayant son siège social à L-1014
Luxembourg, 400, route d'Esch, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
2010.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
Résolution extraite et conforme au Procès verbal de l'Assemblée générale
Esch-sur-AIzette, le 11 août 2010.
Alvin Sold
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2010125005/31.
(100141403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Edita S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 129.294.
<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue Werdstrasse 21 à Zurich le 28 avril 2010 à 14.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
L'assemblée générale renomme aux fonctions d'administrateurs d'Edita S.A. et pour une période de deux ans:
- Madame Danièle Fonck, née le 31 janvier 1953 à Luxembourg et domiciliée à L-2222 Luxembourg, 326, rue de
Neudorf;
- Monsieur Alvin Sold, né le 26 juin 1943 à Luxembourg et domicilié à L-4350 Esch-sur-AIzette, 35, rue Würth Paquet;
- Monsieur Dr. Pietro Supino, né le 10 novembre 1965 à Milan (Italie) et domicilié à CH-8001 Zurich, Wühre 13
(Suisse);
- Monsieur Paul Hammelmann, né le 8 mars 1952 à Esch-sur-AIzette et domicilié à L-8065 Bertrange, 5, rue de la Forêt;
- Monsieur Martin Kall, né le 7 janvier 1961 à Bergisch-Gladbach (Allemagne) et domicilié CH-8702 Zollikon, Son-
nenfeldstrasse 6 (Suisse);
- Et Monsieur Marcel Kohler, né le 15 janvier 1969 à Schaffhausen (Suisse) et domicilié à CH-8248 Uhwiesen, Zöllis-
trasse 14 (Suisse).
<i>6 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L'Assemblée générale renomme aux fonctions de Réviseur d'entreprises et pour une période de un an Pricewate-
rhouseCoopers S.à.r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch et inscrite au Registre de commerce
et des sociétés sous le n° B 65 477.
109013
L
U X E M B O U R G
Cette résolution est prise à l'unanimité.
Résolution extraite et conforme au Procès verbal de l'Assemblée générale
Esch-sur-AIzette, le 11 août 2010.
Alvin Sold
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010124953/30.
(100141411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Yellow Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 108.177.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124324/10.
(100141399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Yago Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124325/10.
(100140956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Pelvis S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 89.034.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124366/10.
(100139698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2010.
C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 82.654.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2010i>
Nach eingehender Prüfung fasst die Generalversammlung folgende Beschlüsse:
1. Der Rücktritt von Frau Heike Gottschalk, geschäftsansässig L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, zum
31. März 2010 als Mitglied des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.
2. Der Rücktritt von Frau Ulrike Holbach verheiratet Alder, geschäftsansässig L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de
la Moselle zum 31. März 2010 als Mitglied des Verwaltungsrates wird einstimmig angenommen.
3. Frau Andrea Laub, geschäftsansässig in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, wird einstimmig zum Mitglied
des Verwaltungsrates ernannt bis zur Generalversammlung 2016
4. Das Mandat von Frau Edith Maerten als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung 2016
verlängert
5. Das Mandat von Herrn Edgar Reifer als Mitglied des Verwaltungsrates wird bis zur Generalversammlung 2016
verlängert
6. Das Mandat der LUX-FIDUCIAIRE Consulting S.à r.l. als Rechnungskommissar der Gesellschaft wird bis zur Gene-
ralversammlung 2016 verlängert.
109014
L
U X E M B O U R G
Wasserbillig, 21.06.2010
Für die Generalversammlung
Edith Maerten
Référence de publication: 2010124648/24.
(100141895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
SunRelaX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9391 Reisdorf, 33, rue de l'Ernz.
R.C.S. Luxembourg B 124.003.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124461/10.
(100140513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
SA Paul Zanzen (Succursale de Luxembourg), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9980 Wilwerdange, Maison 26.
R.C.S. Luxembourg B 109.787.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paul ZANZEN
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010124462/11.
(100140713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
Chephar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 47.209.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du
25 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 284 du 26 juillet 1994.
- Statuts modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L-
LUXEMBOURG, en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1681 du 9 août 2007.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société CHEPHAR S.A. tenue à
Luxembourg le 29 juin 2010, que les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué, du commissaire aux
comptes et du réviseur d'entreprises ont été renouvelés pour une période de 6 ans:
<i>Administrateursi>
- Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450
Luxembourg: administrateur.
- Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roo-
sevelt, L-2450 Luxembourg: administrateur.
- Monsieur Ernesto BENEDINI, consultant économiques, demeurant Via Mazzini n° 17, CH-6901 Lugano: administra-
teur et président.
<i>Administrateur-déléguéi>
- Monsieur Ernesto BENEDINI, consultant économique, demeurant Via Mazzini n° 17, CH-6901 Lugano: administra-
teur-délégué.
<i>Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450
Luxembourg.
<i>Réviseur d'entreprises agrééi>
- ERNST & YOUNG, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 47.771,
domicilié 7, parc d'Activité Syrdall, L-2017 Luxembourg.
109015
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 16 septembre 2010.
<i>Pour la société CHEPHAR S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2010124674/33.
(100141929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
SA Paul Zanzen (Succursale de Luxembourg), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9980 Wilwerdange, Maison 26.
R.C.S. Luxembourg B 109.787.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch.
Paul ZANZEN
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010124463/12.
(100140715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
Sinopia Multi Index Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 63.832.
EXTRAIT
En date du 1
er
mars 2010, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 11, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 9 avril 2010.
Luxembourg, le 14 septembre 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2010124466/14.
(100140463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
Tradinggate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.
R.C.S. Luxembourg B 138.132.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 13 septembre 2010.
Patrick SERRES
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010124470/12.
(100140252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
Willemoes Invest Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 74.395.
Par la présente, le soussigné Monsieur Frank WILLEMOES, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée
Willemoes Invest Holding Sàrl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B74395
et ayant son siège social 412F, route d'Esch à (L-1030) Luxembourg, déclare avoir changé d'adresse privée.
109016
L
U X E M B O U R G
L'ancienne adresse privée du soussigné ayant été 30, Mopane Lodge, (2055) Fourways Gardens à Johannesburg en
Afrique du Sud, la nouvelle adresse à laquelle le soussigné demeure actuellement est Turfpoortstraat 8 à (1411 EG)
Naarden, les Pays-Bas.
Fait à Naarden, le 07-09-2010.
Frank WILLEMOES.
Référence de publication: 2010124473/14.
(100140374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
Fredcat Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 46.120.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 avril 2010i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 30 novembre 2015:
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.
Le mandat de Monsieur John SEIL comme administrateur de la société n’est pas renouvelé.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 novembre 2015:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L - 1510 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration du 22 avril 2010i>
Est élu Président du Conseil d’administration : Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg, qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d’administrateur et tout renouvellement, démission
ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Référence de publication: 2010124736/28.
(100141599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Ydulux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.436.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124474/10.
(100140645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
3D Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 87.083.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124475/10.
(100140648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2010.
109017
L
U X E M B O U R G
"Jardinage de la Moselle S.à r.l.", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6670 Mertert, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 91.926.
Les comptes annuels au 30/06/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124476/10.
(100140830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Lancelot Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 76.092.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises en date du 8 septembre 2010i>
La société SOLLAS HOLDINGS S.A., en sa qualité d’associé unique de la Société, a pris en date du 8 septembre 2010,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique de la Société décide de transférer, avec effet au 8 septembre 2010, le siège social de la Société du
2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, au 30, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique de la Société décide de révoquer le gérant SHIFTWIND LTD. avec effet au 8 septembre 2010.
Il décide de nommer la société SOLLAS HOLDINGS S.A., société de droit panaméen, établie et ayant son siège social
à Via Espana and Elvira Mendez Street, Panama-City (République de Panama), inscrite au Registre Public de Panama au
Microjacket n° 703581, en tant que gérant avec effet à compter du 8 septembre 2010, en remplacement du gérant révoqué.
L’Associé Unique de la Société décide par ailleurs de modifier le pouvoir de signature à compter du 8 septembre 2010:
La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Luxembourg, le 8 septembre 2010.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010124785/24.
(100141791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
as you like it, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 8, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 132.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124477/10.
(100141096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
as you like it, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg, 8, rue des Gaulois.
R.C.S. Luxembourg B 132.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124478/10.
(100141098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
109018
L
U X E M B O U R G
Alpha Personnel System S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 17, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 83.681.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
Signature
Référence de publication: 2010124480/11.
(100140889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
A.L.D. Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 81.880.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 27 mai 2010:i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Com-
missaire sortants, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
Mr Rémy MENEGUZ, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg, Admi-
nistrateur et Président du Conseil d'Administration;
Mr Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg,
Administrateur;
Mr Frédéric NOEL, Avocat, avec adresse professionnelle au 1, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
Fiduciaire MEVEA s.à r.l. établie au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg.
pour une période de trois ans.
Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.L.D. PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010124610/23.
(100141819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Am Haferstück S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 49.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124481/10.
(100140885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
BCM (Luxembourg) SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 116.048.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 août 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
109019
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Marc KOEUNE
- Monsieur Michaël ZIANVENI
- Monsieur Sébastien GRAVIERE
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2010124633/18.
(100142114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Apaj Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 61.392.
Les comptes annuels au 30 novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124482/10.
(100140891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Assay Finances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 119.760.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
Signatures
Référence de publication: 2010124483/11.
(100140884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Best Buy International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 130.067.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 24 août 2010i>
L'assemblée a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur James Lloyd Muehlbauer, né le 19 octobre 1961 au Minnesota, Etats-Unis, avec
adresse professionnelle 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423, Etats-Unis, en tant que gérant de la Société avec
effet au 23 août 2010;
- d'accepter la démission de Monsieur Brian Joseph Dunn, né le 1
er
mars 1960 au New Jersey, Etats-Unis, avec adresse
professionnelle 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423, Etats-Unis, en tant que gérant de la Société avec effet au
23 août 2010;
- d'accepter la démission de Monsieur Sean Thomas Skelley, né le 31 octobre 1966 au Iowa, Etats-Unis, avec adresse
professionnelle 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423, Etats-Unis, en tant que gérant de la Société avec effet au
23 août 2010;
- de nommer Monsieur Keith John Nelsen né le 11 novembre 1963 au Wisconsin, Etats-Unis avec adresse profes-
sionnelle au 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423, Etats-Unis, en tant que gérant de la Société avec effet au 23
août 2010 pour une période illimitée.
- de nommer Madame Susan Sams Grafton, né le 28 janvier 1957 au Georgia, Etats-Unis avec adresse professionnelle
au 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423, Etats-Unis, en tant que gérant et en tant que président du conseil de
gérance de la Société avec effet au 23 août 2010 pour une période illimitée.
Le Conseil sera composé de la façon suivante:
- Monsieur Keith John Nelsen, gérant;
- Madame Susan Sams Grafton, président du conseil de gérance.
109020
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BEST BUY INTERNATIONAL FINANCE S. A R. L.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010125577/33.
(100141871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
B.V.D., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 134.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124484/10.
(100141053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Boesen Ihr Gärtner, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.143.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124485/10.
(100140836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Citibank International plc (Luxembourg Branch), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 78.602.
La liste de mandataires a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 10 septembre 2010.
<i>Pour le compte de Citibank International plc
i>Citibank International plc (Luxembourg Branch)
(Succursale de Citibank International plc)
C. BENINGER
Référence de publication: 2010124486/14.
(100140916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Proteus Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 48.602.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2010i>
<i>Conseil d'Administrationi>
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans. Le Conseil
d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2013 est composé comme suit:
- ANDRIES Rebecca, Administrateur, 16 cité Riedgen, L-8071 Bertrange,
- VAN DEN BERGHE Guido, Administrateur, 15 Ter Beke, B-2650 Edegem,
- BULTYNCK Guy, Administrateur, 6 Kemmelbergstraat, B-2600 Anvers.
<i>Commissaire aux Comptesi>
109021
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans. Le
Commissaire aux Comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2013 est Monsieur Fons MANGEN, Réviseur
d’Entreprises, demeurant à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck.
Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
Référence de publication: 2010124855/20.
(100141921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Credit Suisse - Zweigniederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 104.393.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Credit Suisse - Zweigniederlassung Luxemburg
Signature
Référence de publication: 2010124487/12.
(100140823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
CHARON HOLDING Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 51.034.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010124488/10.
(100141047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Cerlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 74.794.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 août 2010.i>
Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance à la présente, l'assemblée
décide de réduire le nombre d'administrateurs de sept à six et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale
statuant sur l'exercice 2010 comme suit:
<i>Conseil d' administrationi>
<i>- administrateurs de catégorie «A»i>
* Giancarlo Cerutti, demeurant Via Mameli n° 43, I-15133 Casale Monferrato (Italie), Président du conseil d'adminis-
tration
* Mariella Cerutti, demeurant Via P. Micca n° 21, I-10100 Turin (Italie), Administrateur
<i>- administrateurs de catégorie «B»i>
* Andrea Castaldo, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur
* Marco Gostoli, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,
Administrateur
* Manuela D'Amore, employée privée, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Lu-
xembourg, Administrateur
* Leonardo Miocchi, employé privé, demeurant professionnellement 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A. 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
109022
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010124671/32.
(100141910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Fahri-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4754 Pétange, 14, rue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 81.315.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 17 juin 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant la société commerciale, la dissolution
et la liquidation de la société suivante:
la société à responsabilité limitée FAHRI-LUX S.à r.l., dont le siège social à L-4754 Pétange, 14, rue de la Liberté, de
fait inconnue à cette adresse, inscrite au RCS sous le numéro B 81.315;
Ledit jugement a nommé juge-commissaire Madame Christiane JUNCK, vice-présidente au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg et liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 juin 2010 au greffe de la 6
ème
chambre
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010125625/20.
(100142003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
F&C Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 82.782.
Lors d'une assemblée en date du 7 juin 2010, le conseil d'administration a décidé:
- d'accepter les démissions de Cristobal Mendez de Vigo et Scott Stevens avec effet au 7 juin 2010;
- d'élire, avec effet au 7 juin 2010, Patrick Johns, ayant son adresse au Wheatacre House, Wheatacre, Nr. Beccles,
Norfolk, NR34 0AR, Royaume-Uni, comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2010;
- d'élire, avec effet au 7 juin 2010, Hugh Cameron Moir, ayant son adresse professionnelle au F&C Asset Management
plc, Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2NY, Royaume-Uni, comme administrateur de la société jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010;
Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature
Référence de publication: 2010125624/18.
(100141662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.
Enel Finance International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 60.086.
MERGER PROPOSAL
(Section 2:312 Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek),
hereinafter referred to as the "Dutch Civil Code")
at the same time
109023
L
U X E M B O U R G
COMMON MERGER PROPOSAL
(Articles 261 following of the amended Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies.
hereinafter referred to as the "Luxembourg Commercial Act")
constituting
COMMON DRAFT TERMS OF CROSS BORDER MERGER
(Article 5 of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of October 26, 2005 on cross-
border mergers of limited liability companies.
hereinafter referred to as the "Directive 2005/56/EC")
(hereinafter for ease of reference referred to as "Merger Proposal")
1. The management board of ENEL Finance International N.V. (formerly named: ENEL Trading Rus N.V.), a public
company with limited liability (naamloze vennootschap), incorporated and validly existing under the laws of the Nether-
lands, with corporate seat in Amsterdam and office address at Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, and registered
with the Trade Register under number 34313428, (hereinafter referred to as the "Acquiring Company"), and
2. The management board of ENEL Finance International S.A., a public company with limited liability (société anonyme),
incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 11, Bou-
levard de la Foire, 1528 Luxembourg-ville, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Trade and Companies'
Register of Luxembourg under number B 60.086, (hereinafter referred to as the "Disappearing Company").
HEREBY MAKE THE FOLLOWING PROPOSAL FOR A LEGAL CROSS-BORDER MERGER
WHEREAS:
A. Both the Acquiring Company and the Disappearing Company (hereinafter referred to as the "Merging Companies")
are part of the ENEL-Group.
B. The Acquiring Company has a fully paid up share capital of EUR 45.000 represented by 45.000 shares having a
nominal value of EUR 1.- each.
The Disappearing Company has a fully paid up share capital of EUR 1,478,765,370.- represented by 147,876,537 shares
having a nominal value of EUR 10.- each. The issued shares in the share capital of the Disappearing Company are fully
paid up, and no right of usufruct or right of pledge is attached to these shares. The Disappearing Company does not hold
industrial or intellectual property rights nor ownership or other rights on immovable property.
C. All shares in the capital of the Acquiring Company and all shares in the capital of the Disappearing Company are
held by the same (sole) shareholder ENEL S.p.A., a company incorporated and validly existing under the laws of Italy, with
corporate seat and office address at Viale Regina Margherita 137, Rome, Italy, and registered with the Commercial register
in Rome under number 00811720580 (hereinafter referred to as "Enel"), which therefore directly participates in the same
proportion in the Acquiring Company and the Disappearing Company.
D. Neither the Acquiring Company nor the Disappearing Company has a supervisory board.
E. Employee status of Acquiring Company and the Disappearing Company.
1. The Acquiring Company does not have any employees nor a works council.
2. The Disappearing Company has 2 (two) employees.
3. The Disappearing Company does not fulfil the conditions precedent of Chapter I of Title 1 of the Luxembourg Labor
Code (code de travail) relating to the general obligation to elect a works council nor does it fulfil the conditions set forth
in Book IV Chapter VI Title 2 of the Luxembourg Labor Code (code du travail) relating to the participation of employees
in the management of public companies with limited liability (société anonyme) and therefore has not appointed a works
council (représentant du personnel).
F. Neither the Acquiring Company nor the Disappearing Company has been dissolved or declared bankrupt or has
applied for suspension of payments.
G. Within the ENEL-Group it was decided for efficiency reasons to move the activities of the Disappearing Company
to the Netherlands, which includes the corporate restructuring of the Acquiring Company and the Disappearing Company;
it was concluded that it is desirable that the Merging Companies should enter into a cross border merger (hereinafter
referred to as the "Merger") as defined in the Directive 2005/56/EC, in the Articles 261 and following of the Luxembourg
Commercial Act and in Book 2, Title 7 of the Dutch Civil Code.
H. This Merger Proposal will (i) be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register of Luxembourg
and published in the Luxembourg legal gazette "Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" in accordance
with Articles 262 and 9 of the Luxembourg Commercial Act at least one month before the date of the general meeting
called to decide on this Merger Proposal, and (ii) be deposited with the trade register of the Chamber of Commerce in
Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel) and published in the national gazette of the Netherlands
(Staatscourant) and a national newspaper in accordance with Articles 2:314 and 2:333e of the Dutch Civil Code.
109024
L
U X E M B O U R G
I. The Merging Companies agree and undertake that the Acquiring Company will enter into a cross-border merger
with the Disappearing Company according to the Directive 2005/56/EC, the provisions of the Articles 261 and following
of the Luxembourg Commercial Act and the provisions of Title 7, Book 2 of the Dutch Civil Code as a result of which
the Acquiring Company will by operation of law through universal succession acquire all the assets and liabilities of the
Disappearing Company and the Disappearing Company will cease to exist without going into liquidation.
under the following terms and conditions:
(a) Form, corporate denomination, registered office of the Merging Companies and those proposed for the company
resulting from the Merger (Article 5 point (a) of the Directive 2005/56/EC, Articles 2:312 and 2:333d of the Dutch Civil
Code and Article 261 (2) a) of the Luxembourg Commercial Act).
The Merging Companies have the form, corporate denominations and registered offices as set out here before.
As a result of the Merger, the Disappearing Company will be absorbed by the Acquiring Company. Upon the Merger,
the Acquiring Company will maintain its form as a public company with limited liability (naamloze vennootschap), with
corporate seat in the Netherlands, Amsterdam and office address at Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, registered
with the Trade Register under number 34313428, as well as its corporate denomination.
(b) Exchange ratio and cash payment (Article 5 point (b) of the Directive 2005/56/EC, Article 2:328 of the Dutch Civil
Code and Article 261 (2) b) of the Luxembourg Commercial Act).
All issued shares in the Disappearing Company and all issued shares in the Acquiring Company are being held by the
same (sole) shareholder, being Enel, which therefore directly participates in the same proportion in the Acquiring Com-
pany and the Disappearing Company. Shares in the capital of the Acquiring Company will be granted to the shareholder
of the Disappearing Company, in conformity with the exchange ratio mentioned here below.
The exchange ratio of the shares in the Disappearing Company will be as follows: for all the issued and outstanding
shares in the capital of the Disappearing Company, with a nominal value of EUR 10.- each, which are held by Enel,
1,478,765,370 shares in the share capital of the Acquiring Company, each share with a nominal value of EUR 1.-, will be
issued to Enel as the sole shareholder of the Disappearing Company.
(c) Terms of allotment of shares (Article 5 point (c) of the Directive 2005/56/EC, Article 2:325 of the Dutch Civil
Code and Article 261 (2) c) of the Luxembourg Commercial Act).
All the new shares will be issued and allotted in favour of Enel.
The exchange will be performed by way of issue of shares pursuant to the deed of the general meetings resolving upon
the Merger, the deed of merger and registration in the shareholders' register of the Acquiring Company.
(d) Date as from which such shareholding of Enel shall carry the right to participate in the profits and any special
condition regarding that right (Article 5 point (e) of the Directive 2005/56/EC, Articles 2:326 under b of the Dutch Civil
Code and Article 261 (2) d) of the Luxembourg Commercial Act).
The shareholder of the Disappearing Company, Enel, will be entitled to participate in the profits of the Acquiring
Company as per the date the Merger becomes effective as set out below.
Although as the shares to be allotted are shares, which will rank pari passu with the existing shares, there is no fixed
right to participate in the profits of the Acquiring Company and will be subject to the articles of association of the Acquiring
Company. The articles of association state that profits are at the disposal of the general meeting of shareholders.
(e) Date from which the operations of the Disappearing Company will be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Acquiring Company (Article 5 point (f) of the Directive 2005/56/EC, Article 2:312 paragraph
2 under f of the Dutch Civil Code and Article 261 (2) e) of the Luxembourg Commercial Act).
The date of the Merger, from which the transactions of the Disappearing Company will be treated for accounting
purposes as being carried out on behalf of the Acquiring Company is agreed to be July 1, 2010.
(f) Account dates used to establish the conditions of the Merger (Article 5 point (I) of the Directive 2005/56/EC, Article
2:313 in conjunction with Article 2:333d under e of the Dutch Civil Code and Article 261 (4) e) of the Luxembourg
Commercial Act).
The account dates used to establish the conditions of the Merger are:
Acquiring Company: The accounts used for the preparation of the contents of this Merger are the interim balance
sheet as of August 31, 2010 drawn up by the Acquiring Company in accordance with the rules and principles set out by
the Dutch Civil Code which is attached hereto as Annex 1. The last regular annual financial statements were prepared
per December 31, 2009.
Disappearing Company: The closing accounts used for the preparation of the contents of this Merger are the interim
balance sheet as of August 31, 2010 drawn up by the Disappearing Company in accordance with the rules and principles
set out by Article 267 (1) c) and (2) of the Luxembourg Commercial Act which is attached hereto as Annex 2. The last
regular annual financial statements were prepared per June 30, 2010 and has been filed with the Luxembourg Trade and
Companies Register.
Since the interim balance sheet of the Merging Companies as at August 31, 2010 no significant changes have occurred
that could have a consequence on the financial situation of the Merging Companies.
109025
L
U X E M B O U R G
(g) Evaluation of assets and liabilities transferred by the Disappearing Company to the Acquiring Company upon the
Merger (Article 5 point (k) of the Directive 2005/56/EC, Article 2:333d under d. of the Dutch Civil and Article 261 (4)
d) of the Luxembourg Commercial Act).
The assets and liabilities of the Disappearing Company have been valued pursuant to their book value using general
accepted accounting principles. The Acquiring Company will continue in its accounts with the book values of the assets
and liabilities shown in the interim balance sheet of the Disappearing Company taking into account the change from
Luxembourg GAAP to general accepted accounting principle in The Netherlands. Detailed information on the valuation
of the assets and liabilities of the Disappearing Company as at August 31, 2010 is attached to this proposal as Annex 3.
The Merger will have no effect on the goodwill. The value of the assets and liabilities and the balance of the distributable
reserves of the Disappearing Company will be added to the distributable reserves of the Acquiring Company.
(h) Effective date of the Merger (Article 2:318 of the Dutch Civil Code and Articles 272 and 273 (3) of the Luxembourg
Commercial Act).
The resolution to merge will be adopted by Enel as the sole shareholder of each of the Merging Companies in general
meetings, whereas the relevant general meetings of the Merging Companies will be held before a notary public. No other
approvals by any other public authority will be required.
The Merger between the Acquiring Company and the Disappearing Company will come into effect on the day following
the day of execution of the notarial deed of merger, to be executed by a Dutch civil law notary (hereinafter referred to
as the "Effective Date"). This notwithstanding the fact that transactions of the Disappearing Company are treated for
accounting purposes as being those of the Acquiring Company as July 1, 2010.
(i) Intentions involving continuance or termination of activities.
It is the intention that after the Merger the activities of the Disappearing Company will be continued by the Acquiring
Company without any modification.
(j) Title of succession (Articles 261 and following of the Luxembourg Commercial Act and Title 7 of Book 2 of the
Dutch Civil Code).
At the Effective Date of the Merger the Acquiring Company will acquire by operation of law all assets and liabilities
(known and unknown) of the Disappearing Company as follows:
1. All of the assets of the Disappearing Company will be vested in the Acquiring Company and will thereafter be the
property of the Acquiring Company.
2. The Acquiring Company will be liable for all the obligations of the Disappearing Company.
3. The Disappearing Company will cease to exist.
4. The Disappearing Company will hand over to the Acquiring Company the originals of all its incorporating documents,
deeds, amendments, contracts/agreements and transaction documentation of any kind, as well as the bookkeeping and
related archive and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any assets,
the supporting documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other
documents relating to the assets and rights as existing as at the Effective Date.
(k) Rights conferred by the Acquiring Company to shareholders having special rights and/or to holders of securities
other than shares (Article 5 point (g) of the Directive 2005/56/EC, Article 2:320 of the Dutch Civil Code and Article 261
(2) f) of the Luxembourg Commercial Act).
As there are no persons who, in any other capacity as shareholder, have special rights against the Disappearing Com-
pany, no special rights will be given to and no compensation will be paid to anyone.
(I) Creditors' claims (Article 2:333e under c of the Dutch Civil Code and Article 268 of the Luxembourg Commercial
Act) and bondholders' claims (Article 2:333e under c of the Dutch Civil Code and Article 269 of the Luxembourg
Commercial Act).
The conditions of performing rights by the creditors and bondholders of the Merging Companies are as follows:
Creditors of the Acquiring Company may, up till one month after the publication of the notice on the Merger in the
Dutch Staatscourant and a Dutch national newspaper, by filing an application at the court in Amsterdam, the Netherlands,
stating the requested guarantee, object to the Merger.
Creditors and bondholders of the Disappearing Company, whose debts predate the date of publication of the deeds
recording the resolutions of the shareholder of the Merging Companies may, notwithstanding any agreement to the
contrary, apply within two months after the Effective Date of the Merger to the competent court to obtain adequate
safeguards of collateral for any matured or unmatured debts, where the Merger would make such protection necessary.
Detailed information on the above procedures can be found by the creditors and bondholders of the Merging Com-
panies free of charge at the following addresses:
for the Acquiring Company:
Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, the Netherlands
for the Disappearing Company:
11, Boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg-ville, Grand Duchy of Luxembourg
109026
L
U X E M B O U R G
(m) Benefits and/or special advantages granted to the independent experts, or the members of the administrative,
management, supervisory or controlling organs of the Merging Companies (Article 5 point (h) of the Directive 2005/56/
EC, Article 2:312 paragraph 2 under d of the Dutch Civil Code and Article 261 (2) g) of the Luxembourg Commercial
Act).
No benefits and special advantages will be granted to the directors of one of the Merging Companies or any other
person involved in the Merger, and in particular not to members of the administrative, management, supervisory or
controlling organs (if any) or to the independent auditors of the annual accounts or any other accountants and/or auditors
of the Merging Companies.
(n) Statement in relation to likely repercussions of the Merger on the employment (Article 5 point (d) of the Directive
2005/56/EC, Article 2:333d sub b of the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Article 261 (4) b) of the Luxembourg
Commercial Act.
At the time of the Merger, the Disappearing Company employ 2 (two) employees. The Acquiring Company shall not
have any employees.
The legal position of the employees of the Disappearing Company shall not be affected in any way as a result of the
Merger. No negative effect on the social interests or otherwise of the employees of the Merging Companies is expected
as a result of the Merger.
Upon the Merger taking legal effect, the employees' employment relationships with the Disappearing Company shall
be transferred automatically by operation of law to the Acquiring Company in accordance with Article L. 127-3 (1) of
the Luxembourg Labor Code (code du travail). Apart from this change of employer, the content of the employees'
employment relationships with the Disappearing Company will remain unchanged. The so far applicable and the conditions
provided in the individual employment contracts will remain in place in accordance with Article L. 127-3 (3) of the
Luxembourg Labor Code (code du travail).
The management boards of the Merging Companies shall as soon as possible after publication of this Merger Proposal
take the necessary steps, including providing information about the identity of the Merging Companies and the number
of its employees, as well as all information concerning the employment relationships after the Merger including a special
notification to the Acquiring Company and to the Luxembourg Labor Official entity called "Inspection du Travail et des
Mines", in accordance with Article L. 127-3 (2) of the Luxembourg Labor Code.
Similar information regarding the Effective Date of the Merger, the consequences of the Merger and the employment
treatment upon the Merger shall be provided to the employees as soon as possible after publication of this Merger
Proposal.
Upon completion of the Merger, the Acquiring Company as well as the Disappearing Company will be jointly and
severally liable for the settlement of any obligations resulting from an employment agreement or a relation of employment,
existing at the date of the Merger and becoming due prior to the completion of the Merger, in accordance with Article
L. 127-3 (1) of the Luxembourg Labor Law Code (code du travail).
(o) Statement on the involvement of the employees in the definition to their participation (Article 5 point (j) of the
Directive 2005/56/EC, Article 333d in conjunction with Article 2:333k of the Dutch Civil Code and Article 261 (4) c) of
the Luxembourg Commercial Act.
Pursuant to Article L. 426-14 of the Luxembourg Labor Code (code du travail) in case the activity range as prescribed
by Article L. 426-1 (i) of the Luxembourg Labor Code (code du travail) (i.e. employment of at least 1,000 employees
during the last three business years) is not fulfilled, the principles and modalities foreseen in the Articles 12 §§ 2, 3 and 4
of the European Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE)
shall apply as well as the provisions relating to the involvement of employees as prescribed by Title IV of Book IV of the
Luxembourg Labor Code (code du travail).
Pursuant to Article 12 § 2 of the European Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute
for a European company (SE), applicable by analogy to the involvement of employees in case of a cross-border merger,
(a) an agreement on arrangements for employee involvement pursuant to Article 4 of Directive 2001/86/EC has been
concluded, (b) or a decision pursuant to Article 3(6) of the Directive has been taken, (c) or the period for negotiations
pursuant to Article 5 of the Directive has expired without an agreement having been concluded.
For the purpose of the envisaged Merger and according to the provisions set out in Article 3 of the Council Directive
2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of
employees, the management boards of the Merging Companies shall as soon as possible after publication of this Merger
Proposal take the necessary steps, including providing information about the identity of the Merging Companies and the
number of its employees, to start negotiations with the Merging Companies' employees on arrangements for the invol-
vement of employees in the Acquiring Company.
For this purpose, a special negotiating body representative of the employees of the Disappearing Company shall be
created in accordance with the following provisions:
In electing or appointing members of the special negotiating body, it must be ensured:
109027
L
U X E M B O U R G
(i) that these members are elected or appointed in proportion to the number of employees employed in Luxembourg
by allocating one seat per portion of employees employed in Luxembourg which equals 10 %, or a fraction thereof, of
the number of employees employed by the Disappearing Company;
(ii) that in the case of a cross-border merger, there are such further additional members as may be necessary in order
to ensure that the special negotiating body includes at least one member representing each Merging Company which is
registered and has employees in that Member State and which it is proposed will cease to exist as a separate legal entity
following the merger, in so far as:
- the number of such additional members does not exceed 20 % of the number of members designated by virtue of
point (i), and
- the composition of the special negotiating body does not entail a double representation of the employees concerned.
If the number of such employees is higher than the number of additional seats available pursuant to the first subpara-
graph, these additional seats shall be allocated to companies in different Member States by decreasing order of the number
of employees they employ.
At least one member representing each participating company which has employees in the Member State concerned
has to be elected, ie. the Disappearing Company. Such measures must not increase the overall number of members. In
case there are no employees' representatives elected in the Disappearing Company, through no fault of their own, the
employees have the right to elect or appoint members of the special negotiating body.
In the present case only the Disappearing Company has employees which do not have appointed employees' repre-
sentatives.
With regards to the majority and quorum, the special negotiation body will be elected among the employees of the
Disappearing Company further to the rules set out for the election of employees' representatives provided for by Articles
L.413-1 and following of the Luxembourg Labor Code (code du travail).
The special negotiating body shall take decisions by an absolute majority of its members, provided that such a majority
also represents an absolute majority of the employees. Each member shall have one vote. However, should the result of
the negotiations lead to a reduction of participation rights, the majority required for a decision to approve such an
agreement shall be the votes of two thirds of the members of the special negotiating body representing at least two thirds
of the employees.
The special negotiating body and the competent organs of the Merging Companies shall determine, by written agree-
ment, arrangements for the involvement of employees within the Acquiring Company, if any. To this end, the competent
organs of the Merging Companies shall inform the special negotiating body of the plan and the actual process of the
Merger, up to its approval.
Pursuant to Article 3 (6) of the Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a
European company with regard to the involvement of employees and Article L. 426-15 (2) of the Luxembourg labor Code
(code du travail), the special negotiating body may decide by the majority of two third of its members representing at
least two third of the employees not to open negotiations or to terminate negotiations already opened, and to rely on
the rules on information and consultation of employees in force in Luxembourg where the Disappearing Company has
employees (i.e. Section 1 and 2 of Title 2 of Book IV of the Luxembourg Labor Code (code du travail)). Such a decision
shall terminate the procedure to conclude an agreement on the implication of the employees in the Acquiring Company.
In reference to the above provisions, the two employees actually employed by the Disappearing Company are invited
to consider them and to proceed accordingly.
(p) Articles of Association of the Acquiring Company (Article 5 point (i) of the Directive 2005/56/EC, Article 2:312
paragraph 2 under b of the Dutch Civil Code and Article 261 (4) a) of the Commercial Act).
This Merger is a merger by absorption upon which no new company is established. The current articles of association
of the Acquiring Company are attached hereto as Annex 4. These articles of association shall be changed at the time of
the Merger and are attached hereto as Annex 5.
(q) Intentions with regard to the composition of the management board of the Acquiring Company after the Merger
(Article 2:312 paragraph 2 under e of the Dutch Civil Code).
It is the intention not to change the composition of the management board of the Acquiring Company after the Merger.
(r) Withdrawal of shares in the capital of the Acquiring Company (Article 2:325 paragraph 3 of the Dutch Civil Code).
At the time of Merger no shares in the capital of the Acquiring Company shall be withdrawn.
(s) Provisions regarding compensation (Article 2:333d under f of the Dutch Civil Code).
As the Disappearing Company has only one shareholder, the situation as referred to in Article 2:333h of the Dutch
Civil Code cannot materialise. Determining a proposed amount of compensation for a share would therefore serve no
purpose.
(t) Audit (Article 2:328 of the Dutch Civil Code and Article 266 of the Luxembourg Commercial Act).
The management board of the Acquiring Company has requested KPMG Netherlands to examine the present Merger
Proposal and to issue the audit opinion and the report.
109028
L
U X E M B O U R G
The management board of the Disappearing Company has requested G.S.L. FIDUCIAIRE S.à r.l. to examine the present
Merger Proposal and to issue the audit opinion and the report.
(u) Availability of the Merger documentation at the registered offices of the Merging Companies (Article 267 (1) and
(3) of the Luxembourg Commercial Act and Article 2:314 of the Dutch Civil Code).
The following documents will be made available for inspection at the registered office of each of the Merging Companies
at least one month before the date of the general meeting called to decide on this Merger Proposal:
1. this draft Merger Proposal;
2. the adopted annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years (being for the Acquiring
Company 2008 and 2009 and for the Disappearing Company 2008, 2009 and June 2010) as well as the thereto relating
director's reports;
3. the interim accounts of the Merging Companies on the basis of which this Merger Proposal was drafted as of August
31, 2010;
4. the explanatory reports of the management boards of the Merging Companies,
5. the auditors' reports for both Merging Companies issued in relation to the Merger.
Full or partial copies of the documents above referred may be obtained by the shareholder, Enel, upon request and
free of charge.
(v) Costs and fees.
Any costs and fees connected to this Merger and the setting-up and implementation of this Merger Proposal as well
as accruing transaction tax and any other duties (if any) shall be borne by the Acquiring Company.
(w) Invalidity.
Should any provision of this Merger Proposal be legally ineffective or become invalid as a result of any statutory
provisions, this shall not affect the validity of the remaining provisions of this Merger Proposal. The Merging Companies
undertake to replace the ineffective or invalid provisions that comes as close as possible to the economic purposes of
the ineffective or invalid provision. The same shall apply to any omissions discovered in the course of performing the
Merger Proposal.
This text is established on 18 October 2010, in original, in order to be (i) registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register of Luxembourg and published in the Luxembourg legal gazette "Memorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations" in accordance with Articles 262 and 9 of the Luxembourg Commercial Act at least one month
before the date of the general meeting called to decide on this Merger Proposal, and (ii) be deposited with the trade
register of the Chamber of Commerce in Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel) and published in
the national gazette of the Netherlands (Staatscourant) and a national newspaper in accordance with Articles 2:314 and
2:333e of the Dutch Civil Code.
The present Merger Proposal is worded in English followed by a French version. In case of discrepancies between the
English and the French text, the English version will be prevailing.
Signed by:
On 18/10/2010.
The Acquiring Company ENEL Finance International N.V.
M. Vincenzo Accurso
<i>Directori>
On 18/10/2010.
La Société Absorbée ENEL Finance International S.A.
M. Alessandro Canta / M. Francisco Javier Galan Allue / M. Francesco Moglia / M. Armand De Biase
<i>Director / Director / Director / Directori>
On 18/10/2010.
The Acquiring Company ENEL Finance International N.V.
M. Vincenzo Accurso
<i>Directori>
Suit la version française du texte qui précède:
PROJET DE FUSION
(Section 2:312 Code Civil Néerlandais (Burgerlijk Wetboek),
ci-après le "Code Civil Néerlandais"
étant par ailleurs
PROJET COMMUN DE FUSION
(Articles 261 et suivant de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
109029
L
U X E M B O U R G
ci-après la "Loi sur les Sociétés Commerciales"
constituent le
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIERE
(Article 5 de la Directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions
transfrontalières de sociétés de capitaux
ci-après la "Directive 2005/56/CE")
(ci-après référencée par soucis de facilité en tant que "Projet de Fusion")
1. Le conseil d'administration d'ENEL Finance International N.V. (anciennement ENEL Trading Rus N.V.), une société
anonyme (naamloze vennootschap), constituée et existant valablement conformément au droit des Pays-Bas, ayant son
siège social à Amsterdam et adresse à Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce sous le numéro 34313428, (ci-après la "Société Absorbante"), et
2. Le conseil d'administration d'ENEL Finance International S.A., une société anonyme, constituée et existant valable-
ment conformément au droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, Boulevard de la Foire, 1528
Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg, et immatricule auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 60.086, (ci-après la "Société Absorbée").
ETABLISSENT PAR LA PRESENTE LE PROJET SUIVANT AUX FINS D'UNE FUSION TRANSFRONTALIERE
CONSIDERANT QUE:
A. La Société Absorbante et la Société Absorbée (ci-après ensemble les "Parties à la Fusion") font toutes les deux
partie du groupe ENEL.
B. La Société Absorbante dispose d'un capital social entièrement libéré d'un montant de EUR 45.000 représenté par
45.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1.- chacune.
La Société Absorbée dispose d'un capital social entièrement libéré d'un montant de EUR 1.478.765.370,- représenté
par 147.876.537 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune. Les actions émises dans le capital social de la Société
Absorbée ont été entièrement libérées, aucun droit d'usufruit ou de gage n'est attaché à ces actions. La Société Absor-
bante ne détient ni des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ni des droits de propriété et autres droits réels
sur des biens immatériels.
C. Toutes les actions dans le capital social de la Société Absorbante et toutes les actions dans le capital de la Société
Absorbée sont détenues par le même actionnaire (unique), ENEL S.p.A., une société constituée et existant valablement
conformément au droit italien, ayant son siège social et son adresse à Viale Regina Margherita 137, Rome, Italie, et
immatriculée au registre commercial de Rome sous le numéro 00811720580 (ci-après "Enel"), qui de ce fait participe
directement à la même proportion dans la Société Absorbante et le Société Absorbée.
D. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée ne dispose d'un conseil de surveillance.
E. Statuts des employés dans le cadre de la Société Absorbante et dans la Société Absorbée.
1. La Société Absorbante ne dispose ni de salariés ni d'une délégation du personnel.
2. La Société Absorbée emploie deux (2) salariés.
3. La Société Absorbée ne remplit ni les conditions prescrites par le Chapitre I du Titre 1 du Code du Travail Luxem-
bourgeois prévoyant l'obligation générale d'élire une délégation du personnel ni les conditions prescrites par le Livre IV
Chapitre VI Titre 2 du Code du Travail Luxembourgeois relatif à la participation des salariés dans la gestion de sociétés
anonymes et de ce fait n'a pas élu de représentant du personnel.
F. Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont fait l'objet de dissolution, de déclaration en faillite ni ont
demandées le bénéfice de la suspension des paiements.
G. Dans le cadre du groupe ENEL, il a été décidé de transférer pour des raisons d'efficacité l'activité de la Société
Absorbante aux Pays-Bas, y inclut la restructuration juridique de la Société Absorbée et de la Société Absorbante: il a
été décidé qu'il serait souhaitable que les Parties à la Fusion procèdent à une fusion transfrontalière (ci-après la "Fusion")
telle que définie par la Directive 2005/56/CE, dans les articles 261 et suivants de la Loi et du Livre 2, Titre 7 du Code
Civil Néerlandais.
H. Ce Projet de Fusion sera (i) enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations conformément aux dispositions des articles 262 et 9 de la Loi
sur les Sociétés Commerciales au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le
présent Projet de Fusion et (ii) déposée au registre de commerce de la Chambre de Commerce à Amsterdam (Handels-
register van de Kamer van Koophandel) et publié dans la gazette nationale des Pays-Bas (Staatscourant) et un journal
national conformément aux articles 2:314 et 2:333e du Code Civil Néerlandais.
I. Les Parties à la Fusion s'accordent et s'engagent à ce que la Société Absorbante procédera à une fusion transfron-
talière avec la Société Absorbée conformément aux dispositions de la Directive 2005/56/CE, aux dispositions des articles
109030
L
U X E M B O U R G
261 et suivants de la Loi sur les Sociétés Commerciales et au Titre 7, Livre 2 du Code Civil Néerlandais, en vertu de
laquelle la Société Absorbante acquerra de plein droit par voie de transmission universelle tous les actifs et passifs de la
Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation préalable.
Conformément aux conditions et dispositions suivantes:
(a) Forme, dénomination sociale, siège social des Parties à la Fusion et ceux proposés pour la société résultant de la
Fusion (Article 5 point (a) de la Directive 2005/56/CE, Articles 2:312 et 2:333d du Code Civil Néerlandais et Article 261
(2) a) de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
Les Parties à la Fusion ont la forme, la dénomination sociale et le siège social tels qu'indiqués ci-avant.
En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante. Suite à la Fusion, la Société
Absorbante maintiendra sa forme légale de société anonyme (naamloze vennootschap), ayant son siège social aux Pays-
Bas, Amsterdam et adresse à Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, immatriculée au Registre de Commerce sous le
numéro 34313428, tout comme sa dénomination sociale.
(b) Ratio d'échange et soulte (Article 5 point (b) de la Directive 2005/56/CE, Article 2:328 du Code Civil Néerlandais
et Article 261 (2) b) de la Loi).
Toutes les actions émises par la Société Absorbée et toutes les actions émises par la Société Absorbante sont détenues
par le même actionnaire (unique), Enel, lequel de ce fait participe à la même proportion dans la Société Absorbante et
dans la Société Absorbée. La Société Absorbante émettra des actions au profit de l'actionnaire de la Société Absorbée
conformément au ratio d'échange définit ci-dessous:
Le ratio d'échange d'actions de la Société Absorbée sera comme suit: pour toutes les actions émises et existantes dans
le capital social de la Société Absorbée, d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, lesquelles sont détenues par Enel,
1.478.765.370 actions dans le capital social de la Société Absorbante, d'une valeur nominale de EUR 1,- seront émises au
profit d'Enel en sa qualité d'actionnaire unique de la Société Absorbée.
(c) Conditions d'attribution des actions (Article 5 point (c) de la Directive 2005/56/CE, Article 2:325 du Code Civil
Néerlandais et Article 261 (2) c) de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
Toutes les actions nouvelles seront émises et attribuées au profit d'Enel.
L'échange sera effectué par voie d'émission d'actions suite aux assemblées générales se prononçant sur la Fusion et
enregistrement dans le registre d'actionnaires de la Société Absorbante.
(d) Date à partir de laquelle fa détention des actions donnera droit à la participation aux profits et toute condition
spéciale attachée à ce droit (Article 5 point (e) de la Directive 2005/56/CE, Articles 2:326 sous b du Code Civil Néerlandais
et Article 261 (2) d) de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
L'actionnaire de la Société Absorbée, Enel, aura le droit de participer aux profits de la Société Absorbante à compter
de la date à laquelle la Fusion deviendra effective conformément aux stipulations ci-après.
Bien que les actions attribuées soient des actions, lesquelles auront le même rang que les actions existantes, il n'y a
aucun droit de participation fixe aux profits de la Société Absorbante lequel sera déterminé en fonction des statuts de la
Société Absorbante. Les statuts stipulent que les profits sont à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires.
(e) Date à partir de laquelle les opérations effectuées par la Société Absorbée seront considérées, d'un point de vu
comptable, comme étant réalisées pour le compte de la Société Absorbante (Article 5 point (f) de la Directive 2005/56/
CE, Article 2:312 paragraphe 2 sous f du Code Civil Néerlandais et Article 261 (2) e) de la Loi sur les Sociétés Com-
merciales).
La date de la Fusion, à partir de laquelle les transactions effectuées par la Société Absorbante seront considérées, d'un
point de vu comptable, comme réalisées pour le compte de la Société Absorbante, est fixée au 1
er
juillet 2010.
(f) Dates des comptes utilisés pour établir les conditions de la Fusion (Article 5 point (I) de la Directive 2005/56/CE,
Article 2:313 en conjonction avec l'Article 2:333d sous e du Code Civil Néerlandais et Article 261 (4) e) de la Loi sur les
Sociétés Commerciales).
Les dates des comptes utilisés pour établir les conditions de la Fusion sont pour:
La Société Absorbante: Les comptes utilisés pour la préparation de la présente Fusion sont les comptes intérimaires
au 31 août 2010 établis par la Société Absorbante conformément aux règles et principes déterminés par le Code Civil
Néerlandais, tel qu'annexé au présent à l'Annexe 1. Les derniers comptes annuels datent du 31 décembre 2009.
La Société Absorbée: les comptes clôturés utilisés pour la préparation de la présente Fusion sont les comptes intér-
imaires au 31 août 2010 établis par la Société Absorbante conformément aux règles et principes déterminés par l'Article
267 (1) c) et (2) de la Loi sur les Sociétés Commerciales, tel qu'annexé au présent à l'Annexe 2. Les derniers comptes
annuels datent du 30 juin 2010.
Depuis les comptes intérimaires des Parties à la Fusion au 31 août 2010 aucun changement significatif n'est intervenu
qui pourrait avoir une conséquence quelconque sur la situation financière des Parties à la Fusion.
(g) Evaluation des actifs et passifs transférés par la Société Absorbée à la Société Absorbée suite à la Fusion (Article 5
point (k) de la Directive 2005/56/CE, Article 2:333d sous d. du Code Civil Néerlandais et Article 261 (4) d) de la Loi sur
les Sociétés Commerciales).
109031
L
U X E M B O U R G
Les actifs et passifs de la Société Absorbée ont été évalués en fonction de leur valeur comptable au regard des principes
comptables généralement acceptés. La Société Absorbante reprendra dans ses comptes les actifs et passifs à leur valeur
comptable tels que figurant dans les comptes intérimaires de la Société Absorbée, prenant en compte la conversion de
Luxembourg GAAP en principes comptables généralement admis aux Pays-Bas. Les informations détaillées sur l'évaluation
des actifs et passifs de la Société Absorbante au 31 août 2010 sont annexés au présent Projet de Fusion en tant qu'Annexe
3.
La Fusion n'aura aucun effet sur le goodwill. La valeur des actifs et passifs et du compte de réserve distribuables de la
Société Absorbée sera additionnée aux réserves distribuables de la Société Absorbante.
(h) Date effective de Fusion (Article 2:318 du Code Civil Néerlandais et Articles 272 et 273 (3) de la Loi sur les Sociétés
Commerciales).
La résolution de fusionner sera adoptée par Enel en sa qualité d'actionnaire unique des Société Fusionnantes dans le
cadre d'assemblées générales, étant entendu que chaque assemblée générale sera tenue devant notaire. Aucune autre
approbation d'une autre autorité publique n'est requise.
La Fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée prendra effet le jour suivant la date d'exécution de l'acte
notarié de fusion, exécuté par le notaire néerlandais (ci-après la "Date Effective"). Ceci sans préjudice du fait que les
transactions de la Société Absorbante seront considérées d'un point de vue comptable comme effectuées pour le compte
de la Société Absorbante à compter du 1
er
juillet 2010.
(i) Intentions impliquant la continuation ou la cessation d'activité.
La Société Absorbante entend, après la fusion, continuer les activités de la Société Absorbée et ce sans que ces activités
soient modifiées.
(j) Succession universelle (Articles 261 et suivants de la Loi sur les Sociétés Commerciales et Titre 7 du Livre 2 du
Code Civil Néerlandais).
A compter de la Date Effective de la Fusion, la Société Absorbante acquerra de plein droit tous les actifs et passifs
(connus et inconnus) de la Société Absorbée comme suit:
1. Tous les actifs de la Société Absorbée seront transmis à la Société Absorbante et deviendront propriété de la Société
Absorbante.
2. La Société Absorbante sera tenue de toutes les obligations de la Société Absorbée.
3. La Société Absorbée cessera d'exister.
4. La Société Absorbée délivrera à la Société Absorbante les originaux de tous les documents de constitution, actes,
avenants, contrats/conventions et documentation transactionnelle de toute sorte, de même que la documentation relative
à la comptabilité et les archives y afférant et tout autre documentation comptable, titres de propriété, et documentation
relatifs au titre de propriété des actifs, les documents de support d'opérations effectuées, sûretés et contrats, archives,
bons et tout autre document relatif aux actifs et droits existants à la Date Effective de la Fusion.
(k) Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires détenant des droits spéciaux et/ou les détenteurs de
titres autres que les actions (Article 5 point (g) de la Directive 2005/56/CE, Article 2:320 du Code Civil Néerlandais et
Article 261 (2) f) de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
Dans la mesure où la Société Absorbée ne dispose que d'actionnaire et non de titulaire détenant d'autres titres que
les actions, aucun droit spécial ne sera accordé et aucune compensation ne sera payée à qui que ce soit.
(I) Droits des créanciers (Article 2:333e sous c du Code Civil Néerlandais et Article 268 de la Loi sur les Sociétés
Commerciales) et droits des obligataires (Article 2:333e sous c du Code Civil Néerlandais et Article 269 de la Loi sur
les Sociétés Commerciales).
L'exercice des droits attribués aux créanciers et obligataires des Parties à la Fusion se fera comme suit:
Les créanciers de la Société Absorbante pourront, dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de
Fusion dans le Staatscourant néerlandais et un journal national néerlandais, s'opposer à la Fusion par voie de requête
déposée auprès du Tribunal d'Amsterdam, Pays-Bas contenant la sûreté demandée.
Les créanciers et obligataires de la Société Absorbée, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes
constatant les résolutions des actionnaires des Sociétés Fusionnantes pourront, nonobstant toute convention contraire,
dans les deux mois de la Date Effective de la Fusion, demander au tribunal compétent la constitution de sûretés pour des
créances échus et non échus, au cas où l'opération de Fusion réduirait le gage de ces créances.
Les créanciers et obligataires des Parties à la Fusion pourront obtenir sans frais l'information détaillée sur les procé-
dures ci-dessus indiquées aux adresses suivantes:
Pour la Société Absorbante:
Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Pays-Bas
Pour la Société Absorbée:
11, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg
(m) Droits et avantages spéciaux octroyés aux experts indépendants, ou aux membres des organes administratif, de
direction, de supervision ou de contrôle des Parties à la Fusion (Article 5 point (h) de la Directive 2005/56/CE, Article
2:312 paragraphe 2 sous d du Code Civil Néerlandais et Article 261 (2) g) de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
109032
L
U X E M B O U R G
Aucun droit ou avantage spécial ne sera octroyé aux administrateurs des Parties à la Fusion ou à toute autre personne
impliquée dans la Fusion, ni aux membres des organes administratif, de direction, de supervision ou de contrôle ou encore
aux experts indépendants se prononçant sur les comptes annuels ou à tout autre comptable et/ou auditeur des Parties
à la Fusion.
(n) Description des effets probables de la Fusion sur l'emploi (Article 5 point (d) de la Directive 2005/56/EC, Article
2:333d sub b du Code Civil Néerlandais (Burgerlijk Wetboek) et Article 261 (4) b) de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Au moment de la Fusion, la Société Absorbée emploie 2 (deux) salariés. La Société Absorbante n'emploie pas de
salariés.
Le statut des salariés de la Société Absorbée ne sera pas affecté par l'effet de la Fusion. Aucun effet négatif sur les
avantages sociaux ou tout autre avantage acquis des salariés des Parties à la Fusion n'est attendue par l'effet de la Fusion.
Lors de la prise d'effet de la Fusion, les relations de travail existant avec la Société Absorbée seront transférées de
plein droit à la Société Absorbante conformément à l'Article L.127-3 (3) de Code du Travail Luxembourgeois. Mis à part
ce changement d'employeur, le contenu des contrats de travail conclus avec la Société Absorbée ne seront pas modifiés.
Les contrats de travail individuels actuellement en vigueur ainsi que les conditions y comprises resteront en vigueur
conformément à l'Article L.127-3 (3) du Code du Travail Luxembourgeois.
Les conseils d'administration des Parties à la Fusion devront, dès que possible, après la publication du Projet de Fusion
prendre les mesures nécessaires, y compris la notification de l'identité des Parties à la Fusion et le nombre de salariés,
ainsi que les informations concernant les relations de travail après la Fusion comprenant une notification spécifique à la
Société Absorbante et à l'Inspection Luxembourgeoise du Travail et des Mines, conformément à l'Article L.127-3 (2) du
Code du Travail Luxembourgeois.
Les informations concernant la Date d'Effet de la Fusion, les conséquences de la Fusion et les mesures envisagées
concernant l'emploi après la Fusion seront communiquées aux salariés dès que possible après la publication du Projet de
Fusion.
Jusqu'à la prise d'effet de la Fusion, la Société Absorbée et la Société Absorbante seront responsables solidairement
et indéfiniment des obligations résultant d'un contrat ou d'une relation de travail, existant à la date de la Fusion et venues
à échéance avant la date d'Effet de la Fusion, conformément à l'Article L.127-3 (1) du Code du Travail Luxembourgeois.
(o) Modalités relatives à l'implication des salariés dans la définition de leur participation (Article 5 point (j) de la
Directive 2005/56/CE, Article 333d combiné avec l'article 2:333k du Code Civil Néerlandais et de l'Article 261 (4) c) de
la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Conformément à l'article L.426-14 du Code du Travail Luxembourgeois et dans le cas ou le seuil d'occupation prévu
par l'Article L.426-1 (1) du Code du Travail Luxembourgeois (occupation de 1.000 salariés au moins au cours des trois
dernières années) n'est pas atteint, les principes et modalités prévues aux Articles 12 §§ 2, 3 et 4 du Règlement du Conseil
de l'Union Européenne (CE) No 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ainsi que
les dispositions relatives à l'implication des salariés tels que prévus par le Titre IV du Livre IV du Code du Travail Lu-
xembourgeois s'appliquent.
Conformément à l'Article 12 § 2 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne (CE) No 2157/2001 du 8 octobre
2001 relatif au statut de la société européenne (SE), applicable par analogie à l'implication des salariés au sein d'une fusion
transfrontalière, (a) un accord sur les modalités relatives à l'implication des salariés prévue par l'Article 4 de la Directive
2001/86/CE doit être conclue, (b) ou une décision doit être prise conformément à l'article 3 (6) de la Directive, (c) ou
une période de négociation telle que prévue par l'Article 5 de la Directive doit avoir expirée sans aboutir à la conclusion
d'un accord.
En vue de la Fusion et conformément aux dispositions de l'Article 3 de la Directive 2001/86/CE du Conseil complétant
le statut de la Société Européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, les conseils d'administration des
Parties à la Fusion devront dans dès que possible après la publication du présent Projet de Fusion prendre les mesures
nécessaires, y compris la communication d'informations concernant l'identité des Parties à la Fusion ainsi que le nombre
de leurs salariés, pour engager des négociations avec les salariés des Parties à la Fusion sur les modalités relatives à
l'implication des salariés au sein de la Société Absorbée.
A cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les salariés de la Société Absorbante sera créé conformément
aux dispositions ci-après:
Lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller à ce que:
(i) ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés à Luxembourg en allouant un
siège par tranche de salariés employés à Luxembourg qui représente 10%, ou une fraction de ladite tranche, du nombre
de salariés employés par la Société Absorbée;
(ii) dans le cas d'une fusion transfrontalière, d'autres membres supplémentaires soient présents dans la mesure né-
cessaire pour garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant chaque Partie
à la Fusion qui est immatriculée et emploie des salariés dans cet Etat Membre et qui, tel que proposé, cessera d'avoir une
existence juridique propre après la fusion, pour autant que:
- le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20% du nombre de membres désignés conformément au
point (i), et
109033
L
U X E M B O U R G
- la composition du groupe spécial de négociation n'implique pas une double représentation des salariés concernés.
Si le nombre de ces salariés est plus élevé que le nombre des sièges supplémentaires disponibles conformément au
premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des sociétés d'Etats Membres différents selon l'ordre dé-
croissant du nombre de salariés qu'ils emploient.
Au moins un membre représentant chaque société participant qui emploie des salariés dans l'Etat Membre concerné
doit être élu, c'est-à-dire au sein de la Société Absorbée, Cette mesure ne doit pas excéder le nombre maximum de
membres. Dans le cas où un délégué du personnel n'a pas été élu au sein de la Société Absorbée, les salariés ont le droit
d'élire ou de nommer les membres du groupe spécial de négociation.
Dans le cas présent, seule la Société Absorbée emploie des salariés, ces derniers n'ayant pas élus un délégué du
personnel.
Concernant la majorité et le quorum, le groupe spécial de négociation sera élu parmi les salariés de la Société Absorbée
conformément aux règles prévues par les Articles L.413-1 et suivants du Code du Travail Luxembourgeois afférents à la
désignation des délégués du personnel.
Le groupe spécial de négociation peut prendre les décisions à la majorité absolue de ses membres, à la condition que
cette majorité représente une majorité absolue des salariés. Chaque membre disposera d'une voix. Si le résultat des
négociations aboutit à une réduction des droits de participation, la majorité requise pour l'approbation d'une décision,
tel qu'un accord, sera de deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins deux tiers des
salariés.
Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des Parties à la Fusion détermineront, le cas échéant, par
écrit, les modalités relatives à l'implication des salariés au sein de la Société Absorbante. A cette fin, les organes compétents
des Parties à la Fusion informeront le groupe spécial de négociation du projet et de l'avancée de la Fusion, jusqu'à son
approbation.
Conformément à l'article 3 (6) de la Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la
Société européenne pour ce qui concerne l'implication des salariés et l'Article L.426-15 (2) du Code du Travail Luxem-
bourgeois, le groupe spécial de négociation peut décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au
moins deux tiers des salariés de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se
fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des salariés en vigueur au Luxembourg où la
Société Absorbée emploie des salariés (Section 1 et 2 du Titre 2 du Livre IV du Code du Travail Luxembourgeois). Une
telle décision clôturera la procédure de conclusion d'un accord relatif à l'implication des salariés au sein de la Société
Absorbante.
En référence aux dispositions ci-dessus, la Société Absorbée emploie actuellement deux salariés qui sont invités à
procéder conformément aux prédites dispositions.
(p) Statuts de la Société Absorbante (Article 5 point (i) de la Directive 2005/56/CE, Article 2:312 paragraphe 2 sous
b du Code Civil Néerlandais et Article 261 (4) a) de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
La Fusion est une fusion par absorption sans constitution d'une nouvelle société. Les statuts actuels de la Société
Absorbante sont ci-après annexés à l'annexe 4. Ces statuts seront amendés par l'effet de la Fusion et sont ci-après annexés
à l'annexe 5.
(q) intentions concernant la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante après la Fusion (Article
2:312 paragraphe 2 sous e du Code Civil Néerlandais).
La composition du conseil d'administration ne sera pas modifiée par l'effet de la Fusion.
(r) Annulation d'actions au sein du capital de la Société Absorbante (Article 2:325 paragraphe 3 du Code Civil Néer-
landais).
Par l'effet de la Fusion, aucune action au sein du capital de la Société Absorbante ne sera annulée.
(s) Dispositions afférent à la compensation (Article 2:333d sous f du Code Civil Néerlandais).
La Société Absorbante n'étant détenue que par un seul actionnaire, la situation prévue par l'Article 2:333h du Code
Civil Néerlandais n'est pas applicable. Déterminer une compensation d'actions est par conséquent inutile.
(t) Audit (Article 2:328 du Code Civil Néerlandais et Article 266 de la Loi sur les Sociétés Commerciales).
Le conseil d'administration de la Société Absorbante a demandé à KPMG Pays-Bas d'examiner le présent Projet de
Fusion et d'émettre un avis et un rapport.
Le conseil d'administration de la Société Absorbée a demandé à G.S.L. FIDUCIAIRE S.à r.l. d'examiner le présent Projet
de Fusion et d'émettre un avis et un rapport.
(u) Mise à disposition de la documentation au siège social des Parties à la Fusion (Article 267 (1) et (3) de la Loi sur
les Sociétés Commerciales et Article 2:314 du Code Civil Néerlandais).
Les documents suivants seront mis à la disposition pour inspection au siège social de chaque Partie à la Fusion au moins
un mois avant la tenue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le Projet de Fusion:
1. ce Projet de Fusion;
2. les comptes annuels des Parties à la Fusion des trois derniers exercices sociaux (étant pour la Société Absorbante
2008 et 2009 et pour la Société Absorbée 2008, 2009 et juin 2010) ainsi que les rapports de gestion y relatifs;
109034
L
U X E M B O U R G
3. les comptes intérimaires au 31 Août 2010 des Parties à la Fusion sur base desquels ce Projet de Fusion a été établi;
4. Les notes explicatives des conseils d'administration des Parties à la Fusion,
5. les rapport d'audit des Parties à la Fusion établi en relation de la Fusion.
Copie intégrale, ou, s'il le désire, partielle des documents vises ci-dessus peut être obtenue par l'actionnaire, Enel, sans
frais et sur simple demande.
(v) Coûts et frais.
Tous les coûts ou frais engendrés par cette Fusion et sa réalisation, et l'exécution du présent Projet de Fusion ainsi
que les frais de transactions et autres obligations (s'il en existe) seront à la charge de la Société Absorbante.
(w) Nullité - Invalidité.
L'éventuelle nullité ou invalidité du fait d'une disposition statutaire qui entacherait l'une ou l'autre disposition du présent
Projet de Fusion, n'affectera pas la validité des autres dispositions du présent Projet de Fusion. Les Parties à la Fusion
s'engagent à remplacer la disposition nulle ou invalide tout en s'efforçant de respecter l'économie d'une telle disposition.
Il sera procédé de même pour toute omission découverte lors de la réalisation de présent Projet de Fusion.
Le présent texte est établi le 18 octobre 2010, en original, aux fins d'être (i) déposé au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg et d'être publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations au moins un mois avant
la date de l'assemblée générale des associés appelée à se prononcer sur le projet de fusion, conformément à l'Article 262
et 9 de la Loi sur les Sociétés Commerciales et (ii) déposé au registre du commerce de la chambre de commerce
d'Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel) et publié dans un journal officiel néerlandais (staatscourant)
conformément aux Articles 2:314 et 2:333e du Code Civil Néerlandais.
Le présent Projet de Fusion est établit en Anglais suivi d'une version Française. En cas de divergences entre le texte
Anglais et le texte Français, la version Anglaise fera foi.
Signé par:
Le 18/10/2010.
La Société Absorbante ENEL Finance International N.V.
M. Vincenzo Accurso
<i>Administrateuri>
Le 18/10/2010.
La Société Absorbée ENEL Finance International S.A.
M. Alessandro Canta / M. Francisco Javier Galan Allue / M. Francesco Moglia / M. Armand De Biase
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Bedrijf 520 Enel Trading Rus B.V
Balans - Bj 2010
Op datum
Vanaf datum 1-1-2010 Vanaf GB-rekening Alle
T/m 31-8-2010 T/m
Onverwerkt Ja
Valuta EUR x 1
Saldo 31 August 2010
Debet
Credit
Balance sheet
Assets
Current assets
Cash at bank and in Hand
1100 DB EUR ACCOUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.054,60
Totaal Cash at bank and in Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.054,60
Totaal Current assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.054,60
Totaal Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.054,60
Capital and liabilities
Capital and reserves
Share capital
0500 SHARE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000,00
Totaal Share capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000,00
Reserves
0510 SHARE PREMIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.000,00
0520 RETAINED EARNINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.889,27
109035
L
U X E M B O U R G
Totaal Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.110,73
Totaal Capital and reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.110,73
Short term liabilities
Accruals group companies
1880 ACCRUAL SERVICE FEES (EIH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.167,74
Totaal Accruals group companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.167,74
Accruals other
1800 ACCRUAL ADMINISTRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.345,50
1810 ACCRUAL TAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000,00
Totaal Accruals other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.345,50
Totaal Short term liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.513,24
Totaal Capital and liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.623,97
Totaal Balance sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
Saldoverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
Totaal Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
5.569,37
Profit & Loss account
Operating results
General and administrative expenses
Group fees / expenses
4650 SERVICE FEES (EIH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.167,74
Totaal Group fees / expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.167,74
Other expenses
4720 BANKCOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284,85
4725 COST CHAMBER OF COMM El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116,78
Totaal Other expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401,63
Totaal General and administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
Totaal Operating results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
Totaal Profit & Loss account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
Saldoverlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
Totaal Winst & Verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.569,37
5.569,37
Totaal Balans + Winst & Verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.138,74 11.138,74
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.
Interim financial statements for the period from July 1, 2010 to August 31, 2010 (with the report of the Réviseur
d'Entreprises Agréé thereon)
11, Boulevard de la Loire
L-1528 Luxembourg
R.C.S, Luxembourg B 60.086
Share Capital: EUR 1.478,765,370
<i>Balance sheet as at August 31, 2010i>
Notes August 31, 2010
June 30, 2010
EUR
EUR
ASSETS
Formation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.669
Financial assets
Shares as affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
61.171.232
61.171.232
Current assets
Amount owed by affiliated undertakings
4
Becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.537.838.129
1.124.540.456
Becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . .
20.517.500.000 20.517.500.000
23.055.338.129 21.642.040.456
Other debtors
Becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.393.017
3.232.012
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.123
118.339
109036
L
U X E M B O U R G
Prepayments and accrued income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
487.507.259
436.854.204
23.557.461.429 22.143.416.243
LIABILITIES
Capital and reserves
5
Subscsribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
1.478.765.370
1.391.900.230
Reserves
Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
17.928.287
16.680.231
Other reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
-
14.645.362
Profit brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.371.576
80.878.299
Profit for the financial period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.773.256
24.961.111
1.552.838.489
1.529.065.233
Provision for liabilities and charges
Provisions for taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.964.250
19.447.946
Other provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.594
9.594
28.973.844
19.457.540
Creditors
Debenture loans and commercial papers
6.7
Becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.319.368.938
4.924.527.523
Becoming due and payable alier more than one year . . . . . . . . . . . . . . .
12.527.892.623 12.527.892.623
18.847.261.561 17.432.420.146
Amount owed in credit institutions
7
becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.382.533
7.382.177
becoming due and payable after more than one year . . . . . . . . . . . . . . .
2.692.277.073
2.692.277.073
2.696.659.606
2.699.659.250
Amounts owed to affiliated undertakings
8
becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170.288.552
191.157.213
Other creditors
becoming due and payable within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476.878
731.391
Accruals and deferred income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
260.962.499
250.925.470
23.557.461.429 22.143.416.243
The accompanying notes form an integral part of the Interim financial statements.
<i>Profit and Loss account as at August 31,2010i>
Notes Period from
July 1, 2010
to August
31, 2010
Period from
January 1,
2009 to June
30,2010
EUR
EUR
CHARGES
External charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166,894
455,070
Staff costs
Wages and salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72,912
139,459
Social security costs accruing by reference to wages and salaries . . . . . . . . . . .
8,076
32,254
80,988
171,713
Value adjustments in respect of formation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
-
Other operating charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,553
3,027
Interest payable and similar charges
….affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3,601,830
11,683,108
other interest payable and charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
138,965,610 410,080,634
142,567,440 421,763,742
… on profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,516,304
9,993,532
Profit for the financial period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23,773,256
24,961,111
176,104,614 457,348,195
INCOME
Other operating income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
1,472,581
109037
L
U X E M B O U R G
Other interest receivable and similar income
Deriver from affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,3
172,697,654 455,874,809
other interest receivable and similar income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,406,560
805
176,104,614 455,875,614
176,104,614 457,348,195
Notes to the Interim financial statements August 31, 2010
1. General. ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A. (the “Company”) is a company incorporated under Luxembourg
law on July 3, 1997. The registered office of the Company is 11, Boulevard de la Foire, L-1527, Luxembourg. The Company
is registered with the Register of Commerce and companies of Luxembourg under Section B, number 60.086.
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign
companies, the control, the management, as well as the development of these participations. The Company may also
perform any commercial, industrial, or financial operation. In a general fashion, the Company’s activities are limited by
the requirements of the law of August 10, 1915, as modified, on commercial companies.
The Company is established for an indefinite duration.
On August 11, 2010, the Shareholder decided to change its year and from December 31 to June 30.
The Company is a direct subsidiary of Enel S.p.A., Rome, a company registered in Italy whose consolidated accounts
are available at its registered office, Viale Regina Margherita 137, 00198 Rome, Italy.
Enel S.p.A. will provide financial support to the Company, should it not be ale to meet its obligations. Enel S.p.A. has
formally confirmed this intent in a comfort letter issued on October 11, 2010.
2. Significant accounting policies. The Company maintains its books and records in Euro (“EUR”) and the Interim
financial statements have been prepared in conformity with applicable legal requirements in Luxembourg including the
following significant accounting policies and are consistent with the accounting policies in the annual accounts.
The Interim financial statements have been prepared in the frame of the legal cross-border merger.
2.1 Shares in affiliated undertakings
Participations are stated at acquisition cost. Write-downs are recorded if, in the opinion of the Directors, there is any
permanent impairment in value. Income from the participations is recognised when, and to the extent, dividends are
received from the participations.
2.2 Amounts owed by affiliated undertakings
Receivables from related companies are stated at their nominal value, Write-downs are recorded it, in the opinion of
the Directors, there is any permanent impairment in value.
2.3 Creditors
Creditors are valued at the higher of nominal or repayment value.
2.4 Premium and discount on borrowings
Premium and discount on borrowings are accounted for in transitory accounts under assets or liabilities independently
of borrowings to which they are associated, and arc depreciated prorata temporis over the life of the borrowing.
2.5 Cross currency interest rate swaps and cross currency swaps
The Company hedged the Global Medium Term Notes ("The Notes") amount using cross currency interest rate swaps
to limit the risk of exchange rate fluctuations and to fix the EUR interest rate of the Notes. In the event of an exchange
loss arising from the global conversion of the Notes and cross currency interest raw swap, the loss is recorded 10 profit
and loss account. Exchange gain arising from this conversion is not recognized.
The Company hedged the Euro Commercial Papers amount using currency swaps to limit the risk of exchange rate
fluctuations at the end of each period. In the event of an exchange loss arising from the global conversion of the ECP and
currency swap, the loss is charged to profit and loss. The exchange gain arising from this conversion is not recognized,
2.6 Interest income and expenses
Interest income and expenses arc recorded on an accrual basis.
2.7 Foreign currency translation
Current assets and liabilities stated in currencies other than EUR are translated at the exchange tales prevailing at the
date of the balance sheet. Transactions denominated in currencies other than EUR are translated at the rate of transaction.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are recorded in the profit and loss account.
2.8 Going concern
On July 26, 2010 the Board of Directors of the Company resolved to approve the transfer of the activities to the
Netherlands, as a consequence of a decision approved by the parent company, Enel S.p.A.
The transfer, aimed at concentrating in one jurisdiction the international financial activities of the Enel Group, will be
realized through a legal cross-border merger with a Dutch dormant company fully owned by Enel S.p.A. whith effect as
of December 2, 2010, or such earlier or later date as may be the case.
109038
L
U X E M B O U R G
The transaction has not implied a modification of the going concern hasts of preparation of the Interim financial
statements as the merger is done under the European cross-border merger, i.e. all assets, liabilities and contracts are
transfered to a Dutch company.
3. Shares in affiliated undertakings. As of August 31, 2010, the Company held a participation in Enel Ireland Finance
Ltd represented as follows
%
Net Book
Value
Capital and
Reserves
(including
Result for
the period)
(*)
31/08/10
07/12/09
EUR
EUR
Enel Ireland Finance Ltd.
25-28 Adelaide Road, Dublin 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 61.171.232 62.681.626
(*) Unaudited figures as at June 30, 2010,)
On December 18. 2009, the Subsidiary was put into liquidation.
As at August 31, 2010, the Company did not receive any dividend (June 30, 2010: EUR nil).
4. Amounts owed by affiliated undertakings.
August 31. 2010
June 30. 2010
EUR
EUR
I can to Enel S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500.000.000
2.500.000.000
Short-term revolving Credit Line ENEL S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
780.000.000
310.000.000
Intercompany by account ENEL S.p.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422.217.252
59.321.155
Total accounts owed by ENEL S.p.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.702.217.252
2.869.321,155
Loan to Enel North America Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,482,087
1,494,070
Loan to … Russia B.V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70,638,309
61,311,187
Loan to Enel France S.A.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398,927,087
253,255,280
Loan to Enel Green Power France S.A.S. (formerly Erelis S.A.S.) . . . . . . . . . . . .
74,022,681
88,146,236
Loan to Enel Green Power Romania S.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,797,513
26,192,153
Loan to Enel Investment Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55,968,384
143,968,384
Loan in Enel Green Power International B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329,350,046
-
Loan to Enel Trade Romania S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,883,751
10,063,716
Loan to Enel Trade Hungary Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,610,178
1,713,206
Loan to Enel Green Power Bulgaria EAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,414,129
47,414,129
Loan to Enel Lease S.ar.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,796,264
18,271,565
Loan to Impulsiva National de Elecricidad S. de R.I. de C.V . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,509,740
6,929,561
Loan to Enel Union Fenosa Renovables S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,500,000
17,500,000
Loan to Enel Energy Europe S.I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000,000,000 18,000,000,000
Loan to Enel Albania Shpk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
643.391
642.391
Loan to Enel Operations Belgium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,000
100,000
Loan to Marcinelle Energie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,494,415
17,457,000
Total amounts owed by other affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,109,336,278 18,694,459,078
Accrued interest on amount payable by Enel S.p.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.914,589
550,943
Accrued interest on amount payable by … Russia B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277.033
155.783
Accrued interest on amount payable by Impulsera Nacional de Electricida I S,
de R.L de C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133,778
113,904
Accrued interest on amount payable by Enel Union Fenosa Renovables S.A. . . .
122,885
17,067
Accrued interest on amount payable by Enet Energy Europe S.L. . . . . . . . . . . . .
207.000.000
67,500,000
Accrued interest on amount payable by Enel Rus LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25,505
26,053
Accrued interest on amount payable by Enel North America Inc. . . . . . . . . . . . .
40,942
33,793
Accrued interest on amount payable by Enel Prance S.A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,905,858
2,311,836
Accrued interest on amount payable by Enel Green Power France S.A S.
(formely Enel Erelis S.A.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,410,728
1,029,599
Accrued interest on amount payable by Enel Green Power
904,594
-
109039
L
U X E M B O U R G
International B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accrued interest on amount payable by Enel Investment Holding B V. . . . . . . . .
598,542
1.235,707
Accrued interest on amount payable by Marcinelle Energie S.A. . . . . . . . . . . . . .
161,889
32,242
Accrued interest on amount payable by Enel Trade Romania S.r.l. . . . . . . . . . . .
677,352
506,780
Accrued interest on amount payable by Enel Trade Hungary Kft . . . . . . . . . . . .
24,503
16,649
Accrued interest on amount payable by Enel Lease S.ar.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278,302
185,482
Accrued interest on amount payable by Enel Green Power Bulgaria LAD . . . . . .
788,915
563,459
Accrued interest on amount payable by Enel Green Power Romania S.r.l . . . . . .
323,973
198,445
Accrued interest on amount payable by Enel Albania Shpk . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,105
6,944
Accrued interest on amount payable by Enel Operations Belgium S.A. . . . . . . . .
1,742
499
Accrued commitment fees and other intercompanv receivables . . . . . . . . . . . . .
2,181,667
3,775,038
Total accrued interest and fee payable by affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243,783,902
78,260,223
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,055,338,329 21,642,040,456
4.1 Enel S.p.A.
4.1.1 Short-term operations
Short-term revolving credit line
On December 31, 2007, the Company agreed to enter into a Short-Term Revolving Credit Line with Enel S.p.A. for
an aggregate amount of EUR 4.000.000.000, in order to achieve a more efficient management of its cash flows deriving
from the short-term funding activities.
The parties agree the interest rate two business days before each interest period being she aggregate of EURIBOR
and a margin between 15 basis points and 150 basis points. The maturity dale of the Short-Term Credit Line was June
29, 2009 but it was automatically renewed to December 28. 2010. The amount drawn as at August 31. 2010 is EUR
780,000,000 (June 30, 2010: EUR 310,000,000).
Intercompany current account
The amount payable by Enel S.p.A. as at August 31, 2010 is equal to EUR 422.217.252 and bears interest at EURIBOR
(monthly average rate 360 days count basis).
4.1.2 Long-term operations
On Januar 1, 2008, the Company granted two loans to Enel S.p.A., both maturing on December 31, 2013, for a total
amount of EUR 10,509,325,695. The first loan amounted to EUR 2,644,325,695 with interest calculated at a fixed rate of
6.0413%.
The second loan amounted to EUR 7,865,000,000 with interest calculated at EURIBOR one month plus a spread of
0.5263%. On January 7, 2009, the spread increased to 0.901.3% with a retroactive effect from the fourth quarter 2008.
During the first quarter 2009, the spread increased to 2.75%, from the second quarter 2009, it was progressively
reduced to 0.75% to reflect the actual market rates conditions.
On february 1, 2010, Enel S.p.A. asked to prepay its long-term exposure towards the Company for EUR 8,009,325,695
and renegotiated the two loans.
Therefore, while the first loan of EUR 2,644,325,695 was fully prepaid and terminated, the second loan agreement of
EUR 7,865,000,000 was amended to a new commitment of EUR 2,500,000,000.
This loan row bears interest at a fixed rate of 5.60% and matures on December 31, 2025
4.2 Financial relationship existing at the beginning of the year with End Group
4.2.1 Short-term operations
Enel North America. Inc.
The financial relationship with Enel North America, Inc. started on December 1, 2006 when the Company granted an
initial loan for an amount of USD 50,000,000.
During 2017, the Board of Directors of the Company approved the increase of the loan up to a total amount of USD
77,000,000 and the opening of an intercompany current account denominated in USD, considered as a better instrument
for the management of the treasury activities.
In March 2008, the initial loan was totally repaid using the funds deriving from a capital injection. On December 19,
2008, the Board of Directors decided to grant a new Revolving Credit Facility for an aggregate amount of USD
200,000,000. The initial term was December 31, 2009 but was extended to December 31, 2010.
During 2009, with the liquidity deriving from a tax partnership operation, Enel North America, Inc. repaid the out-
standing debit and deposited the remaining cash on the intercompany current account.
During the first eight months of 2010, the cash deposited on the intercompany current account has been totall draw-
down and the Revolving Credit Facility was utilised for EUR 13,482,087 (June 30, 2010 EUR 1,494,070).
The Company hedged both the intercompany current account and the Revolving Credit Facility amount using currency
swaps to limit the risk of exchange rate fluctuations.
109040
L
U X E M B O U R G
Artie Russia B.V.
On July 9, 2007, the Company entered, as a lender, into a loan agreement of USD 200.000.000 with Artie Russia B.V.,
the joint venture between Enel Investment Holding B.V. (40%) and Enel International B.V. (60%), involved in the man-
agement of some Russian gas companies.
The initial term was February 28, 2009 but was extended to December 30, 2010. It bears interest at US LIBOR plus
a spread of 0.65%. On December 17, 2009, the Board of Directors decided to increase the spread to 0.77%.
The amount drawn, as at August 31, 2010, is USD 92,276,550 (EUR 70,638,309), (June 30, 2010: USD 80,928,150, with
a countervalue of EUR 61,311,187).
The Company hedged (he loan amount using currency swaps to limit the risk of exchange rate fluctuations.
Enel France S.A.S.
On January 17, 2007, the Company granted a Revolving Credit facility for an amount up to EUR 15,000,000 a Enel
France S.A.S., a French subsidiary of Enel Group with main activity in the EPR projec jointly with EDF. This credit line
was increased during 2008 and 2009 up to a maximum amount of EUR 310,000,000 to cover the financial needs mainly
deriving from Enel France S.A.S. participation in the EPR project.
On December 17, 2O09, the Board of Directors approved the decrease oft he commitment from EUR 310,000,000
to EUR 270,000,000. The maturity date is December 31, 2010.
On June 22 7010, the Board of Directors approved the increase of the commitment from EUR 270,000,000 to EUR
480,000,000, the amendment of the loan agreement has been signed on July 6, 2010.
It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 1.23% and a commitment fee of 0.0625%. The amount drawn
as at August 31, 2010 is EUR 398.927,087 (June 30, 2010 with a countervalue of EUR 253 255.280).
Enel Green Power France S.A.S. (formerly Enel Erelis S.A.S.)
On January 17, 2007, the Company granted a Revolving Credit Facility for an amount up to EUR 5.000.000 to Enel
Green Power France S.A.S., a French subsidiary of Enel Group operating in the development of wind energy, to 2008 and
2009, the Board of Directors decided to increase this credit line up to the actual amount of EUR 145.000.000. The initial
term was December 31, 2009 but was extended to December 31, 2010.
This Revolving Credit Line bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 2% and a commitment fee of 0.0625%.
The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 74,022,681 (June 30, 20l0:EUR 88,146,236).
Enel Green Power Romania S.r.l.
On March 9, 2008, the Company granted a Revolving Credit Facility to Find Green Power Romania S.r.l. for an aggregate
amount up to EUR 2.000.000. On May 29. 2008 and December 19. 2008. the Board of Directors decided to increase the
aggregate amount up to EUR 20.000,000.
It hears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 2% and a commitment fee of 0.0625% The initial term was
December 31. 2000 hut was extended to December 31. 2010. renewable for further 12 months.
Following a capital injection in December 2009, the facility was repaid almost entirely. On March 15, 2010, the Board
of Directors decided lo increase the commitment of the Revolving Credit Facility up to the actual amount of EUR
42.000.000.
The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 26.797.513 (June 30.2010: EUR 26.192.353).
Enel Investment Holding R.V.
Starting from 2008, in the frame of the joint venture between Enel Investment Holding B.V, (80%)and Duferco Diver-
sification S.A. (20%) in the Belgian project company Marcinelle Energie S.A.. currently developing a 425 MW thermal
power plant, the Company granted a Revolving Credit Facility to Enel Investment Holding B.V. for an initial amount of
EUR 60.000,000. It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 0,45%.
Following the economical and financial crisis throughout the world, during 2008 and the first months of 2009, the two
shareholders of Marcinelle Energie S.A. decided to temporary suspend the execution of the original project finance plan
and to provide directly a temporary financial support.
On April 22, 2000 and on December 17, 2009, the Board of Directors decided to increase the aggregate amount up
to EUR 88.000.000 and the spread to 1.20%. The initial term was December 31. 2009 hat was then extended to December
31. 2010. The amount was fully repaid on July 2010.
On July 9, 2009, the Board of Directors decided to grant a second devolving Credit Facility to Enel Investment Holding
B.V. for an aggregate amount up to EUR 56.000.000. It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 1.20%. The
initial twin is September 28, 2010. The amount drawn is of EUR 55,968,384 as at August 31, 2010.
Enel Trade Romania S.r.l.
On May 29, 2008, the Board of Directors decided to grant a Revolving Credit Facility of RON 37,000,000 to Enel
Trade Romania S.r.l.. in order to finance the energy trading activities of the company it the Romanian energy market.
The agreement was signed in January 2009 and bears interest at ROBOR 3 months plus a spread of 2% and a com-
mitment fee of 0.0625%. The maturity date is December 31, 2010.
109041
L
U X E M B O U R G
On July 9, 2009, the Board of Directing decided to increase the aggregate amount up to RON 60.000,000 The amount
drawn as at August 31. 2010 amounts to RON 42.642.166 (EUR 9.883,751) (June 30, 2010 RON 43,351.633 with a
countervalue of EUR 10,063,716).
The Company hedged the Revolving Credit Facility amount using currency swaps to limit the risk of exchange rate
fluctuations.
Enel Trade Hungary Kft
On May 20, 2008, the Board of Directors, decided to grant a Revolving Credit Facility, for an aggregate amount up to
EUR 5.000.000 to Enel Trade Hungary Kft, in order to finance the energy trading activities of the company in the Hungarian
energy market.
The agreement was signed in January 2O09 and bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 1.50% and a
commitment fee of 0.0625%. The maturity date is December 31. 2010.
On June 22, 2010, the Board of Directors approved the increase of the commitment from EUR 5.000,000 to EUR
10.000,000 the amendment of the loan agreement will be signed in the next months.
The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 2,610,178 (June 30, 2010 EUR 1,713,206)
Enel Green Power Bulgaria EAD
On November 30, 2009, the Company granted a Revolving Credit Facility for an amount to EUR 56,000,000 to Enel
Green Power Bulgaria EAD, in order to allow the closing of the existing Revolving Credit Facility held with Enel Ireland
Finance Ltd. the subsidiary of the Company currently at the liquidation,
It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 2% and a commitment fee of 0.0625%. The maturity date is
December 31, 2010.
The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 47,414,129 (June 30, 2010: EUR 47.414.129).
Enel Lease S.à r.l.
On July 9, 2009, the Board of Directors decided to grant to Enel Lease S.à r.l, a Revolving Credit Facility for an amount
up to EUR 30,000.000. On December 17, 2009, the Board of Directors decided to increase the aggregate amount to EUR
35,000,000. It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 1.25% and a commitment fee of 0.0625%. The maturity
date is December 31, 2010. The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 34,706,264 (June 30, 2010: EUR 18,271,565).
Impulsura National de Electricidad S. de R. L. de C.V.
On November 18, 2000, the Board of Directors decided to grant a Revolving Credit Facility for an aggregate account
up to USD 8.500.000 to Impulsora Nacional de Electricidad S. de R. L de C.V a Mexican company operating in the
renewable energy sector.
It bears interest at US LIBOR 3 months plus a spread of 3% and a commitment fee of 0.0625%. The maturity date is
December 31. 2010, with the possibility to he further extended. The amount drawn as at August 31. 2010 is USD 2,822,187
(EUR 2,509,740). (June 30, 2010: USD 8,499,175 with a countervalue of EUR 6.929.561).
The Company hedged the Resolving Credit Facility amount using currency swaps to limit the risk of exchange rate
fluctuations.
Enel Green Power International B.V.
In the frame of the corporate reorganization related to the grouping of the renewable sector shareholdings, on August
6, 2008, the Company granted a Revolving Credit Facility to Enel Green Power International B.V. for an initial amount
up to EUR 126,000,000, with interest calculated based on EURIBOR 3 months plus a spread of 1.25%. The initial term
was December 31, 2009 but was extended to December 31, 2010.
On December 13, 2009, the Board of Directors decided to … the commitment up to EUR 20,000,000. During 2010,
Enel Green Power International B.V. did not utilise the Revolving Credit Facility and the Company agreed to close it on
August 31. 2010.
On June 21, 2010 in the frame of the upcoming initial public offering ("IPO") of a minority participation of Enel Green
Power S.p.A. ("EGP"), and following the decision to reconsider the funding and treasury process currently in place between
the Company and the foreign subsidiaries of EGP, the Board of Directors of the Company resolved to grant Enel Green
Power International B.V. (“EGP”) the necessary financial facilities to allow it to be the financial company of the Renewable
Division.
The funding and treasury process shall be reconsidered progressively replacing the agreements currently in place with
the foreign subsidiaries of EGP by means of two larger facility agreements to be execute al between the Company, as
lender and EGPI as borrower:
a) a "Multicurrency Long-Term Loan”, in order to finance the long term investments, and
b) a "Multicurrency Short-Term Revolving", in order to secure the necessary cash flexibility.
EGPI in turn will replace the Company as lender towards all the subsidiaries of EGP.
The above-mentioned financial structure shall be managed through a "Paying Agent Agreement" to be executed by and
between the Company and EGPI
109042
L
U X E M B O U R G
The details of terms and conditions of the Multicurrency Long-Term Loan and of the Multicurrency Short-Term
Revolving Facility are the following:
a) Multicurrency Long-Term Loan, for an aggregate commitment amount up to the equivalent of EUR 2,501,000,000
with the following features:
- Currency: Euro, USD and any other currency requested
- Tenor: variable by drawdown, up to 8 years from the signing date of the agreement
- Rate of interest: Fixed or Floating Rate, plus a margin of 200 bps
- Interest period: annual in case of Fixed Rate; semi-annual in case of Floating Rare
- Commitment Fee: 25% of the margin per annum
b) Multicurrency Revolving Facility Agreement, for an aggregate commitment amount up to the equivalent of EUR
1,200,000,000
- Currency: Euro, USD and any other currency requested
- Maturity: December 31, 2010, renewable
- Rate of Interest: Floating Rate plus a margin of 150 bps
- Commitment Fee: 20 bps
The Multicurrency Revolving Facility Agreement and the Paying Agent Agreement have been signed on July I, 2010:
the Multicurrency Long-Term Loan has been signed on July 15, 2010.
The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 329,350,046.
Enel Albania Shpk
On January 3, 2010, the Company decided to grant a Revolving Credit Facility for an amount up to EUR 1,250,000 to
Enel Albania Shpk. It hears interest at EURIBOR 3 mouths plus a spread of 3.00% and a commitment fee of 0.0625%. The
maturity date is December 31, 2010. The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 642,301 (June 30, 2010; EUR
642,391).
End Operations Belgium S.A.
On November 18, 2009, the Board of Directors decided to grant a Revolving Credit Facility for an amount up to EUR
2,000,000 to Enel Operations Belgium S.A. that was only utilised in 2010.
It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 2.00% and a commitment fee of 0.00625%. The maturity date
is December 31, 2010.
The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 300,000 (June 30, 2010; EUR 100,000).
Marcinelle Energie S.A.
On March 15, 2010, the Board of Directors, in order to temporary support Marcinelle Energie S.A., currently devel-
oping a 425 MW thermal power plant, decided to grant a Revolving Credit Facility for an amount up to EUR 220,000,000.
It bears interest at EURIBOR 3 months plus a spread of 2.50% and a commitment fee of 0.0625%. The maturity date is
December 31, 2010. The amount drawn as at August 31, 2010 is EUR 24,494,415 (June 30, 2010; EUR 17.457,000).
4.2.2 Long-term operations
Enel Energy Europe S.L.
On November 30, 2009, the Company granted a loan for an amount of EUR 10,000,000,000 to Enel Energy Europe
S.L., a subsidiary fully owned by Fuel and holding the 92.06% share capital of Endesa SA. This long-term loan allowed Enel
Energy Europe SL. to repay partially the overdraft granted by Enel on the intercompany current account for the acquis-
itions of Endesa SA and to obtain a more adequate financial structure for its long-term assets.
On February I, 2010, Enel Energy Europe S.L., aiming to offsetting the main pan of the residual overdraft on the
intercompany current account granted by Enel S.p.A. and in order to benefit of the opportunities of the financial markets,
asked for and the Company approved, an increase of the commitment to EUR 18.000.000.000. The maturity is 10 years.
The interest rate has therefore been increased from 3.20% to 4.50%. The maturity date is November 30. 2019.
Enel Union Fenosa Renovables S.A.
On December 17, 2009, the Board of Directors decided to enter, us a lender, into a Subordinated Loan agreement
of EUR 17,500,000 with Enel Union Fenosa Renovables S.A., a Spanish joint venture between Enel Group and Gas Natural
Group operating in the renewable energy sector.
The loan hears a floating interest at EURIBOR 6 months plus a spread of 2.50%. The maturity date is August 31, 2013.
4.3 Other interest receivable and similar income derived from affiliated undertakings
Other interest receivable and similar income derived from affiliated undertakings are detailed as follow
August 31, 2010 June 30, 2010
EUR
EUR
Enel S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,728,016
83,732,477
Other affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145,969,638
372,142,332
172,697,654
455,874,809
109043
L
U X E M B O U R G
5. Capital and reserves. As of August 31, 2010, the movements of the capital and reserves are represented as follows:
Opening
balance
as at
July 1, 2010
Allocation
of the profit
as at
June 30, 2010
Net worth
tax allocation
Increase
of the
subscribed
capital
Profit of
the period
Closing
balance
as at
August 31,
2010
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Subscribed capital . . . . 1,391,900,230
-
-
86,865,140
- 1,478,765,370
Legal reserve . . . . . . . .
16,680,231
1,248,056
-
-
-
17,928,287
Other reserves . . . . . .
14,645,362
-
72,219,778 (86,865,140)
-
-
Profit brought
forward . . . . . . . . . . . .
80,878,299
23,713,055
(72,219,778)
-
-
32,371,576
Profit of the financial
period . . . . . . . . . . . . .
24,961,111
(24,961,111)
-
- 23,773,256
23,723,256
1,529,065,233
-
-
- 23,773,256 1,552,838,489
The allocation of the profit as at June 30, 2010 was approved by the Annual General Meeting of the Shareholders dated
August 31. 2010.
5.1 Subscribed capital
As at June 30, 2010, the subscribed capital amounted to EUR 1,391,900,230 represented by 139,190,023 shares with
a nominal value of EUR 10 each.
On July 29, 2010, the Shareholder resolved to increase to the subscribed capital of the Company by an amount of EUR
50,755,250 (note 5.3) by allocation of its other reserves. The subscribed capital increases from EUR 1,391,900,230 to
EUR 1,442,655,480 by issuing 5,075,525 shares with a nominal value of EUR 10 each.
On August 31, 2010, the Shareholder resolved a second increase to the subscribed capital of the Company by an
amount of EUR 36,169,890 (note 5.3) by allocution of its other reserves. The subscribed capital increases from EUR
1,442,655,480 to EUR 1,478,765,370 by issuing 3,610,989 shares with a nominal value of EUR 10 each.
As at August 31, 2010, the subscribed capital amounts to EUR 1,478,765,370 represented by 147,876,537 shares with
a nominal value of EUR 10 each
5.2 Legal reserve
Under Luxembourg law, an amount equal to at least 5% of the annual profit must be appropriated to a non-distributable
reserve until such reserve equals 10% of the issued share capital. This reserve is not available for dividend distribution,
5.3 Other reserves
On July 20, 1010, the Shareholder resolved ¹ transfer FUR 36,109,888 from the profit brought forward to the oilier
reserves.
On the same date, the Shareholder resolved to increase its subscribed capital by an amount of EUR 55,755,250 by
allocation of its other reserves composed by (he net worth tax reserve allocated for the year 2006-2009 (EUR 14,645,362)
and the above-mentioned transfer of EUR 36,109,888 (note 5.1).
The General Meeting of the Shareholders held on August 31, 2010, decided to allocate live times the 2010 … worth
tax due amounting 10 EUR 7,221,978 for a total amount of EUR 36,109,890 and immediately after to convert the amount
in subscribed capital (note 5.1).
The amount of other reserves as at August 31, 2010 is nil.
6. Debenture loans and commercial papers. As at August 31, 2010, all commercial papers and interests on debenture
loans arc becoming due and payable within one year. All debenture loans are becoming due and payable after more than
one year (note 7).
7. Funding activity. Global Medium Term Note Programme
On September 29, 2010, the Board of Directors of Enel S.p.A. resolved the renewal of the Global Medium Term Note
Programme (hereinafter, also “GMTN Programme", or "the Programme") with issuer Enel S p.A and the Company, with
guarantee of Enel S.p.A., for the issue of notes thereinafter, also “Notes" up to an aggregate amount of EUR
10,000,000,000.
The Board of Directors of the Company resolved the accession by the Company to the GMTN Programme on October
21, 2005 and the Company signed the Offering Circular and all other documents necessary to execute the entry into the
Programme on November 8, 2005
As specified in the Offering Circular, under the GMTN Programme, the Company and Enel S.p.A. can issue Notes up
to an aggregate amount of EUR 10,000,000,000. The Notes can be denominated it any currency, can hear fixed or floating
interest rate, can he in bearer form or registered form, will he unconditionally and irrevocably guaranteed by Enel S.p.A.,
and can he admitted to the Official List of the Irish Stock Exchange and traded on its regulated market.
109044
L
U X E M B O U R G
On April 26, 2007, the Board of Directors of the Company approved the increase of the aggregate nominal amount
of the Programme from EUR 10,000,000,000 to EUR 25,000,000.000.
On September 10, 2007, the Board of Directors of the Company approved the issue of Notes, for an amount up to
USD 7,000,000,000.
Following these resolutions, the Company issued fixed rate Notes for a total amount of USD 3,500,000,000 and JPY
20,000,000,000 with final repayment dates in 2013, 2017 and 2037.
On July 8, 2008, the Board of Directors approved the update of the following documents of the GMTN Programme:
- the offering circular relating to the Programme (the Prospectus):
- the amended, and restated agency agreement made between, amongst others, the Company, Enel S.p.A., Bank of
New York, as principal paying agent and register and Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited;
- the amended and restated agreement made between, amongst others, the Company, End S.p.A. and the Dealers.
On July 31, 2000, the Board of Directors of the Company approved the update of the GMTN Programme and the
proposal to issue Notes for an amount up to EUR 10,000,000,000 before the end of the first half of 2010.
The Company signed the Offering Circular and all other documents necessary to execute the entry into the Programme
on September 3, 2009.
On September 10, 2000, following the resolution adopted by the Board of Directors on July 31, 2009, the Company
issued fixed rate Notes for a total amount of EUR 4,000,000,000 and GBP 2,250,000,000.
On September 30, 2009, following the same resolution, the Company issued fixed rate Notes on the United States
and international markets targeted at institutional investors for a total amount of USD 4,500,000,000
In November 2009, the Company issued lived rate Notes for a total amount of EUR 225,000,000. As of August 31,
2010, the Notes issued by the Company under the GMTN Programme are the following:
Notes
Maturity Interest rate
EUR counter-
value
USD 1,000 million fixed rate Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2013
5.7000%
721,946,940
USD 1,250 million fixed rate Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2014
3.8750%
857,582,639
EUR 1,500 million fixed rate Notes
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2016
4.0000%
1,500,000,000
USD 1,500 million fixed rate Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2017
6.2500%
1,083,617,900
USD 1,750 million fixed rate Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2019
5.1250%
1,199,174,051
EUR 125 million fixed rate Notes
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2019
4.5320%
125,000,000
EUR 100 million fixed rate Notes
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020
4.4573%
100,000,000
EUR 2,500 million fixed rate Notes
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2022
5.0000%
2,500,000,000
GBP 850 million fixed rate Notes
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024
5.6250%
969,762,160
USD 1,000 million fixed rate Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2037
6.8000%
722,115,450
JPY 20,000 million fixed rate Notes
1, 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2037
3.2500%
122,451,128
USD 1,500 million fixed rate Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2039
6.0000%
1,030,130,431
GBP 1,400 million fixed rate Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2040
5.7500%
1,596,112,124
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,527,892,623
1 the interest rale is up no 2008: thereafter EURIDOR 6 months+ 0.942%
2 Notes listed on the stock exchange
The upfront fees on cross currency interest rate swaps are accounted for in the caption "accruals and deferred income"
for EUR 32.252.757 (June 30, 2010: EUR 32,629,830). The accrued interest included in "debenture loans and commercial
papers" becoming due and payable within … year amounts to EUR 419,969,611 (June 30, 2010: EUR 380,113,405).
The interests to be received on the cross currency interest rate swaps arc accounted for in the caption "prepayments
and accrued income" for EUR 235,204,019 (June 30, 2010: EUR 228,402,042) and the interests to be paid on cross currency
interest rate swaps are accounted for in the caption “accruals and deferred income” for EUR 214,736,117 (June 30, 2010,
EUR 207,620,515).
The residual fees paid in relation to the Notes and not yet depreciated are accounted for in the caption "prepayments
and accrued income" for EUR 115,684,120.
Euro Commercial Paper Programme
On September 29, 2010, the Board of Directors of Enel S.p.A. has resolved to launch the Euro Commercial Paper
Programme (hereinafter, also "ECP Programme”), having as issuer the Company, with the guarantee of Enel S.p.A..
The Board of Directors of the Company has resolved the accession by the Company to the FCP Programme on
October 21, 2005 and the Company has entered into the Programme on November 7, 2005, by the signing of the
Information Memorandum and all other correlated documents accessory for the execution of the FCP Programme.
109045
L
U X E M B O U R G
Under the FCP Programme, the Company, with guarantee of Enel S.p.A.. can issue short-term promissory note (here-
inafter, “ECP Notes") up to an amount of EUR 4,000,000,000, which can he denominator in any currency, with a minimum
denomination of EUR 500,000 to GBP 100.000. or USD 500,000, or JPY 100,000,000 or its equivalent in the relevant
currency), can have maturity between one day and one year and be in the bearer form. The ECP Notes may be issued
on a discounted basis or may bear fixed or floating interest rate or a coupon calculated by reference to an index or
formula, and will not be listed on any stock exchange.
On May 18, 2011, the Board of Directors approved the increase of the ECP Programme from EUR 4,000,000,000 to
EUR 6,000,000,000.
The total of ECP issued and not reimbursed yet as of August 31, 2010 can be detailed as follows:
Currencies
ECP's
Amounts
EUR counter-
value (*)
EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,639,000,000 5,639,000,000
CFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000,000
15,208,779
JPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,900,000,000
35,583,942
USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261,500,000
209,600,606
5,899,399,327
* the euro commercial Paper (ECP) in foreign currency is converted at month-end exchange rates
The Company Ledged the ECP amount using currency swaps to limit the risk of exchange rate fluctuations at month-
end. In the event of an exchange loss arising from the global conversion of the ECP and currency swap, the loss is charged
to profit and loss. The exchange gain arising from this conversion as not recognized.
Premiums on commercial papers arc included in the "prepayments and accrued income" for an amount of EUR
9,230,948 (June 30, 2010: EUR 8,308,042).
Credit Facility Agreement
On April 9, 2007, the Board has approved to enter into it EUR 35,000,000,000 Credit Facility Agreement, by the
Company, Enel S.p.A., and Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. as an Agent.
The Company catered into this agreement as International Borrower with an initial participation of 40% for a total
amount up to EUR 14,000,000,000 with the guarantee of Enel S.p.A. The Company has used the proceeds of this agreement
in lending the amount to Enel S.p.A, for the purpose indicated above.
The total amount of the Credit Facility Agreement is divided into three different facilities with final maturity late at 12.
36 and 60 months to be calculated from the date of signing the maturity date may be … tended under certain conditions
The initial amounts of these three facilities have been reduced, from time to time, up to EUR 19,500,000,000.
The advance under the facilities pay a rate of interest based on the drawdown period plus a margin determined in
accordance to the credit rating assigned to Enel by Moody's or Standard & Poors.
As of December 31, 2008, the amounts owed to credit institutions becoming due and payable after more than one
year is of FUR 7,513,102,328 under the Facility B and C Commitatents, respectively for EUR 4,366,978,029 and
3,146,124,299
On February 29, 2009, the Board of Directors of the Company decided to enter, together with Enel S.p.A, into:
- a “Facility C Increase" under the EUR 35,000,000,000 Credit Facility Agreement dated April 10, 2007 by a total
amount up to EUR 8,000,000,000 maturing in 2012, and.
- a "Rollover Facility" agreement for an amount up to EUR 8,000,000,000, intended to replace and renew the "Facility
C Increase" as from 2012 with two new- tranches of EUR 5,500,000,000, maturing in April 10, 2014, and EUR
2,500,000,000, maturing in April 10, 2016, with Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., as an Agent.
In 2009, the Company fully reimbursed the Facility B for EUR 4,366,978,029 and reimbursed EUR 1,176,490,466 under
the Facility C.
On June 25, 2009, the Company raised EUR 3,021,500,335 under the Facility C Increase and then lent such proceeds
to Enel S.p.A. through a Bridge Loan Agreement.
During the second semester of 2009, die Company reimbursed FUR 1,129,887,443 under the Facility B Increase.
On April 26, 2010, the Company reimbursed the Facility B for EUR 596,295,016 and the facility B Increase for EUR
572,074,636.
The Company hedged the interest risk exposure using interest rate swaps to achieve a fixed interest rate. As at
December 31, 2009, the notional amount of this operation amounts to EUR 700,000,000. The interests to be received
on the interest rate swaps are accounted for on the caption "prepayments and accrued income" for EUR 12,153 (June
30, 2010: EUR 9,158) and the interests to be paid on interest rate swaps are accounted for in the caption "accruals and
deferred income” for EUR 13,973,625 (June 30, 2010: EUR 10,669,125)
The residual fees paid in relation to the credit facility agreement and not yet depreciated are accounted for on the
caption "prepayments and accrued income" for EUR 75,515,657 (June 30, 2010. EUR 78,480,175).
109046
L
U X E M B O U R G
As of August 31, 2010, the amounts owed lo credit institutions becoming due and payable after more than one year
is of EUR 2,692,277,073 under the Facility C and Facility C Increase C Commitments, respectively for EUR 1,373,338,817
and 1,318,938,256.
Revolving Facility Agreement
On March 15, 2010, the Board of Directors, considering the foreseeable financial support linked to the specific role
of the Company within Enel Group and aiming to secure a reasonable long-term credit facility as very favourable market
conditions, to be considered also as a buck slop credit line to face any possible future liquidity problem affecting the
commercial paper market, approved the entering, together with Enel S.p.A., into a 5-year Multiborrower Revolving Credit
Facility for EUR 10,000,000,000.
The Revolving facility Agreement, with a tenor of 5 years, has been signed on April 19. 2010 and may he used by the
Company and/or by Enel S.p.A.. The cost of the credit line vary depending upon Enel S.p.A. pro tempore rating, offering
at the signing rating levels a margin of 85 basis points above EURIBOR and a commitment fee of 40% of the applicable
margin. This Revolving Facility has not been used as at August 31, 2010.
The residual fees paid on relation to the revolving facility agreement and not yet depreciated are accounted for in the
caption “prepayments and accrued income" for EUR 1,860,362.
8. Amounts owed to affiliated undertakings. The amounts owed to affiliated undertakings mainly comprised intercom-
pany current accounts with group entities for a total amount of EUR 155,009,902 (June 30, 2010: EUR 179,238,510).
It includes also interests and fees payable to Enel S.p.A. mainly in relation to the intercompany guarantees, amounting
to EUR 13,522,740 (June 30, 2010: EUR 10,098,808).
The Company hedged the current accounts using currency swaps to limit the risk of exchange rate fluctuations.
Enel Finance International SA.
Alessandro Canta
Annex
"Enel Finance International S.A. - Accounting policies adopted"
1. General. ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A. (the "Company") is a company incorporated under Luxembourg
law on July 3, 1997. The registered office of the Company is 11, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg. The Company
is registered with the Register of Commerce and companies of Luxembourg under Section B, number 60.086.
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign
companies, the control, the management, as well as the development of these participations. The Company may also
perform any commercial, industrial, or financial operation. In a general fashion, the Company's activities are limited by
the requirements of the law of August 10, 1915, as modified, on commercial companies.
The Company is established for an indefinite duration.
The Company is a direct subsidiary of Enel S.p.A., Rome, a company registered in Italy whose consolidated accounts
are available at its registered office, Viale Regina Margherita 137, 00198 Rome, Italy.
Enel S.p.A. will provide financial support to the Company should it not be able to meet its obligations. Enel S.p.A. has
formally confirmed this intent in a comfort letter issued on August 4, 2010.
The Company also prepares consolidated financial statements that are published according to the provisions of the
law.
2. Significant accounting policies. The Company maintains its books and records in Euro ("EUR") and the financial
statements have been prepared in conformity with applicable legal requirements in Luxembourg including the following
significant accounting policies:
2.1 Shares in affiliated undertakings
Participations are stated at acquisition cost. Write-downs are recorded if, in the opinion of the Directors, there is any
permanent impairment in value. Earnings of the participations are recognised when, and to the extent, dividends are
received from the participations.
2.2 Amounts owed by affiliated undertakings
Receivables from related companies are stated at their nominal value. Write-downs are recorded if, in the opinion of
the Directors, there is any permanent impairment in value.
2.3 Creditors
Creditors are valued at the higher of nominal or repayment value.
2.4 Premium on borrowings
Premium on borrowings are accounted for in transitory accounts under assets or liabilities independently of borrowings
to which they are associated, and are depreciated prorata temporis over the life of the borrowing.
2.5 Cross currency interest rate swaps and cross currency swaps
109047
L
U X E M B O U R G
The Company hedged the Notes amount using cross currency interest rate swaps to limit the risk of exchange rate
fluctuations and to fix the EUR interest rate of the Notes. In the event of an exchange loss arising from the global
conversion of the Notes and cross currency interest rate swap, the loss is recorded to profit and loss account. Exchange
gain arising from this conversion is not recognized.
The Company hedged the Euro Commercial Papers amount using currency swaps to limit the risk of exchange rate
fluctuations at the end of each period. In the event of an exchange loss arising from the global conversion of the ECP and
currency swap, the loss is charged to profit and loss. The exchange gain arising from this conversion is not recognized.
2.6 Interest income and expenses
Interest income and expenses are recorded on an accrual basis.
2.7 Foreign currency translation
Current assets and liabilities stated in currencies other than EUR are translated at the exchange rates prevailing at the
date of the balance sheet. Transactions denominated in currencies other than EUR are translated at the rate of transaction.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are recorded in the profit and loss account.
2.8 Going concern
On July 26, 2010 the Board of Directors of the Company resolved to approve the transfer of the activities to the
Netherlands, as a consequence of a decision approved by the parent company, Enel S.p.A.
The transfer, aimed at concentrating in one jurisdiction the international financial activities of the Enel Group, will be
realized through a legal cross-border merger with a Dutch dormant company fully owned by Enel S.p.A. with effect as of
December 1, 2010, or such earlier or later date as may be the case.
The transaction will not imply a modification of the going concern basis of preparation of the interim accounts.
DOORLOPENDE TEKST van de Statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ENEL Finance
International N.V. (voorheen genaamd: ENEL Trading Rus N.V.), statutair gevestigd te Amsterdam, na akte houdende
partiële statutenwijziging op 4 Oktober 2010 verleden voor mr. M.Y.H.J. den Boer, notaris te Amsterdam (verklaring van
geen bezwaar, de dato 17 September 2010 nummer B.V. 1504468).
STATUTEN:
Naam en zetel:
Art. 1.
1. De vennootschap draagt de naam: ENEL Finance International N.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
Doel:
Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
a. de uitgifte, koop en verkoop van obligaties, schuldbrieven, aandelen, winstbewijzen, -opties en andere waardepa-
pieren van welke aard ook;
b. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;
c. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken
van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van
derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmede de vennootschap in een groep is verbonden;
d. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
e. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
f. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handels-
merken, installaties, procédés, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellec-
tuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren
van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten;
g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Kapitaal en uitgifte:
Art. 3.
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintig duizend euro (EUR 225.000),
verdeeld in tweehonderd vijfentwintig - duizend (225.000) aandelen, elk met een nominale waarde van een euro (EUR
1).
2. Uitgifte van aandelen zal geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als - door de algemene vergadering
van aandeelhouders te bepalen.
3. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale
nominale bedrag van de door hem gehouden aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die
109048
L
U X E M B O U R G
worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Een aandeelhouder heeft evenmin voorkeursrecht op aandelen die
worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
5. De vennootschap kondigt binnen twee weken na een besluit daartoe de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak
waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan de in het aandeel-
houdersregister vermelde adressen. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na
de dag van verzending van de aankondiging.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid als bedoeld in de leden 2 en 4 overdragen aan
een ander orgaan van de vennootschap voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald
hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
7. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
of tot aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is daartoe te besluiten, is een meerderheid van ten minste twee derden van
de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegen-
woordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het -besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het
handelsregister.
8. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een
recht tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitge-
geven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
9. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden
akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
10. De vennootschap kan bij de uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.
Aandelen en certificaten op naam van aandelen:
Art. 4.
1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
Uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De vennootschap kan haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten op naam van aandelen.
Storting op aandelen:
Art. 5.
1. Bij uitgifte van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een
deel, ten hoogste drie Vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal
hebben opgevraagd.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere wijze van inbreng is overeengekomen.
Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Indien in vreemd geld is gestort
wordt binnen twee weken na storting een verklaring van een bankier als bedoeld in artikel 2:93a lid 3 Burgerlijk Wetboek
ten kantore van het Handelsregister neergelegd.
3. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een
bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen.
4. Er wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand
op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor -de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen
een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Alle directeuren ondertekenen de beschrijving; ont-
breekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Over de beschrijving moet een accountant of, indien de wet dit toelaat, een accountant-administratieconsulent, een
verklaring afleggen.
6. Indien de directie overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:94b lid 3 Burgerlijk Wetboek besluit af te zien van de
opstelling van de beschrijving en accountantsverklaring als genoemd in de leden 4 en 5 van dit artikel, legt de vennootschap
niet later dan op de achtste dag voor de dag van inbreng een aankondiging neer ten kantore van het Handelsregister,
welke aankondiging dient te voldoen aan het bepaalde daaromtrent in de wet. Alle directeuren ondertekenen de aan-
kondiging; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt. Binnen een maand na de dag van inbreng -legt de vennootschap ten kantore van het Handelsregister een ver-
klaring neer waarin -wordt vermeld dat zieh in de periode tussen de aankondiging en de inbreng geen nieuwe bijzondere
omstandigheden ten aanzien van de waardering hebben voorgedaan.
7. Blijven een beschrijving en accountantsverklaring achterwege conform het bepaalde -in lid 6 van dit artikel, dan
kunnen een of meer houders van aandelen die op de dag - van het uitgiftebesluit alleen of gezamenlijk ten minste vijf
procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, en mits overigens aan het bepaalde in artikel 2:94b lid 5 Burgerlijk
109049
L
U X E M B O U R G
Wetboek is voldaan, van de directie verlangen dat het alsnog een beschrijving opmaakt waarover een accountantsver-
klaring wordt afgelegd. De directie geeft in de in artikel 2:94b Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen hieraan uitvoering.
Inkoop:
Art. 6.
1. De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen in haar kapitaal om niet te verkrijgen.
2. De vennootschap is voorts, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd voor eigen rekening volgestorte
aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen, indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden;
b. machtiging tot de verkrijging door de algemene vergadering van aandeelhouders is verleend. Deze machtiging geldt
voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen
mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
Voor het boven gestelde is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, ver-
minderd met de verkrijgingprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld
in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaat-
schappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de
jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
3. Onder het begrip aandelen zoals genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt mede verstaan certificaten van
aandelen.
4. Vervreemding door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal kan slechts -geschieden na goedkeuring
daartoe van, en onder de voorwaarden gesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover door de
algemene vergadering van aandeelhouders geen ander orgaan van de vennootschap voor een duur van ten hoogste vijf
jaar is aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.
5. De vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten
daarvan in de vennootschap zekerheid stellen, een koersgarantie afgeven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoof-
delijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt eveneens voor haar dochtermaatschappijen.
De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts leningen verstrekken met het oog op het nemen of
verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in de vennootschap als voldaan is aan het bepaalde in artikel
2:98c Burgerlijk Wetboek.
Het bovenstaande in dit lid geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door
of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
Kapitaalvermindering:
Art. 7.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door in-
trekking van aandelen of door verlaging bij statutenwijziging van de nominale waarde van de aandelen. In dit besluit dienen
de aandelen waarop het besluit betrekking heeft te worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven
minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan het de certificaten
houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting
moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering
van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet
naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
5. Van het vereiste van evenredigheid zoals bedoeld in de leden 3 en 4 mag worden afgeweken met de instemming van
alle betrokken aandeelhouders.
6. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van
de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
8. De vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer bij het Handelsregister en kondigt de
nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. De wettelijke procedure voor kapitaalvermindering dient terzake
gevolgd te worden.
109050
L
U X E M B O U R G
Aandeelhoudersregister:
Art. 8.
1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin de namen en de adressen van alle aandeel-
houders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en het aantal door hen
gehouden aandelen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Indien een aandeelhouder instemt met oproeping voor algemene vergaderingen van aandeelhouders langs elektroni-
sche weg, bevat het register tevens het e-mailadres van de betreffende aandeelhouder.
In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen, de adressen en, indien van toepassing, e-mailadressen van hen
die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht
hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen het stemrecht en de rechten
die de wet toekent aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten toekomen.
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen, adressen en, indien van toepassing, e-mailadressen van de
houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
4. ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en iedere houder van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
5. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders
kunnen rechtsgeldig geschieden aan de laatstelijk aan de vennootschap opgegeven adressen.
De houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de pandhouders en vruchtgebruikers
met stemrecht hierna ook gezamenlijk te noemen: "certificaathouders".
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden. ledere inschrijving en aantekening in het -register wordt getekend door
een directeur.
7. De directie van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder om
niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen:
Art. 9.
1. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De uit een aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan
de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker
voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
3. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
4. In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien dit bij de
vestiging van het recht van vruchtgebruik dan wel het pandrecht is bepaald.
5. Een aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de
rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
van aandelen.
6. Een vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend
aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
Levering van aandelen of beperkte rechten op aandelen:
Art. 10.
1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte
waarbij de betrokkenen partij zijn. Deze akte dient te worden verleden ten overstaan van een notaris met standplaats in
Nederland.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige
lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is dan wel deze
heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel
2:86a en artikel 2:86b Burgerlijk Wetboek.
Gemeenschap:
Art. 11. Indien aandelen of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tot een gemeen-
schap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich- slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen
persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan één
persoon aanwijzen. Indien de gemeenschap aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten - mits eenstemmig - bij
109051
L
U X E M B O U R G
de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn
aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in gemeenschap is gerechtigd.
Bestuur:
Art. 12.
1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren.
Ook rechtspersonen kunnen als directeur worden benoemd.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren vast.
4. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders -worden geschorst of ontslagen.
5. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maan-
den tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
6. Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan - de orde komt in de gelegenheid
gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
7. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het -beleid wordt vastgesteld door
de algemene vergadering van aandeelhouders. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot
en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Indien de
vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft - ingesteld, wordt het bezoldigingsbeleid
schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisgeving aan de
ondernemingsraad aangeboden.
8. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene
vergadering van aandeelhouders.
9. Bij ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur of zijn de overblijvende directeuren met
het besturen van de vennootschap belast.
Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door
een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.
Taak en bevoegdheden:
Art. 13.
1. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. Aan iedere directeur
komt één stem toe. Indien de stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.
De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor
het voorstel hebben uitgesproken.
3. Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
4. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle directeuren, waar ter
wereld zij ook zijn. wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een directievergadering te vormen tenzij
een directeur zich daartegen verzet.
De door de voorzitter van de directie of, indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, de door een directeur
gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van
alle noodzakelijke formaliteiten.
5. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze Statuten. Voorts kunnen de directeuren, al dan
niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directie
omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder
in ieder geval wordt verstaan:
- de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of -een dochtermaatschappij met een
andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap ten waarde van ten minste een derde
van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennoot-
schap, door haar of een dochtermaatschappij.
7. In aanvulling op het bepaalde in het voorgaande lid, behoeft de directie de goedkeuring van de algemene vergadering
van aandeelhouders voor zodanige besluiten als de algemene vergadering van aandeelhouders bij haar specifiek omschre-
ven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
109052
L
U X E M B O U R G
8. Het ontbreken van de ingevolge de voorgaande leden van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
9. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders op te volgen omtrent de
algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
10. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; zij hebben in deze
vergaderingen een adviserende stem.
11. De directie is niet bevoegd zonder opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders aangine te doen tot
faillietverklaring van de vennootschap.
Vertegenwoordiging:
Art. 14.
1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door twee
gezamenlijk handelende directeuren.
2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft, kan de vennootschap niettemin
door die directeur(en) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd, met inachtneming van het bepaalde in lid 1. De algemene
vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen, waaronder begrepen de directeur ten
aanzien van wie het tegenstrijdig belang bestaat, daartoe aan te wijzen.
3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming
van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te
worden ingeschreven in het Handelsregister. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of
jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps of huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal
van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze -aandeelhouder of door
een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor -de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden
door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan
de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.
5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.
Boekjaar, Jaarrekening en jaarverslag:
Art. 15.
1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit
binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering
van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst-
en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken voor de aandeelhouders ter inzage ten
kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan,
onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk
Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun
behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen deze stukken aldaar inzien
en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk
Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap
geldt, dan wel indien als gevolg van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 7
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt niet vastgesteld
indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 6 bedoelde accoun-
tantsverklaring, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te verlenen teneinde de door de directie opgemaakte
jaarrekening -te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en een verklaring af te leggen.
7. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant
als bedoeld in lid 6 van dit artikel, geschiedt het verlenen van deze opdracht door de directie.
8. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en het orgaan
dat de opdracht heeft verleend.
109053
L
U X E M B O U R G
Winstbestemming:
Art. 16.
1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst en verliesrekening.
2. De winst van de vennootschap Staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij staking
van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt ten behoeve van de vennootschap geen winstuitkering gedaan.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is en met
inachtneming van het bepaalde in lid 7.
4. Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de
verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
5. De directie kan, op voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde
in lid 7, uit de nog niet vastgestelde winst interim dividend uitkeren.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in lid 7, besluiten tot uitke-
ringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, venneerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden.
8. De vordering tot uitbetaling van een uitkering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop bedoelde uitkering
betaalbaar wordt gesteld.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders:
Art. 17.
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar - behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend welke onder meer
bestemd is tot:
a. de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige
gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het verlenen van een eventuele décharge aan de directeur(en);
d. het vaststellen van de winstbestemming;
e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft.
Indien er uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, zullen de onderwerpen genoemd in de vorige zin
behandeld worden in een algemene vergadering van aandeelhouders welke niet later dan een maand na de datum tot
waarna het uitstel is verleend dient te worden gehouden.
2. Bovendien wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de directie of een directeur
dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één directeur of één of meer personen,
gerechtigd tot het gezamenlijk uit brengen van ten minste tien procent (10%) van het totaal aantal stemmen dat kan
worden uitgebracht, haar dit schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, onder nauwkeurige opgave van de te behan-
delen onderwerpen verzoeken.
Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na
ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met
inachtneming van het daaromtrent in deze Statuten bepaalde.
Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld.
4. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot de algemene vergadering van aandeelhouders moet
uiterlijk geschieden door of namens de directie op de vijftiende dag voor de vergadering, per oproepingsbrief, met ver-
melding van de punten van behandeling. Indien een aandeelhouder alsmede een certificaathouder hiermee instemt, kan
de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door hem voor dit -doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
5. Niettemin kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen indien geen
oproeping conform lid 4 plaats vond, of het betreffende punt niet bij de oproeping werd vermeld, mits het gehele geplaatste
kapitaal en alle certificaathouders op de vergadering zijn vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt
genomen.
6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, is verzocht door een
of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1 %) van het geplaatste kapitaal van de ven-
nootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de ven-
109054
L
U X E M B O U R G
nootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
Voor de toepassing van dit lid, worden certificaathouders met aandeelhouders gelijkgesteld.
7. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is
gevestigd. Zij kunnen eiders worden gehouden, indien het gehele geplaatste kapitaal en alle certificaathouders ter verga-
dering vertegenwoordigd zijn.
8. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie en, indien de directie geen voorzitter
heeft aangewezen of de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige
directeur.
Is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
9. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de
notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden
opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen
niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de -notaris voldoende.
10. ledere aandeelhouder en iedere certificaathouder is gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij
te wonen en daarin het woord te voeren. Iedere aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker met stemrecht is ge-
rechtigd op de algemene vergadering van aandeelhouders het stemrecht uit te oefenen.
11. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijke
volmacht (waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) doen vertegenwoordigen.
12. Iedere aandeelhouder is tevens bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde (waaronder ook
begrepen per elektronische volmacht) door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene verga-
dering van aandeelhouders deel te nemen daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, zulks onder door
de directie te stellen voorwaarden. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders dient de betreffende
voorwaarden te vermelden.
13. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 12 is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatie-
middel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het
stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging.
14. Lid 12 en 13 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten van certificaathouders.
15. Stemmen voor een algemene vergadering van aandeelhouders die via een elektronisch communicatiemiddel voo-
rafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die
tijdens de vergadering zijn uitgebracht. Dit kan niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Aldus
uitgebrachte stemmen worden geacht geldig te zijn onverminderd enige overdracht van de betreffende aandelen nadien.
De directie stelt de voorwaarden vast waaronder stemmen voorafgaande aan de vergadering dient te geschieden en
vermeld deze in de oproeping.
16. Voor de toepassing van lid 15 hebben als stemgerechtigden te gelden zij die op een bij de oproeping van een
algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een
door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rech-
thebbenden op de aandelen zijn. De uiterste dag van de registratie kan niet eerder dan op de dertigste dag voor die van
de vergadering worden gesteld.
17. Bij de oproeping wordt de dag van de registratie vermeld, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerech-
tigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
18. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk
worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders en mits alle directeuren
in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per telefax
alsmede langs elektronische weg. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan besluitvorming langs elektronische weg.
Een dergelijk genomen besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Deze wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.
Art. 19.
1. Voor zover niet anders bepaald in de wet of deze Statuten, worden alle besluiten van de algemene vergadering van
aandeelhouders genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochter-
maatschappij kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor
een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders
van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht
uitgesloten indien het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het aandeel aan de vennootschap of een
109055
L
U X E M B O U R G
dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor
aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een
bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen
waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is doorslaggevend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering van aandeelhouders
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit ver-
langt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Één of meer aandeelhouders
of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het
recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te
nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
7. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
8. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op het kantoor van de vennoot-
schap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt
desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Statutenwijziging en ontbinding:
Art. 20.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de Statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden.
2. Een voorstel tot wijziging van de Statuten dient bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders
te worden vermeld; de aandeelhouders en certificaathouders kunnen desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstel
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen van de vennootschap verkrijgen. Het voorstel tot wijziging
van de Statuten dient op het kantoor van de vennootschap woordelijk te zijn neergelegd vanaf de dag van oproep tot na
afloop van de vergadering.
3. Na een besluit tot ontbinding van de vennootschap blijven deze Statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie
van kracht.
4. Liquidatie van de vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders
anders bepaalt.
5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan
de aandeelhouders in verhouding tot het nominale bedrag van ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap
zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap plaatsvinden.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven
jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien
een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaar(s).
UITGEGEVEN VOOR DOORLOPENDE TEKST
Mr M.Y.H.J den Boer.
Notariste Amsterdam
( <i>N.B. Pour des raisons techniques, la deuxième partie est publiée au Mémorial C-N° 2273 du 25 octobre 2010.i> )
Référence de publication: 2010140216/1836.
(100160762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
109056
3D Luxembourg S.A.
A.L.D. Participations S.A.
Alpha Personnel System S.A.
Am Haferstück S.A.
Apaj Holding S.A.
Assay Finances S.à r.l.
as you like it
as you like it
BCM (Luxembourg) SA
Best Buy International Finance S.à r.l.
Boesen Ihr Gärtner
B.V.D.
Cerlux S.A.
CHARON HOLDING Société Anonyme
Chephar S.A.
Citibank International plc (Luxembourg Branch)
C.M.W. Canadian Mineral Water Development S.A.
Credit Suisse - Zweigniederlassung Luxemburg
Duro-Lux S.A.
Edita S.A.
Enel Finance International S.A.
Fahri-Lux S.à r.l.
F&C Fund
Fredcat Investments
GSLP I Onshore S.à r.l.
"Jardinage de la Moselle S.à r.l."
Lancelot Sàrl
Pelvis S. à r.l.
Polygraphic Communication S.A.
Proteus Shipping S.A.
SA Paul Zanzen (Succursale de Luxembourg)
SA Paul Zanzen (Succursale de Luxembourg)
Sinopia Multi Index Fund
Sunningdale Properties II S.A.
SunRelaX S.à r.l.
Thistle S.A.
Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl
Tobacco World S.A.
Tradinggate S.A.
Trilantic Capital Partners IV (Europe) Investors S.C.A.
Urals Luxembourg Sàrl
Voltige Luxembourg
Wildhog Industries S.à r.l.
Willemoes Invest Holding S.à r.l.
Yago Immobilière S.A.
Ydulux S.A.
Yellow Invest S.A.