This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2208
18 octobre 2010
SOMMAIRE
Allard Invest Holding Bresil S.à r.l. . . . . . .
105984
Ambassador TE, Ambassador TX, WB
Ambassador Holdings S.e.n.c. . . . . . . . . . .
105984
Argusvalentines S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105978
Cameron Holding (Luxembourg) Sàrl . . .
105945
Cameron Lux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105945
Cerac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105954
DS Care S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105947
EFB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105941
ELRO Tankschiff S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
105941
Entreprise Vert 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
105962
Entreprise Vert 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
105970
Eurotank S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105944
F. 20 S. O. S. Techniques S.à r.l. . . . . . . . . .
105983
FDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105950
Felten-Stein Immobilière S.à.r.l. . . . . . . . . .
105954
Felten-Stein Immobilière S.à.r.l. . . . . . . . . .
105947
Finfrères Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105945
Foncière CG & Associés S.A. . . . . . . . . . . . .
105947
Foncière des Alpes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
105950
F & S S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105954
F & S S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105947
Gebäudereinigung Peifer S. à r.l. . . . . . . . .
105953
HIC Group International Luxembourg . . .
105950
Idamante S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105938
Iena Buildings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105954
Immobilière Maybach S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
105954
Immobilière Rannerwé S.à r.l. . . . . . . . . . . .
105953
International Fair Consulting S.A. . . . . . . .
105961
International Oil Transport S.A. . . . . . . . . .
105961
Investical Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
105969
Jyrom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105961
Kaslion S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105980
Klenke Schifffahrt S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . .
105961
La Financière Montbrillant S.A. . . . . . . . . .
105970
La Financière Montbrillant S.A. . . . . . . . . .
105977
Lanus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105977
Librairie LE MONDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105977
Lorca Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
105978
Luxor Thebes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105978
Luxsteel Equipment & Trading S.à r.l. . . .
105970
Lynceus Financial Consult S. à r. l. . . . . . . .
105978
Modern Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
105979
Modulor Menuiserie + Design S.A. . . . . . . .
105940
Modulor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105950
Modulor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105940
Morgan Stanley Europe Reinsurance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105969
Morgan Stanley Luxembourg Holdings
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105984
Morisot Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
105979
Neuvimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105979
OQUENDO Management S.à r.l. . . . . . . . .
105949
Ostholt Tankschiff S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
105983
OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l. . . . . . . .
105983
Parc Breidfeld sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105953
Pissaro Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
105983
PLH Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
105983
Polytrinity Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
105984
ProCom Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105979
Reinbro Investments SA . . . . . . . . . . . . . . . .
105969
Svea Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105941
Unifida Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105979
105937
L
U X E M B O U R G
Idamante S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.825.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 152.516.
EXTRAIT
En date du 10 juin 2010, chacun des associés suivants a cédé le nombre de parts sociales indiqué à côté de son nom
à Fourth Cinven Fund FCPR un fonds commun de placements à risques de droit français, géré par Cinven S.A., une société
anonyme de droit français, dont le siège social est situé au 4, place Edouard VII, 75009 Paris, France, enregistré auprès
du Registre des Sociétés de Paris sous le numéro B 424 123 487, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le
numéro GP07000004;
- Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV)
Limited Partnership, agissant à son tour par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited inscrite auprès
du Companies House sous le numéro LP011037 a transféré un total de 5,437,200 parts sociales (543.720 parts sociales
de chacune des classes A à J);
- Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV)
Limited Partnership, agissant à son tour par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited inscrite auprès
du Companies House sous le numéro LP011034 a transféré un total de 5,673,200 parts sociales (567.320 parts sociales
de chacune des classes A à J);
- Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership, agissant par son General Partner, Cinven Capital Manage-
ment (IV) Limited Partnership, agissant à son tour par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited
inscrite auprès du Companies House sous le numéro LP011035 a transféré un total de 5,624,700 parts sociales (562.470
parts sociales de chacune des classes A à J);
- Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV)
Limited Partnership, agissant à son tour par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited inscrite auprès
du Companies House sous le numéro LP011142 a transféré un total de 5,368,000 parts sociales (536.800 parts sociales
de chacune des classes A à J);
- Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership, agissant par son General Partner, Cinven Capital Management (IV)
Limited Partnership, agissant à son tour par son General Partner, Cinven Capital Management (IV) Limited inscrite auprès
du Companies House sous le numéro LP011036 a transféré un total de 3,020,000 parts sociales (302.000 parts sociales
de chacune des classes A à J).
Suite au transfert, les parts sociales de la Société sont détenues par les associés tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous:
Associé
Classe de
part
sociale
Nombre de
parts
détenues
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
56,260
Total Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
56,260
Total Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
5,736,250
105938
L
U X E M B O U R G
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
56,260
Total Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
56,260
Total Classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
56,260
Total Classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
279,150
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F
56,260
Total Classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
279,150
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G
56,260
Total Classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
56,260
Total Classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
5,736,250
105939
L
U X E M B O U R G
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
279,150
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
56,260
Total Classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
5,497,630
Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
5,736,250
Fourth Cinven Fund (No.3 - VCOC) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
5,687,280
Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
5,427,600
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
3,053,520
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
2,512,310
Fourth Cinven Fund Co-Investment Patnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
279,150
Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J
56,260
Total Classe J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,250,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282,500,000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2010.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2010121287/133.
(100137031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Modulor Menuiserie + Design S.A., Société Anonyme,
(anc. Modulor S.A.).
Siège social: L-7526 Mersch, 11, allée John W. Leonard.
R.C.S. Luxembourg B 155.296.
STATUTS
L'an deux mille dix, le trois septembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MODULOR S.A.", ayant son
siège social à L-7526 Mersch, 11, allée John W. Leonard, R.C.S Luxembourg section B en cours, constituée suivant acte
reçu le 9 août 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Kai HENGEN, menuisier,
demeurant à L-9831 Consthum, 2A, rue Knupp.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 320 (trois cent vingt) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale de la société en MODULOR MENUISERIE + DESIGN S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité la résolution suivante:
105940
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution unique:i>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en MODULOR MENUISERIE + DESIGN S.A. et
de modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par
les présents statuts dénommée: MODULOR MENUISERIE + DESIGN S.A.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, K. HENGEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 septembre 2010. Relation: LAC/2010/38987. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
Référence de publication: 2010121134/40.
(100137605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
EFB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5570 Remich, 35, rue de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 106.068.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour EFB S.A.
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121039/13.
(100137099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
ELRO Tankschiff S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6231 Bech-Lilien, Maison 5.
R.C.S. Luxembourg B 110.066.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour ELRO TANKSCHIFF SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121041/13.
(100137100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Svea Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 115.995.
In the year two thousand ten, the seventeenth of August.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Svea Holding S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (Société à responsabilité limitée) having its registered office at 9A, Parc D’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, with a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 115.995 (the Company). The Company was incorporated on 28 April 2006 pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations - N° 1323 date 8 July 2006. The articles of association of the Company (the Articles)
105941
L
U X E M B O U R G
have been amended most recently by a notarial deed of Maître Gerard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, dated 1 December 2009, published in the Mémorial C, number 299 of February 11, 2010.
There appeared:
Altor 2003 GP Limited, a company duly incorporated under the laws of Jersey, with registered office at 11-15, Seaton
Place, St Helier, Jersey JE4 0QH, and registered with the JFSC Companies Registry under number 84811 as general partner
of the Altor 2003 Fund (the Sole Shareholder);
hereby represented by Mrs. Anke Jager, employee, residing at 9A, Parc D’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, by virtue
of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That all of the 500 (five hundred) shares having a par value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, representing the
entire subscribed share capital of the Company of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred Euros) are duly re-
presented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
3. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
4. Appointment of the auditor (commissaire aux comptes) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the
Auditor);
5. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
and
6. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates.
III. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring itself to have perfect knowledge
of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary
liquidation (liquidation volontaire).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited
liability company (société anonyme) having its registered office at 9a, Parc D’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, and
registered with the Luxembourg trade and companies registered under number B 131.192; as Liquidator.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Aztec Financial Services (Jersey) Ltd., a Jersey limited company having its
registered office at 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE40QH, as Auditor.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the
Luxembourg act on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).
The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the
circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all
operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior autho-
risation of the general meeting of the shareholder(s) of the Company. The Liquidator may delegate his powers for specific
defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the
operations and tasks so delegated.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liqui-
dation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholder(s) of the Company, in
accordance with article 148 of the Law.
105942
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the directors (gérants) of the Company for the performance
of their respective mandates until the date hereof.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing
party, in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le dix-sept août.
Par-devant Maitre Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblé) des associés de Svea Holding S.à r.l., une société a
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
avec un capital social de 12.500 EUR (douze mille cinq cent euros) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.995 (la Société). La Société a été constituée le 28 avril 2006 en vertu
d'un acte de Maitre Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publie au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N° 1323 du 8 juillet 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
pour la dernière fois le 1
er
décembre 2009 par un acte de Maitre Gérard Lecuit, résidant à Luxembourg au Grand-Duché
de Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 299 du 11 février 2010.
A comparu:
Altor 2003 GP Limited, une société constituée sous le droit de Jersey, ayant son siège social à 11-15, Seaton Place, St
Helier, Jersey JE4 0QH, et enregistrée auprès du JFSC Companies Registry sous le numéro 84811 (l'Associe Unique);
ci-après représenté par Mme. Anke Jager, employée privée, demeurant professionnellement au 9A, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, en vertu d'une procuration donnée par acte sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L'Associe Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'integralite des 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune,
représentant l’intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents
euros), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme dûment constituée
et apte à valablement délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;
II. Que l’ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
3. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
4. Nomination du commissaire aux comptes en vue de la liquidation volontaire de la Société le commissaire);
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
et
6. Décharge (quitus) accorde aux gérants pour l'exercice de leurs mandats respectifs.
III. L'Associé Unique approuve les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, L’Assemblée décide de renoncer
aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant comme dûment convoque et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communique par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
105943
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit lu-
xembourgeois, ayant son siège social au 9A, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, et enregistrée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.192, en tant que Liquidateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Aztec Financial Services (Jersey) Ltd, une société de Jersey, ayant son siège social
au 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE40QH, en tant que Commissaire à la liquidation.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).
L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,
afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de
la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de L’assemblée
générale du/des associé(s). Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres taches
a une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seule responsabilité des opérations et taches ainsi déléguées.
L'Associe Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en
liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, a sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation à / aux associe(s), conformément à l’article 148
de la Loi.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs
jusqu'à la date des présentes.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi
Dont acte, fait et passe, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
signé: A. JAGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 août 2010. Relation: LAC/2010/36977. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 septembre 2010.
Référence de publication: 2010120719/160.
(100136931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Eurotank S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 137.692.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
105944
L
U X E M B O U R G
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour EUROTANK SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121046/13.
(100137101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Finfrères Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 83.808.
Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2010.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2010121059/12.
(100137317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Cameron Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Cameron Holding (Luxembourg) Sàrl).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.440.
In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of August,
Before us Maître Paul BETTINGEN notary residing in Niederanven.
There appeared:
CAMERON LUX I SARL, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands and having transferred its
registered office and its central administration to the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 151 003,
duly represented by Me Cécile JAGER, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg on August 25, 2010.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed entity CAMERON LUX I SARL, is the sole partner of CAMERON HOLDING (LUXEMBOURG) SARL,
a private limited liability company having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of undersigned notary on December 17, 2002, published in Mémorial C
number 116 on February 5, 2003 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
registration number B 90 440 (“the Company”),
The articles of incorporation of the Company have been amended last by deed of the undersigned notary on December
21, 2009, published in the Mémorial C number 776 on April 14, 2010.
Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as
follows:
That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to change the name of the Company from Cameron Holding (Luxembourg) S.à r.l. into Cameron Lux II
S.à r.l.;
2. Decision to transfer the registered office of the Company from 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
to 26 Bd Royal, L-2449 Luxembourg;
3. Subsequent amendment of articles of the Company’s by-laws so as to reflect the proposed amendments.
Then, the sole partner takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner resolves to change the name of the Company from “CAMERON HOLDING (LUXEMBOURG) SARL”
into “Cameron Lux II S.à r.l.”
105945
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolves to transfer the registered office of the Company from 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg to 26 Bd Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner resolves to amend article 2 of the by-laws of the Company in order to reflect the above resolutions,
which now reads as follows:
“ Art. 2. The denomination of the Company is “Cameron Lux II S.à r.l.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000).
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, whom is known to the notary, by her surname, Christian
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le trente août.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
CAMERON LUX I SARL, une société constituée sous le droit des Iles Cayman et ayant transféré son siège statutaire
et son administration centrale su Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg et enregistrée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151 003,
représentée par Me Cécile JAGER, avocat à la Cour, ayant sa résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Luxembourg le 25 août 2010.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant le comparant susnommé et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La société prénommée, CAMERON LUX I SARL est l’associé unique de CAMERON HOLDING (LUXEMBOURG)
SARL, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné date du 17 Décembre 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 février 2003, sous le numéro 116 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Société de et à Luxembourg sous le numéro B 90 440 («la Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 21 décembre 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 avril 2010 numéro 776.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de changer le nom de la Société de «Cameron Holding (Luxembourg) S.à r.l.» en « Cameron Lux II S.à
r.l.»;
2. Décision de transférer le siège social de la Société du 13-15 Avenue de la Liberté au 26 Bd Royal, L-2449 Luxembourg;
3. Modification subséquente des statuts de la Société afin de refléter les modifications envisagées.
Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de “CAMERON HOLDING (LUXEMBOURG)
SARL” en “Cameron Lux II S.à r.l.”
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique de la Société décide de transférer le siège social de la Société actuellement situé au 13-15 Avenue de
la Liberté au 26 Bd Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, pour
lui donner la teneur suivante:
105946
L
U X E M B O U R G
« Art. 2. La dénomination sociale de la Société est “Cameron Lux II S.à r.l.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à mille euros (EUR 1.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Cécile Jager, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 septembre 2010. LAC / 2010 / 38453. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 septembre 2010.
Référence de publication: 2010121010/104.
(100137314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
F & S S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Felten-Stein Immobilière S.à.r.l.).
Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 20.098.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010121047/10.
(100137147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Foncière CG & Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 101.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121049/10.
(100137163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
DS Care S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 18.267.120,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 135.455.
L’an deux mille dix, le trente et unième jour d’août.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DS CARE S.A., avec siège social au 14,
rue du Marché aux Herbes, L – 1728 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
13 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 395 du 15 février 2008, imma-
triculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135455 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
19 février 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 725 du 7 avril 2010.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Zandona, demeurant professionnellement au 12 rue
Léon Laval, L – 3372 Leudelange,
105947
L
U X E M B O U R G
qui désigne comme secrétaire Madame Claudia Schweich, demeurant professionnellement au 14 rue du Marché aux
Herbes, L – 1728 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Zandona, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social d’un montant de EUR 1 548 714 aux fins de porter son montant actuel de EUR 16
718 406 au montant de EUR 18 267 120 par l’émission de 1 548 714 nouvelles actions d’une valeur nominale de 1,- EUR
chacune, partiellement libérées.
2. Souscription des 1 548 714 nouvelles actions par les actionnaires existants et pour autant que de besoin renonciation
à leur droit de souscription préférentiel; - Libération partielle des nouvelles actions comme suit:
- 688 645 actions par Luxempart SA et libérées en espèces à hauteur de EUR 180.086;
- 688 645 actions par Defi EuroCap III et libérées en espèces à hauteur de EUR 180.086;
- 171 424 actions par Sinequanon Health Care SA et libérées en espèces à hauteur de EUR 44.828.
3. Modification de l’article 5 paragraphe 1 des statuts qui aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à dix-huit
millions deux cent soixante sept mille cent vingt euros (EUR 18 267 120) représenté par dix-huit millions deux cent
soixante sept mille cent vingt (18 267 120) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune».
4. Acceptation par l’Assemblée de la démission de Monsieur Alain Huberty en qualité d’administrateur B et décharge
spéciale.
5. Nomination de Monsieur Laurent Zandona en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
„ne varietur“ par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital
social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à
l’ordre du jour. L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première et Deuxième résolutionsi>
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant d’ un million cinq
cent quarante-huit mille sept cent quatorze euros (EUR 1.548.714) aux fins de porter son montant actuel de seize millions
sept cent dix-huit mille quatre cent six euros (EUR 16.718.406) au montant de dix-huit millions deux cent soixante-sept
mille cent vingt euros (EUR 18.267.120) par l’émission d’un million cinq cent quarante-huit mille sept cent quatorze
(1.548.714) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 1 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les 1.548.714 nouvelles actions sont souscrites à l’instant par les actionnaires existants comme suit:
- LUXEMPART, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372
Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 27846, ici représentée par Monsieur Laurent Zandona, précité, en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé le 17 août 2010 à Leudelange, qui déclare souscrire 688.645 actions nouvellement émises et les libérer par-
tiellement par un apport en espèces à hauteur de cent quatre-vingt mille quatre-vingt-six euros (EUR 180.086).
- DEFI EuroCap III, L.P., un limited partnership de droit de Jersey, numéro de registre LP 806 représentée par DEFI
EuroCap III PARTNERS LIMITED en sa qualité de General Partner avec siège social au 22 Grenville Street, St Helier JE4
8PX, certificat d’incorporation numéro 94394, ici représentée par Monsieur Laurent Zandona, précité, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé le St Helier, Jersey, le 19 août 2010, qui déclare souscrire 688.645 actions nouvel-
lement émises et les libérer partiellement par un apport en espèces à hauteur de cent quatre-vingt mille quatre-vingt-six
euros (EUR 180.086).
- Sinequanon Health Care S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 14, rue du
Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 136999 ici représentée par Madame Claudia
Schweich précitée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 23 août 2010, qui déclare
souscrire 171.424 actions nouvelles et les libérer partiellement par un apport en espèces à hauteur de quarante-quatre
mille huit cent vingt-huit euros (EUR 44.828).
L’apport en espèces d’un montant quatre cent cinq mille euros (EUR 405.000) est à la disposition de la Société ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
105948
L
U X E M B O U R G
Ensuite, l'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits apports et d'attribuer les 1.548.714
nouvelles actions aux apporteurs conformément à leurs souscriptions telles que détaillées ci-dessus.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'Article 5
des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. §1. Le capital social est fixé à dix-huit millions deux cent soixante sept mille cent vingt euros (EUR 18.267.120)
représenté par dix-huit millions deux cent soixante sept mille cent vingt (18.267.120) actions d’une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune».
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’acter et accepter la démission de Monsieur Alain Huberty au poste d’ad-
ministrateur B de Société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer Monsieur Laurent ZANDONA, analyste financier, né le 10 juillet
1980 à Metz, demeurant professionnellement au 12 rue Léon Laval, L – 3372 Leudelange, en qualité d’administrateur du
groupe B, qui achèvera le terme du mandat de son prédécesseur à savoir pour une période qui expirera lors de l'assemblée
annuelle de 2012.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’Article 26, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Leudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Claudia Schweich, Laurent Zandona,, Paul Bettingen
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 02 septembre 2010. LAC / 2010/ 38455. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 septembre 2010.
Référence de publication: 2010121032/107.
(100137411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
OQUENDO Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 128.638.
II a été communique à la Société que son associé unique a changé sa dénomination sociale de WALBROOK TRUSTEES
(GUERNSEY) LIMITED en BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent Administratif
i>Signature
Référence de publication: 2010121140/15.
(100137321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105949
L
U X E M B O U R G
FDF, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 72.929.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010121053/9.
(100137300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Foncière des Alpes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 96.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121060/10.
(100137162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
HIC Group International Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 58.744.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Référence de publication: 2010121073/10.
(100137295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Modulor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, 11, allée John W. Leonard.
R.C.S. Luxembourg B 155.296.
STATUTS
L'an deux mille dix, le neuf août.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
Monsieur Kai HENGEN, menuisier, demeurant à L-9831 Consthum, 2A, rue Knupp.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclarent
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par
les présents statuts dénommée: MODULOR S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Mersch.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration respectivement de l'administrateur unique' dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg
et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
105950
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 4. L'objet de la Société est l’exploitation d’une menuiserie ainsi que l’achat et la vente de mobilier et des accessoires
de décoration.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières
qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que
ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 7. Le capital souscrit est fixé à trente deux mille (32.000,-) euros, représenté par trois cent vingt (320) actions de
cent (100.-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration
Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administrateur pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Art. 9. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les
affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes
aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en
cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué. En toutes hypothèses, le titulaire de l’autorisation d’établissement doit être parmi les signa-
taires.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n'excédant pas six années.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires
et prend les décisions par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil d’administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire
des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses
engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment le conseil d’administration préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée
ensemble avec le bilan.
105951
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Tout actionnaire et tout détenteurs d’options ou de promesses de vente d’actions peut prendre communi-
cation au siège social de la Société de tous documents comptables de la société.
Art. 15. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué entre les actionnaires après remboursement de tous comptes courants
d’actionnaires ou avances effectuées par les porteurs d’actions ou de promesses de vente d’actions.
Néanmoins, les actionnaires peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale,
le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 16. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Loi applicable
Art. 19. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit de la manière suivante:
Nombre
d’actions
Capital
souscrit
Kai HENGEN, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
32.000,-
EUR
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 32.000,- EUR (trente-deux mille
euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2011.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé administrateur unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Kai HENGEN, menuisier, demeurant à L-9831 Constum, 2A, rue Knupp, né le 11 août 1979.
La Société se trouvera engagée conformément à l’article 9 des statuts.
2. Le siège social de la Société est établi à L-7526 Mersch, 11, allée John W. Leonard.
105952
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: K. HENGEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 août 2010. Relation: LAC/2010/35819. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Référence de publication: 2010121133/137.
(100137605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Gebäudereinigung Peifer S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 113.792.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour GEBÄUDEREINIGUNG PEIFER SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121063/13.
(100137103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Immobilière Rannerwé S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
R.C.S. Luxembourg B 134.624.
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 31 mai 2010 que l’associé existant de la société IMMOBILIERE
RANNERWE SARL
IMMO C. JANS & ASSOCIES S.A., avec siège à L – 9651 Eschweiler/Wiltz, 4, Rue Tom
a transféré avec effet au 31 mai 2010 ses 50 (cinquante) parts sociales de la société d’une valeur de 140,00 € (cent
quarante euros) chacune à :
la société anonyme MSJCG PARTICIPATIONS S.A., avec siège à L – 9651 Eschweiler/Wiltz, 4, Rue Tom, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch sous le numéro B 139 033.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eschweiler/Wiltz, le 31 mai 2010.
IMMOBILIERE RANNERWE SARL
<i>Les gérantsi>
Référence de publication: 2010121077/18.
(100137309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Parc Breidfeld sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
R.C.S. Luxembourg B 134.790.
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 31 mai 2010 que l’associé existant de la société PARC BREIDFELD
SARL
IMMO C. JANS & ASSOCIES S.A., avec siège à L – 9651 Eschweiler/Wiltz, 4, Rue Tom
a transféré avec effet au 31 mai 2010 ses 50 (cinquante) parts sociales de la société d’une valeur de 140,00 € (cent
quarante euros) chacune à :
la société anonyme MSJCG PARTICIPATIONS S.A., avec siège à L – 9651 Eschweiler/Wiltz, 4, Rue Tom, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Diekirch sous le numéro B 139 033.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
105953
L
U X E M B O U R G
Eschweiler/Wiltz, le 31 mai 2010.
PARC BREIDFELD SARL
<i>Les gérantsi>
Référence de publication: 2010121149/18.
(100137310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Iena Buildings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 99.037.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121086/10.
(100137166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Immobilière Maybach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 84, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 72.405.
Le bilan au 31.12.2009 de la société IMMOBILIERE MAYBACH S.à r.l. a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2010121087/13.
(100137116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
F & S S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Felten-Stein Immobilière S.à.r.l.).
Siège social: L-1818 Howald, 14, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 20.098.
Le bilan au 31.12.2008 de la société IMMOBILIERE MAYBACH S.à r.l. a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2010121088/13.
(100137147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Cerac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 155.298.
STATUTES
In the year two thousand ten, on the twentieth day of August.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard LECUIT,
notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.
There appeared the following:
1) Mr Zohar Yami, Senior Vice President, Business Development, born on the 4
th
day of November, 1971 in Rishon
Le Zion, Israel, residing at 183, Gilboa Street, Nirit, Israel;
2) Mr Adam Ofek, Company Director, born on the 7
th
day of March, 1963 in Florence, (Italy), residing at 16, Remez
Street, Bney Brak, Israel;
105954
L
U X E M B O U R G
3) Mr Ron Weissberg, Private Investor, born on the 17
th
day of September, 1957 in Haifa, Israel, residing at 7,
Hamitnahalim Street, Savyon 56905, Israel;
all here represented by Mr Scott Mckinlay, employee, residing professionally in Schuttrange,
acting by virtue of three proxies given on August 10, 2010,
which proxies after having been signed “ne varietur” by the undersigned notary and the proxyholder, will remain
attached to the present deed in order to be registered with it.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of “CERAC S.A.”
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Schuttrange.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the development, construction
and ownership in wind farms or other forms of renewable energy. Within these limits the corporation may carry out all
business and tasks necessary or useful in order to fulfill this purpose.
The corporation may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits
established by the law.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at THIRTY ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) re-
presented by ONE MILLION SHARES (1,000,000) with no par value.
The authorized capital of the corporation is fixed at EIGHTEEN MILLION EURO (18,000,000.- EUR) to be divided
into ONE MILLION (1,000,000) shares with no par value.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations of the present deed increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
105955
L
U X E M B O U R G
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders,
shall fall within the competence of the board of directors.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be re-elected and removed at any time.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the fourth Friday of May at 12 a.m. and the first time in the year 2011. If such day
is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the
general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1
st
of January and shall terminate on the 31
st
of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31
st
of December 2010.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments thereto.
105956
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and Paymenti>
The appearing parties declare that the shares have been subscribed to as follows:
1) Mr Zohar Yami, prenamed, - 30,438 shares
2) Mr Adam Ofek, prenamed, - 769,562 shares
3) Mr Ron Weissberg, prenamed, - 200,000 shares
TOTAL: 1,000,000 shares,
All the shares have been paid up in cash to the extent of 100%. The result is that as of now the company has at its
disposal the sum of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000) as it was certified to the notary executing this
deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Estimation - Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand three hundred
euros (1,300.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at five and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2015:
1) Mr Helmut Krausser, Managing Director, born on the 3
rd
day of February, 1953 in Bitterfeld, Germany, residing
at 4, An der Sorge, D-06749 Bitterfeld-Wolfen;
2) Mr Adam Broncel, Businessman, born on the 30
th
day of October, 1966 in Lodz, Poland, residing at Ul.Pononcna
34/3, 91-425 Lodz, Poland;
3) Mr Ron Weissberg, Private investor, born on the 17
th
day of September, 1957 in Haifa, Israel, residing at 7,
Hamitnahalim Street, Savyon 56905, Israel;
4) Mr Adam Ofek, Company Director, born on the 7
th
day of March, 1963 in Florence (Italy), residing at 16, Remez
Street, Bney Brak, Israel;
5) Mr Ivor Share, Company Director, born on the 1
st
day of September, 1950 in London (U.K.), residing at 30 Aylmer
Drive, Stanmore, Middlesex, HA7 3EG, (U.K).
3.- The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the
year 2015:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, established at Le Dôme Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 147.571.
4.- The registered office of the company is established in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil dix, le vingt août.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Gérard LECUIT,
notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Zohar Yami, Senior Vice-Président, Business Development, né le 4 novembre 1971 à Rishon Le Zion,
Israel, demeurant à 183, Gilboa Street, Nirit, Israel;
2) Monsieur Adam Ofek, Directeur de Sociétés, né le 7 mars 1963 à Florence, (Italie), demeurant à 16, Remez Street,
Bney Brak, Israel;
105957
L
U X E M B O U R G
3) Monsieur Ron Weissberg, investisseur, né le 17 septembre 1957 à Haifa, Israel, demeurant à 7, Hamitnahalim Street,
Savyon 56905, Israel;
ici représentés par Monsieur Scott Mckinlay, employé, demeurant professionnellement à Schuttrange,
agissant en vertu de trois procurations signées en date du 10 août 2010,
lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur», par le notaire instrumentant et le mandataire des com-
parants, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de “CERAC S.A.”.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Schuttrange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'élaboration, la
construction et la propriété dans les parcs d'éoliennes ou d'autres formes d'énergie renouvelable. Dans ces limites, la
société peut effectuer toutes les activités et tâches nécessaires ou utiles pour accomplir ce but.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par UN MILLION
(1.000.000) d’actions sans valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à DIX-HUIT MILLIONS EUROS (18.000.000,- EUR) qui sera représenté par UN MILLION
(1.000.000) d’actions sans valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
du présent acte, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués
à tout moment par l'assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
105958
L
U X E M B O U R G
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le quatrième vendredi du mois de mai à 12 heures et pour la première fois en 2011.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
105959
L
U X E M B O U R G
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parties comparantes déclarent que les actions ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Zohar Yami, prénommé - 30.438 actions
2) Monsieur Adam Ofek, prénommé - 769.562 actions
3) Monsieur Ron Weissberg, prénommé - 200.000 actions.
TOTAL: 1.000.000 actions.
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de
TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation - Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2015:
1) Monsieur Helmut Krausser, Directeur Manager, né le 3 février 1953 à Bitterfeld, Allemagne, demeurant à 4, An der
Sorge, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Allemagne;
2) Monsieur Adam Broncel, Businessman, né le 30 octobre 1966 à Lodz, Pologne, demeurant à Ul.Pononcna 34/3,
91-425 Lodz, Pologne;
3) Monsieur Ron Weissberg, investisseur, né le 17 septembre 1957 à Haifa, Israel, demeurant à 7, Hamitnahalim Street,
Savyon 56905, Israel;
4) Monsieur Adam Ofek, Directeur de Sociétés, né le 7 mars 1963 à Florence (Italie), demeurant à 16, Remez Street,
Bney Brak, Israel;
5) Monsieur Ivor Share, Directeur de Sociétés, né le 1
er
septembre 1950 à Londres (GB), demeurant à 30, Aymler
Drive, Stanmore, Middlesex, HA7 3EG (GB).
3.- Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année
2015:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, établie au Le Dôme Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 147.571.
4. Le siège social de la société est fixé à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Mckinlay, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 août 2010. Relation: LAC/2010/37356. Reçu: soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
105960
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Référence de publication: 2010121013/333.
(100137619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
International Fair Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 50.123.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A.
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121090/13.
(100137105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
International Oil Transport S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5429 Hëttermillen, 5, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 29.115.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A.
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121091/13.
(100137106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Jyrom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7243 Bereldange, 76, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 53.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121096/10.
(100137178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Klenke Schifffahrt S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5480 Wormeldange, 143, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 143.487.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour KLENKE SCHIFFFAHRT SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121098/13.
(100137107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105961
L
U X E M B O U R G
Entreprise Vert 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.287.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the twenty-third August.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1.- “Special Situations Venture Partners II Structured, LP”, a company incorporated under the laws of Guernsey, having
its registered office at Les Echelons , Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, registered at
the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under the number 731,
2.- “Special Situations Venture Partners II, LP”, a company incorporated under the laws of Guernsey, having its regis-
tered office at Les Echelons , Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, registered at the
Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under the number 732,
3.- “Soriak GmbH & Co. KG”, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at
Südliche Münchner Str. 8, D-82031 Grünwald, Germany, registered at the Handelsregister B des Amtsgerichts München
under the number HRA 163036,
4.- “Kiriak GmbH & Co. KG”, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at
Südliche Münchner Str. 8, D-82031 Grünwald, Germany, registered at the Handelsregister A des Amtsgerichts München
under the number HRA 88060,
all here represented by Mr Paul WEILER, residing professionally at L- 2740 Luxemburg, 3, rue Nicolas Welter, by
virtue of four proxies given under private seal in Guernsey and Grünwald on 13
th
August 2010.
The beforesaid proxies, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which
its declares to incorporate:
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company, governed by the
present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended,
and the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company’s name is "Entreprise Vert 7 S.à r.l.".
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31
st
, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
105962
L
U X E M B O U R G
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
105963
L
U X E M B O U R G
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-Up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
105964
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31
st
, 2010.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows
and fully paid up in cash:
Special Situations Venture Partners II Structured, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,912
Special Situations Venture Partners II, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,434
Soriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,077
Kiriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,077
12,500
Therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company
Entreprise Vert 7 S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about nine hundred and fifty Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Frank PRZYGODDA, manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the jointly signature of two managers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahr zweitausendundzehn, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- “Special Situations Venture Partners II Structured, LP”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanal-
inseln, mit Sitz in Les Echelons, Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, eingetragen im
„Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey” unter der Nummer 731,
2.- “Special Situations Venture Partners II, LP”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanalinseln, mit
Sitz in Les Echelons, Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, eingetragen im „Register of
Limited Partnerships of the Island of Guernsey” unter der Nummer 732,
3.- “Soriak GmbH & Co. KG”, Gesellschaft gegründet unter der deutschen Gesetzgebung, mit Sitz in Südliche Münchner
Str. 8, D-82031 Grünwald, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer
HRB 163036,
4.- “Kiriak GmbH & Co. KG”, a Gesellschaft gegründet unter der deutschen Gesetzgebung, mit Sitz in Südliche
Münchner Str. 8, D-82031 Grünwald, Deutschland, eingetragen im Handelsregister A des Amtsgerichts München unter
der Nummer HRA 88060,
allesamt hier vertreten durch Herrn Paul WEILER, Angestellter, mit Berufsanschrift in L-2740 Luxemburg, 3, rue
Nicolas Welter, auf Grund von vier Vollmachten gegeben in Grünwald und Guernsey am 13. August 2010.
Diese Vollmachten sollen nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit dieser einregistriert zu werden.
Diese erschienenen Parteien, wie oben angegeben vertreten, haben den unterzeichneten Notar beauftragt, die Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzunehmen:
105965
L
U X E M B O U R G
Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dieser Satzung und den derzeitigen luxem-
burgischen Gesetzen unterliegt und insbesondere den abgeänderten Gesetzen vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften, vom 18. September 1933 und vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie
die vorliegende Satzung.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist „Entreprise Vert 7 S.à r.l.“.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-
riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft
als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teil-
weise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von
Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen
Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles
Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen,
gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder
indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtsper-
sonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu
verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser
Zweckerfüllung beitragen jedoch ohne das Gesetz vom 31. Juli 1929 über Holding-Gesellschaften zu nutzen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung der Satzung beschließt.
Auf Beschluss der Geschäftsführer, kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,
wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs oder
Insolvenz eines der Gesellschafter.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,
weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf
tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro)
Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.
Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.
Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern
bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.
In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.
105966
L
U X E M B O U R G
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesell-
schafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,
durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können
ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die
Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine
Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer angenommen.
Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende
Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der
ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.
Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-
pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.
Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-
den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder
schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Ge-
sellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen
nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.
Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-
gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.
Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der
Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse
zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.
Art. 15. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten,
dafür gestimmt haben.
Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben
zu einer zweiten Versammlung einberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die Mehrheit des vertretenen Kapitals gefasst.
Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-
den, die wenigstens drei Viertel des Kapitals darstellen.
Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter
der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer
Zusammenfassung der Verpflichtungen und der Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.
Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen
mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.
105967
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann dieses Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-
schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.
Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage
zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals
der Gesellschaft erreicht hat.
Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich aus welchem Grunde.
Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,
beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.
Auflösung
Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.
Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis
ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.
Geltende Gesetzgebung
Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht
ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Alle Anteile wurden vollständig und wie folgt eingezahlt:
Special Situations Venture Partners II Structured, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.912
Special Situations Venture Partners II, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.434
Soriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.077
Kiriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.077
12.500
Der Betrag von 12.500.- EUR (zwölf tausend fünf hundert Euro) entsprechend dem Gesellschaftskapital steht der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, wie dies dem Notar belegt wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die die Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung
tragen oder bezahlen muss, wurden auf 950.- EUR (neun hundert und fünfzig Euro) geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft, haben die oben bezeichneten Personen, die die Gesamtheit des gezeich-
neten Kapitals darstellen und die der Sitzung erteilten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse getroffen:
1.- Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer wurde ernannt:
- Herr Frank PRZYGODDA, Manager, mit beruflicher Adresse in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.
In Einklang mit Artikel 11 dieser Satzung, ist die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Ge-
schäftsführern gebunden.
2.- Die Gesellschaft wird ihren Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg haben.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der oben erschienenen
Partei, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der gleichen
Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend.
Zur Beurkundung dessen, dieser Akt aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie Eingangs.
Nach Vorlesung dieses Dokuments, hat die erschienene Person dieses zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: P. WEILER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 août 2010. Relation: LAC/2010/37427. Reçu 75,- € (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
105968
L
U X E M B O U R G
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den 31. August 2010.
Référence de publication: 2010121033/373.
(100137180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Investical Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 127.803.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2i>
<i>septembre 2010i>
Monsieur GANDINI Alessandro, Monsieur DE BERNARDI Alexis et Monsieur KARA Mohammed sont renommés
administrateurs.
Monsieur HEITZ Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes.
Monsieur DE BERNARDI Alexis est nommé Président du Conseil d'administration.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.
Pour extrait sincère et conforme
INVESTICAL PROPERTIES S.A.
Mohammed KARA
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010121293/18.
(100136975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Morgan Stanley Europe Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 56.611.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 6 septembre 2010i>
L'assemblée décide de nommer Administrateurs les personnes suivantes jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant
sur l'exercice 2010:
Mme B. Elizabeth Fischer,
M. Frank Lagerstedt,
M. Jorge Iragorri,
M. Fabrice Frere.
L'assemblée décide de nommer Deloitte s.a., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en tant que réviseur indépen-
dant jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2010.
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2010121320/19.
(100136992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Reinbro Investments SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 86.780.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010121162/9.
(100137281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105969
L
U X E M B O U R G
Luxsteel Equipment & Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn.
R.C.S. Luxembourg B 71.617.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour LUXSTEEL EQUIPMENT & TRADING SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121100/13.
(100137110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
La Financière Montbrillant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 78.857.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2010.i>
Madame Sophie CHAMPENOIS, née le 4 septembre 1971 à Uccle (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommée représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.;
<i>Pour la société
i>LA FINANCIERE MONTBRILLANT S.A.
Référence de publication: 2010121101/12.
(100137087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Entreprise Vert 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.286.
In the year two thousand and ten, on the twenty-third August.
Before Maître Paul DECKER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1.- “Special Situations Venture Partners II Structured, LP”, a company incorporated under the laws of Guernsey, having
its registered office at Les Echelons , Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, registered at
the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under the number 731,
2.- “Special Situations Venture Partners II, LP”, a company incorporated under the laws of Guernsey, having its regis-
tered office at Les Echelons , Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, registered at the
Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under the number 732,
3.- “Soriak GmbH & Co. KG”, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at
Südliche Münchner Str. 8, D- 82031 Grünwald, Germany, registered at the Handelsregister B des Amtsgerichts München
under the number HRA 163036,
4.- “Kiriak GmbH & Co. KG”, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at
Südliche Münchner Str. 8, D- 82031 Grünwald, Germany, registered at the Handelsregister A des Amtsgerichts München
under the number HRA 88060,
are here all represented by Mr. Paul WEILER, residing at L-2740 Luxemburg, 3, rue Nicolas Welter, by virtue of four
proxies given under private seal in Guernsey and Grünwald on 13
th
August 2010.
The beforesaid proxies, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company, governed by the
present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
105970
L
U X E M B O U R G
companies, of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended,
and the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company’s name is "Entreprise Vert 8 S.à r.l.".
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31
st
, 1929, on Holding Companies.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12 500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
105971
L
U X E M B O U R G
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of
shareholders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
105972
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-Up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2010.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows
and fully paid up in cash:
Special Situations Venture Partners II Structured, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,912
Special Situations Venture Partners II, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,434
Soriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,077
Kiriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,077
12,500
Therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is as now at the disposal of the Company
Entreprise Vert 8 S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about ** euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Frank PRZYGODDA, manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the jointly signature of two managers.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
105973
L
U X E M B O U R G
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes
Im Jahr zweitausendundzehn, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, sind erschienen:
1.- “Special Situations Venture Partners II Structured, LP”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanal-
inseln, mit Sitz in Les Echelons, Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, eingetragen im
„Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey” unter der Nummer 731,
2.- “Special Situations Venture Partners II, LP”, Gesellschaft gegründet unter der Gesetzgebung der Kanalinseln, mit
Sitz in Les Echelons, Barclays Court, St. Peter Port, Guernsey GY1 6AW, Channel Islands, eingetragen im „Register of
Limited Partnerships of the Island of Guernsey” unter der Nummer 732,
3.- “Soriak GmbH & Co. KG”, Gesellschaft gegründet unter der deutschen Gesetzgebung, mit Sitz in Südliche Münchner
Str. 8, D-82031 Grünwald, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer
HRB 163036,
4.- “Kiriak GmbH & Co. KG”, a Gesellschaft gegründet unter der deutschen Gesetzgebung, mit Sitz in Südliche
Münchner Str. 8, D-82031 Grünwald, Deutschland, eingetragen im Handelsregister A des Amtsgerichts München unter
der Nummer HRA 88060, allesamt hier vertreten durch Herrn Paul WEILER, Angestellter, mit Berufsanschrift in L-2740
Luxemburg, 3, rue Nicolas Welter, auf Grund von vier Vollmachten gegeben in Grünwald und Guernsey am 13. August
2010.
Diese Vollmachten sollen nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit dieser einregistriert zu werden.
Diese erschienenen Parteien, wie oben angegeben vertreten, haben den unterzeichneten Notar beauftragt, die Satzung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzunehmen:
Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dieser Satzung und den derzeitigen luxem-
burgischen Gesetzen unterliegt und insbesondere den abgeänderten Gesetzen vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften, vom 18. September 1933 und vom 28. Dezember 1992 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie
die vorliegende Satzung.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist „Entreprise Vert 8 S.à r.l.“
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-
riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft
als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teil-
weise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von
Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen
Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles
Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen,
gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder
indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtsper-
sonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu
verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser
Zweckerfüllung beitragen jedoch ohne das Gesetz vom 31. Juli 1929 über Holding-Gesellschaften zu nutzen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung der Satzung beschließt.
Auf Beschluss der Geschäftsführer, kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,
wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs oder
Insolvenz eines der Gesellschafter.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,
weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
105974
L
U X E M B O U R G
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf
tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro)
Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.
Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.
Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern
bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.
In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesell-
schafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,
durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können
ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die
Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine
Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer angenommen.
Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende
Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der
ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.
Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-
pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.
Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-
den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit
Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird.
Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Gesellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis
gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Ent-
schädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.
Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-
gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.
Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der
Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.
105975
L
U X E M B O U R G
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse
zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.
Art. 15. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten,
dafür gestimmt haben.
Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben
zu einer zweiten Versammlung einberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die Mehrheit des vertretenen Kapitals gefasst.
Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-
den, die wenigstens drei Viertel des Kapitals darstellen.
Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter
der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der
Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.
Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen
mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann dieses Inventar und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-
schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.
Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage
zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals
der Gesellschaft erreicht hat.
Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich aus welchem Grunde.
Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,
beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.
Auflösung
Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.
Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis
ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.
Geltende Gesetzgebung
Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht
ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Alle Anteile wurden vollständig und wie folgt eingezahlt:
Special Situations Venture Partners II Structured, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.912
Special Situations Venture Partners II, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.434
Soriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.077
Kiriak GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.077
12.500
Der Betrag von 12.500.-EUR (zwölf tausend fünf hundert euro) entsprechend dem Gesellschaftskapital steht der Ge-
sellschaft ab sofort zur Verfügung, wie dies dem Notar belegt wurde.
105976
L
U X E M B O U R G
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die die Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung
tragen oder bezahlen muss, wurden auf 950.-EUR (neun hundert und fünfzig Euro) geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung der Gesellschaft, haben die oben bezeichneten Personen, die die Gesamtheit des gezeich-
neten Kapitals darstellen und die der Sitzung erteilten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse getroffen:
1.- Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer wurden ernannt:
- Herr Frank PRZYGODDA, Manager, mit beruflicher Adresse in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg,
In Einklang mit Artikel 11 dieser Satzung, ist die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Ge-
schäftsführern gebunden.
2.- Die Gesellschaft wird ihren Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg haben.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der oben erschienenen
Partei, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der gleichen
Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend.
Zur Beurkundung dessen, dieser Akt aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie Eingangs.
Nach Vorlesung dieses Dokuments, hat die erschienene Person dieses zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: P. WEILER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 août 2010. Relation: LAC/2010/37428. Reçu 75,- € (soixante-quinze euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions erteilt.
Luxemburg, den 31. August 2010.
Référence de publication: 2010121034/372.
(100137181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
La Financière Montbrillant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 78.857.
Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121102/10.
(100137088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Lanus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 125.687.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 7 septembre 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010121104/10.
(100137122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Librairie LE MONDE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 3, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 98.943.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
105977
L
U X E M B O U R G
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour LIBRAIRIE LE MONDE
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121113/13.
(100137108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Lorca Management S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 43.047.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121115/10.
(100137167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Luxor Thebes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 151.971.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2010.
Référence de publication: 2010121120/10.
(100137091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Argusvalentines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 96.751.
EXTRAIT
Démission d'administrateur:
Par courrier recommandé du 3 novembre 2006 au siège de la société à L-1251 Luxembourg, 13 avenue du Bois à
l'attention du domiciliataire, Mme Catherine STEVENSON, demeurant à Luxembourg, a démissionné avec effet immédiat
de son poste d'administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7/9/2010.
<i>Pour la société
i>s° Marc MODERT
<i>Avocati>
Référence de publication: 2010121246/17.
(100136796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Lynceus Financial Consult S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 142.687.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour LYNCEUS FINANCIAL CONSULT SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121121/13.
(100137109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105978
L
U X E M B O U R G
Modern Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 68.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121132/10.
(100137169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Morisot Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 122.117.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121135/10.
(100137170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Neuvimmo S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 53.538.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121137/10.
(100137171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
ProCom Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2273 Luxembourg, 10-12, rue de l'Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 62.799.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010121148/11.
(100137150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Unifida Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 20.035.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour UNIFIDA HOLDING S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2010121206/11.
(100137289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105979
L
U X E M B O U R G
Kaslion S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.557.533.725,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 119.161.
In the year two thousand five, on the fifth day of August,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Notary"). The
meeting opened at 11.00 pm.
The "Company" is Kaslion S.àr.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg by a notarial deed dated 18 August 2006 of the notary Me Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, having
its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 119.161 and whose articles of association (the "Articles")
have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2044 dated 31 October 2006,
page 98101 and have been amended for the last time by a notarial deed drawn up on 5
th
, August 2010, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Appointment of chairman, Secretary and Scrutineeri>
Gavin Solomons, Lawyer, whose professional address is in Luxembourg, acted as Chairman of the meeting with the
consent of the meeting.
The Chairman appointed Cora Maglo, Lawyer, whose professional address is in Luxembourg, to act as Secretary.
The meeting elected Judit Stern, Lawyer, whose professional address is in Luxembourg, to act as Scrutineer.
<i>Declaration by chairmani>
These appointments having been made, the Chairman declared that:
The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "Ap-
pearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list,
signed by or on behalf of the Appearing Shareholders, the Notary, the Chairman, the Scrutineer and the Secretary,
together with the proxy forms, signed ne varietur by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the
Notary and the Chairman, the Scrutineer and the Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be
registered with it.
The attendance list shows that shareholders holding a total of 62,301,349 shares with a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25) each, representing the whole share capital of the Company are present at the meeting or represented at
the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the
agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore
properly constituted and can validly consider all items of the agenda.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To dissolve the Company and to put it into liquidation.
2. To appoint the liquidator(s), as required by article 21.2 of the Articles.
3. To determine the powers and compensations of the liquidator(s).
4. Miscellaneous
<i>1. Resolutionsi>
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to dissolve and to put the Company into liquidation as
of the date of the present deed.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved pursuant to article 21.2 of the Articles to appoint Avega
Services (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140376, as the liquidator
of the Company, who has accepted that mandate.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved that the liquidator shall receive the powers and com-
pensations as determined hereafter.
105980
L
U X E M B O U R G
The extraordinary general meeting of shareholders resolved that the liquidator is exempted from the obligation of
drawing up an inventory and shall fully rely on the books and financial documents of the Company.
The liquidator has the authority to perform and execute all operations provided for in Articles 144 and 145 of the
Luxembourg company law Act of 10 August 1915, as amended, without specific prior authorisation of a shareholders
general meeting.
The liquidator may under its own responsibility delegate, regarding special or specific operations, such part of its
powers as it may deem fit, to one or several representatives.
The liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it.
The liquidator’s signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.
The liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with
supporting accounts and documents.
The extraordinary general meeting of shareholders resolved that the liquidator shall be granted no compensation for
the performance of its duties as liquidator of the Company.
<i>Costs, Conclusion of meeting and Notarial deedi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately two thousand one hundred Euros (2,100.- EUR).
Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting
closed.
The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a
French version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the
French texts, the English version will prevail.
This notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are
known to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appro-
priate, their proxyholders), the Notary, the Chairman, the Secretary and the Scrutineer have together signed this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille dix, le cinq août.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire").
L'assemblée s'est ouverte à 11.00 heures.
La "Société" est Kaslion S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgois, constituée par un acte
notarié en date du 18 aout 2006 du notaire Me Henri Hellinckx, résident à Luxembourg, ayant son siège social au 61, rue
de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B.119.161 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations sous le numéro 2044 en date du 31 octobre 2006, page 98101 et ont été modifiés pour
la dernière fois par un acte notarié daté du 5 août 2010 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations.
<i>Nomination des président, Secrétaire et Scrutateuri>
Gavin Solomons, Avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, a agi en tant que Président de l'assemblée
avec l'accord de l'assemblée.
Le Président a nommé Cora Maglo, Avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que
Secrétaire.
L'assemblée a élu Judit Stern, Avocat, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que Scrutateur.
<i>Déclaration du présidenti>
Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:
Les noms des associés présents et de ceux représentés à l'assemblée (ensemble définis comme les "Associés Com-
parants") et le nombre de parts sociales détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de
présence, signée par et au nom des Associés Comparants, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble
avec les formulaires de procuration, signés ne varietur par les associés représentés à l'assemblée par des mandataires, le
Notaire et le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés
avec cet acte.
Il ressort de la liste de présence que les associés détenant un total de 62.301.349 parts, toutes d'une valeur nominale
de vingt-cinq Euro (EUR 25), chacune, représentant la totalité du capital social de la Société sont présents à l'assemblée
ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Associés Comparants ont déclaré avoir été préalablement
correctement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux formalités de convocation. L'assemblée est
par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.
105981
L
U X E M B O U R G
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissoudre la Société et la mettre en liquidation.
2. Nommer le(s) liquidateur(s), comme prévu par l’article 21.2.
3. Déterminer les pouvoirs et la rémunération du(des) liquidateur(s).
4. Divers.
<i>Résolutionsi>
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de dissoudre et de mettre la société en liquidation à partir
du jour de cet acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé conformément à l’article 21.2 des Statuts de nommer comme
liquidateur Avega Services (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 140376, qui a accepté ce mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé que le liquidateur recevra les pouvoirs et rémunérations
comme déterminés ci-après.
L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé que le liquidateur est dispensé de l’obligation de dresser un
inventaire et se réfèrera entièrement sur les livres et documents financiers de la Société.
Le liquidateur a le pouvoir d’accomplir et d’exécuter toutes les opérations prévues par les articles 144 et 145 de la
Loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, sans autorisation spécifique préalable de l’assemblée
générale des associés.
Le liquidateur peut déléguer sous sa propre responsabilité, concernant des opérations spéciales ou spécifiques, telle
partie de ses pouvoirs qu’il détermine à un ou plusieurs représentants.
Le liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu’envers la société, pour l’exécution du mandat qui lui est donné.
La signature du liquidateur lie valablement et sans limitation la société dans le processus de liquidation.
Le liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l’emploi des actifs sociaux, comptes et
documents à l’appui.
L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de ne pas accorder au liquidateur de compensation pour
l’exécution de son mandat de liquidateur de la société.
<i>Frais, Conclusion de l'assemblée et Acte notariéi>
Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement deux mille cents Euros (2.100.- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'as-
semblée est close.
Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version
française, et qu'à la demande des Associés Comparants, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Ce document ayant été lu aux Associés Comparants (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le
Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, les Associés Comparants (ou, selon le cas leurs
mandataires), le Notaire, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur ont ensemble signé cet acte.
Signé: C. MAGLO, J. STERN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 août 2010. Relation: LAC/2010/35471. Reçu douze euros (12.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
Référence de publication: 2010121097/157.
(100137315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105982
L
U X E M B O U R G
Ostholt Tankschiff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 108.549.
Le bilan arrêté au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 7 septembre 2010.
<i>Pour OSTHOLT TANKSCHIFF SARL
i>Fiduciaire Roger Linster
p.d. Viviane Roman
Référence de publication: 2010121141/13.
(100137111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
F. 20 S. O. S. Techniques S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 132.828.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour F.20 S.O.S. TECHNIQUES s.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2010121267/11.
(100136627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 125.057.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Référence de publication: 2010121145/10.
(100137351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Pissaro Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 121.928.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121156/10.
(100137172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
PLH Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 137.581.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121157/10.
(100137173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
105983
L
U X E M B O U R G
Polytrinity Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 130.004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010121158/10.
(100137174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Allard Invest Holding Bresil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 144.537.
Il résulte, conformément à la signature d'un contrat de cession des parts sociales en date du 10 août 2010, que l'ancien
associé Global Palaces Investors S.à r.l. a cédé 125 parts sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune, à la société
ALLARD INVESTMENTS BRESIL S.A.S., société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 43 avenue
Hoche, 75008 PARIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 375 310.
Mathieu VILLAUME
<i>Gérant de Classe Ai>
Référence de publication: 2010121243/14.
(100136619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Morgan Stanley Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 114.471.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'actionnaire unique tenue à Luxembourg en date du 6 septembre 2010i>
«Après discussion, il est décidé:
De reconduire en tant que Commissaire aux comptes DELOITTE S.A., jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant
sur l'exercice se terminant le 31 décembre 2009.»
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2010121314/14.
(100136970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Ambassador TE, Ambassador TX, WB Ambassador Holdings S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 142.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2010.
WB Ambassador Holdings S.à r.l.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Represented by Alexandra Petitjean and Eric Lechat
<i>Attorneys in Fact Ai>
Référence de publication: 2010121349/14.
(100137280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
105984
Allard Invest Holding Bresil S.à r.l.
Ambassador TE, Ambassador TX, WB Ambassador Holdings S.e.n.c.
Argusvalentines S.A.
Cameron Holding (Luxembourg) Sàrl
Cameron Lux II S.à r.l.
Cerac S.A.
DS Care S.A.
EFB S.A.
ELRO Tankschiff S. à r.l.
Entreprise Vert 7 S.à r.l.
Entreprise Vert 8 S.à r.l.
Eurotank S.à r.l.
F. 20 S. O. S. Techniques S.à r.l.
FDF
Felten-Stein Immobilière S.à.r.l.
Felten-Stein Immobilière S.à.r.l.
Finfrères Holding S.A.
Foncière CG & Associés S.A.
Foncière des Alpes S.A.
F & S S.à.r.l.
F & S S.à.r.l.
Gebäudereinigung Peifer S. à r.l.
HIC Group International Luxembourg
Idamante S.àr.l.
Iena Buildings S.A.
Immobilière Maybach S.à r.l.
Immobilière Rannerwé S.à r.l.
International Fair Consulting S.A.
International Oil Transport S.A.
Investical Properties S.A.
Jyrom S.A.
Kaslion S. à r.l.
Klenke Schifffahrt S. à r. l.
La Financière Montbrillant S.A.
La Financière Montbrillant S.A.
Lanus S.à r.l.
Librairie LE MONDE
Lorca Management S.A.
Luxor Thebes S.A.
Luxsteel Equipment & Trading S.à r.l.
Lynceus Financial Consult S. à r. l.
Modern Properties S.A.
Modulor Menuiserie + Design S.A.
Modulor S.A.
Modulor S.A.
Morgan Stanley Europe Reinsurance S.A.
Morgan Stanley Luxembourg Holdings S.àr.l.
Morisot Investment S.A.
Neuvimmo S.A.
OQUENDO Management S.à r.l.
Ostholt Tankschiff S.à r.l.
OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l.
Parc Breidfeld sàrl
Pissaro Investment S.A.
PLH Investments S.à r.l.
Polytrinity Investment S.à r.l.
ProCom Consult S.A.
Reinbro Investments SA
Svea Holding S. à r.l.
Unifida Holding S.A.