This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2131
9 octobre 2010
SOMMAIRE
Abattoir Ettelbruck S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102280
A.F.M.S. Accounting Financial & Manage-
ment Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102283
Agence EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102263
Algim S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102284
Algos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102283
Alsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102284
AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102282
Bad Langensalza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102284
Bad Langensalza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102265
Bad Schönborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102285
Bad Schönborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102285
Bad Schönborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102286
Bountiful S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102280
Colt Group S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102286
Compagnie de l'Europe du Sud S.A. . . . . .
102281
Compagnie Financière et Boursière Lu-
xembourgeoise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102256
Djedefre S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102284
Imprimerie de l'Europe . . . . . . . . . . . . . . . . .
102261
International Business Consultants S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102261
LSF JRPI Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
102286
Ositech SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102283
Predica Infrastructure S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102277
RE Capital S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102285
SAE Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
102281
Sagamore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102265
Sethos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102256
Shay Properties Bury S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
102257
Simonthal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102257
SKB Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102257
Société Cotonnière Financière S.A. . . . . . .
102257
Société Flue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102258
Solum 488 Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102282
Solum 488 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102282
Stadlux Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102258
Steiner und Schmidt Gruppe Investholding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102258
Sublim Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102259
Symbolinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102259
Tanis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102259
Targa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102259
Tellux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102260
Tenadu Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102260
Tenadu Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
102260
Thamesline Investments . . . . . . . . . . . . . . . .
102260
Tintoretto Sicar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102261
Topaze Funds S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102261
Torsch Private Equity S.A., SPF . . . . . . . . .
102273
Treno Finanz S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102264
Trustlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102257
Unidiam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102262
UTM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102262
UTM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102262
Valence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102263
Vento Italia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102263
V Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102263
VH Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102264
Visylia Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102264
VLT Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102264
Vratislavia Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
102265
Walterstuff s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102273
WCMG (Working Capital Management
Group) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102277
Whiskey 1 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
102249
Whiskey 2 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
102242
Zeppelin Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102280
102241
L
U X E M B O U R G
Whiskey 2 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 131.415.
In the year two thousand and ten, on the fifth day of July,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Special Situations Realty Partners II, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its regis-
tered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS II (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by G. Tostevin and P. Scarlatti, here represented by Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing
in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.
Special Situations Realty Partners FF, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its re-
gistered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS IV (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by N. Meader and D. Fisseler, here represented by Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing
in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.
Thomas Kronsteiner, born on September 22
nd
, 1965, residing in 3573 Rosenburg Nr. 84, Austria, represented by
Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July
2010.
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed
to the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to state that:
- Special Situations Realty Partners II, L.P., prenamed, owns 9,563 of the shares issued by Whiskey 2 Holding S.à r.l.,
a Luxembourg limited liability company, société à responsabilité limitée, with registered office in L-1882 Luxembourg, 5,
rue Guillaume Kroll registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg, under number B 131.415, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on 27 July, 2007, published in the Mémorial C, number 2273 of 11 October 2007 (the “Company”);
- Special Situations Realty Partners FF, L.P., prenamed, owns 1,687 of the shares issued by the Company;
- M. Thomas Kronsteiner, prenamed, owns 1,250 of the shares issued by the Company;
- The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) parts with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
After this had been set forth, the above named participants, representing the whole corporate capital, have decided
to take the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to fully amend and restate the articles of association of the Company, which shall now
read as follows:
“Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability company, governed by the
present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Company”).
Art. 2. The Company's name is Whiskey 2 Holding S.à r.l.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
102242
L
U X E M B O U R G
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers
or the sole manager as the case may be.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders subject to any other agreement made between the
shareholders of the Company from time to time.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
The Company may repurchase its own shares in accordance with Luxembourg law.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles or any agreement made between the shareholders
of the Company from time to time to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or
in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
102243
L
U X E M B O U R G
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders rights
Art. 14. The shareholders of the Company enjoy the rights granted to shareholders of private limited companies under
Luxembourg law as well as the following rights.
Each shareholder has a preferential subscription right to newly issued shares of the Company pro rata to his partici-
pation in the Company’s share capital prior to the relevant capital increase. The preferential subscription right may only
be fully used, i.e. a shareholder using its preferential subscription right cannot subscribe for less shares than its full
preferential subscription right allows it to subscribe.
Each shareholder has the right to request to the board of managers to be provided with information on the Company’s
course of business, and to inspect the Company’s books kept at the Company’s registered office. The board of managers
of the Company satisfies any such request if it is reasonable and does not negatively affect the Company’s conduct of
business.
Shareholders decisions
Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the issued share
capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken by simple majority of voting rights present or duly represented at such
second meeting.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be approved by shareholders re-
presenting at least three quarters of the issued share capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on private limited companies, sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 18. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.
102244
L
U X E M B O U R G
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary. “
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,200.-
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German Version
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes
Im Jahr zweitausend und zehn, am fünften Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
Special Situations Realty Partners II, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz
in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS II (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
G. Tostevin und P. Scarlatti, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg,
rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.
Special Situations Realty Partners FF, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz
in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS IV (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
N. Meader und D. Fisseler, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg,
rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.
Thomas Kronsteiner, geboren am 22. September 1965, wohnhaft in 3573 Rosenburg Nr. 84, Österreich, vertreten
durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg, rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht
vom 1 Juli 2010.
Eine Kopie der vorgenannten Beschlüsse bleibt, nachdem sie „ne varietur“ von der hier Erschienenen und dem un-
terzeichneten Notar unterschrieben wurden, der vorliegenden Urkunde zwecks Einreichung bei den Registrierungsbe-
hörden beigefügt.
Die hier erschienenen Parteien bitten den amtierenden Notar, Folgendes festzuhalten:
- Special Situations Realty Partners II, L.P., hält 9,563 Anteile des gezeichneten Kapitals von Whiskey 2 Holding S.à r.l.,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-1822
Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll, eingetragen bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter
Nummer B 131.415, errichtet am 27. Juli 2007 durch notarielle Urkunde des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 11. Oktober 2007 unter der Nummer 2273;
- Special Situations Realty Partners FF L.P., vorgenannt, hält 1,687 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
102245
L
U X E M B O U R G
- M. Thomas Kronsteiner, vorgenannt, hält 1,250 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
- Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12,500) aufgeteilt in zwölf tausend
fünf hundert (12,500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).
Nach Darlegung dessen, treffen die das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellenden oben genannten Personen den
folgenden Beschluss:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft vollumfänglich zu ändern und neu zu formulieren, die
fortan wie folgt lautet:
„Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es ist hierbei eine „société à responsabilité limitée“, eine dem gegenwärtig geltenden luxemburgischen Recht
und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist Whiskey 2 Holding S.à r.l..
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-
riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft
als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teil-
weise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von
Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen
Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles
Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen,
gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder
indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtsper-
sonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu
verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser
Zweckerfüllung beitragen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung dieser Satzung beschließt.
Auf Beschluss der Geschäftsführer oder im gegebenen Falle des alleinigen Geschäftsführers, kann der Sitz der Gesell-
schaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,
wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.
Art. 6. Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs
oder Insolvenz eines der Gesellschafter.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,
weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf
tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro)
Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.
Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar, abhängig von jeglichen anderen zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft von Zeit zu Zeit eingegangenen Vereinbarungen.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.
Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.
102246
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft ist unter den vom luxemburgischen Recht vorgeschriebenen Bedingungen berechtigt, eigene Anteile
zurück zu erwerben.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern
bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.
In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung oder andere zwischen den Gesellschaftern
der Gesellschaft getroffene Vereinbarungen der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen
der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,
durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können
ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die
Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.
Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der
ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.
Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-
pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.
Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-
den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder
schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Ge-
sellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen
nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.
Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine
Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer angenommen.
Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende
Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-
gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.
Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der
Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.
Rechte der Gesellschafter
Art. 14. Die Gesellschafter der Gesellschaft genießen die den Gesellschaftern einer Gesellschaft beschränkter Haftung
nach luxemburgischem Gesetz gewährten sowie die im Folgenden dargelegten Rechte.
Jeder Gesellschafter hat ein anteiliges vorrangiges Bezugsrecht aller neu ausgegebenen Anteile der Gesellschaft im
Einklang mit seiner vor der entsprechenden Kapitalerhöhung bestehenden Beteiligung am Gesellschaftskapital der Ge-
sellschaft. Das vorrangige Bezugsrecht darf nur in vollem Umfang ausgeübt werden, d.h. ein sein vorrangiges Bezugrecht
ausübender Gesellschafter darf nicht weniger Anteile zeichnen als es ihm sein gesamtes vorrangiges Bezugsrecht gestattet.
Jeder Gesellschafter hat das Recht von der Geschäftsführung die den Geschäftsverkehr der Gesellschaft betreffenden
Informationen zu verlangen und die am Sitz der Gesellschaft gehaltenen Bücher der Gesellschaft einzusehen. Die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft kommt diesen Anfragen nach, sofern diese angemessen sind und die Geschäfte der
Gesellschaft nicht nachteilig beinflussen.
102247
L
U X E M B O U R G
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse
zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.
Art. 16. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals
vertreten, dafür gestimmt haben.
Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben
zu einer zweiten Versammlung einberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die einfache Mehrheit der auf dieser zweiten Ver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst.
Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-
den, die wenigstens drei Viertel des gezeichneten Kapitals darstellen.
Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Ein Alleingesellschafter übt alleine die der Versammlung der Gesellschafter nach den Bestimmungen des Artikels XII
des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, société à responsabilité limitée, obliegenden Rechte aus.
Daraus folgt, dass alle über die Rechte der Geschäftsführer hinausgehenden Entscheidungen durch den Alleingesell-
schafter getroffen werden.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter
der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der
Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.
Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen
mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.
Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-
schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.
Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage
zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals
der Gesellschaft erreicht hat. Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich
aus welchem Grunde.
Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,
beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.
Auflösung
Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.
Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis
ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.
Geltende Gesetzgebung
Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht
ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.„
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Entschädigungen und Aufwendungen jeglicher Form, welche von der Gesellschaft zu begleichen
sind, werden auf ungefähr EUR 1.200.-. geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen
der oben erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung
abgefasst ist; auf Verlangen derselben oben erschienenen Person soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich sein.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg, am Tag wie eingangs dieses Dokuments erwähnt, aufgenommen
wurde.
102248
L
U X E M B O U R G
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Perso-
nenstand und Wohnort bekannt ist, hat diese Person diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. LABUSCH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30383. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 26. Juli 2010.
Référence de publication: 2010116043/388.
(100131963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Whiskey 1 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 131.595.
In the year two thousand and ten, on the fifth day of July,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Special Situations Realty Partners IV, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its re-
gistered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS IV (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by N. Meader and D. Fisseler, here represented by Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing
in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.
Special Situations Realty Partners III, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its regis-
tered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS III (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by P. Radford, F. Marcantetti, N. Carey and C. Schmitz-Valckenb, here represented by Janine
LABUSCH, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.
Thomas Kronsteiner, born on September 22
nd
, 1965, residing in 3573 Rosenburg Nr. 84, Austria, represented by
Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July
2010.
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed
to the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to state that:
- Special Situations Realty Partners IV, L.P., prenamed, owns 5,528 of the shares issued by Whiskey 1 Holding S.à r.l.,
a Luxembourg limited liability company, société à responsabilité limitée, with registered office in L-1882 Luxembourg, 5
rue Guillaume Kroll registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg, under number B 131.595, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on 27 July, 2007, published in the Mémorial C, number 2309 of 15 October 2007 (the “Company”);
- Special Situations Realty Partners III, L.P., prenamed, owns 5,722 of the shares issued by the Company;
- M. Thomas Kronsteiner, prenamed, owns 1,250 of the shares issued by the Company;
- The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) parts with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
After this had been set forth, the above named participants, representing the whole corporate capital, have decided
to take the following resolutions:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting decides to fully amend and restate the articles of association of the Company, which shall now
read as follows:
“ Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability company, governed by the
present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Company”).
Art. 2. The Company's name is Whiskey 1 Holding S.à r.l..
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
102249
L
U X E M B O U R G
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers
or the sole manager as the case may be.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders subject to any other agreement made between the
shareholders of the Company from time to time.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
The Company may repurchase its own shares in accordance with Luxembourg law.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles or any agreement made between the shareholders
of the Company from time to time to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or
in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
102250
L
U X E M B O U R G
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art.12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders rights
Art. 14. The shareholders of the Company enjoy the rights granted to shareholders of private limited companies under
Luxembourg law as well as the following rights.
Each shareholder has a preferential subscription right to newly issued shares of the Company pro rata to his partici-
pation in the Company’s share capital prior to the relevant capital increase. The preferential subscription right may only
be fully used, i.e. a shareholder using its preferential subscription right cannot subscribe for less shares than its full
preferential subscription right allows it to subscribe.
Each shareholder has the right to request to the board of managers to be provided with information on the Company’s
course of business, and to inspect the Company’s books kept at the Company’s registered office. The board of managers
of the Company satisfies any such request if it is reasonable and does not negatively affect the Company’s conduct of
business.
Shareholders decisions
Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the issued share
capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken by simple majority of voting rights present or duly represented at such
second meeting.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be approved by shareholders re-
presenting at least three quarters of the issued share capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on private limited companies, sociétés à responsabilité limitée.
102251
L
U X E M B O U R G
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 18. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary. “
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,200.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German Version Deutsche
Übersetzung des Vorhergehenden Textes
Im Jahr zweitausend und zehn, am fünften Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Special Situations Realty Partners IV, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz
in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS IV (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
N. Meader und D. Fisseler, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg,
rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.
Special Situations Realty Partners III, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz
in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS III (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
P. Radford, F. Marcantetti, N. Carey und C. Schmitz-Valckenb, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin,
geschäftlich ansässig in Luxemburg, rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.
Thomas Kronsteiner, geboren am 22. September 1965, wohnhaft in 3573 Rosenburg Nr. 84, Österreich, vertreten
durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg, rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht
vom 1 Juli 2010.
Die Vollmachten bleiben, nachdem sie „ne varietur“ von der hier Erschienenen und dem unterzeichneten Notar un-
terschrieben wurden, der vorliegenden Urkunde zwecks Einreichung bei den Registrierungsbehörden beigefügt.
102252
L
U X E M B O U R G
Die hier erschienenen Parteien bitten den amtierenden Notar, Folgendes festzuhalten:
- Special Situations Realty Partners IV, L.P., hält 5.528 Anteile des gezeichneten Kapitals von Whiskey 1 Holding S.à
r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-1822
Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll, eingetragen bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter
Nummer B 131.595, errichtet am 27. Juli 2007 durch notarielle Urkunde des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 15. Oktober 2007 unter der Nummer 2309;
- Special Situations Realty Partners III L.P., vorgenannt, hält 5.722 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
- M. Thomas Kronsteiner, vorgenannt, hält 1.250 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
- Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12,500) aufgeteilt in zwölf tausend
fünf hundert (12,500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).
Nach Darlegung dessen, treffen die das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellenden oben genannten Personen den
folgenden Beschluss:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft vollumfänglich zu ändern und neu zu formulieren, die
fortan wie folgt lautet:
„Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es ist hierbei eine „société à responsabilité limitée“, eine dem gegenwärtig geltenden luxemburgischen Recht
und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist Whiskey 1 Holding S.à r.l..
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-
riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft
als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teil-
weise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von
Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen
Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles
Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen,
gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder
indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtsper-
sonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu
verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser
Zweckerfüllung beitragen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung dieser Satzung beschließt.
Auf Beschluss der Geschäftsführer oder im gegebenen Falle des alleinigen Geschäftsführers, kann der Sitz der Gesell-
schaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,
wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.
Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.
Art. 6. Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs
oder Insolvenz eines der Gesellschafter.
Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,
weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.
Kapital - Aktien
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf
tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro)
102253
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.
Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar, abhängig von jeglichen anderen zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft von Zeit zu Zeit eingegangenen Vereinbarungen.
Die Anteile dürfen nicht „inter vivos“ an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.
Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.
Die Gesellschaft ist unter den vom luxemburgischen Recht vorgeschriebenen Bedingungen berechtigt, eigene Anteile
zurück zu erwerben.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern
bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.
In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung oder andere zwischen den Gesellschaftern
der Gesellschaft getroffene Vereinbarungen der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen
der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,
durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können
ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.
Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die
Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.
Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der
ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.
Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-
pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.
Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-
den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder
schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Ge-
sellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen
nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.
Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine
Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer angenommen.
Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende
Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.
Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-
gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.
Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der
Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.
Rechte der Gesellschafter
Art. 14. Die Gesellschafter der Gesellschaft genießen die den Gesellschaftern einer Gesellschaft beschränkter Haftung
nach luxemburgischem Gesetz gewährten sowie die im Folgenden dargelegten Rechte.
102254
L
U X E M B O U R G
Jeder Gesellschafter hat ein anteiliges vorrangiges Bezugsrecht aller neu ausgegebenen Anteile der Gesellschaft im
Einklang mit seiner vor der entsprechenden Kapitalerhöhung bestehenden Beteiligung am Gesellschaftskapital der Ge-
sellschaft. Das vorrangige Bezugsrecht darf nur in vollem Umfang ausgeübt werden, d.h. ein sein vorrangiges Bezugrecht
ausübender Gesellschafter darf nicht weniger Anteile zeichnen als es ihm sein gesamtes vorrangiges Bezugsrecht gestattet.
Jeder Gesellschafter hat das Recht von der Geschäftsführung die den Geschäftsverkehr der Gesellschaft betreffenden
Informationen zu verlangen und die am Sitz der Gesellschaft gehaltenen Bücher der Gesellschaft einzusehen. Die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft kommt diesen Anfragen nach, sofern diese angemessen sind und die Geschäfte der
Gesellschaft nicht nachteilig beinflussen.
Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse
zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.
Art. 16. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals
vertreten, dafür gestimmt haben.
Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben
zu einer zweiten Versammlung einberufen.
Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die einfache Mehrheit der auf dieser zweiten Ver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst.
Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-
den, die wenigstens drei Viertel des gezeichneten Kapitals darstellen.
Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Ein Alleingesellschafter übt alleine die der Versammlung der Gesellschafter nach den Bestimmungen des Artikels XII
des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, société à responsabilité limitée, obliegenden Rechte aus.
Daraus folgt, dass alle über die Rechte der Geschäftsführer hinausgehenden Entscheidungen durch den Alleingesell-
schafter getroffen werden.
Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter
der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der
Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.
Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen
mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.
Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-
schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.
Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent abgezogen und der gesetzlichen Rücklage
zugeführt.
Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals
der Gesellschaft erreicht hat. Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich
aus welchem Grunde.
Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,
beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.
Auflösung
Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.
Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis
ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.
Geltende Gesetzgebung
Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht
ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind. „
102255
L
U X E M B O U R G
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Entschädigungen und Aufwendungen jeglicher Form, welche von der Gesellschaft zu begleichen
sind, werden auf ungefähr EUR 1.200.- geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen
der oben erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung
abgefasst ist; auf Verlangen derselben oben erschienenen Person soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich sein.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg, am Tag wie eingangs dieses Dokuments erwähnt, aufgenommen
wurde.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Perso-
nenstand und Wohnort bekannt ist, hat diese Person diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. LABUSCH, und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30382. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SANDT.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 26. Juli 2010.
Référence de publication: 2010116042/387.
(100131960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Sethos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 93.031.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010115999/13.
(100131700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
COFIBOL, Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 20.803.
<i>Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la compagnie financiers et boursière Luxembourgeoise en abrégé COFIBOLi>
<i>du 26 mai 2010i>
Est nommé à l'unanimité Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Michel Parizel.
249, rue de l'Eglise
B- 6717 Thiaumont (Belgique)
Est nommé à l'unanimité Directeur Général:
Monsieur Michel Parizel
Sont nommés à l'unanimité Administrateurs Délégués:
Monsieur Alex De Jésus
Madame Elisabeth Lacouture
Le Conseil d'Administration a nommé à l'unanimité pour une durée de 1 an au poste de Réviseurs:
DELOITTE SA
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2010116099/21.
(100131061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
102256
L
U X E M B O U R G
Shay Properties Bury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 124.723.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2010.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010116001/14.
(100131703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Simonthal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 91.691.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116006/9.
(100131908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
SKB Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.634.
J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat d’administrateur.
Ma démission prendra effet à compter du 31 août 2010.
Luxembourg, le 26 août 2010.
Sandrine ANTONELLI.
Référence de publication: 2010116007/10.
(100131777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Société Cotonnière Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 32.130.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2010.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2010116008/12.
(100131918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Trustlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 54.001.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 27 juillet 2010,
que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Sixième résolution:i>
Le mandat du commissaire aux comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de le renouveler jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011 le mandat de la société Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.,
Via Tortona 25, 20144 Milano, Italia, en qualité de Commissaire.
102257
L
U X E M B O U R G
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée prend note du changement de l'adresse professionnelle de deux administrateurs de la société comme suit:
- Monsieur Davide MURARI,30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Mirko LA ROCCA, 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2010.
<i>Pour la société TRUSTLUX S.A.
Le domiciliataire
i>BANQUE BPP S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010116351/23.
(100131374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Société Flue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 71.083.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 15 avril 2010 que:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, a
été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116010/13.
(100131582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Stadlux Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 79.412.
J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat d’administrateur.
Ma démission prendra effet à compter du 31 août 2010.
Luxembourg, le 26 août 2010.
Sandrine ANTONELLI.
Référence de publication: 2010116012/10.
(100131778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 52.864.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du
04 juin 2010 à 11.00 h
a été nommé commissaire aux comptes CRT REGISTER INTERNATIONAL SA, RCS No. B105875, ayant son siège
social 60 Grand-Rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg,
à effet rétroactif du 1
er
juin 2010 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 en remplacement de ALFA
FINANCIAL CONTROL SERVICES Sàrl.
102258
L
U X E M B O U R G
Le 25 août 2010.
STEINER UND SCHMIDT GRUPPE INVESTHOLDING S.A.,
Société de gestion de patrimoine familial (SPF)
J.H. VAN LEUVENHEIM
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2010116013/20.
(100132002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Symbolinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 123.683.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2010.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2010116015/11.
(100131988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Sublim Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 115.498.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2010.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Gabriele Schneider / Pierre Schmit
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010116014/13.
(100131919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Tanis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 92.370.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010116017/13.
(100131701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Targa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 67.250.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 décembre 2009i>
<i>Résolution:i>
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à
l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 comme suit:
<i>Commissaire aux comptes:i>
Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
102259
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010116018/18.
(100131222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Tenadu Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 64.404.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010116021/10.
(100131794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Tellux Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 110.881.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2010.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2010116020/11.
(100131989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Tenadu Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 64.404.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010116024/10.
(100131796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Thamesline Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 100.193.
Il résulte de quatre courriers adressés à la Société que Monsieur José Correia, Madame Géraldine Schmit, Monsieur
Alan Dundon, administrateurs de la Société ainsi que Read S.à r.l. commissaire aux comptes de la Société ont démissionné
de leurs mandats respectifs en date du 26 juillet 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Correia José / Schmit Géraldine
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010116025/14.
(100131259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
102260
L
U X E M B O U R G
Imprimerie de l'Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 6.968.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 23 marsi>
<i>2009 à 12.00 heuresi>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de l'administrateur Marina Gazzo, domiciliée 283, avenue Henri Giraud
à F-06140 Vence pour une durée de 5 ans.
L'Assemblée décide de nommer administrateur Lorenzo Riccardi, domicilié 73, avenue des Archiducs à B-1170 Bru-
xelles pour une durée de 5 ans.
L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes Marisa Nicoli, domiciliée 36, avenue Jeanne à B-1050 Bru-
xelles pour une durée de 5 ans.
Luxembourg, le 23 mars 2009.
Pour extrait conforme
IMPRIMERIE DE L'EUROPE S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116110/19.
(100131196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Tintoretto Sicar S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.850.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010116026/13.
(100131830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Topaze Funds S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 144.796.
J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat d’administrateur.
Ma démission prendra effet à compter du 31 août 2010.
Luxembourg, le 26 août 2010.
Sandrine ANTONELLI.
Référence de publication: 2010116027/10.
(100131779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
International Business Consultants S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 51.863.
Après vérification de l'extrait RCS de la société International Business Consultants S.A. ayant son siège sociale au 43,
boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg B51863, l'administrateur délégué Marc Hurner, a constaté que les modifi-
cations suivantes s'imposent:
-Conseil d'administration: Strategic Management Consulting S.A.
La dénomination sociale de cette société a été modifiée en FIP (Luxembourg) S.A. ainsi que son siège social. La nouvelle
adresse est 43, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et remplace donc l'ancienne: 26, boulevard Royal L-2449
Luxembourg.
L'adresse de Monsieur Marc Hurner est actuellement 364 boulevard Lambermont B-1030 Bruxelles et remplace donc
l'ancienne: 107 rue F. Bossaerts B-1030 Bruxelles.
102261
L
U X E M B O U R G
Délégué(s) à la gestion journalière: Marc HURNER
L'adresse de Monsieur Marc Hurner est actuellement 364 boulevard Lambermont B-1030 Bruxelles et remplace donc
l'ancienne: 107 rue F. Bossaerts B-1030 Bruxelles.
Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes: Overseas Transactions Limited S.A.
La dénomination sociale de cette société a été modifiée en FIP International S.A.
Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes: Paul DAVID
Cette personne étant décédée, elle doit être radiée.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2010116880/25.
(100133214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.
Unidiam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 125.480.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 9 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116030/10.
(100131932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
UTM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 26.059.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116031/11.
(100131611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
UTM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 26.059.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2010:i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Alain Louis TRICOLET, demeurant à 78, route Bleue, F-13620 Carry Le Rouet, aux fonctions d'adminis-
trateur;
- Monsieur Jacques RECKINGER, demeurant professionnellement au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d’administrateur
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.
L’Assemblée Générale nomme comme commissaire aux comptes:
- Fiduciaire de Luxembourg S.A., 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116032/18.
(100131612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
102262
L
U X E M B O U R G
Agence EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 5.271.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 23 marsi>
<i>2009 à 11.00 heuresi>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs Ferdinando Riccardi, domicilié avenue Jeanne 36 à
B-1050 Bruxelles et Marina Gazzo, domiciliée 283, avenue Henri Giraud à F-06140 Vence pour une durée de 5 ans.
Luxembourg, le 23 mars 2010.
Pour extrait conforme
AGENCE EUROPE S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116070/15.
(100131209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
V Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 81.471.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116033/9.
(100132011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Valence S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 92.314.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010116034/13.
(100131702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Vento Italia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 107.849.
Il a été décidé par l'envoi d'un courrier recommandé en date du 3 août 2010 que la société PKF ABAX AUDIT, 6 place
de Nancy L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 27761, démissionne de son mandat de commissaire da la société
VENTO ITALIA S.A. avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2010.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2010116035/13.
(100131550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
102263
L
U X E M B O U R G
Treno Finanz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 233.300,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 116.871.
<i>Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on July 8 i>
<i> t i>
<i>hi>
<i> i>
<i> , 2010i>
Mr. Philippe Stanko, born on 15 January 1977 in Wittlich, Germany, having his professional address at 412F, Route
d'Esch, L-2086 Luxembourg is appointed as additional Manager of category B. Mr. Philippe Stanko is appointed for an
unlimited period.
Suit la traduction française de ce qui précède:
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 juillet 2010i>
Monsieur Philippe Stanko, né le 15 janvier 1977 à Wittlich, Allemagne, avec adresse professionnelle à 412F, Route
d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé en tant que gérant de catégorie B pour une durée illimitée.
TRENO FINANZ S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2010116159/19.
(100131109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
VH Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 138.820.
RECTIFICATIF
Cette mention rectificative annule et remplace la version déposée antérieurement le 8 juin 2010 sous le No:
L100080061
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2010.
Référence de publication: 2010116036/13.
(100131788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Visylia Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 136.902.
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2010.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2010116038/12.
(100131920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
VLT Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 115.108.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
102264
L
U X E M B O U R G
d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2009.
Luxembourg, le 25 juin 2010.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010116039/18.
(100131422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Bad Langensalza, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.481.
Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116084/11.
(100131006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 101.882.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2010.
Référence de publication: 2010116040/10.
(100131507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Sagamore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 101.667.
In the year two thousand and ten, on the eighteenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Sagamore S.A.”, a joint-stock company (société
anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 101667 (the Company), incorporated by a deed of Maître Léon Thomas, known as
Tom Metzler, notary residing in Luxembourg, of July 6, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 906 of September 10, 2004 and whose bylaws have been last amended by a deed of Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of October 10, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 365 of February 18, 2006.
The meeting is chaired by Mr Marc VAN HOEK, chartered accountant, with 527.500 EUR professional address at 16,
rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address at 74, Avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, and as scrutineer Mr Raymond THILL, “maître en droit”, with professional address at
74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act that:
I. The shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be registered with the present minutes.
II. It appears from the said attendance list that all the five thousand two hundred and fifty (5,250) shares of the Company
with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, which shares are fully paid up, are present or represented
at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. The
shareholders represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so
that no convening notices were necessary.
102265
L
U X E M B O U R G
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgement of the auditor’s report issued by ACSE Audit Conseil Services, with registered office at 41,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Acknowledgement of the report issued by the board of directors for the purposes of the issue by the Company of
convertible bonds (and including their terms and conditions), a copy of these reports having been sent to each shareholder
of the Company;
3. Acknowledgement that:
3.1. the CBs (as defined below) are convertible into shares in registered form of the Company (the Conversion Shares)
at a conversion ratio of 1:1 (i.e. one CB in a nominal amount of one hundred Euro (EUR 100,00) entitles its registered
holder), upon the conversion thereof being made in accordance with the terms and conditions of the CBs, to one Con-
version Share in a nominal amount of one hundred Euro (EUR 100,00), and
3.2. on the issue of the Conversion Shares, such shares shall be issued in accordance with the terms and conditions
of the CBs, entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding
shares, as the case may be, save as otherwise provided in the terms and conditions of the CBs;
4. Authorization of the issue by the Company (the Issue) of twenty-one thousand (21,000) convertible bonds, having
a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each (the CBs);
5. Waiver by Xerius Limited, an International Business Company, incorporated and existing under the laws of Anguilla,
having its registered office at Caribbean Suite, The Valley, Anguilla and registered with the Companies Register of the
British West Indies under number 2038357 of its preferential subscription right in respect of two hundred and nineteen
(219) CBs;
6. Empowerment of and authorization to the board of directors (a) to implement the Issue and determine its terms
and conditions, and (b) to determine the date of the Issue;
7. Authorization for the creation and update of the bondholders’ register of the Company;
8. Increase of the share capital by an amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.00) in order to raise it
from its present amount of five hundred twenty-five thousand Euro (EUR 525,000.00) to five hundred twenty-seven
thousand five hundred Euro (EUR 527,500.00) by creation and issue of twentyfive (25) new shares, with a nominal value
of one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of three million six hundred
seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 3,672,500.00);
9. Exercise, by the shareholders, of their preferential subscription right in respect of the share’s issue;
10. Subscription by Xerius Limited, prenamed, for nineteen (19) new shares with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two million seven hundred ninety-one thousand one
hundred Euro (EUR 2,791,100.00) and full payment in the total amount of two million seven hundred ninety-three thou-
sand Euro (EUR 2,793,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of a
receivable held by Xerius Limited towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Xerius
Receivable);
11. Subscription by Silver Ax Systems Corporation, an International Business Company, incorporated and existing
under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Yarmaj Building, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, and registered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number 632759, for four
(4) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the
amount of five hundred eighty-seven thousand six hundred Euro (EUR 587.600,00) and full payment in the total amount
of five hundred eightyeight thousand Euro (EUR 588,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a
portion in the same amount of a receivable held by Silver Ax Systems Corporation towards the Company, which receivable
is incontestable, payable and due (the Silver Receivable);
12. Subscription by Waseda International Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of Panama,
having its registered office at Fifth Avenue and Thirtieth East Street 30-11, P.O. Box 6974, Panama 5, Panama, and regis-
tered with the Commercial Registry of Panama under number 162839, for two (2) new shares with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two hundred ninety-three thou-
sand eight hundred Euro (EUR 293,800.00) and full payment in the total amount of two hundred ninety-four thousand
Euro (EUR 294,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of a receivable
held by Waseda International Inc. towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Waseda
Receivable);
13. Acceptance by the Company of the valuation and of the independent auditor’s report, in accordance with article
32-1 (5) of the law of August 10, 1915, on commercial companies, established by ACSE Audit Conseil Services, auditor,
prenamed;
14. Amendment of article 5, first paragraph of the Company’s bylaws which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. First paragraph. The share capital is set at five hundred twentyseven thousand five hundred Euro (EUR
527,500.00) represented by five thousand two hundred and seventy-five (5,275) shares of one hundred Euro (EUR 100.00)
each.”
102266
L
U X E M B O U R G
15. Miscellaneous.
IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting acknowledges the report established by ACSE Audit Conseil Services, prenamed, in connection with the
Issue by the Company of the CBs, which report concludes as follows:
<i>Conclusioni>
“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of
each contribution, which corresponds at least to the value of the shares which would be issued in exchange of the
Convertible Bonds.”
<i>Second resolutioni>
The meeting acknowledges the report of the board of directors of the Company dated August 3, 2010, which includes
the terms and conditions of the issue of the CBs.
<i>Third resolutioni>
The meeting acknowledges that: (i) the CBs are convertible into Conversion Shares at a conversion ratio of 1:1 (i.e.
one CB in a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) entitles its registered holder, upon the conversion thereof
being made in accordance with the terms and conditions of the CBs which are hereby approved by the meeting, to one
Conversion Share of a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00), and that (ii) upon the conversion and the issue
of the Conversion Shares, such shares shall be issued as shares in accordance with the terms and conditions of the CBs,
entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding shares of the
Company save as otherwise stated in the terms and conditions of the CBs.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to approve the terms and conditions of the CBs as set forth in the report issued by the board
of directors and to approve the issue of twenty-one thousand (21,000) CBs, with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.00) each, for an aggregate amount of two million one hundred Euro (EUR 2,100,000.00).
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to record the waiver by Xerius Limited, prenamed, of its preferential subscription right in respect
of two hundred and nineteen (219) CBs.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolves to authorize the board of directors to: (i) implement the issue of the CBs in accordance with
and subject to its terms and conditions, and to: (ii) determine the date of the issue of the CBs and its terms and conditions
as set forth in the directors’ report.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolves to authorize the creation and update of the bondholders’ register of the Company.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred Euro
(EUR 2,500.00) in order to raise it from its present amount of five hundred twenty-five thousand Euro (EUR 525,000.00)
to five hundred twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 527,500.00) by creation and issue of twenty-five (25)
new shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount
of three million six hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 3,672,500.00), for an aggregate amount of
four million two hundred thousand Euro (EUR 4,200,000.00).
<i>Ninth resolutioni>
The meeting resolves to record the exercise by the shareholders of their preferential subscription rights in respect
of the shares issue.
<i>Subscription - Paymenti>
Xerius Limited, prenamed, declares to subscribe for nineteen (19) new shares with a nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two million seven hundred ninety-one thousand
one hundred Euro (EUR 2,791,100.00) and to fully pay them up for an aggregate amount of two million seven hundred
ninety-three thousand Euro (EUR 2,793,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the
same amount of the Xerius Receivable.
Silver Ax Systems Corporation, prenamed, declares to subscribe for four (4) new shares with a nominal value of one
hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of five hundred eighty-seven thousand
102267
L
U X E M B O U R G
six hundred Euro (EUR 587,600.00) and to fully pay them up for an aggregate amount of five hundred eighty-eight thousand
Euro (EUR 588,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of the Silver
Receivable.
Waseda International Inc., prenamed, declares to subscribe for two (2) new shares with a nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two hundred ninety-three thousand eight
hundred Euro (EUR 293,800.00) and to fully pay them up for an aggregate amount of two hundred ninety-four thousand
Euro (EUR 294,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of the
Waseda Receivable.
The value of their contribution in kind is declared by Xerius Limited to be of two million seven hundred ninety-three
thousand Euro (EUR 2,793,000.00), by Silver Ax Systems Corporation to be of five hundred eighty-eight thousand Euro
(EUR 588,000.00) and by Waseda International Inc. to be of two hundred ninetyfour thousand Euro (EUR 294,000.00)
for a total value of three million six hundred seventy-five thousand (EUR 3,675,000.00), which valuation is accepted by
the Company and was subject to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended, established by ACSE Audit Conseil Services, prenamed, which report
concludes as follows:
<i>Conclusioni>
“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of
each contribution, which corresponds at least to the value of the shares to be issued to each contributor, plus their
respective share premium.”
The above mentioned report, being initialized ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Effective implementation of the contributioni>
Xerius Limited prenamed, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Xerius Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally
and conventionally freely transferable.
- the Xerius Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Xerius Limited
is entitled to any rights as to the Xerius Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Xerius Receivable, in order to duly carry
out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.
Silver Ax Systems Corporation, prenamed, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Silver Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally
and conventionally freely transferable;
- the Silver Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Silver Ax
Systems Corporation is entitled to any rights as to the Silver Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Silver Receivable, in order to duly carry
out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.
Waseda International Inc., prenamed, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Waseda Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally
and conventionally freely transferable;
- the Waseda Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Waseda
International Inc. is entitled to any rights as to the Waseda Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Waseda Receivable, in order to duly carry
out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Directors’ interventioni>
Thereupon intervened the directors of the Company, duly represented by Mr Marc VAN HOEK, who require the
notary to act as follows:
The directors acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as
directors of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of
this contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Tenth resolutioni>
The meeting resolves to approve the valuation and the independent auditor’s report issued, in accordance with article
32-1 (5) of the law of August 10, 1915, on commercial companies, established by ACSE Audit Conseil Services, auditor,
prenamed.
102268
L
U X E M B O U R G
<i>Eleventh resolutioni>
Pursuant to the above capital increase, the meeting resolves to restate article 5, first paragraph of the Company’s
bylaws which shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. First paragraph. The share capital is set at five hundred twentyseven thousand five hundred Euro (EUR
527,500.00) represented by five thousand two hundred and seventy-five (5,275) shares of one hundred Euro (EUR 100.00)
each.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand two hundred Euro (EUR 3,200.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille dix, le dix-huit août.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Sagamore S.A.”, ayant son
siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101667 (la Société), constituée suivant acte de Maître Léon
Thomas connu sous le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 6 juillet 2004, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 906, du 10 septembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire, résident à Luxembourg, reçu en
date du 10 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°365, du 18 février 2006.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, ayant son adresse
professionnelle au 16, rue de Nassau, L2213 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, ayant son adresse professionnelle
au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, et comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, ayant
son adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Il apparaît de cette liste de présence que les cinq mille deux cent cinquante (5,250) actions de la Société, d’une valeur
nominale de cent (EUR 100.00) chacune, toutes entièrement libérées, sont présentes ou représentées à la présente
assemblée, de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour. Il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Prise de connaissance du rapport d’audit émis par ACSE Audit Conseil Services, domicilié au 41, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg;
2. Prise de connaissance du rapport émis par le conseil d’administration en vue de l’émission par la Société d’obligations
convertibles (incluant leurs termes et conditions), une copie de ces rapports ayant été envoyée à chacun des actionnaires
de la Société;
3. Reconnaissance de ce que:
3.1. les OCs (tels que définis ci-après) sont convertibles en actions nominatives de la Société (les Actions de Conver-
sion) à un taux de conversion de 1:1 (c’est-à-dire qu’une OC d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) donne
droit à son détenteur inscrit, lors de la conversion de celle-ci soumise et faite conformément aux conditions générales
des OCs, à une Action de Conversion d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) et que,
3.2. lors de la conversion et de l’émission des Actions de Conversion, ces actions seront émises conformément aux
termes et conditions des OCs, conférant selon le cas à leurs détenteurs respectifs les mêmes droits que les détenteurs
102269
L
U X E M B O U R G
des actions de la Société actuellement émises et en circulation, sauf autrement prévu dans les termes et conditions des
OCs;
4. Emission par la Société (l’Emission) de vingt et un mille (21.000) obligations convertibles, d’une valeur nominale de
cent Euro (EUR 100,00) chacune (les OCs);
5. Renonciation par Xerius Limited, une International Business Company, régie par les lois d’Anguilla, ayant son siège
social au Caribbean Suite, The Valley, Anguilla, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Antilles Britanniques
sous le numéro 2038357, à son droit de souscription préférentiel sur deux cent dix-neuf (219) OCs;
6. Pouvoir et autorisation au conseil d’administration (i) de mettre en oeuvre l’Emission conformément à et d’après
les conditions générales des OCs telles que définies dans son rapport, (ii) de déterminer la date de l’Emission;
7. Pouvoirs pour la création et la mise à jour du registre des obligations de la Société;
8. Augmentation du capital social à concurrence de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,00) pour le porter de son
montant actuel de cinq cent vingt-cinq mille Euro (EUR 525.000,00) à cinq cent vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR
527.500,00) par la création et l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune pour un montant total de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,00) ensemble avec une prime d’émission
de trois millions six cent soixante-douze mille cinq cents Euro (EUR 3.672.500,00);
9. Exercice par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription eu égard à l’émission d’actions;
10. Souscription par Xerius Limited, susnommée, à dix-neuf (19) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro
(EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-onze mille
cent Euro (EUR 2.791.100,00) et libération intégrale pour un montant total de deux millions sept cent quatre-vingt-treize
mille Euro (EUR 2.793.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant
d’une créance détenue par Xerius Limited envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible (la Créance
Xerius);
11. Souscription par Silver Ax Systems Corporation, une International Business Company, régie par les lois des Iles
Vierges Britanniques, ayant son siège social au Yarmaj Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et enre-
gistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 632759, à quatre (4) nouvelles actions
d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de cinq cent
quatre-vingt-sept mille six cents Euro (EUR 587.600,00) et libération intégrale pour un montant total de cinq cent quatre-
vingt huit mille Euro (EUR 588.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même
montant d’une créance détenue par Silver Ax Systems Corporation envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide
et exigible (la Créance Silver);
12. Souscription par Waseda International Inc., une corporation régie par les lois de Panama, ayant son siège social au
Fifth Avenue and Thirtieth East Street 30-11, P.O. Box 6974, Panama 5, Panama, et enregistrée auprès du Registre des
Sociétés de Panama sous le numéro 162839, à deux (2) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00)
chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux cent quatre-vingt-treize mille huit cents Euro (EUR
293.800,00) et libération intégrale par un montant total de deux cent quatrevingt-quatorze mille Euro (EUR 294.000,00),
par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant d’une créance détenue par Waseda
International Inc. envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible (la Créance Waseda);
13. Approbation par la Société de l’évaluation et du rapport du réviseur indépendant, conformément à l’article 32-1
(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, établit par ACSE Audit Conseil Services, susnommé;
14. Modification de l’article 5, premier alinéa des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent vingt-sept mille cinq cents Euro
(EUR 527.500,00) divisé en cinq mille deux cent soixante-quinze (5.275) actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune.»;
15. Divers
IV. L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend connaissance du rapport établi par ACSE Audit Conseil Services, susnommé, relatif à l’émission
d’obligations convertibles par la Compagnie, lequel rapport conclu comme suit:
<i>Conclusioni>
“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of
each contribution, which corresponds at least to the value of the shares which would be issued in exchange of the
Convertible Bonds.”
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend connaissance du rapport du conseil d’administration de la Société daté du 3 août 2010, incluant les
conditions générales de l’émission des OCs.
102270
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate que: les OCs sont convertibles en actions de conversion à un taux de conversion de 1:1 (c’est-
à-dire qu’une OC d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) donne droit à son détenteur inscrit lors de la
conversion de celle-ci conformément aux conditions générales des OCs, qui sont par la présente approuvées par l’as-
semblée, à une Action de Conversion d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) et que: (ii) lors de la conversion
et de l’émission des Actions de Conversion, ces actions seront émises conformément aux conditions générales des OCs,
conférant à leurs détenteurs respectifs les mêmes droits que les détenteurs des actions de la Société émises et en
circulation, sauf autrement prévu dans les conditions générales des OCs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver les termes et conditions des OCs, telles que définies dans le rapport émis par le conseil
d’administration et d’autoriser l’émission de vingt et un mille (21.000) OCs, d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune, pour un montant total de deux millions cent mille Euro (EUR 2.100.000,00)
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’acter la renonciation par Xerius Limited, susnommée à son droit préférentiel de souscription
sur deux cent dix-neuf (219) OCs.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à: (i) mettre en œuvre l’émission d’OCs conformément aux
conditions générales des OCs telles que définies dans son rapport, et: (ii) déterminer la date de l’émission d’OCs.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser la création et la mise à jour du registre des obligations de manière à inscrire l’émission
d’OCs.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux mille cinq cents Euro (EUR
2.500,00) pour le porter de son montant actuel de cinq cent vingt-cinq mille Euro (EUR 525.000,00) à cinq cent vingt-
sept mille cinq cents Euro (EUR 527.500,00) par la création et l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles actions de cent Euro
(EUR 100,00) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions six cent soixante-douze mille cinq cents
Euro (EUR 3.672.500,00), pour un montant total de quatre millions deux cent mille Euro (EUR 4.200.000,00).
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de prendre acte de l’exercice par les actionnaires de leur droit de souscription préférentiel relatif
à l’émission d’actions.
<i>Souscription - Libérationi>
Xerius Limited, susnommée, déclare souscrire à dix-neuf (19) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro
(EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-onze mille
cent Euro (EUR 2.791.100,00) et les libérer intégralement pour un montant total de deux millions sept cent quatre-vingt-
treize mille Euro (EUR 2.793.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même
montant de la Créance Xerius.
Silver Ax Systems Corporation, susnommée, déclare souscrire à quatre (4) nouvelles actions d’une valeur nominale
de cent Euro (EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de cinq cent quatre-vingt-sept mille
six cents Euro (EUR 587.600,00) et les libérer intégralement pour un montant total de cinq cent quatre-vingt huit mille
Euro (EUR 588.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant de la
Créance Silver.
Waseda International Inc., susnommée, déclare souscrire à deux (2) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent
Euro (EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux cent quatre-vingt-treize mille huit
cents Euro (EUR 293.800,00) et les libérer intégralement pour un montant total de deux cent quatre-vingt-quatorze mille
Euro (EUR 294.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant de la
Créance Waseda.
La valeur de leur apport en nature est déclarée être de deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille Euro (EUR
2.793.000,00) par Xerius Limited, de cinq cent quatre-vingt-huit mille Euro (EUR 588.000,00) par Silver Ax Systems
Corporate et de deux cent quatre-vingt-quatorze mille Euro (EUR 294.000,00) par Waseda International Inc., pour un
montant total de trois million six cent soixante-quinze mille Euro (EUR 3.675.000,00); les estimations, acceptées par la
Société, ont été sujettes au rapport d’un réviseur d’entreprise indépendant conformément à l’article 32-1 (5) de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée, établi par ACSE Audit Conseil Services, susnommé, et
dont le rapport conclut comme suit:
102271
L
U X E M B O U R G
<i>Conclusioni>
“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of
each contribution, which corresponds at least to the value of the shares to be issued to each contributor, plus their
respective share premium.”
Ledit raport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte pour être formalisé avec lui.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
Xerius Limited, susnommée, par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire sans restriction de la Créance Xerius et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance Xerius n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que
Xerius Limited ne détient de droit sur la Créance Xerius;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance Xerius, aux fins
d’effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.
Silver Ax Systems Corporation, susnommée, par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire sans restriction de la Créance Silver et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance Silver n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que
Silver Ax Systems Corporation ne détient de droit sur la Créance Silver;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance Silver, aux fins
d’effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.
Waseda International Inc., susnommée, par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire sans restriction de la Créance Waseda et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance Waseda n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que
Waseda International Inc. ne détient de droit sur la Créance Waseda;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance Waseda, aux fins
d’effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.
<i>Intervention des administrateursi>
Sont alors intervenus les administrateurs de la Société, ici représentés par Monsieur Marc VAN HOEK, qui prient le
notaire d'acter que:
Les administrateurs reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement
engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, ils consentent expres-
sément à la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la
libération.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver l’évaluation et le rapport du réviseur indépendant, conformément à l’article 32-1 (5)
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, établi par ACSE Audit Conseil Services, susnommé.
<i>Onzième résolutioni>
Suite à l’augmentation du capital social, l’assemblée décide de modifier l’article 5, premier alinéa des statuts de la Société
pour lui conférer la teneur suivante:
« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent vingt-sept mille cinq cents Euro
(EUR 527.500,00) divisé en cinq mille deux cent soixante-quinze (5.275) actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison de la présente, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille deux cents euros (EUR 3.200,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
102272
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite aux comparantes, connus du notaire par leur nom, prénom, statut et demeure, les membres du
bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Van Hoek, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 août 2010. LAC/2010/37345. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2010.
Référence de publication: 2010116679/415.
(100132250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2010.
Walterstuff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.
R.C.S. Luxembourg B 97.790.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010116044/10.
(100131226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Torsch Private Equity S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 155.182.
STATUTS
L'an deux mil dix, le vingt-six août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
TORSCH FINANCIERE S.A., SPF, société anonyme de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
ici représentée par Madame Cristina SOARES, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxem-
bourg, 2, avenue Charles de Gaulle,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 19 août 2010.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société anonyme à constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société de gestion de patrimoine familial sous forme d’une société anonyme
qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.
La société prend la dénomination de TORSCH PRIVATE EQUITY S.A., SPF.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l’administrateur unique, la société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d’une résolution de l’actionnaire unique ou en cas de
pluralité d’actionnaires au moyen d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
102273
L
U X E M B O U R G
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs constitués d’ins-
truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d’espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.
Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s’immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.
Les titres qu’elle émettra ne pourront faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de
valeurs.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d’une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois
mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros) qui sera
représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 août 2015, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme
qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
102274
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou
téléphonique dans les formes prévues par la loi.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous
les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d’administrateur unique, par la
signature individuelle de l’administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le quatrième mardi du mois d’avril à 14.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
102275
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai
2007 sur la société de gestion de patrimoine familial ("SPF") trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre
2010.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique, TORSCH FINANCIERE S.A., SPF, ayant
son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros (EUR
1.100,-).
<i>Résolutions de l’actionnaire uniquei>
L’actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du
premier exercice social:
1. Monsieur John SEIL, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-
rant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
2. Monsieur Guy HORNICK, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, maître en sciences économiques, demeurant pro-
fessionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
3. Monsieur Luc HANSEN, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant pro-
fessionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Monsieur John SEIL, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les
comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65.469.
102276
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses noms,
prénoms, états et demeures, la mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Soares, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 26 août 2010. Relation: RED/2010/1201. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 31 août 2010.
Référence de publication: 2010117993/206.
(100133998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2010.
WCMG (Working Capital Management Group) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 63.826.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2010.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010116045/12.
(100132003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Predica Infrastructure S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 27.600.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 137.978.
In the year two thousand and ten, on the twenty-nine day of June,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of the shareholders of Predica
Infrastructure S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 137.978 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul
Bettingen, notary of residence in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg on March 28, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1185 of May 15, 2008, the articles of incorporation of which were amended
for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg dated November 19, 2009,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 44 of January 7, 2010.
The Extraordinary General Meeting was opened at 15.15 p.m., with Mrs. Maya Van Belleghem, licenciée en droit,
residing professionally in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary, Mrs. Emilie Dallemagne, licenciée en droit, residing professionally in Luxembourg.
The Extraordinary General Meeting elected as scrutineer, Mrs. Anne-Laure Mollard, avocat, residing professionally in
Luxembourg.
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to state:
I. That the shareholder present or represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of
its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholder or the proxyholder of the
represented shareholder and by the board of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present
deed in order to be registered therewith.
The proxy of the represented shareholder, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to
the present deed.
II That it appears from the attendance list, which shall remain attached to the present deed to be filed therewith with
the registration authorities, that two million one hundred sixty thousand (2,160,000) redeemable class A shares having a
102277
L
U X E M B O U R G
nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, representing the entire share capital of the Company, are present or repre-
sented at the Extraordinary General Meeting.
III. That the entire share capital being present or represented at the present Extraordinary General Meeting and the
shareholder present or represented declaring that it had due notice and received knowledge of the below agenda as well
as any information in relation thereto prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.
IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and
may validly deliberate on all the items of the agenda as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by a contribution in cash;
2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
“The Company has a subscribed share capital of twenty-seven million six hundred thousand Euro (EUR 27,600,000.-),
represented by two million seven hundred sixty thousand (2,760,000) redeemable class A shares (the “Class A Shares”),
with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.”
3. Miscellaneous.
After having duly deliberated on all items of the agenda, the Extraordinary General Meeting unanimously took the
following resolutions and requested the officiating notary to record as follows:
<i>First Resolutioni>
The Extraordinary General Meeting resolved to increase the share capital of the Company by six million Euro (EUR
6,000,000.-), from twenty-one million six hundred thousand Euro (EUR 21,600,000.-) up to twenty-seven million six
hundred thousand Euro (EUR 27,600,000.-), by the issue of six hundred thousand (600,000) new redeemable class A
shares, with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.
The six hundred thousand (600,000) redeemable class A shares newly issued have been entirely subscribed and fully
paid up by Predica S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of
France, having its registered office located at 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris, France, registered with the Register
of Companies of Paris under number 334.028.123, here represented by Mrs. Maya Van Belleghem, by virtue of a proxy
given under private seal, here annexed, by a contribution in cash, so that the amount of six million Euro (EUR 6,000,000.-)
is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Second Resolutioni>
As a result of the foregoing resolution, the Extraordinary General Meeting resolved to modify the first paragraph of
article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:
“The Company has a subscribed share capital of twenty-seven million six hundred thousand Euro (EUR 27,600,000.-),
represented by two million seven hundred sixty thousand (2,760,000.-) redeemable class A shares (the “Class A Shares”),
with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.”
The rest of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged.
<i>Estimate of Costsi>
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of this Extraordinary General Meeting is estimated at approximately EUR
3,800.-
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version, on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille dix, le vingt-neuf juin,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de Predica Infrastructure S.A., une
société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.978
(la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 28 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1185 du 15
mai 2008, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx, de résidence à
102278
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, en date du 19 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 44 du 7
janvier 2010.
L’Assemblée est ouverte à 15h15 sous la présidence de Madame Maya Van Belleghem, licenciée en droit, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Emilie Dallemagne, licenciée en droit, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Laure Mollard, avocat, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d'actions de l’actionnaire,
sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par l’actionnaire ou par son mandataire et par les membres du
bureau de l’Assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La procuration de l’actionnaire représenté, paraphée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera aussi annexée au présent acte.
II. Il ressort de la liste de présence, qui restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, que les deux
millions cent soixante mille (2.160.000) actions rachetables de classe A d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune, composant l’intégralité du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à l’Assemblée.
III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée et l’actionnaire présent ou
représenté déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour ci-dessous et de toute information y relative avant
l’Assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.
IV. La présente Assemblée, représentant l’intégralité du capital social de la Société, est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du Jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société par un apport en numéraire;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société;
«La Société a un capital souscrit de vingt-sept millions six cent mille euros (EUR 27.600.000,-), représenté par deux
millions sept cent soixante mille (2.760.000,-) actions rachetables de classe A (les «Actions de Classe A») d'une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»
3. Divers.
Après avoir délibéré sur tous les points à l’ordre du jour, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes et
a requis le notaire instrumentant de bien vouloir acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de six millions d’euros (EUR 6.000.000,-),
pour le porter de son montant actuel de vingt et un millions six cent mille euros (EUR 21.600.000,-) à vingt-sept millions
six cent mille euros (EUR 27.600.000,), par l’émission de six cent mille (600.000) actions rachetables de classe A, d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les six cent mille (600.000) actions rachetables de classe A nouvellement émises ont été entièrement souscrites et
libérées par Predica S.A., une société anonyme constituée et régie selon la loi française, ayant son siège social au 50-56,
rue de la Procession, 75015 Paris, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 334.028.123, ici représentée par Madame Maya Van Belleghem, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-
annexée, par un apport en numéraire, de sorte que la somme de six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) se trouve à la
disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts
de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société a un capital souscrit de vingt-sept millions six cent mille euros (EUR 27.600.000,-), représenté par deux
millions sept cent soixante mille (2.760.000,-) actions rachetables de classe A (les «Actions de Classe A») d'une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»
Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de cette Assemblée est estimé à environ EUR 3.800,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
102279
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française, sur demande des comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connu du notaire instrumentant par leur nom, prénom
usuel, état et demeure, les comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. VAN BELLEGHEM, E. DALLEMAGNE, A.-L. MOLLARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30373. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 août 2010.
Référence de publication: 2010116946/150.
(100132915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.
Zeppelin Park, Société à responsabilité limitée,
(anc. Bountiful S.à r.l.).
Capital social: EUR 2.019.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 114.775.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010116046/12.
(100132026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Abattoir Ettelbruck S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.
R.C.S. Luxembourg B 130.564.
L'an deux mille dix, le six août.
Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch.
A comparu:
Monsieur Claude GRAFF, administrateur délégué, demeurant à L-9132 Schieren, 6, Op der Schlaed,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme "ABATTOIR ETTEL-
BRUCK S.A.", avec siège social à L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale, numéro du RCS Luxembourg B
130564;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro
2074 du 24 septembre 2007,
en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration, prise en sa réunion du 5 juillet 2010 et
dont une copie du procès-verbal restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:
I. Que le capital social de la société "ABATTOIR ETTELBRUCK S.A." s'élève actuellement à quatre millions (4.000.000)
euros, divisé en huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) euros chacune.
II. Que dans le cadre du capital autorisé prévu à l'article 5 des statuts de la société anonyme unipersonnelle "ABATTOIR
ETTELBRUCK S.A.", le conseil d'administration, en sa réunion du 31 mai 2010, a autorisé d'augmenter le capital social
de la société de maximal un million (1.000.000) euros en fixant la date limite pour la souscription au trente et un juillet
deux mille dix.
III. Que le montant du capital effectivement souscrit et libéré se chiffre à neuf cent cinquante-huit mille (958.000) euros.
IV. Que le capital social de la société est augmenté de neuf cent cinquante-huit mille (958.000) euros pour le porter
de son montant actuel de quatre millions (4.000.000) euros à quatre millions neuf cent cinquante-huit mille (4.958.000)
euros.
Cette augmentation est réalisée par émission de mille neuf cent seize (1.916) actions d'une valeur nominale de cinq
cents (500) euros chacune.
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de neuf cent
cinquante-huit mille (958.000) euros se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
102280
L
U X E M B O U R G
Monsieur Claude GRAFF, ès-qualtiés qu'il agisse, déclare que la société anonyme "ABATTOIR ETTELBRUCK S.A." a
approuvé cette augmentation de capital et qu'elle a renoncé à son droit préférentiel de souscription.
Les nouveaux actionnaires ainsi que le nombre d'actions souscrites par eux sont repris sur une liste, laquelle, après
avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentaire et le comparant restera annexée au présentes pour être
enregistrée avec elles.
A la suite de cette décision, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est à modifier et aura désormais la teneur
suivante:
" Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quatre millions neuf cent cinquante-huit mille (4.958.000) euros,
représenté par neuf mille neuf cent seize (9.916) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) euros chacune. Chaque
action donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à dix millions
(10.000.000) euros, représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) euros chacune."
<i>Déclaration - Frais.i>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,
que les conditions requises pour l'augmentation de capital ont été remplies.
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison
des présentes est estimé à la somme de neuf cents (900) euros.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Graff, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 11 août 2010. Relation: DIE/2010 / 7755. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société.
Diekirch, le 19 août 2010.
Fernand UNSEN.
Référence de publication: 2010116061/58.
(100129525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2010.
Compagnie de l'Europe du Sud S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 96.502.
GLOBAL TRUST ADVISORS SA a dénoncé par lettre datée du 06 Août 2010 tout office de domiciliation de la société
COMPAGNIE DE L'EUROPE DU SUD SA, domiciliée 38 Avenue de la Faïencerie (RCSL B96502),avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Août 2010.
Global Trust Advisors S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116064/12.
(100130460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2010.
SAE Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 150.334.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 août 2010i>
Il ressort des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire de SAE CAPITAL HOLDINGS S.A.:
- que Madame Candice de Boni, Madame Catherine Koch et Monsieur Nicolas Gérard ont démissionné de leur fonction
d’administrateur.
- que Madame Catherine Koch a démissionné de sa fonction de Président du Conseil d’Administration
- que les personnes suivantes ont été nommées administrateur de la société jusqu'à l’assemblée générale statutaire de
2016:
* Monsieur Alessandro BENEDETTI, né le 13 juillet 1961 à Bologne (Italie) et demeurant à Riva Paradiso 7, CH-6900
Paradiso (Suisse);
* Monsieur Bertrand GAUQUELIN des PALLIERES, né le 11 novembre 1966 à Argenteuil (France), et demeurant à
Via dei Banchi Vecchi 35, I-00135, Rome (Italie);
102281
L
U X E M B O U R G
* Monsieur Christian KRUPPA, né le 8 mars 1965, à Augsburg (Allemagne) et demeurant à Al Nessnass St 32 C, Jumeira
3, Dubai (Emirats Arabes Unis);
* Monsieur Elie Gabriel LAHYANI, né le 16 novembre 1961, à Midelt (Maroc), et demeurant à Palm Jumeira Frond L
Villa 125, BP 79265 Dubai (Emirats Arabes Unis);
* Monsieur Laurence SUDWARTS, né le 14 juin 1975, à Londres (Royaume-Uni) et demeurant à Kleine Sperlgasse,
1/33, 1020 WIEN (GKZ 9001), Autriche.
<i>POUR LA SOCIETE
i>SGG S.A.
Référence de publication: 2010116974/26.
(100133156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.
Solum 488 Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 141.414.
La fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclare
démissionner de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, de la société SOLUM 488 GROUP S.A.
situé au 273, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B141 414.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie sàrl
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010116067/17.
(100130450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2010.
Solum 488 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 141.411.
La fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclare
démissionner de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, de la société SOLUM 488 SA. situé au
273, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B141 411.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie sàrl
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010116068/17.
(100130448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2010.
AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 43.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 123.678.
Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société le 19 juillet 2010, il a été décidé de reconduire pour une
période renouvelable d'un an prenant fin lors de l'approbation par des comptes annuels de la Société au 31 décembre
2010, les mandats des gérants suivants:
- TMF Corporate Services S.A.
- M. Röhn Thomas Grazer et,
- M. Antonius Woutherus Josef van Vlerken
102282
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2010.
<i>Pour la société
i>TMF Corporate Services S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010116078/20.
(100130834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
A.F.M.S. Accounting Financial & Management Services, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 99.470.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 6 janvier 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Lex EIPPERS en son rapport oral et le Ministère Public
en ses conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme A.F.M.S.
ACCOUNTING FINANCIAL & MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant eu son siège social à L-9554 Wiltz, 3, Hannelast,
liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch en date du 24 juillet 2007.
Le même jugement a donné décharge au liquidateur, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et a laissé les frais à charge de l'Etat.
Pour extrait conforme
s. Me Daniel BAULISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010116069/17.
(100131077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Algos, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.472.
Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Référence de publication: 2010116072/12.
(100130972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Ositech SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 28.446.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue en date du 18 août 2010i>
<i>à 14.30 heures au siège social de la sociétéi>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
2016.
Le conseil d'administration se compose comme suit:
- Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la cour , né le 2 septembre 1962 à Curepipe, République de Maurice, demeurant
à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde
- Monsieur André Lutgen, avocat à la cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à L-1371 Luxembourg, 47,
Val Ste Croix
- Monsieur Stephane Lataste, avocate à la cour, né le 14 janvier 1965 à Laval (53) France, demeurant 39, rue de Crécy,
L-1364 Luxembourg
102283
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale accepte de la démission de Monsieur John A. Geddes en tant que commissaire de la Société et
nomme en ses lieux et place Monsieur André Van Acker, né à Sint-Genesius-Rode, le 8 septembre 1947, demeurant à
Lenniksebaan 1114, B-1602 Vlezenbeek. Son mandat prend effet lors de l'exercice social 2009 et viendra à échéance à
l'assemblée qui se tiendra en 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2010116938/25.
(100133229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.
Algim S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9163 Kehmen, 6, Uesperwee.
R.C.S. Luxembourg B 96.299.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010116075/10.
(100130764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Alsa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 111.448.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Référence de publication: 2010116076/12.
(100130965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Bad Langensalza, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.481.
Les comptes annuels au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Référence de publication: 2010116083/12.
(100130945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Djedefre S.A. Holding, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.352.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 6 août 2010i>
L'assemblée générale, décide de renouveler le mandat de M. Alain MARSCHALLIK de sa fonction d'administrateur
unique. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2016.
L'assemblée générale, accepte la démission de Monsieur Fabien RIGHESCHI, chargé d'affaires, de sa fonction de com-
missaire aux Comptes et de nommer en remplacement LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, société anonyme, ayant
son siège à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B
et le numéro 83.827. Son mandat expirera lors de l'assemblée statutaire de 2016.
L'assemblée générale, décide de transférer le siège social de la société établi à 2A, place de Paris à L-2314 Luxembourg
au 25C, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
102284
L
U X E M B O U R G
En conséquence, le siège social de la société est désormais établi au 25C, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alain MARSCHALLIK
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2010116215/20.
(100131397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.
Bad Schönborn, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.473.
Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Référence de publication: 2010116085/12.
(100130824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Bad Schönborn, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.473.
Les comptes annuels au 31 janvier 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Référence de publication: 2010116086/12.
(100130826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
RE Capital S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.287.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés prises en date du 20 mai 2010 que:
1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, administrateur de sociétés, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), ayant son adresse
au 20, rue des Muguets, L-8035 Strassen, Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de Gérant de la Société avec effet
depuis le 6 juillet 2009.
2. Monsieur Claudio Zaniboni, administrateur de sociétés, né le 16 août 1957 à Carpenedolo (Italie), ayant son adresse
au 9, Via Don Schena, 25013, Carpenedolo, Italie, a été nommé pour une durée indéterminée comme Gérant de la Société
avec effet depuis le 6 juillet 2009.
Depuis le 6 juillet 2009, le Conseil de Gérance est composé comme suit:
- Monsieur Augusto Bessi, administrateur de sociétés, né le 19 janvier 1976 à Padova (Italie), ayant son adresse pro-
fessionelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Madame Petra Ekas, administrateur de sociétés, née le 13 mars 1973 à Eemnes (Pays-Bas), ayant son adresse pro-
fessionelle au Berkeley Square House, Berkeley Square, W1J6BR, Londres, Grande-Bretagne;
- Monsieur Christophe Mathieu, administrateur de sociétés, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son
adresse professionelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Claudio Zaniboni, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
102285
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, 26 août 2010.
Pour extrait conforme
RE Capital S.à r.l.
Représentée par Monsieur Augusto Bessi
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010118095/30.
(100133091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.
Bad Schönborn, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.473.
Les comptes annuels au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
Signature
Référence de publication: 2010116087/11.
(100130925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
Colt Group S.A, Société Anonyme Holding.
Capital social: EUR 445.791.894,50.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 115.679.
Monsieur Tony Bates a informé le conseil d'administration de Colt Group S.A. (la "Société") qu'il souhaitait se retirer
de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 Juillet 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2010.
<i>Pour la société Colt Group S.A.
i>Esmée Chengapen
Référence de publication: 2010116093/14.
(100131072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.
LSF JRPI Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 253.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 129.121.
In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of August.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by
Mr Philippe Detournay,
here represented by Ms Mathilde Ostertag, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Luxembourg, on 23 August 2010,
AND
Rising Sun III Holding, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with
registered office at Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box
2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Mr Takehisa Tei,
here represented by Ms Mathilde Ostertag, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Tokyo, on 23 August 2010,
(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
102286
L
U X E M B O U R G
The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent
the entire share capital of LSF JRPI Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129.121, incorporated pursuant to a deed
of Maître Martine Schaeffer dated 10 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°
1625 of 2 August 2007, that has been amended since and for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated
23 April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1204 of 9 June 2010.
The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that they
may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 307,750 (three hundred seven
thousand seven hundred fifty euro) by an amount of EUR 54,750 (fifty-four thousand seven hundred fifty euro) to an
amount of EUR 253,000 (two hundred fifty-three thousand euro) by the cancellation of 438 (four hundred thirty-eight)
ordinary shares with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each; and
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 307,750 (three
hundred seven thousand seven hundred fifty euro), represented by 2,461 (two thousand four hundred sixtyone) ordinary
shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an
amount of EUR 54,750 (fifty-four thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 253,000 (two hundred fifty-
three thousand euro), represented by 2,023 (two thousand twenty-three) ordinary shares and 1 (one) preferred share,
with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 438 (four hundred
thirty-eight) ordinary shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and by reim-
bursement to Lone Star Capital Investments S.à r.l. of the said amount of EUR 54,750 (fifty-four thousand seven hundred
fifty euro).
As a consequence of the share capital reduction, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 2,023 (two thousand
twenty-three) ordinary shares and Rising Sun III Holding holds 1 (one) preferred share.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of
the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 253,000 (two hundred fifty-three thousand euro),
represented by 2,023 (two thousand twenty-three) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of
EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each."
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mil dix, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 7, rue Robert Stümper, L2557 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay,
ici représentée par Me Mathilde Ostertag, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à Luxembourg, le 23 août 2010,
ET
Rising Sun III Holding, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Century Yard, Cricket
Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par M. Takehisa
Tei,
102287
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Me Mathilde Ostertag, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à Tokyo, le 23 août 2010,
(les Associés)
lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes
et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée dénommée LSF JRPI Investments S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.121, constituée
selon acte de Maître Martine Schaeffer du 10 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
1625 du 2 août 2007, modifié la dernière fois par acte de Maître Martine Schaeffer en date du 23 avril 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1204 du 9 juin 2010.
Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et qu'ils peu-
vent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital de la Société de son montant actuel de EUR 307.750 (trois cent sept mille sept cent cinquante
euros) par un montant de EUR 54.750 (cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros) à un montant de EUR 253.000
(deux cent cinquante-trois mille euros) par voie d'annulation de 438 (quatre cent trente-huit) parts sociales ordinaires
de la Société ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune; et
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 307.750
(trois cent sept mille sept cent cinquante euros), représenté par 2.461 (deux mille quatre cent soixante-etune) parts
sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)
chacune, par le biais d'une réduction de EUR 54.750 (cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros) à un montant de
EUR 253.000 (deux cent cinquante-trois mille euros), représenté par 2.023 (deux mille vingt-trois) parts sociales ordi-
naires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par
voie d'annulation de 438 (quatre cent trente-huit) parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de
EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et par voie de remboursement du montant de EUR 54.750 (cinquante-quatre
mille sept cent cinquante euros) à Lone Star Capital Investments S.à r.l..
Suite à cette réduction de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 2.023 (deux mille vingt-trois) parts
sociales ordinaires et Rising Sun III Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont
la version française aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 253.000 (deux cent cinquante-trois mille euros),
représenté par 2.023 (deux mille vingt-trois) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: M. Ostertag et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 août 2010. Relation: LAC/2010/37677. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 août 2010.
Référence de publication: 2010117491/130.
(100133625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
102288
Abattoir Ettelbruck S.A.
A.F.M.S. Accounting Financial & Management Services
Agence EUROPE
Algim S.à.r.l.
Algos
Alsa S.A.
AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à r.l.
Bad Langensalza
Bad Langensalza
Bad Schönborn
Bad Schönborn
Bad Schönborn
Bountiful S.à r.l.
Colt Group S.A
Compagnie de l'Europe du Sud S.A.
Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A.
Djedefre S.A. Holding
Imprimerie de l'Europe
International Business Consultants S.A.
LSF JRPI Investments S.àr.l.
Ositech SPF S.A.
Predica Infrastructure S.A.
RE Capital S.àr.l.
SAE Capital Holdings S.A.
Sagamore S.A.
Sethos S.A.
Shay Properties Bury S.à r.l.
Simonthal S.A.
SKB Capital S.A.
Société Cotonnière Financière S.A.
Société Flue S.A.
Solum 488 Group S.A.
Solum 488 S.A.
Stadlux Investment S.A.
Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A.
Sublim Investments S.A.
Symbolinvest S.A.
Tanis S.A.
Targa S.A.
Tellux Invest S.A.
Tenadu Investments S.A.
Tenadu Investments S.A.
Thamesline Investments
Tintoretto Sicar S.A.
Topaze Funds S.A.
Torsch Private Equity S.A., SPF
Treno Finanz S.à.r.l.
Trustlux S.A.
Unidiam S.A.
UTM S.A.
UTM S.A.
Valence S.A.
Vento Italia S.A.
V Finance S.A.
VH Estates S.A.
Visylia Investments S.A.
VLT Properties S.A.
Vratislavia Holdings S.A.
Walterstuff s.à r.l.
WCMG (Working Capital Management Group) S.A.
Whiskey 1 Holding S.à r.l.
Whiskey 2 Holding S.à r.l.
Zeppelin Park