logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2131

9 octobre 2010

SOMMAIRE

Abattoir Ettelbruck S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102280

A.F.M.S. Accounting Financial & Manage-

ment Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102283

Agence EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102263

Algim S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102284

Algos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102283

Alsa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102284

AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102282

Bad Langensalza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102284

Bad Langensalza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102265

Bad Schönborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102285

Bad Schönborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102285

Bad Schönborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102286

Bountiful S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102280

Colt Group S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102286

Compagnie de l'Europe du Sud S.A.  . . . . .

102281

Compagnie Financière et Boursière Lu-

xembourgeoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102256

Djedefre S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102284

Imprimerie de l'Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102261

International Business Consultants S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102261

LSF JRPI Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .

102286

Ositech SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102283

Predica Infrastructure S.A. . . . . . . . . . . . . . .

102277

RE Capital S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102285

SAE Capital Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

102281

Sagamore S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102265

Sethos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102256

Shay Properties Bury S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

102257

Simonthal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102257

SKB Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102257

Société Cotonnière Financière S.A.  . . . . . .

102257

Société Flue S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102258

Solum 488 Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102282

Solum 488 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102282

Stadlux Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102258

Steiner und Schmidt Gruppe Investholding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102258

Sublim Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102259

Symbolinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102259

Tanis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102259

Targa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102259

Tellux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102260

Tenadu Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

102260

Tenadu Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

102260

Thamesline Investments  . . . . . . . . . . . . . . . .

102260

Tintoretto Sicar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102261

Topaze Funds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102261

Torsch Private Equity S.A., SPF  . . . . . . . . .

102273

Treno Finanz S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102264

Trustlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102257

Unidiam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102262

UTM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102262

UTM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102262

Valence S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102263

Vento Italia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102263

V Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102263

VH Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102264

Visylia Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102264

VLT Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102264

Vratislavia Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102265

Walterstuff s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102273

WCMG (Working Capital Management

Group) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102277

Whiskey 1 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

102249

Whiskey 2 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

102242

Zeppelin Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102280

102241

L

U X E M B O U R G

Whiskey 2 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.415.

In the year two thousand and ten, on the fifth day of July,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

Special Situations Realty Partners II, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its regis-

tered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS II (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by G. Tostevin and P. Scarlatti, here represented by Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing
in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.

Special Situations Realty Partners FF, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its re-

gistered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS IV (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by N. Meader and D. Fisseler, here represented by Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing
in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.

Thomas Kronsteiner, born on September 22 

nd

 , 1965, residing in 3573 Rosenburg Nr. 84, Austria, represented by

Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July
2010.

Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state that:
- Special Situations Realty Partners II, L.P., prenamed, owns 9,563 of the shares issued by Whiskey 2 Holding S.à r.l.,

a Luxembourg limited liability company, société à responsabilité limitée, with registered office in L-1882 Luxembourg, 5,
rue Guillaume Kroll registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg, under number B 131.415, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on 27 July, 2007, published in the Mémorial C, number 2273 of 11 October 2007 (the “Company”);

- Special Situations Realty Partners FF, L.P., prenamed, owns 1,687 of the shares issued by the Company;
- M. Thomas Kronsteiner, prenamed, owns 1,250 of the shares issued by the Company;
- The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) parts with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

After this had been set forth, the above named participants, representing the whole corporate capital, have decided

to take the following resolutions:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to fully amend and restate the articles of association of the Company, which shall now

read as follows:

“Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability company, governed by the

present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Company”).

Art. 2. The Company's name is Whiskey 2 Holding S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

102242

L

U X E M B O U R G

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers

or the sole manager as the case may be.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders subject to any other agreement made between the

shareholders of the Company from time to time.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
The Company may repurchase its own shares in accordance with Luxembourg law.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles or any agreement made between the shareholders

of the Company from time to time to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or
in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,

102243

L

U X E M B O U R G

except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member

of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders rights

Art. 14. The shareholders of the Company enjoy the rights granted to shareholders of private limited companies under

Luxembourg law as well as the following rights.

Each shareholder has a preferential subscription right to newly issued shares of the Company pro rata to his partici-

pation in the Company’s share capital prior to the relevant capital increase. The preferential subscription right may only
be  fully  used,  i.e.  a  shareholder  using  its  preferential  subscription  right  cannot  subscribe  for  less  shares  than  its  full
preferential subscription right allows it to subscribe.

Each shareholder has the right to request to the board of managers to be provided with information on the Company’s

course of business, and to inspect the Company’s books kept at the Company’s registered office. The board of managers
of the Company satisfies any such request if it is reasonable and does not negatively affect the Company’s conduct of
business.

Shareholders decisions

Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the issued share

capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken by simple majority of voting rights present or duly represented at such

second meeting.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be approved by shareholders re-

presenting at least three quarters of the issued share capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10 

th

 , 1915 on private limited companies, sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 18. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

102244

L

U X E M B O U R G

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 

st

 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary. “

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 1,200.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German Version

Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes

Im Jahr zweitausend und zehn, am fünften Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

Special Situations Realty Partners II, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz

in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS II (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
G. Tostevin und P. Scarlatti, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg,
rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.

Special Situations Realty Partners FF, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz

in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS IV (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
N. Meader und D. Fisseler, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg,
rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.

Thomas Kronsteiner, geboren am 22. September 1965, wohnhaft in 3573 Rosenburg Nr. 84, Österreich, vertreten

durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg, rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht
vom 1 Juli 2010.

Eine Kopie der vorgenannten Beschlüsse bleibt, nachdem sie „ne varietur“ von der hier Erschienenen und dem un-

terzeichneten Notar unterschrieben wurden, der vorliegenden Urkunde zwecks Einreichung bei den Registrierungsbe-
hörden beigefügt.

Die hier erschienenen Parteien bitten den amtierenden Notar, Folgendes festzuhalten:
- Special Situations Realty Partners II, L.P., hält 9,563 Anteile des gezeichneten Kapitals von Whiskey 2 Holding S.à r.l.,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-1822
Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll, eingetragen bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter
Nummer B 131.415, errichtet am 27. Juli 2007 durch notarielle Urkunde des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 11. Oktober 2007 unter der Nummer 2273;

- Special Situations Realty Partners FF L.P., vorgenannt, hält 1,687 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;

102245

L

U X E M B O U R G

- M. Thomas Kronsteiner, vorgenannt, hält 1,250 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
- Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12,500) aufgeteilt in zwölf tausend

fünf hundert (12,500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).

Nach Darlegung dessen, treffen die das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellenden oben genannten Personen den

folgenden Beschluss:

<i>Alleiniger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft vollumfänglich zu ändern und neu zu formulieren, die

fortan wie folgt lautet:

„Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es ist hierbei eine „société à responsabilité limitée“, eine dem gegenwärtig geltenden luxemburgischen Recht

und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet.

Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist Whiskey 2 Holding S.à r.l..

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-

riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft
als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teil-
weise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von
Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen
Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles
Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen,
gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder
indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtsper-
sonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu
verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser
Zweckerfüllung beitragen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-

ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung dieser Satzung beschließt.

Auf Beschluss der Geschäftsführer oder im gegebenen Falle des alleinigen Geschäftsführers, kann der Sitz der Gesell-

schaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,

wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation  mit  dem  Gesellschaftssitz  oder  zwischen  dem  Gesellschaftssitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen,  kann  die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.

Art. 6. Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs

oder Insolvenz eines der Gesellschafter.

Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,

weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.

Kapital - Aktien

Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf

tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro)

Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.

Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar, abhängig von jeglichen anderen zwischen den

Gesellschaftern der Gesellschaft von Zeit zu Zeit eingegangenen Vereinbarungen.

Die  Anteile  dürfen  nicht  „inter  vivos“  an  Nicht-Gesellschafter  übertragen  werden,  es  sei  denn  die  Vertreter  von

wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.

Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.

102246

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft ist unter den vom luxemburgischen Recht vorgeschriebenen Bedingungen berechtigt, eigene Anteile

zurück zu erwerben.

Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern

bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.

In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung oder andere zwischen den Gesellschaftern

der Gesellschaft getroffene Vereinbarungen der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen
der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können

ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die

Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.

Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der

ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.

Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-

pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.

Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-

den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder
schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Ge-
sellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen
nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.

Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine

Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.

In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen

Geschäftsführer angenommen.

Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende

Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-

gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.

Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der

Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.

Rechte der Gesellschafter

Art. 14. Die Gesellschafter der Gesellschaft genießen die den Gesellschaftern einer Gesellschaft beschränkter Haftung

nach luxemburgischem Gesetz gewährten sowie die im Folgenden dargelegten Rechte.

Jeder Gesellschafter hat ein anteiliges vorrangiges Bezugsrecht aller neu ausgegebenen Anteile der Gesellschaft im

Einklang mit seiner vor der entsprechenden Kapitalerhöhung bestehenden Beteiligung am Gesellschaftskapital der Ge-
sellschaft. Das vorrangige Bezugsrecht darf nur in vollem Umfang ausgeübt werden, d.h. ein sein vorrangiges Bezugrecht
ausübender Gesellschafter darf nicht weniger Anteile zeichnen als es ihm sein gesamtes vorrangiges Bezugsrecht gestattet.

Jeder Gesellschafter hat das Recht von der Geschäftsführung die den Geschäftsverkehr der Gesellschaft betreffenden

Informationen zu verlangen und die am Sitz der Gesellschaft gehaltenen Bücher der Gesellschaft einzusehen. Die Ge-
schäftsführung  der  Gesellschaft  kommt  diesen  Anfragen  nach,  sofern  diese  angemessen  sind  und  die  Geschäfte  der
Gesellschaft nicht nachteilig beinflussen.

102247

L

U X E M B O U R G

Beschlüsse der Gesellschafter

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse

zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.

Art. 16. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals

vertreten, dafür gestimmt haben.

Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben

zu einer zweiten Versammlung einberufen.

Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die einfache Mehrheit der auf dieser zweiten Ver-

sammlung anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst.

Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-

den, die wenigstens drei Viertel des gezeichneten Kapitals darstellen.

Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Ein Alleingesellschafter übt alleine die der Versammlung der Gesellschafter nach den Bestimmungen des Artikels XII

des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, société à responsabilité limitée, obliegenden Rechte aus.

Daraus folgt, dass alle über die Rechte der Geschäftsführer hinausgehenden Entscheidungen durch den Alleingesell-

schafter getroffen werden.

Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter

der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der
Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.

Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen

mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.

Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-

schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.

Von  dem  so  berechneten  Nettogewinn  werden  jedes  Jahr  fünf  Prozent  abgezogen  und  der  gesetzlichen  Rücklage

zugeführt.

Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals

der Gesellschaft erreicht hat. Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich
aus welchem Grunde.

Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,

beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.

Auflösung

Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu

sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.

Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis

ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.

Geltende Gesetzgebung

Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht

ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.„

<i>Kostenschätzung

Die Ausgaben, Kosten, Entschädigungen und Aufwendungen jeglicher Form, welche von der Gesellschaft zu begleichen

sind, werden auf ungefähr EUR 1.200.-. geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen

der oben erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung
abgefasst ist; auf Verlangen derselben oben erschienenen Person soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich sein.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg, am Tag wie eingangs dieses Dokuments erwähnt, aufgenommen

wurde.

102248

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Perso-

nenstand und Wohnort bekannt ist, hat diese Person diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. LABUSCH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30383. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. Juli 2010.

Référence de publication: 2010116043/388.
(100131963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Whiskey 1 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.595.

In the year two thousand and ten, on the fifth day of July,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

Special Situations Realty Partners IV, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its re-

gistered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS IV (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by N. Meader and D. Fisseler, here represented by Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing
in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.

Special Situations Realty Partners III, L.P., a limited partnership established under the laws of Guernsey, with its regis-

tered office in St. Peter Port, represented by its general partner RESS III (GP) LIMITED, with its registered office in St.
Peter Port, represented by P. Radford, F. Marcantetti, N. Carey and C. Schmitz-Valckenb, here represented by Janine
LABUSCH, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July 2010.

Thomas Kronsteiner, born on September 22 

nd

 , 1965, residing in 3573 Rosenburg Nr. 84, Austria, represented by

Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, as duly empowered attorney by virtue of a proxy dated 1 July
2010.

Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state that:
- Special Situations Realty Partners IV, L.P., prenamed, owns 5,528 of the shares issued by Whiskey 1 Holding S.à r.l.,

a Luxembourg limited liability company, société à responsabilité limitée, with registered office in L-1882 Luxembourg, 5
rue Guillaume Kroll registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg, under number B 131.595, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, on 27 July, 2007, published in the Mémorial C, number 2309 of 15 October 2007 (the “Company”);

- Special Situations Realty Partners III, L.P., prenamed, owns 5,722 of the shares issued by the Company;
- M. Thomas Kronsteiner, prenamed, owns 1,250 of the shares issued by the Company;
- The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) parts with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

After this had been set forth, the above named participants, representing the whole corporate capital, have decided

to take the following resolutions:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to fully amend and restate the articles of association of the Company, which shall now

read as follows:

“ Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», private limited liability company, governed by the

present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Company”).

Art. 2. The Company's name is Whiskey 1 Holding S.à r.l..

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular
for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial

102249

L

U X E M B O U R G

and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company
associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the
Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere),
whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential
real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other
legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers

or the sole manager as the case may be.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders subject to any other agreement made between the

shareholders of the Company from time to time.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
The Company may repurchase its own shares in accordance with Luxembourg law.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles or any agreement made between the shareholders

of the Company from time to time to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or
in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

102250

L

U X E M B O U R G

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art.12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member

of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders rights

Art. 14. The shareholders of the Company enjoy the rights granted to shareholders of private limited companies under

Luxembourg law as well as the following rights.

Each shareholder has a preferential subscription right to newly issued shares of the Company pro rata to his partici-

pation in the Company’s share capital prior to the relevant capital increase. The preferential subscription right may only
be  fully  used,  i.e.  a  shareholder  using  its  preferential  subscription  right  cannot  subscribe  for  less  shares  than  its  full
preferential subscription right allows it to subscribe.

Each shareholder has the right to request to the board of managers to be provided with information on the Company’s

course of business, and to inspect the Company’s books kept at the Company’s registered office. The board of managers
of the Company satisfies any such request if it is reasonable and does not negatively affect the Company’s conduct of
business.

Shareholders decisions

Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the issued share

capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken by simple majority of voting rights present or duly represented at such

second meeting.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be approved by shareholders re-

presenting at least three quarters of the issued share capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10 

th

 , 1915 on private limited companies, sociétés à responsabilité limitée.

102251

L

U X E M B O U R G

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 18. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the Company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 

st

 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary. “

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 1,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German Version Deutsche

Übersetzung des Vorhergehenden Textes

Im Jahr zweitausend und zehn, am fünften Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Special Situations Realty Partners IV, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz

in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS IV (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
N. Meader und D. Fisseler, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg,
rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.

Special Situations Realty Partners III, L.P., eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht Guernseys mit Sitz

in St. Peter Port, vertreten durch ihren Komplementär RESS III (GP) LIMITED mit Sitz in St. Peter Port, vertreten durch
P. Radford, F. Marcantetti, N. Carey und C. Schmitz-Valckenb, hier vertreten durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin,
geschäftlich ansässig in Luxemburg, rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht vom 1 Juli 2010.

Thomas Kronsteiner, geboren am 22. September 1965, wohnhaft in 3573 Rosenburg Nr. 84, Österreich, vertreten

durch Janine LABUSCH, Rechtsanwältin, geschäftlich ansässig in Luxemburg, rechtmässig bevollmächtigt kraft Vollmacht
vom 1 Juli 2010.

Die Vollmachten bleiben, nachdem sie „ne varietur“ von der hier Erschienenen und dem unterzeichneten Notar un-

terschrieben wurden, der vorliegenden Urkunde zwecks Einreichung bei den Registrierungsbehörden beigefügt.

102252

L

U X E M B O U R G

Die hier erschienenen Parteien bitten den amtierenden Notar, Folgendes festzuhalten:
- Special Situations Realty Partners IV, L.P., hält 5.528 Anteile des gezeichneten Kapitals von Whiskey 1 Holding S.à

r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-1822
Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll, eingetragen bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter
Nummer B 131.595, errichtet am 27. Juli 2007 durch notarielle Urkunde des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 15. Oktober 2007 unter der Nummer 2309;

- Special Situations Realty Partners III L.P., vorgenannt, hält 5.722 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
- M. Thomas Kronsteiner, vorgenannt, hält 1.250 Anteile des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft;
- Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12,500) aufgeteilt in zwölf tausend

fünf hundert (12,500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).

Nach Darlegung dessen, treffen die das gesamte Kapital der Gesellschaft darstellenden oben genannten Personen den

folgenden Beschluss:

<i>Alleiniger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft vollumfänglich zu ändern und neu zu formulieren, die

fortan wie folgt lautet:

„Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es ist hierbei eine „société à responsabilité limitée“, eine dem gegenwärtig geltenden luxemburgischen Recht

und dieser Satzung (die „Satzung“) unterliegende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet.

Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist Whiskey 1 Holding S.à r.l..

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, indust-

riellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Kauf von jeglichen Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art
sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft
als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teil-
weise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von
Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen
Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles
Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen,
gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, in Luxemburg oder im Ausland, direkt oder
indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtsper-
sonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu
verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser
Zweckerfüllung beitragen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt Großherzogtum Luxemburg.
Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss der außer-

ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung dieser Satzung beschließt.

Auf Beschluss der Geschäftsführer oder im gegebenen Falle des alleinigen Geschäftsführers, kann der Sitz der Gesell-

schaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer,

wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommuni-
kation  mit  dem  Gesellschaftssitz  oder  zwischen  dem  Gesellschaftssitz  und  dem  Ausland  beeinträchtigen,  kann  die
Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.

Art. 6. Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs

oder Insolvenz eines der Gesellschafter.

Art. 7. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen,

weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner
Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanz-
berichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.

Kapital - Aktien

Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf €12.500 (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf

tausend fünf hundert) Anteile von jeweils €1 (ein Euro)

102253

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Alle Anteile haben die gleichen Rechte zum Zeitpunkt der Beschlussnahme.

Art. 10. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar, abhängig von jeglichen anderen zwischen den

Gesellschaftern der Gesellschaft von Zeit zu Zeit eingegangenen Vereinbarungen.

Die  Anteile  dürfen  nicht  „inter  vivos“  an  Nicht-Gesellschafter  übertragen  werden,  es  sei  denn  die  Vertreter  von

wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.

Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an.
Die Gesellschaft ist unter den vom luxemburgischen Recht vorgeschriebenen Bedingungen berechtigt, eigene Anteile

zurück zu erwerben.

Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern

bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu
jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.

In dem Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Operationen in Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung
durchzuführen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung oder andere zwischen den Gesellschaftern

der Gesellschaft getroffene Vereinbarungen der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen
der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft ist durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, bei mehreren Geschäftsführern,

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann seine) können

ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftrage übertragen.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer (kann) können die

Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder
sonstige zutreffenden Bedingungen davon.

Die Befugnisse und Entlohnungen der Geschäftsführer, die an einem späteren Datum zusätzlich oder an Stelle der

ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden in der Ernennungsurkunde bestimmt.

Art. 12. Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Ver-

pflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.

Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schä-

den, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen,
in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der
Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine
Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder
schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Ge-
sellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen
nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.

Art. 13. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in dessen Sitzungen gefasst.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine

Mehrheit der Geschäftsführer anwesend ist.

In diesem Fall werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen

Geschäftsführer angenommen.

Die Benutzung von Videokonferenzeinrichtungen und Telefonkonferenzen sind zugelassen, wenn jeder teilnehmende

Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden, gleich
ob sie diese Technologie benutzen oder nicht und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist dazu
ermächtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Tele-

gramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.

Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der

Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per
Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.

Rechte der Gesellschafter

Art. 14. Die Gesellschafter der Gesellschaft genießen die den Gesellschaftern einer Gesellschaft beschränkter Haftung

nach luxemburgischem Gesetz gewährten sowie die im Folgenden dargelegten Rechte.

102254

L

U X E M B O U R G

Jeder Gesellschafter hat ein anteiliges vorrangiges Bezugsrecht aller neu ausgegebenen Anteile der Gesellschaft im

Einklang mit seiner vor der entsprechenden Kapitalerhöhung bestehenden Beteiligung am Gesellschaftskapital der Ge-
sellschaft. Das vorrangige Bezugsrecht darf nur in vollem Umfang ausgeübt werden, d.h. ein sein vorrangiges Bezugrecht
ausübender Gesellschafter darf nicht weniger Anteile zeichnen als es ihm sein gesamtes vorrangiges Bezugsrecht gestattet.

Jeder Gesellschafter hat das Recht von der Geschäftsführung die den Geschäftsverkehr der Gesellschaft betreffenden

Informationen zu verlangen und die am Sitz der Gesellschaft gehaltenen Bücher der Gesellschaft einzusehen. Die Ge-
schäftsführung  der  Gesellschaft  kommt  diesen  Anfragen  nach,  sofern  diese  angemessen  sind  und  die  Geschäfte  der
Gesellschaft nicht nachteilig beinflussen.

Beschlüsse der Gesellschafter

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.
Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.
In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse

zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.

Art. 16. Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals

vertreten, dafür gestimmt haben.

Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben

zu einer zweiten Versammlung einberufen.

Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die einfache Mehrheit der auf dieser zweiten Ver-

sammlung anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst.

Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen wer-

den, die wenigstens drei Viertel des gezeichneten Kapitals darstellen.

Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird.
Ein Alleingesellschafter übt alleine die der Versammlung der Gesellschafter nach den Bestimmungen des Artikels XII

des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, société à responsabilité limitée, obliegenden Rechte aus.

Daraus folgt, dass alle über die Rechte der Geschäftsführer hinausgehenden Entscheidungen durch den Alleingesell-

schafter getroffen werden.

Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter

der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der
Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.

Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen

mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.

Art. 19. Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Ab-

schreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar.

Von  dem  so  berechneten  Nettogewinn  werden  jedes  Jahr  fünf  Prozent  abgezogen  und  der  gesetzlichen  Rücklage

zugeführt.

Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals

der Gesellschaft erreicht hat. Die Rücklage muss wieder aufgenommen werden, wenn dies nicht mehr der Fall ist, gleich
aus welchem Grunde.

Der Saldo steht der Gesellschaft frei zur Verfügung.
Die Geschäftsführer können jedoch, mit der Mehrheit der Stimmen und in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung,

beschließen, diesen Saldo vorzutragen oder einer außerordentlichen Rücklage zuzuführen.

Auflösung

Art. 20. Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter zu

sein brauchen, die von den Gesellschaftern ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen.

Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an die Gesellschafter, im Verhältnis

ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.

Geltende Gesetzgebung

Art. 21. Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht

ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind. „

102255

L

U X E M B O U R G

<i>Kostenschätzung

Die Ausgaben, Kosten, Entschädigungen und Aufwendungen jeglicher Form, welche von der Gesellschaft zu begleichen

sind, werden auf ungefähr EUR 1.200.- geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen

der oben erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung
abgefasst ist; auf Verlangen derselben oben erschienenen Person soll im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text der englische Text maßgeblich sein.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg, am Tag wie eingangs dieses Dokuments erwähnt, aufgenommen

wurde.

Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit Namen, Vornamen, Perso-

nenstand und Wohnort bekannt ist, hat diese Person diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. LABUSCH, und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30382. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. Juli 2010.

Référence de publication: 2010116042/387.
(100131960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Sethos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 93.031.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010115999/13.
(100131700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

COFIBOL, Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 20.803.

<i>Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la compagnie financiers et boursière Luxembourgeoise en abrégé COFIBOL

<i>du 26 mai 2010

Est nommé à l'unanimité Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Michel Parizel.
249, rue de l'Eglise
B- 6717 Thiaumont (Belgique)
Est nommé à l'unanimité Directeur Général:
Monsieur Michel Parizel
Sont nommés à l'unanimité Administrateurs Délégués:
Monsieur Alex De Jésus
Madame Elisabeth Lacouture
Le Conseil d'Administration a nommé à l'unanimité pour une durée de 1 an au poste de Réviseurs:
DELOITTE SA

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010116099/21.
(100131061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

102256

L

U X E M B O U R G

Shay Properties Bury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.723.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2010.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010116001/14.
(100131703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Simonthal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 91.691.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116006/9.
(100131908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

SKB Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 110.634.

J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat d’administrateur.
Ma démission prendra effet à compter du 31 août 2010.

Luxembourg, le 26 août 2010.

Sandrine ANTONELLI.

Référence de publication: 2010116007/10.
(100131777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Société Cotonnière Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 32.130.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2010.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2010116008/12.
(100131918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Trustlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 54.001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 27 juillet 2010,

que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Sixième résolution:

Le mandat du commissaire aux comptes arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de le renouveler jusqu'à

l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011 le mandat de la société Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.,
Via Tortona 25, 20144 Milano, Italia, en qualité de Commissaire.

102257

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L'assemblée prend note du changement de l'adresse professionnelle de deux administrateurs de la société comme suit:

- Monsieur Davide MURARI,30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Mirko LA ROCCA, 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2010.

<i>Pour la société TRUSTLUX S.A.
Le domiciliataire
BANQUE BPP S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010116351/23.

(100131374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Société Flue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 71.083.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 15 avril 2010 que:

- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, a

été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010116010/13.

(100131582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Stadlux Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.412.

J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat d’administrateur.

Ma démission prendra effet à compter du 31 août 2010.

Luxembourg, le 26 août 2010.

Sandrine ANTONELLI.

Référence de publication: 2010116012/10.

(100131778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 52.864.

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du

04 juin 2010 à 11.00 h

a été nommé commissaire aux comptes CRT REGISTER INTERNATIONAL SA, RCS No. B105875, ayant son siège

social 60 Grand-Rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg, Luxembourg,

à effet rétroactif du 1 

er

 juin 2010 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013 en remplacement de ALFA

FINANCIAL CONTROL SERVICES Sàrl.

102258

L

U X E M B O U R G

Le 25 août 2010.

STEINER UND SCHMIDT GRUPPE INVESTHOLDING S.A.,
Société de gestion de patrimoine familial (SPF)
J.H. VAN LEUVENHEIM
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010116013/20.
(100132002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Symbolinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 123.683.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2010116015/11.
(100131988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Sublim Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 115.498.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2010.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Gabriele Schneider / Pierre Schmit
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010116014/13.
(100131919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Tanis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.370.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010116017/13.
(100131701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Targa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 67.250.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 décembre 2009

<i>Résolution:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à

l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2010 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

Fiduciaire MEVEA Sàrl, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

102259

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010116018/18.
(100131222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Tenadu Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 64.404.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010116021/10.
(100131794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Tellux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 110.881.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2010.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2010116020/11.
(100131989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Tenadu Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 64.404.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010116024/10.
(100131796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Thamesline Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 100.193.

Il résulte de quatre courriers adressés à la Société que Monsieur José Correia, Madame Géraldine Schmit, Monsieur

Alan Dundon, administrateurs de la Société ainsi que Read S.à r.l. commissaire aux comptes de la Société ont démissionné
de leurs mandats respectifs en date du 26 juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Correia José / Schmit Géraldine
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010116025/14.
(100131259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

102260

L

U X E M B O U R G

Imprimerie de l'Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 6.968.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 23 mars

<i>2009 à 12.00 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de l'administrateur Marina Gazzo, domiciliée 283, avenue Henri Giraud

à F-06140 Vence pour une durée de 5 ans.

L'Assemblée décide de nommer administrateur Lorenzo Riccardi, domicilié 73, avenue des Archiducs à B-1170 Bru-

xelles pour une durée de 5 ans.

L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes Marisa Nicoli, domiciliée 36, avenue Jeanne à B-1050 Bru-

xelles pour une durée de 5 ans.

Luxembourg, le 23 mars 2009.

Pour extrait conforme
IMPRIMERIE DE L'EUROPE S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116110/19.
(100131196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Tintoretto Sicar S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.850.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010116026/13.
(100131830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Topaze Funds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 144.796.

J’ai l’honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat d’administrateur.
Ma démission prendra effet à compter du 31 août 2010.

Luxembourg, le 26 août 2010.

Sandrine ANTONELLI.

Référence de publication: 2010116027/10.
(100131779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

International Business Consultants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 51.863.

Après vérification de l'extrait RCS de la société International Business Consultants S.A. ayant son siège sociale au 43,

boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg B51863, l'administrateur délégué Marc Hurner, a constaté que les modifi-
cations suivantes s'imposent:

-Conseil d'administration: Strategic Management Consulting S.A.
La dénomination sociale de cette société a été modifiée en FIP (Luxembourg) S.A. ainsi que son siège social. La nouvelle

adresse est 43, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg et remplace donc l'ancienne: 26, boulevard Royal L-2449
Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Marc Hurner est actuellement 364 boulevard Lambermont B-1030 Bruxelles et remplace donc

l'ancienne: 107 rue F. Bossaerts B-1030 Bruxelles.

102261

L

U X E M B O U R G

Délégué(s) à la gestion journalière: Marc HURNER
L'adresse de Monsieur Marc Hurner est actuellement 364 boulevard Lambermont B-1030 Bruxelles et remplace donc

l'ancienne: 107 rue F. Bossaerts B-1030 Bruxelles.

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes: Overseas Transactions Limited S.A.
La dénomination sociale de cette société a été modifiée en FIP International S.A.
Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes: Paul DAVID
Cette personne étant décédée, elle doit être radiée.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2010116880/25.
(100133214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

Unidiam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 125.480.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 9 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116030/10.
(100131932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

UTM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 26.059.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116031/11.
(100131611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

UTM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 26.059.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2010:

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Alain Louis TRICOLET, demeurant à 78, route Bleue, F-13620 Carry Le Rouet, aux fonctions d'adminis-

trateur;

- Monsieur Jacques RECKINGER, demeurant professionnellement au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d’administrateur

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.
L’Assemblée Générale nomme comme commissaire aux comptes:
- Fiduciaire de Luxembourg S.A., 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116032/18.
(100131612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

102262

L

U X E M B O U R G

Agence EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 5.271.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 23 mars

<i>2009 à 11.00 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs Ferdinando Riccardi, domicilié avenue Jeanne 36 à

B-1050 Bruxelles et Marina Gazzo, domiciliée 283, avenue Henri Giraud à F-06140 Vence pour une durée de 5 ans.

Luxembourg, le 23 mars 2010.

Pour extrait conforme
AGENCE EUROPE S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116070/15.
(100131209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

V Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 81.471.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010116033/9.
(100132011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Valence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 92.314.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010116034/13.
(100131702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Vento Italia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 107.849.

Il a été décidé par l'envoi d'un courrier recommandé en date du 3 août 2010 que la société PKF ABAX AUDIT, 6 place

de Nancy L-2212 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 27761, démissionne de son mandat de commissaire da la société
VENTO ITALIA S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2010.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2010116035/13.
(100131550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

102263

L

U X E M B O U R G

Treno Finanz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 233.300,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 116.871.

<i>Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on July 8 

<i> t 

<i>h

<i> 

<i> , 2010

Mr. Philippe Stanko, born on 15 January 1977 in Wittlich, Germany, having his professional address at 412F, Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg is appointed as additional Manager of category B. Mr. Philippe Stanko is appointed for an
unlimited period.

Suit la traduction française de ce qui précède:

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 juillet 2010

Monsieur Philippe Stanko, né le 15 janvier 1977 à Wittlich, Allemagne, avec adresse professionnelle à 412F, Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé en tant que gérant de catégorie B pour une durée illimitée.

TRENO FINANZ S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2010116159/19.
(100131109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

VH Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 138.820.

RECTIFICATIF

Cette  mention  rectificative  annule  et  remplace  la  version  déposée  antérieurement  le  8  juin  2010  sous  le  No:

L100080061

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2010.

Référence de publication: 2010116036/13.
(100131788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Visylia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 136.902.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2010.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2010116038/12.
(100131920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

VLT Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 115.108.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2010

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route

102264

L

U X E M B O U R G

d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2009.

Luxembourg, le 25 juin 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010116039/18.
(100131422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Bad Langensalza, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.481.

Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116084/11.
(100131006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 101.882.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2010.

Référence de publication: 2010116040/10.
(100131507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Sagamore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 101.667.

In the year two thousand and ten, on the eighteenth of August.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Sagamore S.A.”, a joint-stock company (société

anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 101667 (the Company), incorporated by a deed of Maître Léon Thomas, known as
Tom  Metzler,  notary  residing  in  Luxembourg,  of  July  6,  2004,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations n° 906 of September 10, 2004 and whose bylaws have been last amended by a deed of Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of October 10, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 365 of February 18, 2006.

The meeting is chaired by Mr Marc VAN HOEK, chartered accountant, with 527.500 EUR professional address at 16,

rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address at 74, Avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, and as scrutineer Mr Raymond THILL, “maître en droit”, with professional address at
74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act that:
I. The shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman,

the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be registered with the present minutes.

II. It appears from the said attendance list that all the five thousand two hundred and fifty (5,250) shares of the Company

with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, which shares are fully paid up, are present or represented
at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. The
shareholders represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so
that no convening notices were necessary.

102265

L

U X E M B O U R G

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Acknowledgement of the auditor’s report issued by ACSE Audit Conseil Services, with registered office at 41,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

2. Acknowledgement of the report issued by the board of directors for the purposes of the issue by the Company of

convertible bonds (and including their terms and conditions), a copy of these reports having been sent to each shareholder
of the Company;

3. Acknowledgement that:
3.1. the CBs (as defined below) are convertible into shares in registered form of the Company (the Conversion Shares)

at a conversion ratio of 1:1 (i.e. one CB in a nominal amount of one hundred Euro (EUR 100,00) entitles its registered
holder), upon the conversion thereof being made in accordance with the terms and conditions of the CBs, to one Con-
version Share in a nominal amount of one hundred Euro (EUR 100,00), and

3.2. on the issue of the Conversion Shares, such shares shall be issued in accordance with the terms and conditions

of the CBs, entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding
shares, as the case may be, save as otherwise provided in the terms and conditions of the CBs;

4. Authorization of the issue by the Company (the Issue) of twenty-one thousand (21,000) convertible bonds, having

a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each (the CBs);

5. Waiver by Xerius Limited, an International Business Company, incorporated and existing under the laws of Anguilla,

having its registered office at Caribbean Suite, The Valley, Anguilla and registered with the Companies Register of the
British West Indies under number 2038357 of its preferential subscription right in respect of two hundred and nineteen
(219) CBs;

6. Empowerment of and authorization to the board of directors (a) to implement the Issue and determine its terms

and conditions, and (b) to determine the date of the Issue;

7. Authorization for the creation and update of the bondholders’ register of the Company;
8. Increase of the share capital by an amount of two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.00) in order to raise it

from its present amount of five hundred twenty-five thousand Euro (EUR 525,000.00) to five hundred twenty-seven
thousand five hundred Euro (EUR 527,500.00) by creation and issue of twentyfive (25) new shares, with a nominal value
of one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of three million six hundred
seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 3,672,500.00);

9. Exercise, by the shareholders, of their preferential subscription right in respect of the share’s issue;
10. Subscription by Xerius Limited, prenamed, for nineteen (19) new shares with a nominal value of one hundred Euro

(EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two million seven hundred ninety-one thousand one
hundred Euro (EUR 2,791,100.00) and full payment in the total amount of two million seven hundred ninety-three thou-
sand Euro (EUR 2,793,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of a
receivable held by Xerius Limited towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Xerius
Receivable);

11. Subscription by Silver Ax Systems Corporation, an International Business Company, incorporated and existing

under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Yarmaj Building, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, and registered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands under number 632759, for four
(4) new shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the
amount of five hundred eighty-seven thousand six hundred Euro (EUR 587.600,00) and full payment in the total amount
of five hundred eightyeight thousand Euro (EUR 588,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a
portion in the same amount of a receivable held by Silver Ax Systems Corporation towards the Company, which receivable
is incontestable, payable and due (the Silver Receivable);

12. Subscription by Waseda International Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of Panama,

having its registered office at Fifth Avenue and Thirtieth East Street 30-11, P.O. Box 6974, Panama 5, Panama, and regis-
tered with the Commercial Registry of Panama under number 162839, for two (2) new shares with a nominal value of
one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two hundred ninety-three thou-
sand eight hundred Euro (EUR 293,800.00) and full payment in the total amount of two hundred ninety-four thousand
Euro (EUR 294,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of a receivable
held by Waseda International Inc. towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Waseda
Receivable);

13. Acceptance by the Company of the valuation and of the independent auditor’s report, in accordance with article

32-1 (5) of the law of August 10, 1915, on commercial companies, established by ACSE Audit Conseil Services, auditor,
prenamed;

14. Amendment of article 5, first paragraph of the Company’s bylaws which shall henceforth read as follows:

“  Art. 5. First paragraph.  The  share  capital  is  set  at  five  hundred  twentyseven  thousand  five  hundred  Euro  (EUR

527,500.00) represented by five thousand two hundred and seventy-five (5,275) shares of one hundred Euro (EUR 100.00)
each.”

102266

L

U X E M B O U R G

15. Miscellaneous.
IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting acknowledges the report established by ACSE Audit Conseil Services, prenamed, in connection with the

Issue by the Company of the CBs, which report concludes as follows:

<i>Conclusion

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of

each contribution, which corresponds at least to the value of the shares which would be issued in exchange of the
Convertible Bonds.”

<i>Second resolution

The meeting acknowledges the report of the board of directors of the Company dated August 3, 2010, which includes

the terms and conditions of the issue of the CBs.

<i>Third resolution

The meeting acknowledges that: (i) the CBs are convertible into Conversion Shares at a conversion ratio of 1:1 (i.e.

one CB in a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) entitles its registered holder, upon the conversion thereof
being made in accordance with the terms and conditions of the CBs which are hereby approved by the meeting, to one
Conversion Share of a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00), and that (ii) upon the conversion and the issue
of the Conversion Shares, such shares shall be issued as shares in accordance with the terms and conditions of the CBs,
entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding shares of the
Company save as otherwise stated in the terms and conditions of the CBs.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to approve the terms and conditions of the CBs as set forth in the report issued by the board

of directors and to approve the issue of twenty-one thousand (21,000) CBs, with a nominal value of one hundred Euro
(EUR 100.00) each, for an aggregate amount of two million one hundred Euro (EUR 2,100,000.00).

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to record the waiver by Xerius Limited, prenamed, of its preferential subscription right in respect

of two hundred and nineteen (219) CBs.

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to authorize the board of directors to: (i) implement the issue of the CBs in accordance with

and subject to its terms and conditions, and to: (ii) determine the date of the issue of the CBs and its terms and conditions
as set forth in the directors’ report.

<i>Seventh resolution

The meeting resolves to authorize the creation and update of the bondholders’ register of the Company.

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred Euro

(EUR 2,500.00) in order to raise it from its present amount of five hundred twenty-five thousand Euro (EUR 525,000.00)
to five hundred twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 527,500.00) by creation and issue of twenty-five (25)
new shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount
of three million six hundred seventy-two thousand five hundred Euro (EUR 3,672,500.00), for an aggregate amount of
four million two hundred thousand Euro (EUR 4,200,000.00).

<i>Ninth resolution

The meeting resolves to record the exercise by the shareholders of their preferential subscription rights in respect

of the shares issue.

<i>Subscription - Payment

Xerius Limited, prenamed, declares to subscribe for nineteen (19) new shares with a nominal value of one hundred

Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two million seven hundred ninety-one thousand
one hundred Euro (EUR 2,791,100.00) and to fully pay them up for an aggregate amount of two million seven hundred
ninety-three thousand Euro (EUR 2,793,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the
same amount of the Xerius Receivable.

Silver Ax Systems Corporation, prenamed, declares to subscribe for four (4) new shares with a nominal value of one

hundred Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of five hundred eighty-seven thousand

102267

L

U X E M B O U R G

six hundred Euro (EUR 587,600.00) and to fully pay them up for an aggregate amount of five hundred eighty-eight thousand
Euro (EUR 588,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of the Silver
Receivable.

Waseda International Inc., prenamed, declares to subscribe for two (2) new shares with a nominal value of one hundred

Euro (EUR 100.00) each, together with a share premium in the amount of two hundred ninety-three thousand eight
hundred Euro (EUR 293,800.00) and to fully pay them up for an aggregate amount of two hundred ninety-four thousand
Euro (EUR 294,000.00), by contribution in kind consisting in the conversion of a portion in the same amount of the
Waseda Receivable.

The value of their contribution in kind is declared by Xerius Limited to be of two million seven hundred ninety-three

thousand Euro (EUR 2,793,000.00), by Silver Ax Systems Corporation to be of five hundred eighty-eight thousand Euro
(EUR 588,000.00) and by Waseda International Inc. to be of two hundred ninetyfour thousand Euro (EUR 294,000.00)
for a total value of three million six hundred seventy-five thousand (EUR 3,675,000.00), which valuation is accepted by
the Company and was subject to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended, established by ACSE Audit Conseil Services, prenamed, which report
concludes as follows:

<i>Conclusion

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of

each contribution, which corresponds at least to the value of the shares to be issued to each contributor, plus their
respective share premium.”

The above mentioned report, being initialized ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Effective implementation of the contribution

Xerius Limited prenamed, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Xerius Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally

and conventionally freely transferable.

- the Xerius Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Xerius Limited

is entitled to any rights as to the Xerius Receivable;

- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Xerius Receivable, in order to duly carry

out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

Silver Ax Systems Corporation, prenamed, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Silver Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally

and conventionally freely transferable;

- the Silver Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Silver Ax

Systems Corporation is entitled to any rights as to the Silver Receivable;

- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Silver Receivable, in order to duly carry

out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

Waseda International Inc., prenamed, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Waseda Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally

and conventionally freely transferable;

- the Waseda Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Waseda

International Inc. is entitled to any rights as to the Waseda Receivable;

- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Waseda Receivable, in order to duly carry

out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Directors’ intervention

Thereupon intervened the directors of the Company, duly represented by Mr Marc VAN HOEK, who require the

notary to act as follows:

The directors acknowledge having been previously informed of the extent of their responsibility, legally engaged as

directors of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of
this contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Tenth resolution

The meeting resolves to approve the valuation and the independent auditor’s report issued, in accordance with article

32-1 (5) of the law of August 10, 1915, on commercial companies, established by ACSE Audit Conseil Services, auditor,
prenamed.

102268

L

U X E M B O U R G

<i>Eleventh resolution

Pursuant to the above capital increase, the meeting resolves to restate article 5, first paragraph of the Company’s

bylaws which shall henceforth read as follows:

“  Art. 5. First paragraph.  The  share  capital  is  set  at  five  hundred  twentyseven  thousand  five  hundred  Euro  (EUR

527,500.00) represented by five thousand two hundred and seventy-five (5,275) shares of one hundred Euro (EUR 100.00)
each.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand two hundred Euro (EUR 3,200.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le dix-huit août.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Sagamore S.A.”, ayant son

siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101667 (la Société), constituée suivant acte de Maître Léon
Thomas connu sous le nom de Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 6 juillet 2004, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 906, du 10 septembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire, résident à Luxembourg, reçu en
date du 10 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°365, du 18 février 2006.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, ayant son adresse

professionnelle au 16, rue de Nassau, L2213 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, ayant son adresse professionnelle

au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, et comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, ayant
son adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,

signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Il apparaît de cette liste de présence que les cinq mille deux cent cinquante (5,250) actions de la Société, d’une valeur

nominale de cent (EUR 100.00) chacune, toutes entièrement libérées, sont présentes ou représentées à la présente
assemblée, de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à son ordre du jour. Il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Prise de connaissance du rapport d’audit émis par ACSE Audit Conseil Services, domicilié au 41, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg;

2. Prise de connaissance du rapport émis par le conseil d’administration en vue de l’émission par la Société d’obligations

convertibles (incluant leurs termes et conditions), une copie de ces rapports ayant été envoyée à chacun des actionnaires
de la Société;

3. Reconnaissance de ce que:
3.1. les OCs (tels que définis ci-après) sont convertibles en actions nominatives de la Société (les Actions de Conver-

sion) à un taux de conversion de 1:1 (c’est-à-dire qu’une OC d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) donne
droit à son détenteur inscrit, lors de la conversion de celle-ci soumise et faite conformément aux conditions générales
des OCs, à une Action de Conversion d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) et que,

3.2. lors de la conversion et de l’émission des Actions de Conversion, ces actions seront émises conformément aux

termes et conditions des OCs, conférant selon le cas à leurs détenteurs respectifs les mêmes droits que les détenteurs

102269

L

U X E M B O U R G

des actions de la Société actuellement émises et en circulation, sauf autrement prévu dans les termes et conditions des
OCs;

4. Emission par la Société (l’Emission) de vingt et un mille (21.000) obligations convertibles, d’une valeur nominale de

cent Euro (EUR 100,00) chacune (les OCs);

5. Renonciation par Xerius Limited, une International Business Company, régie par les lois d’Anguilla, ayant son siège

social au Caribbean Suite, The Valley, Anguilla, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Antilles Britanniques
sous le numéro 2038357, à son droit de souscription préférentiel sur deux cent dix-neuf (219) OCs;

6. Pouvoir et autorisation au conseil d’administration (i) de mettre en oeuvre l’Emission conformément à et d’après

les conditions générales des OCs telles que définies dans son rapport, (ii) de déterminer la date de l’Emission;

7. Pouvoirs pour la création et la mise à jour du registre des obligations de la Société;
8. Augmentation du capital social à concurrence de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,00) pour le porter de son

montant actuel de cinq cent vingt-cinq mille Euro (EUR 525.000,00) à cinq cent vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR
527.500,00) par la création et l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune pour un montant total de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,00) ensemble avec une prime d’émission
de trois millions six cent soixante-douze mille cinq cents Euro (EUR 3.672.500,00);

9. Exercice par les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription eu égard à l’émission d’actions;
10. Souscription par Xerius Limited, susnommée, à dix-neuf (19) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro

(EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-onze mille
cent Euro (EUR 2.791.100,00) et libération intégrale pour un montant total de deux millions sept cent quatre-vingt-treize
mille Euro (EUR 2.793.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant
d’une créance détenue par Xerius Limited envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible (la Créance
Xerius);

11. Souscription par Silver Ax Systems Corporation, une International Business Company, régie par les lois des Iles

Vierges Britanniques, ayant son siège social au Yarmaj Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et enre-
gistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 632759, à quatre (4) nouvelles actions
d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de cinq cent
quatre-vingt-sept mille six cents Euro (EUR 587.600,00) et libération intégrale pour un montant total de cinq cent quatre-
vingt huit mille Euro (EUR 588.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même
montant d’une créance détenue par Silver Ax Systems Corporation envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide
et exigible (la Créance Silver);

12. Souscription par Waseda International Inc., une corporation régie par les lois de Panama, ayant son siège social au

Fifth Avenue and Thirtieth East Street 30-11, P.O. Box 6974, Panama 5, Panama, et enregistrée auprès du Registre des
Sociétés de Panama sous le numéro 162839, à deux (2) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00)
chacune,  ainsi  qu’à  une  prime  d’émission  d’un  montant  de  deux  cent  quatre-vingt-treize  mille  huit  cents  Euro  (EUR
293.800,00) et libération intégrale par un montant total de deux cent quatrevingt-quatorze mille Euro (EUR 294.000,00),
par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant d’une créance détenue par Waseda
International Inc. envers la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible (la Créance Waseda);

13. Approbation par la Société de l’évaluation et du rapport du réviseur indépendant, conformément à l’article 32-1

(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, établit par ACSE Audit Conseil Services, susnommé;

14. Modification de l’article 5, premier alinéa des statuts de la Société comme suit:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent vingt-sept mille cinq cents Euro

(EUR 527.500,00) divisé en cinq mille deux cent soixante-quinze (5.275) actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune.»;

15. Divers
IV. L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend connaissance du rapport établi par ACSE Audit Conseil Services, susnommé, relatif à l’émission

d’obligations convertibles par la Compagnie, lequel rapport conclu comme suit:

<i>Conclusion

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of

each contribution, which corresponds at least to the value of the shares which would be issued in exchange of the
Convertible Bonds.”

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend connaissance du rapport du conseil d’administration de la Société daté du 3 août 2010, incluant les

conditions générales de l’émission des OCs.

102270

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate que: les OCs sont convertibles en actions de conversion à un taux de conversion de 1:1 (c’est-

à-dire  qu’une  OC  d’une  valeur  nominale  de  cent  Euro  (EUR  100,00)  donne  droit  à  son  détenteur  inscrit  lors  de  la
conversion de celle-ci conformément aux conditions générales des OCs, qui sont par la présente approuvées par l’as-
semblée, à une Action de Conversion d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,00) et que: (ii) lors de la conversion
et de l’émission des Actions de Conversion, ces actions seront émises conformément aux conditions générales des OCs,
conférant  à  leurs  détenteurs  respectifs  les  mêmes  droits  que  les  détenteurs  des  actions  de  la  Société  émises  et  en
circulation, sauf autrement prévu dans les conditions générales des OCs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’approuver les termes et conditions des OCs, telles que définies dans le rapport émis par le conseil

d’administration et d’autoriser l’émission de vingt et un mille (21.000) OCs, d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune, pour un montant total de deux millions cent mille Euro (EUR 2.100.000,00)

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’acter la renonciation par Xerius Limited, susnommée à son droit préférentiel de souscription

sur deux cent dix-neuf (219) OCs.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à: (i) mettre en œuvre l’émission d’OCs conformément aux

conditions générales des OCs telles que définies dans son rapport, et: (ii) déterminer la date de l’émission d’OCs.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’autoriser la création et la mise à jour du registre des obligations de manière à inscrire l’émission

d’OCs.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux mille cinq cents Euro (EUR

2.500,00) pour le porter de son montant actuel de cinq cent vingt-cinq mille Euro (EUR 525.000,00) à cinq cent vingt-
sept mille cinq cents Euro (EUR 527.500,00) par la création et l’émission de vingt-cinq (25) nouvelles actions de cent Euro
(EUR 100,00) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions six cent soixante-douze mille cinq cents
Euro (EUR 3.672.500,00), pour un montant total de quatre millions deux cent mille Euro (EUR 4.200.000,00).

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de prendre acte de l’exercice par les actionnaires de leur droit de souscription préférentiel relatif

à l’émission d’actions.

<i>Souscription - Libération

Xerius Limited, susnommée, déclare souscrire à dix-neuf (19) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euro

(EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-onze mille
cent Euro (EUR 2.791.100,00) et les libérer intégralement pour un montant total de deux millions sept cent quatre-vingt-
treize mille Euro (EUR 2.793.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même
montant de la Créance Xerius.

Silver Ax Systems Corporation, susnommée, déclare souscrire à quatre (4) nouvelles actions d’une valeur nominale

de cent Euro (EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de cinq cent quatre-vingt-sept mille
six cents Euro (EUR 587.600,00) et les libérer intégralement pour un montant total de cinq cent quatre-vingt huit mille
Euro (EUR 588.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant de la
Créance Silver.

Waseda International Inc., susnommée, déclare souscrire à deux (2) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent

Euro (EUR 100,00) chacune, ainsi qu’à une prime d’émission d’un montant de deux cent quatre-vingt-treize mille huit
cents Euro (EUR 293.800,00) et les libérer intégralement pour un montant total de deux cent quatre-vingt-quatorze mille
Euro (EUR 294.000,00), par paiement en nature consistant en la conversion d’une portion d’un même montant de la
Créance Waseda.

La valeur de leur apport en nature est déclarée être de deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille Euro (EUR

2.793.000,00) par Xerius Limited, de cinq cent quatre-vingt-huit mille Euro (EUR 588.000,00) par Silver Ax Systems
Corporate et de deux cent quatre-vingt-quatorze mille Euro (EUR 294.000,00) par Waseda International Inc., pour un
montant total de trois million six cent soixante-quinze mille Euro (EUR 3.675.000,00); les estimations, acceptées par la
Société, ont été sujettes au rapport d’un réviseur d’entreprise indépendant conformément à l’article 32-1 (5) de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée, établi par ACSE Audit Conseil Services, susnommé, et
dont le rapport conclut comme suit:

102271

L

U X E M B O U R G

<i>Conclusion

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the valuation made of

each contribution, which corresponds at least to the value of the shares to be issued to each contributor, plus their
respective share premium.”

Ledit raport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

<i>Réalisation effective de l’apport

Xerius Limited, susnommée, par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire sans restriction de la Créance Xerius et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissible;

- la Créance Xerius n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que

Xerius Limited ne détient de droit sur la Créance Xerius;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance Xerius, aux fins

d’effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

Silver Ax Systems Corporation, susnommée, par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire sans restriction de la Créance Silver et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissible;

- la Créance Silver n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que

Silver Ax Systems Corporation ne détient de droit sur la Créance Silver;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance Silver, aux fins

d’effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

Waseda International Inc., susnommée, par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire sans restriction de la Créance Waseda et possède les pouvoirs d’en disposer, celle-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissible;

- la Créance Waseda n’a pas fait l’objet d’une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que

Waseda International Inc. ne détient de droit sur la Créance Waseda;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance Waseda, aux fins

d’effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Intervention des administrateurs

Sont alors intervenus les administrateurs de la Société, ici représentés par Monsieur Marc VAN HOEK, qui prient le

notaire d'acter que:

Les administrateurs reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement

engagés en leur qualité de gérants de la Société en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, ils consentent expres-
sément à la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité de la souscription et de la
libération.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’approuver l’évaluation et le rapport du réviseur indépendant, conformément à l’article 32-1 (5)

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, établi par ACSE Audit Conseil Services, susnommé.

<i>Onzième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, l’assemblée décide de modifier l’article 5, premier alinéa des statuts de la Société

pour lui conférer la teneur suivante:

« Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent vingt-sept mille cinq cents Euro

(EUR 527.500,00) divisé en cinq mille deux cent soixante-quinze (5.275) actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR
100,00) chacune»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison de la présente, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille deux cents euros (EUR 3.200,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

102272

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite aux comparantes, connus du notaire par leur nom, prénom, statut et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Van Hoek, S. Dupont, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 août 2010. LAC/2010/37345. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2010.

Référence de publication: 2010116679/415.
(100132250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2010.

Walterstuff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R.C.S. Luxembourg B 97.790.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010116044/10.
(100131226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Torsch Private Equity S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 155.182.

STATUTS

L'an deux mil dix, le vingt-six août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TORSCH FINANCIERE S.A., SPF, société anonyme de gestion de patrimoine familial, ayant son siège social à L-1653

Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

ici représentée par Madame Cristina SOARES, employée privée, demeurant professionnellement à L-1653 Luxem-

bourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 19 août 2010.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une

société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société de gestion de patrimoine familial sous forme d’une société anonyme

qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de TORSCH PRIVATE EQUITY S.A., SPF.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l’administrateur unique, la société pourra établir

des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l’administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d’une résolution de l’actionnaire unique ou en cas de
pluralité d’actionnaires au moyen d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

102273

L

U X E M B O U R G

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs constitués d’ins-

truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d’espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s’immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu’elle émettra ne pourront faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d’une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros) qui sera

représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 août 2015, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d’administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme

qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

102274

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de

gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  société  est  engagée  en  toutes  circonstances,  en  cas  d’administrateur  unique,  par  la

signature individuelle de l’administrateur unique, ou en cas de pluralité d’administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. S’il y a seulement un actionnaire, l’actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale

des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le quatrième mardi du mois d’avril à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

102275

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 11 mai

2007 sur la société de gestion de patrimoine familial ("SPF") trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2010.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique, TORSCH FINANCIERE S.A., SPF, ayant

son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros (EUR

1.100,-).

<i>Résolutions de l’actionnaire unique

L’actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur John SEIL, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

2. Monsieur Guy HORNICK, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, maître en sciences économiques, demeurant pro-

fessionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

3. Monsieur Luc HANSEN, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant pro-

fessionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Monsieur John SEIL, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65.469.

102276

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses noms,

prénoms, états et demeures, la mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Soares, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 26 août 2010. Relation: RED/2010/1201. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117993/206.
(100133998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2010.

WCMG (Working Capital Management Group) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 63.826.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2010.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010116045/12.
(100132003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Predica Infrastructure S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 27.600.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.978.

In the year two thousand and ten, on the twenty-nine day of June,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of the shareholders of Predica

Infrastructure S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 137.978 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul
Bettingen, notary of residence in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg on March 28, 2008, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1185 of May 15, 2008, the articles of incorporation of which were amended
for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg dated November 19, 2009,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 44 of January 7, 2010.

The Extraordinary General Meeting was opened at 15.15 p.m., with Mrs. Maya Van Belleghem, licenciée en droit,

residing professionally in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary, Mrs. Emilie Dallemagne, licenciée en droit, residing professionally in Luxembourg.
The Extraordinary General Meeting elected as scrutineer, Mrs. Anne-Laure Mollard, avocat, residing professionally in

Luxembourg.

The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state:

I. That the shareholder present or represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of

its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholder or the proxyholder of the
represented shareholder and by the board of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present
deed in order to be registered therewith.

The proxy of the represented shareholder, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to

the present deed.

II That it appears from the attendance list, which shall remain attached to the present deed to be filed therewith with

the registration authorities, that two million one hundred sixty thousand (2,160,000) redeemable class A shares having a

102277

L

U X E M B O U R G

nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, representing the entire share capital of the Company, are present or repre-
sented at the Extraordinary General Meeting.

III. That the entire share capital being present or represented at the present Extraordinary General Meeting and the

shareholder present or represented declaring that it had due notice and received knowledge of the below agenda as well
as any information in relation thereto prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by a contribution in cash;
2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
“The Company has a subscribed share capital of twenty-seven million six hundred thousand Euro (EUR 27,600,000.-),

represented by two million seven hundred sixty thousand (2,760,000) redeemable class A shares (the “Class A Shares”),
with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.”

3. Miscellaneous.
After having duly deliberated on all items of the agenda, the Extraordinary General Meeting unanimously took the

following resolutions and requested the officiating notary to record as follows:

<i>First Resolution

The Extraordinary General Meeting resolved to increase the share capital of the Company by six million Euro (EUR

6,000,000.-), from twenty-one million six hundred thousand Euro (EUR 21,600,000.-) up to twenty-seven million six
hundred thousand Euro (EUR 27,600,000.-), by the issue of six hundred thousand (600,000) new redeemable class A
shares, with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.

The six hundred thousand (600,000) redeemable class A shares newly issued have been entirely subscribed and fully

paid up by Predica S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of
France, having its registered office located at 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris, France, registered with the Register
of Companies of Paris under number 334.028.123, here represented by Mrs. Maya Van Belleghem, by virtue of a proxy
given under private seal, here annexed, by a contribution in cash, so that the amount of six million Euro (EUR 6,000,000.-)
is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Second Resolution

As a result of the foregoing resolution, the Extraordinary General Meeting resolved to modify the first paragraph of

article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

“The Company has a subscribed share capital of twenty-seven million six hundred thousand Euro (EUR 27,600,000.-),

represented by two million seven hundred sixty thousand (2,760,000.-) redeemable class A shares (the “Class A Shares”),
with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.”

The rest of the articles of incorporation of the Company shall remain unchanged.

<i>Estimate of Costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of this Extraordinary General Meeting is estimated at approximately EUR
3,800.-

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version, on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-neuf juin,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de Predica Infrastructure S.A., une

société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.978
(la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 28 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1185 du 15
mai 2008, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Henri Hellinckx, de résidence à

102278

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, en date du 19 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 44 du 7
janvier 2010.

L’Assemblée est ouverte à 15h15 sous la présidence de Madame Maya Van Belleghem, licenciée en droit, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Emilie Dallemagne, licenciée en droit, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Laure Mollard, avocat, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d'actions de l’actionnaire,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par l’actionnaire ou par son mandataire et par les membres du
bureau de l’Assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La procuration de l’actionnaire représenté, paraphée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, restera aussi annexée au présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence, qui restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, que les deux

millions cent soixante mille (2.160.000) actions rachetables de classe A d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune, composant l’intégralité du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à l’Assemblée.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée et l’actionnaire présent ou

représenté déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour ci-dessous et de toute information y relative avant
l’Assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente Assemblée, représentant l’intégralité du capital social de la Société, est régulièrement constituée et

peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un apport en numéraire;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société;
«La Société a un capital souscrit de vingt-sept millions six cent mille euros (EUR 27.600.000,-), représenté par deux

millions sept cent soixante mille (2.760.000,-) actions rachetables de classe A (les «Actions de Classe A») d'une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

3. Divers.
Après avoir délibéré sur tous les points à l’ordre du jour, l’Assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes et

a requis le notaire instrumentant de bien vouloir acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de six millions d’euros (EUR 6.000.000,-),

pour le porter de son montant actuel de vingt et un millions six cent mille euros (EUR 21.600.000,-) à vingt-sept millions
six cent mille euros (EUR 27.600.000,), par l’émission de six cent mille (600.000) actions rachetables de classe A, d’une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les six cent mille (600.000) actions rachetables de classe A nouvellement émises ont été entièrement souscrites et

libérées par Predica S.A., une société anonyme constituée et régie selon la loi française, ayant son siège social au 50-56,
rue de la Procession, 75015 Paris, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 334.028.123, ici représentée par Madame Maya Van Belleghem, en vertu d'une procuration sous seing privé, ci-
annexée, par un apport en numéraire, de sorte que la somme de six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) se trouve à la
disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a un capital souscrit de vingt-sept millions six cent mille euros (EUR 27.600.000,-), représenté par deux

millions sept cent soixante mille (2.760.000,-) actions rachetables de classe A (les «Actions de Classe A») d'une valeur
nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette Assemblée est estimé à environ EUR 3.800,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

102279

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française, sur demande des comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connu du notaire instrumentant par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. VAN BELLEGHEM, E. DALLEMAGNE, A.-L. MOLLARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2010. Relation: LAC/2010/30373. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 août 2010.

Référence de publication: 2010116946/150.
(100132915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

Zeppelin Park, Société à responsabilité limitée,

(anc. Bountiful S.à r.l.).

Capital social: EUR 2.019.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 114.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010116046/12.
(100132026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Abattoir Ettelbruck S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 130.564.

L'an deux mille dix, le six août.
Pardevant le soussigné Fernand UNSEN, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Monsieur Claude GRAFF, administrateur délégué, demeurant à L-9132 Schieren, 6, Op der Schlaed,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme "ABATTOIR ETTEL-

BRUCK S.A.", avec siège social à L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale, numéro du RCS Luxembourg B
130564;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juillet 2007, publié au Mémorial C numéro

2074 du 24 septembre 2007,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration, prise en sa réunion du 5 juillet 2010 et

dont une copie du procès-verbal restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:
I. Que le capital social de la société "ABATTOIR ETTELBRUCK S.A." s'élève actuellement à quatre millions (4.000.000)

euros, divisé en huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) euros chacune.

II. Que dans le cadre du capital autorisé prévu à l'article 5 des statuts de la société anonyme unipersonnelle "ABATTOIR

ETTELBRUCK S.A.", le conseil d'administration, en sa réunion du 31 mai 2010, a autorisé d'augmenter le capital social
de la société de maximal un million (1.000.000) euros en fixant la date limite pour la souscription au trente et un juillet
deux mille dix.

III. Que le montant du capital effectivement souscrit et libéré se chiffre à neuf cent cinquante-huit mille (958.000) euros.
IV. Que le capital social de la société est augmenté de neuf cent cinquante-huit mille (958.000) euros pour le porter

de son montant actuel de quatre millions (4.000.000) euros à quatre millions neuf cent cinquante-huit mille (4.958.000)
euros.

Cette augmentation est réalisée par émission de mille neuf cent seize (1.916) actions d'une valeur nominale de cinq

cents (500) euros chacune.

Ces  actions  ont  été  intégralement  libérées  par  des  versements en espèces, de sorte que la  somme de neuf cent

cinquante-huit mille (958.000) euros se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

102280

L

U X E M B O U R G

Monsieur Claude GRAFF, ès-qualtiés qu'il agisse, déclare que la société anonyme "ABATTOIR ETTELBRUCK S.A." a

approuvé cette augmentation de capital et qu'elle a renoncé à son droit préférentiel de souscription.

Les nouveaux actionnaires ainsi que le nombre d'actions souscrites par eux sont repris sur une liste, laquelle, après

avoir été signée "ne varietur" par le notaire instrumentaire et le comparant restera annexée au présentes pour être
enregistrée avec elles.

A la suite de cette décision, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est à modifier et aura désormais la teneur

suivante:

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quatre millions neuf cent cinquante-huit mille (4.958.000) euros,

représenté par neuf mille neuf cent seize (9.916) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) euros chacune. Chaque
action donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à dix millions

(10.000.000) euros, représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) euros chacune."

<i>Déclaration - Frais.

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,

que les conditions requises pour l'augmentation de capital ont été remplies.

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison

des présentes est estimé à la somme de neuf cents (900) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Graff, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 11 août 2010. Relation: DIE/2010 / 7755. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la société.

Diekirch, le 19 août 2010.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2010116061/58.
(100129525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2010.

Compagnie de l'Europe du Sud S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 96.502.

GLOBAL TRUST ADVISORS SA a dénoncé par lettre datée du 06 Août 2010 tout office de domiciliation de la société

COMPAGNIE DE L'EUROPE DU SUD SA, domiciliée 38 Avenue de la Faïencerie (RCSL B96502),avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Août 2010.

Global Trust Advisors S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116064/12.
(100130460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2010.

SAE Capital Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.334.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 août 2010

Il ressort des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire de SAE CAPITAL HOLDINGS S.A.:
- que Madame Candice de Boni, Madame Catherine Koch et Monsieur Nicolas Gérard ont démissionné de leur fonction

d’administrateur.

- que Madame Catherine Koch a démissionné de sa fonction de Président du Conseil d’Administration
- que les personnes suivantes ont été nommées administrateur de la société jusqu'à l’assemblée générale statutaire de

2016:

* Monsieur Alessandro BENEDETTI, né le 13 juillet 1961 à Bologne (Italie) et demeurant à Riva Paradiso 7, CH-6900

Paradiso (Suisse);

* Monsieur Bertrand GAUQUELIN des PALLIERES, né le 11 novembre 1966 à Argenteuil (France), et demeurant à

Via dei Banchi Vecchi 35, I-00135, Rome (Italie);

102281

L

U X E M B O U R G

* Monsieur Christian KRUPPA, né le 8 mars 1965, à Augsburg (Allemagne) et demeurant à Al Nessnass St 32 C, Jumeira

3, Dubai (Emirats Arabes Unis);

* Monsieur Elie Gabriel LAHYANI, né le 16 novembre 1961, à Midelt (Maroc), et demeurant à Palm Jumeira Frond L

Villa 125, BP 79265 Dubai (Emirats Arabes Unis);

* Monsieur Laurence SUDWARTS, né le 14 juin 1975, à Londres (Royaume-Uni) et demeurant à Kleine Sperlgasse,

1/33, 1020 WIEN (GKZ 9001), Autriche.

<i>POUR LA SOCIETE
SGG S.A.

Référence de publication: 2010116974/26.
(100133156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

Solum 488 Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 141.414.

La fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclare

démissionner de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, de la société SOLUM 488 GROUP S.A.
situé au 273, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B141 414.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie sàrl
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010116067/17.
(100130450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2010.

Solum 488 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 141.411.

La fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, déclare

démissionner de sa fonction de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, de la société SOLUM 488 SA. situé au
273, Route de Longwy, L-1941 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B141 411.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2010.

Pour extrait sincère et conforme
Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie sàrl
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010116068/17.
(100130448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2010.

AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.678.

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société le 19 juillet 2010, il a été décidé de reconduire pour une

période renouvelable d'un an prenant fin lors de l'approbation par des comptes annuels de la Société au 31 décembre
2010, les mandats des gérants suivants:

- TMF Corporate Services S.A.
- M. Röhn Thomas Grazer et,
- M. Antonius Woutherus Josef van Vlerken

102282

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2010.

<i>Pour la société
TMF Corporate Services S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2010116078/20.
(100130834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

A.F.M.S. Accounting Financial &amp; Management Services, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 99.470.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 6 janvier 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Lex EIPPERS en son rapport oral et le Ministère Public
en ses conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme A.F.M.S.
ACCOUNTING FINANCIAL &amp; MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant eu son siège social à L-9554 Wiltz, 3, Hannelast,
liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch en date du 24 juillet 2007.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et a laissé les frais à charge de l'Etat.

Pour extrait conforme
s. Me Daniel BAULISCH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010116069/17.
(100131077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Algos, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.472.

Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT

Référence de publication: 2010116072/12.
(100130972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Ositech SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 28.446.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue en date du 18 août 2010

<i>à 14.30 heures au siège social de la société

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en

2016.

Le conseil d'administration se compose comme suit:
- Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la cour , né le 2 septembre 1962 à Curepipe, République de Maurice, demeurant

à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde

- Monsieur André Lutgen, avocat à la cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à L-1371 Luxembourg, 47,

Val Ste Croix

- Monsieur Stephane Lataste, avocate à la cour, né le 14 janvier 1965 à Laval (53) France, demeurant 39, rue de Crécy,

L-1364 Luxembourg

102283

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale accepte de la démission de Monsieur John A. Geddes en tant que commissaire de la Société et

nomme en ses lieux et place Monsieur André Van Acker, né à Sint-Genesius-Rode, le 8 septembre 1947, demeurant à
Lenniksebaan 1114, B-1602 Vlezenbeek. Son mandat prend effet lors de l'exercice social 2009 et viendra à échéance à
l'assemblée qui se tiendra en 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2010116938/25.
(100133229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

Algim S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9163 Kehmen, 6, Uesperwee.

R.C.S. Luxembourg B 96.299.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010116075/10.
(100130764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Alsa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 111.448.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT

Référence de publication: 2010116076/12.
(100130965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Bad Langensalza, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.481.

Les comptes annuels au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT

Référence de publication: 2010116083/12.
(100130945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Djedefre S.A. Holding, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.352.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 6 août 2010

L'assemblée générale, décide de renouveler le mandat de M. Alain MARSCHALLIK de sa fonction d'administrateur

unique. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2016.

L'assemblée générale, accepte la démission de Monsieur Fabien RIGHESCHI, chargé d'affaires, de sa fonction de com-

missaire aux Comptes et de nommer en remplacement LE COMITIUM INTERNATIONAL SA, société anonyme, ayant
son siège à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B
et le numéro 83.827. Son mandat expirera lors de l'assemblée statutaire de 2016.

L'assemblée générale, décide de transférer le siège social de la société établi à 2A, place de Paris à L-2314 Luxembourg

au 25C, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

102284

L

U X E M B O U R G

En conséquence, le siège social de la société est désormais établi au 25C, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alain MARSCHALLIK
<i>Administrateur unique

Référence de publication: 2010116215/20.
(100131397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2010.

Bad Schönborn, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.473.

Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT

Référence de publication: 2010116085/12.
(100130824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Bad Schönborn, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.473.

Les comptes annuels au 31 janvier 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT

Référence de publication: 2010116086/12.
(100130826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

RE Capital S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.287.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 20 mai 2010 que:

1. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, administrateur de sociétés, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Italie), ayant son adresse

au 20, rue des Muguets, L-8035 Strassen, Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de Gérant de la Société avec effet
depuis le 6 juillet 2009.

2. Monsieur Claudio Zaniboni, administrateur de sociétés, né le 16 août 1957 à Carpenedolo (Italie), ayant son adresse

au 9, Via Don Schena, 25013, Carpenedolo, Italie, a été nommé pour une durée indéterminée comme Gérant de la Société
avec effet depuis le 6 juillet 2009.

Depuis le 6 juillet 2009, le Conseil de Gérance est composé comme suit:

- Monsieur Augusto Bessi, administrateur de sociétés, né le 19 janvier 1976 à Padova (Italie), ayant son adresse pro-

fessionelle au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Madame Petra Ekas, administrateur de sociétés, née le 13 mars 1973 à Eemnes (Pays-Bas), ayant son adresse pro-

fessionelle au Berkeley Square House, Berkeley Square, W1J6BR, Londres, Grande-Bretagne;

- Monsieur Christophe Mathieu, administrateur de sociétés, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son

adresse professionelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Claudio Zaniboni, prénommé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

102285

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, 26 août 2010.

Pour extrait conforme
RE Capital S.à r.l.
Représentée par Monsieur Augusto Bessi
<i>Gérant

Référence de publication: 2010118095/30.
(100133091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2010.

Bad Schönborn, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.473.

Les comptes annuels au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2010116087/11.
(100130925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

Colt Group S.A, Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 445.791.894,50.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.679.

Monsieur Tony Bates a informé le conseil d'administration de Colt Group S.A. (la "Société") qu'il souhaitait se retirer

de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 Juillet 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2010.

<i>Pour la société Colt Group S.A.
Esmée Chengapen

Référence de publication: 2010116093/14.
(100131072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2010.

LSF JRPI Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 253.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.121.

In the year two thousand and ten, on the twenty-third day of August.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company established at 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by
Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Mathilde Ostertag, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Luxembourg, on 23 August 2010,

AND
Rising Sun III Holding, an exempt company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with

registered office at Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box
2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Mr Takehisa Tei,

here represented by Ms Mathilde Ostertag, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Tokyo, on 23 August 2010,

(the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

102286

L

U X E M B O U R G

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of LSF JRPI Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129.121, incorporated pursuant to a deed
of Maître Martine Schaeffer dated 10 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°
1625 of 2 August 2007, that has been amended since and for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated
23 April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1204 of 9 June 2010.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that they

may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 307,750 (three hundred seven

thousand seven hundred fifty euro) by an amount of EUR 54,750 (fifty-four thousand seven hundred fifty euro) to an
amount of EUR 253,000 (two hundred fifty-three thousand euro) by the cancellation of 438 (four hundred thirty-eight)
ordinary shares with a par value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 307,750 (three

hundred seven thousand seven hundred fifty euro), represented by 2,461 (two thousand four hundred sixtyone) ordinary
shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by an
amount of EUR 54,750 (fifty-four thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 253,000 (two hundred fifty-
three thousand euro), represented by 2,023 (two thousand twenty-three) ordinary shares and 1 (one) preferred share,
with a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 438 (four hundred
thirty-eight) ordinary shares having a nominal value of EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each, and by reim-
bursement to Lone Star Capital Investments S.à r.l. of the said amount of EUR 54,750 (fifty-four thousand seven hundred
fifty euro).

As a consequence of the share capital reduction, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 2,023 (two thousand

twenty-three) ordinary shares and Rising Sun III Holding holds 1 (one) preferred share.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the articles of association of

the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 253,000 (two hundred fifty-three thousand euro),

represented by 2,023 (two thousand twenty-three) ordinary shares and 1 (one) preferred share, with a nominal value of
EUR 125 (one hundred and twenty-five euro) each."

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mil dix, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 7, rue Robert Stümper, L2557 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay,

ici représentée par Me Mathilde Ostertag, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

à Luxembourg, le 23 août 2010,

ET
Rising Sun III Holding, une société établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à Century Yard, Cricket

Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, représentée par M. Takehisa
Tei,

102287

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Me Mathilde Ostertag, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

à Tokyo, le 23 août 2010,

(les Associés)
lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social

de la société à responsabilité limitée dénommée LSF JRPI Investments S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.121, constituée
selon acte de Maître Martine Schaeffer du 10 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
1625 du 2 août 2007, modifié la dernière fois par acte de Maître Martine Schaeffer en date du 23 avril 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1204 du 9 juin 2010.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et qu'ils peu-

vent valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital de la Société de son montant actuel de EUR 307.750 (trois cent sept mille sept cent cinquante

euros) par un montant de EUR 54.750 (cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros) à un montant de EUR 253.000
(deux cent cinquante-trois mille euros) par voie d'annulation de 438 (quatre cent trente-huit) parts sociales ordinaires
de la Société ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 307.750

(trois cent sept mille sept cent cinquante euros), représenté par 2.461 (deux mille quatre cent soixante-etune) parts
sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros)
chacune, par le biais d'une réduction de EUR 54.750 (cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros) à un montant de
EUR 253.000 (deux cent cinquante-trois mille euros), représenté par 2.023 (deux mille vingt-trois) parts sociales ordi-
naires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par
voie d'annulation de 438 (quatre cent trente-huit) parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur nominale de
EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, et par voie de remboursement du montant de EUR 54.750 (cinquante-quatre
mille sept cent cinquante euros) à Lone Star Capital Investments S.à r.l..

Suite à cette réduction de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 2.023 (deux mille vingt-trois) parts

sociales ordinaires et Rising Sun III Holding détient 1 (une) part sociale préférentielle.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, les Associés de la Société décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont

la version française aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 253.000 (deux cent cinquante-trois mille euros),

représenté par 2.023 (deux mille vingt-trois) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une
valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune."

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: M. Ostertag et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 août 2010. Relation: LAC/2010/37677. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2010.

Référence de publication: 2010117491/130.
(100133625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

102288


Document Outline

Abattoir Ettelbruck S.A.

A.F.M.S. Accounting Financial &amp; Management Services

Agence EUROPE

Algim S.à.r.l.

Algos

Alsa S.A.

AMB Europe Luxembourg Holding 1 S.à r.l.

Bad Langensalza

Bad Langensalza

Bad Schönborn

Bad Schönborn

Bad Schönborn

Bountiful S.à r.l.

Colt Group S.A

Compagnie de l'Europe du Sud S.A.

Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A.

Djedefre S.A. Holding

Imprimerie de l'Europe

International Business Consultants S.A.

LSF JRPI Investments S.àr.l.

Ositech SPF S.A.

Predica Infrastructure S.A.

RE Capital S.àr.l.

SAE Capital Holdings S.A.

Sagamore S.A.

Sethos S.A.

Shay Properties Bury S.à r.l.

Simonthal S.A.

SKB Capital S.A.

Société Cotonnière Financière S.A.

Société Flue S.A.

Solum 488 Group S.A.

Solum 488 S.A.

Stadlux Investment S.A.

Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A.

Sublim Investments S.A.

Symbolinvest S.A.

Tanis S.A.

Targa S.A.

Tellux Invest S.A.

Tenadu Investments S.A.

Tenadu Investments S.A.

Thamesline Investments

Tintoretto Sicar S.A.

Topaze Funds S.A.

Torsch Private Equity S.A., SPF

Treno Finanz S.à.r.l.

Trustlux S.A.

Unidiam S.A.

UTM S.A.

UTM S.A.

Valence S.A.

Vento Italia S.A.

V Finance S.A.

VH Estates S.A.

Visylia Investments S.A.

VLT Properties S.A.

Vratislavia Holdings S.A.

Walterstuff s.à r.l.

WCMG (Working Capital Management Group) S.A.

Whiskey 1 Holding S.à r.l.

Whiskey 2 Holding S.à r.l.

Zeppelin Park