This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1851
9 septembre 2010
SOMMAIRE
Alymere Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
88805
Anthill S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88808
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88828
Cameco Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
88806
Cattleya Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88806
CD Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88807
CD Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88807
CD Private Equity Sicar S.à r.l. . . . . . . . . . .
88807
CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l. . . . . .
88808
Charme Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
88843
Climalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88807
Computer Associates Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88805
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l. . . . . . . . . . . .
88818
De Longhi Household S.A. . . . . . . . . . . . . . .
88818
Ert Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88820
European Logistics Feeder S.C.A. . . . . . . .
88820
Fides Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . .
88821
Fides Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . .
88821
Fiduciaire GLACIS S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
88802
Finalam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88803
Fininfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88822
France Properties Invest S.A. . . . . . . . . . . .
88804
Freo Investment Management S.à r.l. . . . .
88821
Fruit Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88822
Fund Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88822
GE Intelligent Platforms Europe S.A. . . . .
88827
Gerim, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88827
Girst & Schneider S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88822
Glasgore Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88825
Glasgore Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88825
Glasgore Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88825
Global Care Solutions (GCS) S.A. . . . . . . .
88828
Global Care Solutions (GCS) S.A. . . . . . . .
88828
Global Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88826
Greenmix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88827
Green Way Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88826
Grenache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88826
H&F Wings Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
88833
HICL Infrastructure 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
88833
Hutchison 3G Austria Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88848
Hutchison Telecommunications Interna-
tional Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88834
Hutchison Telecommunications (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88833
Hutchison Telecommunications (Vietnam)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88834
Hutchison Whampoa 3G Content S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88848
Hutchison Whampoa 3G IP S.à r.l. . . . . . .
88848
Hutchison Whampoa Europe Investments
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88843
Hutchison Whampoa Finance S.à r.l. . . . .
88843
INVESCO Paris CDG Airport Hotel Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88834
KBC Equity Fund (L) Conseil Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88842
KBC Flexible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88826
Kohler Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88848
Nemus International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88827
Repco 35 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88802
Repco 36 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88802
Repco 37 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88803
Repco 38 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88803
Repco 43 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88804
Repco 45 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88804
Société de Participations FILUNOR . . . . .
88805
The Private Equity Company SA . . . . . . . .
88834
Thiel AS Logistics A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
88806
Tower 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88820
88801
L
U X E M B O U R G
Repco 35 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 347.370,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 126.422.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant lesi>
<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur
A;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur A;
4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,
administrateur B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094406/22.
(100104296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Repco 36 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 606.300,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 128.235.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant lesi>
<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur
A;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur A;
4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,
administrateur B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094407/22.
(100104301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Fiduciaire GLACIS S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 81.939.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010094522/10.
(100104876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88802
L
U X E M B O U R G
Repco 37 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 128.234.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant lesi>
<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur
A;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur A;
4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,
administrateur B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094408/22.
(100104311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Repco 38 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 128.188.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant lesi>
<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur
A;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur A;
4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,
administrateur B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094409/22.
(100104228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Finalam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 77.409.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010094527/10.
(100104895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88803
L
U X E M B O U R G
Repco 43 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 422.840,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 131.082.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant lesi>
<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur
A;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur A;
4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,
administrateur B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094410/22.
(100104230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Repco 45 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 33.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 131.081.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant lesi>
<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur
A;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur
A;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur A;
4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,
administrateur B;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010094411/22.
(100104232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.
France Properties Invest S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.303.
Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28/6/2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094529/10.
(100105291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88804
L
U X E M B O U R G
Alymere Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.203.600,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.462.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 14 juillet 2010i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date 30 juin
2010 qu'il a été décidé de réélire, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.
Le mandat du réviseur d'entreprise ainsi réélu expirera immédiatement après l'Assemblée Générale des Associés de
la Société devant se tenir en l'année 2011 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice ayant débuté
le 1 janvier 2010.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>Manfred Zisselsberger
Référence de publication: 2010094427/20.
(100104606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Computer Associates Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 103.372.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Mars 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2010.
Computer Associates Luxembourg S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010094470/15.
(100104566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Société de Participations FILUNOR, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 6.739.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 juin 2010i>
<i>Quatrième résolution:i>
L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Madame Nathalie REHM, employée privée, née à
Strasbourg (France) le 29/08/1966, résidant professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg et la
nomination, avec effet immédiat de Madame Nadine VINCENT, née à Toulon (France) le 06/09/1962, employée privée,
résidant professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'As-
semblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR
Société Anonyme
SGBT AGENT PRESTATAIRE
Signatures
Référence de publication: 2010094680/19.
(100105105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88805
L
U X E M B O U R G
Cameco Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.998.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 de la société grand-mère ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CAMECO LUXEMBOURG S.A.
i>Markus BOPP / Jean-Christophe DAUPHIN
Référence de publication: 2010094474/12.
(100104735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Cattleya Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.383.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2010i>
La démission de Monsieur John SEIL comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2012:
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094476/15.
(100105432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Thiel AS Logistics A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 75.394.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 03. Mai 2010i>
Es geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre der THIEL AS LOGISTICS
A.G. vom 03. Mai 2010 Folgendes hervor:
1. Das Mandat als Aufsichtsratskommissar wurde von Frau Sonja Rock beendet.
2. Frau Katja Kolf, geb. Weishaupt, wohnhaft in Dollbachstrasse 4, 54298 Igel, geboren am 9. Mai 1973 in Saarburg,
wurde zum Aufsichtsratskommissar für das Geschäftsjahr 2009 (das heißt bis einschließlich der Hauptversammlung, die
über den Jahresabschluss 2009 entscheidet) ernannt.
3. Frau Stefanie Britz hat ihr Mandat als Verwaltungsratsmitglied zum 30. April 2010 niedergelegt.
4. Herr Thomas Peter hat sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied, und somit auch sein Mandat als Geschäftsführer,
zum 30. April 2010 niedergelegt.
5. Herr Dr. Antonius Wagner, geboren am 1. September 1961 in Merfeld mit Geschäftssitz in 5, an de Längten, L-6776
Grevenmacher wurde mit sofortiger Wirkung und bis zum Ablauf der Generalversammlung, die im Jahre 2013 stattfinden
wird, zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.
6. Herr Peer Brauer, geboren am 13. März 1972 in Göttingen, mit Geschäftssitz in 5, an de Längten, L-6776 Greven-
macher wurde mit sofortiger Wirkung und bis zum Ablauf der Generalversammlung, die im Jahre 2013 stattfinden wird,
zum Verwaltungsratsmitglied ernannt.
7. Das Mandat von Herrn Hans-Volker Seidel wird bis zum Ablauf der Generalversammlung, die im Jahre 2013 statt-
finden wird bestätigt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 13. Juli 2010.
Eva Hörner.
Référence de publication: 2010094709/27.
(100105471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88806
L
U X E M B O U R G
CD Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.125.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CD PARTICIPATIONS SARL
G. GUISSARD / C. DARMON
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2010094477/12.
(100104552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
CD Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.854.553,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.125.
<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil de Gérance en date du 8 juillet 2010i>
Il est pris acte de la modification de l'adresse professionnelle des deux Gérants de catégorie B comme suit:
Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé MBA, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-
xembourg
Monsieur Grégory GUISSARD, employé privé, demeurant au 23, boulevard de la cluse, CH-1205 Genève (Suisse)
Le 8 juillet 2010.
Certifié sincère et conforme
CD PARTICIPATIONS SARL
G. GUISSARD / C. DARMON
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2010094478/18.
(100104761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
CD Private Equity Sicar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.802.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CD PRIVATE EQUITY SICAR SARL
G. GUISSARD / C. DARMON
<i>Gérant B / Gérant Ai>
Référence de publication: 2010094479/12.
(100104551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Climalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 17.165.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
88807
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 13 juillet 2010.
MAZARS
Signature
Référence de publication: 2010094483/12.
(100104553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.026.800,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2010.
Godfrey Abel / Martina Schümann
<i>Gérantsi>
Référence de publication: 2010094480/13.
(100105191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Anthill S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.541.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the fifth day of July.
Before the undersigned Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
INTRUMA PARTICIPATIONS S. à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri,
here represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to this present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party in the capacity of which it acts has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation (the «Articles») of a «société anonyme» which such party declares to incorporate.
Name - Purpose - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société anonyme», public company limited by shares (the «Company») governed
by the Articles and by the current Luxembourg laws (the «Law»), in particular the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.
Art. 2. The Company's name is ANTHILL S.A.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can act as director or liquidator of other companies.
The Company can also, in Luxembourg or in foreign countries, provide Consultancy and Management Services.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
88808
L
U X E M B O U R G
The Company can supply assistance services in any form whatsoever, in the study, the supervision and the management
of projects in any commercial, industrial, financial, technical and scientific areas and in the field of company organisation.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case
may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not within a permanent establishment), both in Luxembourg
and abroad.
In the event that the board of directors should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of directors of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or the sole shareholder.
Capital - Shares
Art. 7. The Company's issued share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-), represented
by THREE HUNDRED AND TEN (310) shares with a nominal value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each.
The amount of the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amend-
ment of the Articles.
Art. 8. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 9. The shares are freely transferable.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law on
Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option in certificates representing single shares or two or
more shares.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 10. The Company shall have power to redeem its own shares under the conditions stated in the Law.
Management - Supervision
Art. 11. The Company will be managed by a board of directors composed of at least three directors. However, when
all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the board of directors may be formed with a single director
under the conditions stated in the Law. The director(s) need not be shareholders of the Company.
When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company
of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate
of director of the Company.
The director(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of
shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the director(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The director(s) are re-eligible.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any director.
In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining
directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in
accordance with the Law.
The term of the office of the director(s) which shall not exceed six years, is fixed by the general meeting of the
shareholders or by the decision of the sole shareholder.
88809
L
U X E M B O U R G
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing
the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of share-
holders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.
In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose and provided
the terms of these Articles shall have been complied with.
According to article 60 of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revo-
cation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board
of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on
the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic
proxy or power of attorney by private instrument.
The Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the single director (as the case may
be). With respect to matters which relate to the daily management of the business of the Company, the Company will
also be bound by the signature of the person to whom the daily management of the business of the Company has been
delegated (as the case may be).
The board of directors may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc
agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.
The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 12. The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not
have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman,
the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may
also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.
The board of directors shall meet when convened by one director.
Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram or telex, electronic means or by any
other suitable communication means, of each director.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another director as his proxy.
A director may represent more than one director.
Any meeting of the board of directors shall take place in the Grand-Duchy of Luxembourg and shall require at least
the presence of half of the directors or of the single director (as the case may be), either present in person or by
representative, which shall form a quorum.
According to article 64bis (3) of the Law, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone,
videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.
Decisions of the board of directors are taken by the majority of directors participating to the meeting or duly repre-
sented thereto.
The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or, if applicable, by his substitute, or by two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the
board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two directors.
In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a
resolution passed at a meeting of the board of directors.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
88810
L
U X E M B O U R G
When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such
time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.
Art. 13. Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholder(s)
Art. 14. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the
shareholders. One general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on the first Monday of
June at 4.00 p.m. o'clock. If such a day is a public holiday, the general meeting shall be held the following business day at
the same time. Other general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in
the notice of the meeting.
Art. 15. General meetings of shareholders or the sole shareholder are convened by the board of directors, failing
which by shareholders representing one tenth or more of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent by registered letters to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general
meeting for which the notice shall be sent by registered letter at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the
meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
The directors may attend and speak in general meetings of shareholders.
General meetings of shareholders deliberate at the quorum and majority vote determined by the Law.
Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholders who request to do so.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1 and closes on December 31.
Art. 17. Each year, with effect as of December 31, the board of directors will draw up the balance sheet which will
contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) and statutory auditor(s) towards the Com-
pany, if any.
At the same time the board of directors will prepare a profit and loss account which will be transmitted, at least one
month before the date of the annual general meeting of shareholders together with a report on the operations of the
Company, to the statutory auditors that shall draft a report.
Art. 18. 15 (fifteen) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the head
office the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors and any document in accordance
with Article 73 of the Law.
Supervision of the company
Art. 19. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux
comptes), who may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six years
by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.
The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting
of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/
their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.
Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one
or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».
Dividend - Reserves
Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
88811
L
U X E M B O U R G
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders, at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder, may decide
that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Interim dividend
Art. 21. The board of directors may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in
accordance with the Law.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles may resolve
the dissolution of the Company.
Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders or by the sole shareholder which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders
proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
1.- Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2010.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2011.
<i>Payment - Contributionsi>
The THREE HUNDRED AND TEN (310) shares have been subscribed by INTRUMA PARTICIPATIONS S. à r.l.,
named above, and entirely paid up in cash, so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (EUR 31,000.-) is
avalaible to the company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 1,200.- Euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following
resolutions:
1) The number of directors is set at one and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one.
2) Is appointed as director:
INTRUMA CORPORATE SERVICES S. à r.l., with registered office at L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri,
Mr. Paul de Haan, born in Alkmaar, on 20 June 1971, professionally residing in L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince
Henri, will act as permanent representative.
In accordance with article 11 of its articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of the
single director.
The director shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be
held in June 2014.
3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes):
Mrs. Mireille HERBRAND, born in Malmedy, on 30 April 1974, professionally residing in L-1724 Luxembourg, 17,
boulevard Prince Henri.
In accordance with article 19 of the Articles, the statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the
annual general meeting of shareholders which will be held in June 2014.
4) The Company shall have its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
88812
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxies holders, said persons signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le cinq juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
soussigné.
Comparait:
INTRUMA PARTICIPATIONS S. à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri,
ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, en qualité par laquelle elle agit, a requis du notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les
lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.
Art. 2. La dénomination de la Société sera ANTHILL S.A.
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut agir en qualité d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
La Société a également pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la prestation de services dans le domaine du
Conseil et du Management.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
La société peut prester des services d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude, la surveillance et
la direction de toutes opérations dans des domaines financiers, commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et
dans le domaine de l'organisation des entreprises.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'adminis-
tration.
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) adoptée
selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
88813
L
U X E M B O U R G
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que
ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.
Capital social - Actions
Art. 7. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-), représenté par TROIS CENT DIX
(310) actions d'une valeur nominale de CENT EURO (EUR 100,-) chacune.
Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des
actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 8. Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.
Art. 9. Les actions sont librement cessibles.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Art. 10. La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.
Administration
Art. 11. La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois,
lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un
seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoire-
ment actionnaire(s) de la Société.
Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la
Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société.
L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale
des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s)
l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur
(s) est/sont rééligible(s).
L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).
En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour
toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pour-
voir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.
La durée du mandat de(s) l'administrateur(s) qui n'excédera pas 6 années, est fixée par l'assemblée générale des
actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil
d'administration.
Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société
et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les termes de ces
Statuts auront été respectés.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
88814
L
U X E M B O U R G
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle du seul admi-
nistrateur (selon le cas). En ce qui concerne les affaires relevant de la gestion journalière de la Société, la Société sera
également engagée par la signature de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société aura été déléguée (selon
le cas)
Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.
Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de
leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 12. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura
pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du
président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'ad-
ministration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable
de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche
spécifiée par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.
Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au
moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le
procès verbal de la réunion du conseil d'administration.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex,
moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à l'heure et au lieu
précisé précédemment lors d'une résolution du conseil d'administration.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,
câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de
la moitié des directeurs en personne ou représentés ou de la l'unique administrateur (selon le cas), laquelle sera consti-
tutive du quorum.
Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'adminis-
tration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identifi-
cation.
Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la
réunion ou qui y sont valablement représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou,
si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront
annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.
En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une
résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.
Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs
documents ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou
tout autre moyen de communication approprié.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique,
aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.
Art. 13. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.
88815
L
U X E M B O U R G
Assemblées générales des actionnaires
Art. 14. En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des ac-
tionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le premier lundi du mois de juin à seize
heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à la même
heure. Toute autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à
l'assemblée.
Art. 15. Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'admi-
nistration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour
laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours par courrier recommandé avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas
être nécessairement actionnaire.
Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.
Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la
demande.
L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire
des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que
les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.
Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins
un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations
de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.
Art. 18. 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre con-
naissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout
document mentionné dans l'article 73 de la Loi.
Surveillance de la société
Art. 19. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent
pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par
l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.
La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de
l'actionnaire unique.
Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un
ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'action-
naire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Dividendes - Réserves
Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.
L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
88816
L
U X E M B O U R G
Dividendes intérimaires
Art. 21. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice
social dans les conditions prévues dans la Loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises
pour la modification des statuts.
Art. 23. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur ré-
munération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans
le capital social de la Société.
Loi applicable
Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2010.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2011.
<i>Libération - Apportsi>
Les TROIS CENT DIX (310) actions ont été souscrites par INTRUMA PARTICIPATIONS S.à r.l., prédésignée, et
entièrement libérées apport en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) est
à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.200.- euros.
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a
tenu une assemblée générale d'actionnaires et, reconnaissant avoir été valablement convoqué, a pris les résolutions
suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2) Est nommée administrateur:
INTRUMA CORPORATE SERVICES S. à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri,
ayant comme représentant permanent:
Monsieur Paul de Haan, né à Alkmaar, le 20 juin 1971, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 17,
boulevard Prince Henri.
Conformément à l'article 11 de ses statuts, la Société est engagée par la signature individuelle de l'unique administra-
teur.
L'administrateur est nommé pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en juin 2014.
3) Madame Mireille HERBRAND, née à Malmedy, le 30 avril 1974, demeurant professionnellement à L-1724 Luxem-
bourg, 17, boulevard Prince Henri, est nommée comme commissaire aux comptes.
Conformément à l'article 19 des Statuts, le commissaire au compte est nommé pour une durée expirant le jour de
l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en juin 2014.
4) Le siège social de la Société est établi au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
88817
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2010. Relation: LAC/2010/31628. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 juillet 2010.
Référence de publication: 2010103495/527.
(100116383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2010.
De Longhi Household S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 95.384.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 20 avrili>
<i>2010i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur DIEDERICH Georges et Monsieur BIELLA Stefano sont renommés admi-
nistrateurs.
Monsieur DONATI Régis est renommé commissaire aux comptes.
Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.
Pour extrait sincère et conforme
DE LONGHI HOUSEHOLD S.A.
Georges DIEDERICH / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010094494/17.
(100104868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 119.271.
In the year two thousand and ten, on the ninth day of July.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary public notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CVI Global Value Fund Cayman L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, with registered office c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
duly represented by Andreia-Beatrice Ghioca, by virtue of a proxy given on 8 July 2010.
This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.,a société à
responsabilité limitée having its registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 119271, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on 4 September 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2046, on 29
November 2006, and amended on 26 February 2010 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 716, on 6 April 2010 (the “Company”).
The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 12 of the articles of incorporation of the Company which shall now
read as follows:
“ Art. 12. The Company shall be managed by at least one (1) A manager and one (1) B manager, who do not need to
be shareholders.
In dealings with third parties, the managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
88818
L
U X E M B O U R G
The managers are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the term
of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as the case
may be, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
The board of managers shall deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, among whom at least
one (1) A manager, is present or represented and all decisions are validly taken at the majority of the managers present
or represented, among whom at least one (1) A manager.
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.”
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about eight hundred euro (EUR 800.-).
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille dix, le neuf juillet.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CVI Global Value Fund Cayman L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant
son siège social c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïmans,
ici représentée par Andreia-Beatrice Ghioca, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 juillet 2010.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de CVI GVF (Lux) Master S.à r.l., une société à responsabilité
limitée ayant son siège social à 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 119271, constituée par un acte du notaire soussigné du 4 septembre 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2046, le 29 novembre 2006 et modifié le 26 février 2010 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 716, le 6 avril 2010 (la «Société»).
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 12. La Société est gérée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B, qui ne
doivent pas nécessairement être associés.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Les gérants sont nommés par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat des gérants.
Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il
soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
Le conseil de gérance délibère ou agit valablement seulement si au moins la majorité des gérants, parmi lesquels au
moins un (1) gérant de classe A, est présente ou représentée et que toutes les décisions sont valablement prises à la
majorité des gérants présents ou représentés, parmi lesquels au moins un (1) gérant de classe A.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ huit cents euros (EUR 800,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
88819
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A-B. Ghioca et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 juillet 2010. LAC/2010/31011. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2010.
Référence de publication: 2010095508/91.
(100106716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.
Ert Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 123.255.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 31 mai 2010i>
Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg avec effet au 1
er
juillet 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010094512/12.
(100105192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
European Logistics Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.820.
EXTRAIT
En date du 28 mai 2010, l'assemblée générale de la société European Logistics Feeder S.C.A. a approuvé:
de renouveler le mandat de:
- MAZARS
Comme Réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tient en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour European Logistics Feeder S.C.A.
i>Signature
Référence de publication: 2010094516/15.
(100105468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Tower 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 142.847.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés tenue le 30 juin 2010 à 10.00 heures au siège social de lai>
<i>sociétéi>
Le président informe l’assemblée que Monsieur John Seil, par lettre datée du 30 juin, a donné sa démission de ses
fonctions de membre du Conseil de Gérance de la société.
L’assemblée décide d’accepter sa démission avec effet immédiat et conformément à l’article 8 des statuts décide d'élire
gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Giorgio Mancuso, né le 10 septembre 1970 a Sant’Agata di Militello (Italie), demeurant professionnellement
au 1, Riva Albertolli, 6900 Lugano (Suisse);
- Monsieur Federico Franzina, né le 1
er
avril 1961 à Padova (Italie), demeurant professionnellement au 5, Place du
Théâtre, L-2613 Luxembourg;
88820
L
U X E M B O U R G
- Madame Vania Baravini né le 21 mai 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre,
L-2613 Luxembourg.
- Monsieur Massimiliano Seliziato né le 6 janvier 1982 à Mirano (Italie), demeurant professionnellement au 5, Place du
Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire commissaire aux comptes pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31décembre 2010:
- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B 47771
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2010.
Référence de publication: 2010095146/27.
(100106446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2010.
Fides Capital Partners S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 88.641.
En ma qualité d'agent domiciliataire, je soussignée, la fiduciaire Jean-Marc FABER S.à.r.l. déclare dénoncer avec effet
immédiat le siège de la société FIDES CAPITAL PARTNERS S.A. situé au 63-65 rue de Merl à L-2146 Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 88 641.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010094524/14.
(100105321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Fides Capital Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 88.641.
Je soussignée, la fiduciaire Jean-Marc FABER & Cie S.à.r.l., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg, démissionne de sa fonction de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat de la société FIDES CAPITAL
PARTNERS S.A. situé au 63-65 rue de Merl à L-2146 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 88 641.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010094525/16.
(100105322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Freo Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 123.898.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FREO INVESTMENT MANAGEMENT S.àr.l.
i>Heike
Référence de publication: 2010094530/11.
(100105093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88821
L
U X E M B O U R G
Girst & Schneider S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage.
R.C.S. Luxembourg B 100.844.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 LUXEMBOURG
4, RUE HENRI SCHNADT
Signature
Référence de publication: 2010094546/13.
(100104937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Fruit Invest S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 78.474.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FRUIT INVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010094532/12.
(100104548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Fund Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 86.828.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 2010i>
L'Assemblée Générale Statutaire approuve la réélection de DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d'Entreprises pour
un nouveau mandat d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FUND PARTNERS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094533/14.
(100105259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Fininfra, Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 137.745.
In the year two thousand and ten,
on the thirteenth day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“AXA Infrastructure Partners FCPR”, a fonds commun de placement à risque, represented by AXA Investment Ma-
nagers Private Equity Europe, a company governed by French law, having its registered office at 20, place Vendôme, 75001
Paris, France and registered under number 403 201 882 RCS Paris,
here represented by Mrs Jennifer FERRAND, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 12 July 2010.
The appearing is the sole shareholder of “Fininfra”, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, whose
registered office is at 6 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
88822
L
U X E M B O U R G
Companies under number B 137745, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at
Sanem, of 31 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, dated 7 May 2008, number
1120 (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have last been amended by a deed of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary residing at Sanem, of 14 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des sociétés et
associations, dated 15 February 2010, number 330.
The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the corporate capital by an amount of one thousand nine hundred fifty euro (EUR 1,950.-) so as to raise
it from its present amount of one million four hundred twenty-seven thousand seven hundred seventythree euro (EUR
1,427,773.-) to one million four hundred twenty-nine thousand seven hundred twenty-three euro (EUR 1,429,723.-).
2 To issue one thousand nine hundred fifty (1,950) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share
having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To accept subscription for these new shares by AXA Infrastructure Partners FCPR and to accept payment in full for
such new shares by a contribution in cash.
4 To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the increase of the issued capital of the
Company.
5 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one thousand nine
hundred fifty euro (EUR 1,950.-) so as to raise it from its present amount of one million four hundred twenty-seven
thousand seven hundred seventy-three euro (EUR 1,427,773.-) to one million four hundred twenty-nine thousand seven
hundred twenty-three euro (EUR 1,429,723.-).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to issue one thousand nine hundred fifty (1,950) new shares with a nominal value of
one euro (EUR 1.-) per share having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon has appeared Mrs Jennifer FERRAND, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact
of AXA Infrastructure Partners FCPR, prenamed, by virtue of a proxy given on 12 July 2010 (the “Subscriber”).
The Subscriber declared to subscribe for one thousand nine hundred fifty (1,950) new shares having each a nominal
value of one euro (EUR 1.-) and to make payment for such new shares by a contribution in cash.
The amount of one thousand nine hundred fifty euro (EUR 1,950.-) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the one thousand
nine hundred fifty (1,950) new shares to the Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 5, first paragraph of the articles
of incorporation, which will from now on read as follows:
Art. 5. Capital (first paragraph). “The issued capital of the Company is set at one million four hundred twenty-nine
thousand seven hundred twenty-three euro (EUR 1,429,723.) divided into one million four hundred twenty-nine thousand
seven hundred twenty-three (1,429,723) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which have been
fully paid-in."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at
seven hundred euro.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status
and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
88823
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix,
le treize juillet,
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
est apparu:
«AXA Infrastructure Partners FCPR», un fonds commun de placement à risque, représenté par AXA Investment
Managers Private Equity Europe, une société de droit français, ayant son siège social à 20, place Vendôme, 75001 Paris,
France et enregistrée sous le numéro 403 201 882 RCS Paris,
représentée par Maître Jennifer FERRAND, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration donnée le 12 juillet 2010.
Le comparant est l'associé unique de «Fininfra», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137745, constituée suivant acte notarié de Maître Jean-
Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 31 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, en date du 7 mai 2008, numéro 1120 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 décembre 2009, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 15 février 2010, numéro 330.
Le comparant, représenté comme mentionnée ci-dessus, a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre
sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social d'un montant de mille neuf cent cinquante euros (EUR 1.950,-) pour le porter de son
montant actuel de un million quatre cent vingt-sept mille sept cent soixante-treize euros (EUR 1.427.773,-) à un million
quatre cent vingt-neuf mille sept cent vingt-trois euros (EUR 1.429.723,-).
2 Émission de mille neuf cent cinquante (1.950) actions nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune
ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces actions nouvelles par AXA Infrastructure Partners FCPR et acceptation de la
libération intégrale de ces actions nouvelles par apport en espèces.
4 Modification de l'article 5 des statuts de manière à refléter l'augmentation du capital social de la Société.
5 Divers.
et a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille neuf cent cinquante euros
(EUR 1.950,-) pour le porter de son montant actuel d'un million quatre cent vingt-sept mille sept cent soixante-treize
euros (EUR 1.427.773,-) à un million quatre cent vingt-neuf mille sept cent vingt-trois euros (EUR 1.429.723,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé d'émettre mille neuf cent cinquante (1.950) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un
euro (EUR 1,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite Maître Jennifer FERRAND, prénommée, s'est présenté, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé
de AXA Infrastructure Partners FCPR, précité, en vertu d'une procuration donnée le 12 juillet 2010 (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur a déclaré souscrire mille neuf cent cinquante (1.950) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un
euro (EUR 1,-) chacune et libérer intégralement ces actions nouvelles par un apport en numéraire.
Le montant de mille neuf cent cinquante euros (EUR 1.950,-) est à partir de maintenant à la disposition de la Société,
la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.
Ensuite, l'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'attribuer les mille neuf cent
cinquante (1.950) actions nouvelles au Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5, premier alinéa
des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
Art. 5. Capital social (alinéa premier). «Le capital social de la Société est fixé à un million quatre cent vingt-neuf mille
sept cent vingt-trois euros (EUR 1.429.723,-) divisé en un million quatre cent vingt-neuf mille sept cent vingt-trois
(1.429.723) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, intégralement libérées.»
88824
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à sept cents euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. FERRAND, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 juillet 2010. Relation: EAC/2010/8539. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010097369/136.
(100108851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.
Glasgore Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.671.
Le bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2010.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094534/12.
(100105201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Glasgore Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.671.
Le bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2010.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094535/12.
(100105216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Glasgore Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.671.
Le bilan au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2010.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094536/12.
(100105220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88825
L
U X E M B O U R G
KBC Flexible, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 139.453.
<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 2010i>
Messieurs Luc ROMBOUTS et Dirk VAN LIEMPT, résidant professionnellement Waaistraat 6, B-3000 Leuven, Mon-
sieur Ignace VAN OORTEGEM, résidant professionnellement 2, Avenue du Port B-1080 Bruxelles et Monsieur Karel DE
CUYPER, résidant professionnellement 5 Place de la Gare, L-1616 Luxembourg sont réélus à leur poste d'Administrateur
pour un nouveau terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.
DELOITTE S.A. est réélu en tant que Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale
Statutaire de 2011.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC FLEXIBLE
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094599/18.
(100105198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Global Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 129.759.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 2010i>
L'Assemblée Générale Statutaire approuve la réélection de DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d'Entreprises pour
un nouveau mandat d'un an, se terminant à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GLOBAL PARTNERS
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094537/14.
(100105266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Green Way Arbitrage, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 48.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2010094538/10.
(100104994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Grenache, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 134.649.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 14 juillet 2010i>
Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date 30 juin
2010 qu'il a été décidé de réélire, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.
Le mandat du réviseur d'entreprise ainsi réélu expirera immédiatement après l'Assemblée Générale des Associés de
la Société devant se tenir en l'année 2011 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice ayant débuté
le 1
er
janvier 2010.
88826
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>Manfred Zisselsberger
Référence de publication: 2010094539/20.
(100104600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Greenmix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9572 Weidingen, 1, rue des Vieilles Tanneries.
R.C.S. Luxembourg B 99.766.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010094549/10.
(100104669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
GE Intelligent Platforms Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 105.114.
La Société, soumise au droit luxembourgeois, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire
résident alors à Mersch, en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 311 du 8 avril 2005 alors
dénommée "GE Fanuc Automation Solutions Europe S.A.".
Les statuts de la Société ont été successivement modifiés suivant actes reçus par le notaire susmentionné, alors de
résidence à Mersch et ensuite à Luxembourg, en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 377 du
26 avril 2005, en date du 15 février 2005, publié au Mémorial C numéro 194 du 4 mars 2005 et en date du 15 octobre
2007, publié au Mémorial C numéro 2914 du 14 décembre 2007. Les statuts de la Société ont été dernièrement
modifiés par acte notarié de Maître Martine SCHAEFFER changeant la dénomination de la société en "GE Intelligent
Platforms Europe S.A." en date du 7 janvier 2010, publié au Mémorial C, numéro 670 du 30 mars 2010.
Les comptes et les annexes de la Société pour la période du 1
er
janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094540/20.
(100105077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Gerim, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6978 Hostert, 4, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 33.986.
Lors de l'assemblée extraordinaire de la GÉRIM S.A.R.L. B33986 du 23/06/2010 il a été retenu ce qui suit: Monsieur
Jacques Steiwer cède son unique part sociale de la GÉRIM S.A.R.L. à Mme Steiwer Laure.
<i>Pour GÉRIM S.A.R.L
La Gérantei>
Référence de publication: 2010094545/11.
(100105320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Nemus International, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 88.969.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 juin 2010, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1/ Acceptation de la démission des administrateurs suivants avec effet immédiat:
- Kai Hennen, avec adresse professionnelle au 58, Rue Charles Martel, L-213 4 Luxembourg
- Kathryn Bergkoetter, avec adresse professionnelle au 58, Rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
88827
L
U X E M B O U R G
- Noel McCormack, avec adresse professionnelle au 58, Rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
2/ Nomination des administrateurs suivants:
- Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat d'adminis-
trateur
- James Paterson, avec adresse au Aviator Park, Station Road, KT15 2PG Addlestone, Surrey, Royaume-Uni
avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2009 et qui se tiendra en 2010.
3/ Transfert du siège social de la société du 58, Rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 7a, Rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mentioNn aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2010.
Référence de publication: 2010095660/23.
(100106491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.
Global Care Solutions (GCS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 78.388.
Le bilan modifié au 31 Décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et
remplace le bilan au 31 Décembre 2007 précédemment déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la référence L100011535.05 le 22/01/210.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094547/14.
(100105229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Global Care Solutions (GCS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 78.388.
Le bilan modifié au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et
remplace le bilan au 31 Décembre 2008 précédemment déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la référence L100011537.05 le 22/01/210.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2010.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094548/14.
(100105235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.026.506,37.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 146.948.
In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of the month of June.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l (the
"Company"), a société à responsabilité limitée with registered office in L-2440 Luxembourg, 63, rue Rollingergrund,
incorporated by deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 30
th
June 2009, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1443 dated 27
th
July 2009. The articles of
88828
L
U X E M B O U R G
the Company have been amended for the last time on 26
th
April 2010 by deed of the undersigned notary, not yet published
in the Mémorial.
The meeting was presided by Me Susanne Goldacker, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Me Antoine Daurel, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Me Stéphanie Damien, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list signed
by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary, which will be attached to
the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all one hundred two million six hundred fifty thousand six hundred thirty-
seven (102,650,637) shares of different classes (and categories) in issue in the Company were represented at the general
meeting and all the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the
meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.
II. The agenda of the meeting is as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company by eight thousand one hundred fifteen Euro and fifty-three Euro
cent (€8,115.53) to one million thirty-four thousand six hundred twenty-one Euro and ninety Euro cent (€1,034,621.90)
and issue of eight hundred eleven thousand five hundred fifty-three (811,553) shares of a nominal value of one euro cent
(€0.01) each in the classes and categories as set forth below to BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co KG, an
existing shareholder, against the cash contribution of seven hundred ninety-five thousand four hundred thirty-seven Euro
and thirty Euro cent (€795,437.30) to the Company, allocation of an amount of eight thousand one hundred and fifteen
Euro and fifty-three Euro cent (€8,115.53) of the contribution to the share capital account and the remainder of seven
hundred eighty-seven thousand three hundred twenty-one Euro and seventy-seven Euro cent (€787,321.77) to the freely
distributable share premium:
Class
Category
Number
of shares
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-O
81,155
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-O
81,155
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C-O
81,155
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C-O
81,155
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-O
81,155
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F-O
81,155
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G-O
81,155
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H-O
81,156
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-O
81,156
J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J-O
81,156
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total Ordinary 811,553
consequential amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
" 5.1. The issued share capital of the Company is set at one million thirty-four thousand six hundred twenty-one Euro
and ninety Euro cent (€1,034,621.90) represented by one hundred three million four hundred sixty-two thousand one
hundred ninety (103,462,190) Shares of Class A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J (each Class of Shares sub-divided into one
Ordinary Category and two Preferred Categories as set forth below) of a nominal value of one Euro cent (€0.01) each
and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation, as follows:
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred sixteen (10,346,216) Class A Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-seven (2,227,867) Category A-O Shares, three million
nine hundred seventy-seven thousand nine hundred ninety-one (3,977,991) Category A-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-eight (4,140,358) Category A-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred sixteen (10,346,216) Class B Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-seven (2,227,867) Category B-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category B-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-eight (4,140,358) Category B-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred sixteen (10,346,216) Class C Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-seven (2,227,867) Category C-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category C-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-eight (4,140,358) Category C-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred seventeen (10,346,217) Class D Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-eight (2,227,868) Category D-O Shares, three million
88829
L
U X E M B O U R G
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety one (3,977,991) Category D-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-eight (4,140,358) Category D-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred nineteen (10,346,219) Class E Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-eight (2,227,868) Category E-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category E-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-nine (4,140,359) Category E-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred nineteen (10,346,219) Class F Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-eight (2,227,868) Category F-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category F-PB Shares four million one hundred
forty thousand three hundred fifty-nine (4,140,359) Category F-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred twenty-one (10,346,221) Class G Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred seventy (2,227,870) Category G-O Shares, three million nine
hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category G-PB Shares and four million one hundred
forty thousand three hundred fifty-nine (4,140,359) Category G-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred twenty-two (10,346,222) Class H Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred seventy-one (2,227,871) Category H-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category H-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-nine (4,140,359) Category H-PK Shares;
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred twenty-two (10,346,222) Class I Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred seventy-one (2,227,871) Category I-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category I-PB Shares four million one hundred
forty thousand three hundred fifty-nine(4,140,359) Category I-PK Share; and
- ten million three hundred forty-six thousand two hundred twenty-two (10,346,222) Class J Shares divided into two
million two hundred twenty-seven thousand eight hundred seventy-one (2,227,871) Category J-O Shares, three million
nine hundred seventy seven thousand nine hundred ninety two (3,977,992) Category J-PB Shares and four million one
hundred forty thousand three hundred fifty-nine (4,140,359) Category J-PK Shares."
The above having been approved by the meeting, the following resolution was unanimously passed:
<i>Sole resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital by eight thousand one hundred fifteen Euro and fifty-three
Euro cent (€8,115,53) to one million thirty-four thousand six hundred twenty-one Euro and ninety Euro cent
(€1,034,621.90) by the issue of eight hundred eleven thousand five hundred fifty-three (811,553) shares of a nominal value
of one Euro cent (€0.01) each in classes (and categories) as set forth in the agenda above for a total subscription price
of seven hundred ninety-five thousand four hundred thirty-seven Euro and thirty Euro cent (€795,437.30).
Thereupon BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co KG, an existing shareholder, here represented by Susan
Goldacker, by virtue of one of the aforementioned proxies, subscribed to and fully paid each of such newly issued shares
and the meeting resolved to issue such shares.
Evidence of the full payment of the subscription price of seven hundred ninety-five thousand four hundred thirty-seven
Euro and thirty Euro cents (€795,437.30) was shown to the undersigned notary.
The meeting resolved to allocate an amount of eight thousand one hundred fifteen Euro and fifty-three Euro cent
(€8,115,53) to the share capital and the remainder to the fully distributable share premium and to amend article 5.1 as
set forth in the agenda.
There being nothing further on the agenda and all agenda items having been considered and resolved upon, the meeting
was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about EUR 2,400.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le seize juin,
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
88830
L
U X E M B O U R G
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l. (la "Société"),
une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 63, rue Rollingergrund, constituée suivant
acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") n°1443 du 27 juillet 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois le 26 avril 2010 suivant acte reçu du notaire soussigné, pas encore publié au Mémorial.
L'assemblée a été présidée par M
e
Susanne Goldacker, demeurant à Luxembourg.
La présidente a nommé comme secrétaire M
e
Antoine Daurel, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Me Stéphanie Damien, demeurant à Luxembourg.
La présidente a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné, laquelle restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Il ressort de ladite liste de présence que toutes les cent deux millions six cent cinquante mille six cent trente-sept
(102.650.637) parts sociales de différentes classes (et catégories) émises dans la Société étaient représentées à l'assemblée
générale et tous les associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour de sorte que
l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Augmentation du capital social émis de la Société de huit mille cent quinze euros et cinquante-trois centimes d'euros
(€8.115,53) à un million trente quatre mille six cent vingt et un euros et quatre-vingt-dix centimes d'euros (€1.034.621,90)
et émission de huit cent onze mille cinq cent cinquante trois (811,553) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime
d'euros (€0,01) chacune dans les classes et catégories telles que décrites ci-dessous à BMG RM Management Beteiligungs
GmbH & Co. KG, un actionnaire existant, en contrepartie de l'apport de sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent
trente-sept euros et trente centimes d'euros (€795.437,30) à la Société, allocation d'un montant de huit mille cent quinze
euros et cinquante-trois centimes d'euros (€8.115,53) au compte du capital social et le solde de sept cent quatre-vingt-
sept mille trois cent vingt-et-un euros et soixante-dix-sept centimes d'euros (€787.321,77) au compte de la prime
d'émission librement distribuable:
Classe
Catégorie
Nombre
de parts
sociales
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-O
81.155
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-O
81.155
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C-O
81.155
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C-O
81.155
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-O
81.155
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F-O
81.155
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G-O
81.155
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H-O
81.156
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I-O
81.156
J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J-O
81.156
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total Ordinaires
811.553
modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à un million trente-quatre mille six cent vingt et un euros et quatre-
vingt-dix centimes d'euros (€1.034.621,90) représenté par cent trois millions quatre cent soixante-deux mille cent quatre-
vingt-dix (103.462.190) Parts Sociales de Classe A, B, C, D, E, F, G, H, I et J (chaque Classe de Parts Sociales étant divisée
en une Catégorie Ordinaire et deux Catégories Préférentielles, tel que décrit ci-après) d'une valeur nominale d'un centime
d'euros (€ 0,01) chacune, et ayant les droits et obligations tels que décrits dans les présents Statuts, comme suit:
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent seize (10.346.216) Parts Sociales de Classe A divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-sept (2.227.867) Parts Sociales de Catégorie A-O, trois millions neuf
cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie A-PB et quatre millions
cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie A-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent seize (10.346.216) Parts Sociales de Classe B divisées en deux
millions deux vingt-sept mille huit cent soixante-sept (2.227.867) Parts Sociales de Catégorie B-O, trois millions neuf cent
soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3,977,991) Parts Sociales de Catégorie B-PB et quatre millions cent
quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie B-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent seize (10.346.216) Parts Sociales de Classe C divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-sept (2.227.867) Parts Sociales de Catégorie C-O, trois millions neuf
88831
L
U X E M B O U R G
cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie C-PB et quatre millions
cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie C-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent dix-sept (10.346.217) Parts Sociales de Classe D divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-huit (2.227.868) Parts Sociales de Catégorie D-O, trois millions neuf
cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze (3.977.991) Parts Sociales de Catégorie D-PB et quatre millions
cent quarante mille trois cent cinquante-huit (4.140.358) Parts Sociales de Catégorie D-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent dix-neuf (10.346.219) Parts Sociales de Classe E divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-huit (2.227.868) Parts Sociales de Catégorie E-O, trois millions neuf
cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie E-PB et quatre millions
cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie E-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent dix-neuf (10.346.219) Parts Sociales de Classe F divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-huit (2.227.868) Parts Sociales de Catégorie F-O, trois millions neuf
cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie F-PB et quatre millions
cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie F-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent vingt-et-un (10.346.221) Parts Sociales de Classe G divisées en
deux millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix (2.227.870) Parts Sociales de Catégorie G-O, trois millions
neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie G-PB et quatre
millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie G-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent vingt-deux (10.346.222) Parts Sociales de Classe H divisées en
deux millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-et-onze (2.227.871) Parts Sociales de Catégorie H-O, trois
millions neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie H-PB et
quatre millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie H-PK;
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent vingt-deux (10.346.222) Parts Sociales de Classe I divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante-et-onze (2.227.871) Parts Sociales de Catégorie I-O, trois millions
neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie I-PB et quatre
millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie I-PK; et
- dix millions trois cent quarante-six mille deux cent vingt-deux (10.346.222) Parts Sociales de Classe J divisées en deux
millions deux cent vingt-sept mille huit cent soixante et onze (2.227.871) Parts Sociales de Catégorie J-O, trois millions
neuf cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (3.977.992) Parts Sociales de Catégorie J-PB et quatre
millions cent quarante mille trois cent cinquante-neuf (4.140.359) Parts Sociales de Catégorie J-PK."
Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, la résolution suivante a été prise à l'unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de huit mille cent quinze euros et cinquante trois centimes
d'euros (€8.115,53) afin de le porter à un million trente quatre mille six cent vingt et un euros et quatre-vingt-dix centimes
d'euros (€1.034.621,90) par l'émission de huit cent onze mille cinq cent cinquante trois (811,553) parts sociales d'une
valeur nominale d'un centime d'euros (€0,01) chacune dans les classes (et catégories) telles que spécifiées dans l'ordre
du jour ci-dessus, pour un prix de souscription total s'élevant à sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent trente-
sept euros et trente centimes d'euros (€795.437,30).
En conséquence, BMG RM Management Beteiligungs GmbH & Co KG, un actionnaire existant, ici représenté par
Susanne Goldacker,
en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, a souscrit et a entièrement libéré chacune de ces parts sociales
nouvellement émises et l'assemblée a décidé d'émettre de telles parts sociales.
Preuve du paiement complet du prix de souscription s'élevant à sept cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent trente-
sept euros et trente centimes d'euros (€795.437,30) a été donnée au notaire soussigné.
L'assemblée a décidé d'affecter un montant de huit mille cent quinze euros et cinquante trois centimes d'euros
(€8.115,53) au compte du capital de la Société et le restant au compte de la prime d'émission librement distribuable et
de modifier l'article 5.1 tel que spécifié dans l'ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa
charge en raison de son augmentation de capital au taux d'enregistrement fixe sont estimés à environ EUR 2.400,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties com-
parantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. GOLDACKER, S. DAMIEN et H. HELLINCKX.
88832
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2010. Relation: LAC/2010/27875. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME – délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 juillet 2010.
Référence de publication: 2010098029/242.
(100109949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2010.
H&F Wings Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.072,04.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.173.
EXTRAIT
En date du 8 décembre 2009, H&F Wings Lux 1 S.àr.l. a transféré 170.300 parts sociales ordinaires et 276 parts sociales
préférentielles dans la Société à WINGS MGTEQUITYCO LIMITED.
Suite à ce transfert des parts sociales de la Société, les associés de la Société sont les suivants:
1) H&F Wings Lux 1 S.àr.l. détenant 1.809.556 parts sociales ordinaires et 5.403 parts sociales préférentielles;
2) Hellman & Friedman Capital Partners VI (Cayman), L.P. détenant 1 part sociale ordinaire;
3) Hellman & Friedman Capital Partners VI (Cayman Parallel), L.P. détenant 1 part sociale ordinaire;
4) Hellman & Friedman Capital Associates VI (Cayman), L.P. détenant 1 part sociale ordinaire;
5) Hellman & Friedman Capital Executives VI (Cayman), L.P. détenant 1 part sociale ordinaire; et
6) WINGS MGTEQUITYCO LIMITED détenant 190.440 parts sociales ordinaires et 1.801 parts sociales préférentielles
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2010.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2010094550/22.
(100104616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 112.244.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094551/10.
(100104639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
HICL Infrastructure 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 75.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 115.190.
EXTRAIT
Un des gérants de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS, a changé son adresse anciennement 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg comme suit:
- 30 rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg,
Luxembourg, le 14 juillet 2010.
<i>Pour HICL INFRASTRUCTURE 1 S.à.r.l.
i>Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2010094559/16.
(100104898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88833
L
U X E M B O U R G
Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 102.750.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094552/10.
(100104647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
The Private Equity Company SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 84.556.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 juin 2010i>
1/ Le mandat de Monsieur John SEIL n'est pas renouvelé.
2/ Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 décembre 2015:
- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président.
- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg,
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 décembre 2015:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094707/22.
(100105161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Hutchison Telecommunications International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 114.959.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094553/10.
(100104666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
INVESCO Paris CDG Airport Hotel Investments S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.394.700,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.193.
In the year two thousand and ten on the eighteenth day of March.
Before Us, Maitre Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Invesco European Hotel Real Estate S.à r.l. (the “Shareholder”) a société à responsabilité limitée, incorporated under
the laws of Luxembourg with registered address at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with
Luxembourgish trade register under number B119686;
here represented by Simone Schmitz, with professional address in Luxembourg,
88834
L
U X E M B O U R G
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on March 15
th
, 2010.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that the Shareholder is the sole shareholder of Invesco Paris CDG Airport Hotel Investments S.A., a société anonyme,
having its registered office in L2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, incorporated by a deed of the notary Decker
on 10
th
November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 87 of 1
st
February
2005. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maitre Hellinckx, residing
in Luxembourg, dated 26
th
March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 852
of 21
st
April 2009;
- that the sole member has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decided to change the articles of incorporation to be read as follows:
A. Name - Registered Office - Duration - Purpose
Art. 1. There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of Invesco Paris CDG Airport
Hotel Investments S.A. (the “Company”). The Company will be governed by these articles of association (the “Articles”)
and the relevant legislation.
The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of
its shareholders deliberating in the manner provided for amendment of these Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the
company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.
The company is set up for an unlimited period of time.
The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles.
Art. 2. The purpose of the Company is the direct or indirect holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourgish and foreign real estate companies and any other form of real estate investment, the acquisition by pur-
chase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind
and the administration, control and development of its real estate portfolio.
The purpose of the Company is also to invest in real estate property, either by means of purchase, exchange or such
other manners as well as the disposal, the administration, the development and the management of real estate property
throughout Europe and carry out any operation relating directly or indirectly thereto or which it may deem useful in the
accomplishment and development of this purpose.
The Company may further guarantee, borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures or grant
loans in any other form or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general member with unlimited liability or a limited member with limited liability
for all debts and obligations of memberships or similar corporate structures.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly to its purpose.
B. Share Capital - Shares
Art. 3. The subscribed share capital is fixed at one million three hundred thousand and ninety-four thousand Euros
(EUR 1,394,700.-), represented by thirteen thousand nine hundred forty-seven (13,947) shares, with a nominal value of
one hundred Euros (EUR 100.-) per share.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles. The Company may repurchase its own shares with its free reserves under the
provisions set forth in Article 49-2 of the law on commercial companies.
Art. 4. All shares of the Company shall be issued in registered form.
A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the
Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile
as indicated to the Company and the number of shares held by him.
88835
L
U X E M B O U R G
The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such
registered shares.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to
such share(s).
The Company may have one or several shareholders subject however that the Company shall ensure all times that (i)
there will be no more than thirty (30) members in the Company and (ii) none of the members in the Company will be a
physical person and (iii) following any transfer of shares, clauses (i) and (ii) will remain satisfied.
For the avoidance of doubt this provision operates only to give the Company the opportunity to qualify as a special
foreign fund (Spezial-Investmentvermögen) within the meaning of article 16 of the German Investment Tax Act for Ger-
man Tax purposes and each shareholder understands and agrees that it has no action whatsoever for damages whether
in contract or tort (and will not seek to pursue any such action) against the Company's assets in the event that this
provision is breached or amended.
C. Board of directors
Art. 5. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be
shareholders of the Company.
However, if the Company is incorporated by one single shareholder or if it is noted at a shareholders' meeting that
all the shares issued by the Company are held by one single shareholder, the Company may be managed by one single
director in which case all reference herein to the “board of directors” shall be to such sole director and the relevant
legislation shall apply.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders at a simply majority of the votes cast, which shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of
the votes validly cast.
If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.
The general meeting of shareholders may decide to appoint directors of two different classes, being class A directors
and class B directors. Any such classification of directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the directors be identified with respect to the class they belong to.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company's
object; all matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles are within the com-
petence of the board of directors.
In case of one single director, the latter is vested with all the powers of the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, including by way of facsimile or by electronic mail (without electronic
signature), except in case of emergency, in which case the nature of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be waived by the consent of each director in writing, by facsimile, by electronic mail (without electronic
signature) or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings at which all
the directors are present or represented as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
by facsimile, by electronic mail (without electronic signature) or by any means of communication. A director may represent
one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another provided that it must be initiated
and chaired from Luxembourg. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting or the holding of the meeting in person.
88836
L
U X E M B O U R G
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the votes of the directors present or represented at
such meeting. In case of a tie the chairman has no casting vote.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by any two managers of the board.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two directors, each acting individually.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the Company in connection therewith to one or more directors, agents or other officers; they need not be
shareholders of the company.
Art. 7. Towards third parties the company is validly bound in any circumstances by the signature of the sole director
in the case of a sole director and, in the case of a board of directors, by the joint signatures of two directors or by the
individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one Director will be
sufficient to represent the company validly with the public administrations.
Art. 8. The company undertakes to indemnify any director against loss, damages, or expenses incurred by him in
connection with any action or suit to which he may be made a party in his present or past capacity as director of the
company, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action to be liable for gross negligence
or wilful misconduct.
D. Supervision of the company
Art. 9. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The
statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual
general meeting of shareholders. The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with
or without cause.
In the case the thresholds set by law as to the appointment of an independent auditor are met, the accounts of the
Company shall be supervised by an independent auditor (réviseur d'entreprises).
E. General meetings of shareholders
Art. 10. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that
they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and the conduct of the meetings of shareholders of
the Company, unless otherwise provided herein.
Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing
their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication
used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an
effective participation of all such persons in the meeting.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing, by electronic mail (without electronic signature), by facsimile or by any other means of commu-
nication.
Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the shares represented
and vote, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the articles of association, in which case the
resolution will be passed with a majority of the two thirds of the vote validly cast.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
Art. 11. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the last but one business day of the month October at 4 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
F. Financial Year - Profits
Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on 1
st
July of each year and shall terminate on 30
th
June of
the next year.
Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
88837
L
U X E M B O U R G
capital of the Company, as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
3 hereof.
The general meeting of shareholders will determine, on the proposal of the Board of Directors, how the balance of
the yearly net profit will be allocated. Interim dividends may be distributed by the board of directors in compliance with
the terms and conditions provided for by law.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders
or as interim dividends by decision of the board of directors. The general meeting of shareholders may decide to allocate
any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
G. Liquidation of the Company
In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be performed
by liquidators or by the board of directors then in office who will be endowed with the powers provided by articles 144
et seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of
shares in the Company.
H. Applicable law
Art. 14. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Second resolution:i>
The sole shareholder decided to have the articles of incorporation translated into German instead of French whereby
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be binding.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
There being no further business the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present original deed.
Follows the German version:
Im Jahre zweitausendundzehn am achtzehnten März.
Vor der Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxembourg
ERSCHIEN:
Invesco European Hotel Real Estate S.à r.l. eine société à responsabilité limitée, bestehend unter den Gesetzen des
Großherzogtums Luxembourg, mit Geschäftsanschrift 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg und registriert beim
Luxembourg Handelsregister unter Nummer B 119686,
hier representiert durch Frau Simone Schmitz, beruflich ansässig in Luxembourg, bevollmächtigt durch privatrechtliche
Vollmacht, gegeben am 15 März 2010.
Diese Vollmacht, die vom Bevollmächtigten und dem Notar “ne varietur” unterzeichnet wird, wird als Anlage mit
dieser Urkunde verbunden bleiben um beim zuständigen Register registriert zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben benannt, hat die unterzeichnende Notarin gebeten, folgendes zu beur-
kunden:
- dass Invesco European Hotel Real Estate S.à r.l. der alleinige Gesellschafter von Invesco Paris CDG Airport Hotel
Investment S.A., eine société anonyme, mit Gesellschaftssitz in der 25C Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gegründet
durch die Urkunde des Notars Decker, ansässig in Luxembourg-Eich, vom 10. November 2004, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétes et Associations, nº87 am 1. Februar 2005 ist. Die Satzung wurde das letzte Mal abgeändert durch
Urkunde der Notar Hellinckx, mit Amstsitz in Luxembourg, am 26. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétes et Associations nº 943 am 5. Mai 2009;
- dass der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Aktionäre haben beschlossen die Gründungsurkunde der Gesellschaft wir folgt zu ändern:
88838
L
U X E M B O U R G
A. Name – Gesellschaftssitz – Dauer - Zweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den erschienenen Parteien und allen natürlichen und juristischen Personen, die gege-
benenfalls darin Mitglieder werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen "Invesco Paris CDG
Airport Hotel Investments S.à r.l." (die "Gesellschaft") errichtet. Die Gesellschaft wird durch diesen Gesellschaftsvertrag
und durch die entsprechende Gesetzgebung geregelt.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Dieser kann an jeden Ort im Großherzogtum verlegt werden. Dies geschieht durch Beschluss einer außerordentlichen
Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages vorgesehenen
Art und Weise, beraten.
Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Stadtgemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts-und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Solche vorübergehende Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführung vorgenommen und den
beteiligten Parteien mitgeteilt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Besitz von Anteilen in jeglicher Form in luxemburgischen und ausländischen
Firmen und in jeglicher weiteren Form von Beteiligungen, wie den Erwerb durch Kauf, Übereignung oder in anderer Form
sowie die Abtretung durch Verkauf, unter anderem durch Austausch von Sicherheiten jeglicher Art und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung des Portfolios.
Zweck der Gesellschaft ist auch die Beteiligung in Immobilienbesitz entweder durch Erwerb, Austausch oder ähnliches
sowie durch Veräußerung, Verwaltung, und Entwicklung von Immobilienbesitz in Europa sowie jegliche Tätigkeit durch-
zuführen, die mittelbar oder unmittelbar damit im Zusammenhang steht oder welche sinnvoll zur Ausführung und
Entwickling des Gesellschaftszwecks erscheint.
Die Gesellschaft kann bürgen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften, in denen sie Anteile mittelbar oder un-
mittelbar hält oder die am selben Portfolio der Gesellschaft teilhaben, unterstützen.
Die Gesellschaft kann weiter als allgemeiner oder beschränkter Teilhaber mit beschränkter oder voller Haftung für
alle Verpflichtungen aufgrund der Teilhaberschaft oder ähnlichen Gesellschaftsformen agieren.
Die Gesellschaft kann zu ihren und auch zu Gunsten Dritter jegliche Tätigkeiten ausführen, die der Durchführung des
Gesellschaftszwecks dienen oder welche direkt oder indirekt im Bezug zum Gesellschaftszweck stehen.
B. Aktienkapital - Aktien
Art. 3. Das herausgegebene Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf eine Million dreihundertvierundneunzigtau-
sendsiebenhundert Euro (1,394,700) Euro, aufgeteilt auf dreizehntausendneunhundertsiebenundvierzig (13,947) Anteile
mit einem Nennwert von jeweils hundert (100) Euro.
Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Aktionäre, in der für die Veränderung des Gesellschaftsvertrages
vorgesehenen Art und Weise, erhöht oder verringert werden. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen
unter Nutzung der Kapitalreserve wie in den Bestimmungen in Artikel 49-2 des Handelsgeschaftsgesetzes.
Art. 4. Alle Anteile der Gesellschaft sollen registriert werde.
Ein Register der registrierten Anteile soll die Gesellschaft aufbewahren oder eine oder mehrere Personen, die von der
Gesellschaft ernannt wurden. Das Register soll den Namen der jeweiligen Aktionäre enthalten, die Anschrift, welche der
Gesellschaft mitgeteilt wurde und die Anzahl der eigenen Aktien.
Die Eintragung des Aktionärs in das Register der registrierten Aktien beweist das Recht auf den Besitz der eingetra-
genen Aktien.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär per Aktie an. Wenn eine oder mehrere Aktien gemeinsam gehalten
werden oder wenn solche Aktien angefochten werden müssen alle Personen die ein Anrecht an solchen Aktien haben
müssen einen Bevollmächtigten ernennen, der Sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Das Fehlschlagen der Ernennung
eines Bevollmächtigten bedeutet die Aufhebung aller Recht in Verbindung mit solchen Aktien.
Die Gesellschaft stellt sicher, dass zu keinem Zeitpunkt (i) mehr als 30 Gesellschafter vorhanden sind und (ii) keines
dieser Mitglieder eine natürliche Person ist und (iii) im Anschluss an jede Übertragung von Anteilen die Klauseln (i) und
(ii) erfüllt bleiben.
88839
L
U X E M B O U R G
Soweit notwendig wirkt diese Bestimmung nur um der Gesellschaft die Gelegenheit zu geben, sich im Sinne des Artikels
16 des deutschen Investmentsteuergesetzes zu deutschen Steuerzwecken als Spezial-Investmentvermögen zu qualifizie-
ren. Jeder Anteilsinhaber versteht und erklärt sich damit einverstanden, dass er keinen Anspruch auf Ersatz von Schäden
aus dem Gesellschaftsvermögen hat, weder aus Vertrag noch aus Delikthandlungen (und dass er keine solche Handlung
gerichtlich verfolgen wird), wenn gegen diese Bestimmung verstoßen oder diese geändert wird.
C. Geschäftsführung
Art. 5. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch mindestens drei Geschäftsführer die keine Gesellschafter
sein müssen.
Wenn die Gesellschaft jedoch von einem Gesellschafter gegründet wurde oder wenn ein Aktionärbeschluss festlegt,
dass alle Aktien der Gesellschaft von einem Aktionär gehalten werden kann die Gesellschaft von einem Gesellschafter
geregelt werden und somit ist jede Referenz zu dem Verwaltungrat gleich mit dem alleinigen Geschäftsführer und die
entsprechende Gesetzgebung soll Anwendung finden.
Die Geschäftsführer wird von einer Generalversammlung der Aktionäre mit einfach Mehrheit ernannt. Sie legen die
Anzahl, die Entlohnung und deren Amtsdauer fest. Die Amtsdauer soll sechs Jahre nicht überschreiten und die Ge-
schäftsführer sollen erst ihr Amt ablegen wenn ihr Nachfolger ernannt wurde. Die Geschäftsführer können unter
bestehenden Bedingungen wiederernannt werden.
Die Geschäftsführer können mit oder ohne Grund mit einfacher Mehrheit von der Generalversammlung der Aktionäre
abgewählt werden.
Wenn eine Rechtspersönlichkeit zum Geschäftsführer ernannt wird, muss dies Rechtspersönlichkeit eine permanente
Vertretung bestimmen, die die Rolle im Namen und im Auftrag von der Rechtspersönlichkeit übernimmt. Die jeweilige
Rechtspersönlichkeit kann ihre permanente Vertretung nur abwählen wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt.
Im Falle einer freien Stelle auf Grund von Tod, Rente oder ähnliches muss diese freie Stelle vorübergehend, bis zur
nächsten Versammlung der Aktionäre, besetzt werden in Einhaltung der zutreffenden rechtlichen Bestimmungen.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann entscheiden Geschäftsführer verschiedener Kategorien zu ernennen,
zum Beispiel Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung muss
ordnungsgemäß in den Mitschriften festgehalten werden und die Geschäftsführer müssen im Bezug auf ihre Kategorie
identifiziert werden.
Art. 6. Die Geschäftsführung hat das Recht zu jeglichen Handlung die dem Gesellschaftszweck dienen; alle Angelegen-
heiten die nicht ausschließlich der Generalversammlung vorbehalten sind, per Gesetz festgelegt oder in der vorliegenden
Gründungsurkunde, liegen in der Kompetenz der Geschäftsführung.
Im Falle eines Geschäftsführers hat dieser alle Rechte der Geschäftsführung.
Die Geschäftsführung wählt unter sich einen Präsidenten.
Die Geschäftsführung soll auf verlangen des Präsidenten oder von zwei Geschäftsführern sich an einem bekanntgege-
benen Ort versammeln.
Der Präsident soll auf allen Aktionär – sowie Geschäftsführerversammlungen den Vorsitz führen aber in seiner Ab-
wesenheit können die Aktionäre oder die Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer als Präsident vorübergehend
ernennen, durch Abstimmung der Mehrheit der der Versammlung anwesenden.
Jede Geschäftsführerversammlung muss schriftlich, inklusive Telefax und Email (ohne elektronische Unterschrift), min-
destens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung bekanntgegeben werden, außer im Notfall. Der Grund des Notfalls
muss schriftlich genannt werden. Dies kann im Einverständniserklärung eines jeden Geschäftsführers schriftlich, per Te-
lefax, per Email (ohne elektronische Unterschrift) oder mit Hilfe ähnlicher Kommunikationsmittel erlassen werden. Dies
ist nicht notwendig für Versammlungen an denen alle Geschäftsführer teilnehmen oder vertreten sind sowie für indivi-
duelle Versammlungen, die vorher mit Ort und Datum festgelegt und von den Geschäftsführern beschlossen wurden.
Jeder Geschäftsführer kann auf jeder Versammlung, durch schriftliche Ernennung per Telefex, per Email (ohne elekt-
ronische Unterschrift) oder sonstiger Kommunikationsmittel eines anderen Geschäftsführers als seine Vertretung,
handeln. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung
stehenden Kommunikationsmitteln, die es ihm ermöglichen mit anderen zu kommunizieren, teilnehmen, vorausgesetzt,
dass die Sitzung welche mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten wird, von
Luxemburg aus geleitet und initiiert wird.
Die Teilnahme, oder das Abhalten einer solchen Versammlung, entspricht einer persönlichen Teilnahme an den Sitz-
ungen.
Die Geschäftsführer können nur rechtsgültig handeln wenn eine Mehrheit der Geschäftsführer an der Versammlung
teilnimmt oder vertreten ist.
Entscheidungen sollen nur nach Einverständnis der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer ge-
troffen werden. Im Falle von einem Gleichstand zählt nicht die Stimme des Präsidenten.
Die Protokolle aller Vorstandssitzungen werden von zwei beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.
88840
L
U X E M B O U R G
Kopien oder Auszüge solcher Mitschriften die aus juristischen Prozessen stammen sind vom Präsidenten und von dem
Sekretär oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.
Die Geschäftsführung kann ihre Rechte ganz oder teilweise im Bezug auf das laufende Geschäft und im Bezug auf die
Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Geschäftsführer, an Vermittler oder andere Direktoren delegieren;
diese müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein.
Art. 7. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft in jeglicher Hinsicht an die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers
gebunden, wenn es einen alleinigen Geschäftsführer gibt, im Falle einer Geschäftsführung, ist eine gemeinsame Unterschrift
erforderlich. Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn dies von der Geschäftsführung delegiert wurde. Die Unterschrift eines
Geschäftsführers ist ausreichend um die Gesellschaft rechtsgültig bei den öffentlichen Behörden zu vertreten.
Art. 8. Die Gesellschaft ist verpflichtet die Geschäftsführer für Verluste, Schäden oder entstandene Kosten zu ent-
schädigen, die im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten oder einer Klage, in der sie als momentane oder frühere
Geschäftsführer als Partei involviert waren, entstanden sind; davon ausgenommen sind die Angelegenheiten, in denen
abschließend festgestellt wurde, dass sie aufgrund grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes selber haftbar sind.
D. Überprüfung der Gesellschaft
Art. 9. Die Tätigkeiten der Gesellschaft sollen von einem gesetzlichen Wirtschaftsprüfer überwacht werden welcher
kein Aktionär sein soll. Der gesetzliche Wirtschaftsprüfer wird von der Generalversammlung für den Zeitraum bis zur
nächsten Generalversammlung der Aktionäre ernannt. Der amtsausführende Wirtschaftsprüfer kann zu jeder Zeit von
den Aktionären mit oder ohne Grund entlassen werden.
Sollte der vom Gesetz vorgegebene Grenzwert im Bezug auf die Ernennung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfer
zutreffen, muss die Buchführung der Gesellschaft von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise)
überwacht werden.
E. Generalversammlung der Aktionäre
Art. 10. Auf jeder regelmäßig stattfindenden Aktionärsversammlung der Gesellschaft sollen alle Aktionären vertreten
sein. Die Versammlung soll rechtsmäßige Aktionen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft betreffen, anordnen, durchfüh-
ren und ratifizieren können. Wenn alle Aktionäre auf der Aktionärsversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn
sie erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind kann die Ver-
sammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
Die Beschlussfähigkeit und die gesetzlich notwendige Zeit soll die Ankündigung und Führung einer Aktionärsversamm-
lung der Gesellschaft regeln, wenn nicht anders festgelegt.
Aktionäre, die an der Versammlung per Videokonferenz oder mit Hilfe anderer Kommunikationsmittel, die ihre Iden-
tifikation ermöglichen, teilnehmen, sind als anwesend zu sehen und können daher bei der Beschlussfähigkeit berücksichtigt
werden. Die verwendeten Kommunikationsmittel müssen es allen Teilnehmern sich untereinander zu fortdauernd zu
verstehen und eine effektive Teilnahme muss gewärleistet sein.
Jede Aktie entspricht einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Aktionärsversammlung vertreten lassen in dem
er eine andere Person schriftlich, per Email (ohne elektronische Unterschrift), per Telefax oder mit Hilfe anderer Kom-
munikationsmittel zu seiner Vertretung erklärt.
Beschlüssen von ordnungsgemäß versammelten Aktionären können mit einfacher Mehrheit der vertretenen und wäh-
lenden Aktien getroffen werden, es sei denn der Beschluss betrifft die Änderung der Gründungsurkunde, in diesem Fall
muss der Beschluss von einer Mehrheit zwei Dritteln der berechtigten Aktien rechtsgültig getroffen werden.
Die Geschäftsführung muss alle anderen Bestimmungen ermitteln, die von den Aktionären erfüllt sein müssen um an
jeglichen Aktionärsversammlungen teilzunehmen.
Art. 11. Die Jahresgeneralversammlung soll in Luxembourg, im Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen angekün-
digten Ort am vorletzten Arbeitstag des Monats Oktober um 16.00 Uhr abgehalten werden.
Wenn der genannte Tag ein Feiertag ist, soll die Versammlung am darauffolgenden Werktag stattfinden.
Andere Aktionärsversammlungen werden an dem Ort und zu dem angekündigten Zeitpunkt abgehalten.
F. Geschäftsjahr – Gewinn
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni jedes Folgejahres. den Anteilinhabern im Gesell-
schaftssitz zur Verfügung.
Art. 13. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden dem vom Gesetz verlangten Reserve-
fonds zugewiesen. Diese Zuweisung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange der Reservefonds sich auf zehn Prozent
(10%) des Kapitals der Gesellschaft beläuft, wie in Artikel 3 beschrieben oder von Zeit zu Zeit erhöht oder reduziert wie
in Artikel 3 erwähnt.
Die Aktionärsversammlung wird auf Vorschlag der Geschäftsführer hin entscheiden wie der Nettogewinn ausgeschüt-
tet werden soll. Zwischendividenden können von den Geschäftsführern im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen
verteilt werden.
88841
L
U X E M B O U R G
Das Anteilsprämienkonto wird durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre an die Anteilsinhaber ausge-
geben oder als Zwischendividenden auf Beschluss der Geschäftsführung hin. Die Generalversammlung kann beschließen,
jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf das Reservekonto zu überweisen.
G. Liquidation einer Gesellschaft
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren welche Ge-
sellschafter oder nicht sein können. Diese werden mit den Rechten nach Artikel 144 et seq. des Gesetzes vom 10. August
1915 ausgestattet.
Wenn alle Schulden, Kosten und Ausgaben in Zusammenhang mit der Auflösung getilgt sind, kann die resultierende
Bilanz an die Aktionäre gezahlt werden.
H. Anwendbares Gesetz
Art. 14. Für alle nicht in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Angelegenheiten findet das Gesetz vom 10 August
1915 and alle Änderungen hierzu Anwendung.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär hat beschlossen, dass die Satzung in deutsch anstatt französisch übersetzt wird, allerdings ist im
Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und deutschem Text die englische Version maßgeblich.
<i>Kosteni>
Sämtliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf ungefähr
eintausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.
Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxembourg ausgestellt, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten
Tag.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelegt wurde, hat sie das vorliegende Protokoll zusammen mit
dem Notar unterzeichnet.
Signé: S. Schmitz et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 mars 2010. Relation: LAC/2010/12826. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 116 juillet 2010.
Référence de publication: 2010097458/434.
(100108888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.
KBC Equity Fund (L) Conseil Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 113.979.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 mars 2010i>
L'assemblée décide de réélire ERNST & YOUNG en tant que commissaire aux comptes pour un nouveau terme de 3
ans
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC EQUITY FUND (L) CONSEIL HOLDING S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2010094598/14.
(100105209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
88842
L
U X E M B O U R G
Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 73.153.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094554/10.
(100104649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Hutchison Whampoa Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 92.698.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094555/10.
(100104642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Charme Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 88.675.
In the year two thousand and ten, on the twenty-first of June
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED
Frédéric LEMOINE, attorney-in-law, residing in Luxembourg,
acting by virtue of decisions of CHARME MANAGEMENT S.r.l., manager of CHARME INVESTMENTS S.C.A., taken
on June 15, 2010, copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
Who declared and required the notary to record that:
I) The company CHARME INVESTMENTS S.C.A. (the “Company”), having its registered office in L-1449 Luxembourg,
18, rue de l’Eau, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B number 88 675,
was incorporated by deed of Maître Paul Frieders, then notary residing in Luxembourg, dated July 30, 2002, published in
the Mémorial C number 1487 of October 15, 2002. The articles of incorporation have been amended several times and
for the last time by a deed of Maître Paul Frieders, prenamed, on June 24, 2008, published in the Mémorial C, number
2593 of October 23, 2008.
II) According to article 5 of the articles of incorporation (the “Articles”), the issued capital has been fixed at nine
hundred and forty-two thousand two hundred and fifty euro (942,250.00 €) divided into seven hundred and fiftythree
thousand and eight hundred (753,800) Shares comprising:
(1) six hundred and three thousand and forty (603,040) redeemable Shares having a par value of one euro and twenty-
five cent (1.25 €) each (hereafter referred to as the “A Shares”);
(2) seventy-five thousand three hundred and eighty (75,380) ordinary Shares having a par value of one euro and twenty-
five cent (1.25 €) each (hereafter referred to as the “B Shares”);
(3) seventy-five thousand three hundred and eighty (75,380) (representing at all times at least 10% of the share capital
of the Company) Shares having a par value of one euro and twenty-five cent (1.25 €) each, allocated to the Unlimited
Shareholder (hereafter referred to as the “C Shares”).
In addition to the issued capital, issue premiums equal to a total amount of one hundred and forty-five million eight
hundred and seventy-eight thousand nine hundred and forty euro and ninety cent (145,878,940.90 €) have been paid on
the A Shares. The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve (hereafter referred to as
“Free Premium Reserves”), which, upon a resolution of the Unlimited Shareholder, may be distributed to the Shareholders
or used by the Unlimited Shareholder of the Company to redeem the A Shares.
The Company shall have an authorised share capital of one million two hundred and fifty thousand euro (1,250,000 €)
divided into eight hundred thousand (800,000) A Shares having a par value of one euro and twenty-five cent (1.25 €)
each, one hundred thousand (100,000) B Shares having a par value of one euro and twenty-five cent (1.25 €) each and
88843
L
U X E M B O U R G
one hundred thousand (100,000) C Shares having a par value of one euro and twenty-five cent (1.25 €) each, such C
Shares representing at all times at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company.
The Unlimited Shareholder is authorised to issue further A Shares, B Shares and C Shares with or without an issue
premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from
time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such Shares within a period of five (5)
years as from the extraordinary general meeting of shareholders dated as of May 26, 2008.
The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in general meeting from
time to time, in the manner required for amendment of the Articles.
The Unlimited Shareholder is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B
Shares and C Shares from time to time.
When the Unlimited Shareholder effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to
above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Unlimited Shareholder
is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.
III) Pursuant to this authorization, the Unlimited Shareholder has decided on June 15, 2010 to increase the share capital
of the Company, by an amount of eighteen thousand one hundred and sixty-two euro and fifty cent (18,162.50 €) in order
to bring it from its present amount of nine hundred and forty-two thousand two hundred and fifty euro (942,250.00 €)
to nine hundred and sixty thousand four hundred and twelve euro and fifty cent (960,412.50 €) by the creation and the
issue of eleven thousand six hundred and twenty-four (11,624) new A Shares having a par value of one euro and twenty-
five cent (1.25 €) each together with a share premium of two hundred and forty-eight point four three seven five euro
(248.4375 €), one thousand four hundred and fifty-three (1,453) new B Shares having a par value of one euro and twenty-
five cent (1.25 €) each and one thousand four hundred and fifty-three (1,453) new C Shares having a par value of one
euro and twenty-five cent (1.25 €) each;
The Unlimited Shareholder resolved, pursuant to article 5 of the Articles of the Company, to issue these A Shares
and B Shares in Units comprising eight (8) A Shares and one (1) B Share each and these C shares.
The Unlimited Shareholder decided to accept the subscription and the paying up in cash of eight thousand two hundred
and twenty (8,220) new A Shares, one thousand four hundred and two (1,402) new B Shares and one thousand four
hundred and fifty-three (1,453) new C Shares as follows:
Shareholders
Class A
Shares
Class B
Shares
Class C
Shares
Banca Intermobiliare di Investimento e Gestione S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
624
78
Giovanni Cacace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Diego Della Valle Sapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
936
117
FI.SVI. CINQUE S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
396
MAIS S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
624
78
Moncanino S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Luca Cordero di Montezemolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
12
Nextrend S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Orion S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Transmec Holding S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Giovanni Punzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
UniCredit Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,552
194
Columbus VC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Moschini S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,032
254
Charme Management S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,453
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,220
1,402
1,453
The amount of two million and fifty-six thousand euro (2,056,000.00 €) out of which an amount of thirteen thousand
eight hundred and forty-three euro and seventy-five cent (13,843.75 €) is allocated to the corporate capital and an amount
of two million forty-two thousand one hundred and fifty-six euro and twenty-five cent (2,042,156.25 €) is allocated to
the Free Premium Reserves, paid up in cash by the aforementioned subscribers, is now available to the Company, proof
of which has been given to the undersigned notary, who expressly confirms this.
The Unlimited Shareholder decided to accept the subscription and paying-up of three thousand four hundred and four
(3,404) new A Shares and fifty one (51) new B Shares by the contribution in kind effected by FI.SVI. CINQUE S.r.l. of a
liquid, certain and exercisable claim in the total amount of eight hundred and fifty thousand euro (850,000 €) it holds
against the Company.
In satisfaction of articles 26-1 (3) and 32-1 (5) of the law of August 10, 1915 as amended on commercial companies,
the existence and value of the contribution in kind have been confirmed by a report draw up by Mr. Hanspeter KRÄMER,
réviseur d’entreprises, residing at 30 rue Schrobilgen, L2526 Luxembourg, dated June 15, 2010.
88844
L
U X E M B O U R G
The conclusion of said report is the following:
“On the basis of the work performed, as outlined above, we have no observation to make on the total value of the
Contribution In Kind which is at least equal 3,404 A shares and 51 B shares with a nominal value of EUR 1.25 each to be
issued in exchange for the contribution together with a total issue premium of EUR 845,681.25.”
The report will be signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary and shall stay affixed to
these minutes with which it will be registered.
As a consequence of such increase of capital, the six first paragraphs of article 5 of the Articles of the Company will
now read as follows:
Art. 5. Share capital. “The Company has an issued capital of nine hundred and sixty thousand four hundred and twelve
euro and fifty cent (960,412.50 EUR) divided into seven hundred and sixty-eight thousand three hundred and thirty
(768,330) Shares comprising:
(i) six hundred and fourteen thousand six hundred and sixty-four (614,664) redeemable Shares having a par value of
one euro and twenty-five cent (1.25 EUR) each (hereafter referred to as the “A Shares”);
(ii) seventy-six thousand eight hundred and thirty-three (76,833) ordinary Shares having a par value of one euro and
twenty-five cent (1.25 EUR) each (hereafter referred to as the “B Shares”);
(iii) seventy-six thousand eight hundred and thirty-three (76,833) (representing at all times at least 10% of the share
capital of the Company) Shares having a par value of one euro and twenty-five cent (1.25 EUR) each, allocated to the
Unlimited Shareholder (hereafter referred to as the “C Shares”).
The terms “Share” and “Shares” shall, in these Articles, unless otherwise explicitly or implicitly stated, include res-
pectively the A Shares, the B Shares and the C Shares.
In addition to the issued capital issue premiums equal to a total amount of one hundred and forty-eight million seven
hundred and sixty-six thousand seven hundred and seventy-eight euro and forty cent (148,766,778.40 EUR) have been
paid on the A Shares. The total of the issue premiums shall be allocated to an extraordinary reserve (hereafter referred
to as “Free Premium Reserves”), which, upon a resolution of the Unlimited Shareholder, may be distributed to the
Shareholders or used by the Unlimited Shareholder of the Company to redeem the A Shares.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately three thousand one hundred euro (€
3,100.-).
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by surname, given name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version
L'an deux mille dix, le vingt et un juin
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
A COMPARU
Frédéric LEMOINE, avocat, residant à Luxembourg
agissant en vertu de résolutions de CHARME MANAGEMENT S.r.l. agissant en qualité de gérant de CHARME IN-
VESTMENTS S.C.A. prises le 15 juin 2010, copie de ces résolutions, après avoir été signée ne varietur par la comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
I) La société CHARME INVESTMENTS S.C.A. (la «Société»), avec siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 88 675, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 2002, publié au Mémorial
C, numéro 1487 du 15 octobre 2002. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte
reçu par Maître Paul Frieders, prénommé, en date du 24 juin 2008, publié au Mémorial C, numéro 2593 du 23 octobre
2008.
88845
L
U X E M B O U R G
II) Aux termes de l'article 5 des statuts (les «Statuts»), le capital social de la société a été fixé à neuf cent quarante-
deux mille deux cent cinquante euros (942.250,00 €), divisé en sept cent cinquante-trois mille huit cents (753.800) Actions,
comprenant:
(1) six cent trois mille quarante (603.040) Actions rachetables d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents
(1,25 €) chacune (ci-après les “Actions A”);
(2) soixante-quinze mille trois cent quatre-vingts (75.380) Actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro et vingt-
cinq cents (1,25€) chacune (ci-après les “Actions B”);
(3) soixante-quinze mille trois cent quatre-vingts (75.380) (représentant à tout moment au moins dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société) Actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 €) chacune, attribuées à
l’Actionnaire Commandité (ci-après les “Actions C”).
En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de cent quarante-cinq millions huit cent soixante-
dix-huit mille neuf cent quarante euros et quatre-vingt-dix cents (145.878.940,90 €) ont été payées sur les Actions A. Le
total des primes d’émission sera alloué à une réserve extraordinaire (ci-après la «Réserve Libre de Prime»), qui, par
décision de l’Actionnaire Commandité, pourra être distribuée aux Actionnaires ou utilisée par l’Actionnaire Commandité
de la Société pour racheter les Actions A.
La Société aura un capital autorisé d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- €) divisé en huit cent mille
(800.000) Actions A ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 €) chacune, cent mille (100.000) Actions
B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 €) chacune et cent mille (100.000) Actions C ayant une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 €) chacune, ces dernières représentant à tout moment au moins dix
pour cent (10%) du capital de la Société.
L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre des Actions A, B et C supplémentaires avec ou sans prime d’émission
afin de porter le capital total de la Société jusqu’au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion
et à accepter la souscription de telles Actions au cours d’une période de cinq (5) années à partir de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 26 mai 2008.
La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des Actionnaires en
assemblée générale statuant comme en matière de modification des Statuts.
L’Actionnaire Commandité est autorisé à déterminer périodiquement les conditions de souscription des Actions A,
B et C.
A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par l’Actionnaire Commandité conformément
aux dispositions ci-dessus, celui-ci prendra les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin de constater cette
modification et l’Actionnaire Commandité est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exé-
cution et la publication d’une telle modification conformément à la loi.
III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les Statuts, l'Actionnaire Commandité a décidé le 15 juin 2010 de
procéder à une augmentation de capital à concurrence d’un montant de dix-huit mille cent soixante-deux euros et cin-
quante cents (18.162,50 €) pour le porter de son montant actuel de neuf cent quarante-deux mille deux cent cinquante
euros (942.250,00 €) à neuf cent soixante mille quatre cent douze euros et cinquante cents (960.412,50 €) par la création
et l'émission de onze mille six cent vingt-quatre (11.624) nouvelles Actions A chacune avec une prime d’émission de deux
cent quarante-huit virgule quatre trois sept cinq euros (248,4375 €), mille quatre cent cinquante-trois (1.453) nouvelles
Actions B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 €) chacune et mille quatre cent cinquante-trois
(1.453) nouvelles Actions C ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 €) chacune.
L'Actionnaire Commandité a décidé d’émettre ces Actions A et Actions B en Unités comprenant huit (8) Actions A
et une (1) Action B chacune et ces Actions C conformément à l’article 5 des statuts de la Société.
L'Actionnaire Commandité a décidé d'accepter la souscription et la libération par paiement en numéraire de huit mille
deux cent vingt (8.220) nouvelles Actions A, mille quatre cent deux (1.402) nouvelles Actions B et mille quatre cent
cinquante-trois (1.453) nouvelles Actions C comme suit:
Actionnaires
Actions
A
Actions
B
Actions
C
Banca Intermobiliare di Investimento e Gestione S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
624
78
Giovanni Cacace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Diego Della Valle Sapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
936
117
FI.SVI. CINQUE S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
396
MAIS S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
624
78
Moncanino S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Luca Cordero di Montezemolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
12
Nextrend S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Orion S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Transmec Holding S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Giovanni Punzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
88846
L
U X E M B O U R G
UniCredit Bank AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.552
194
Columbus VC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
39
Moschini S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.032
254
Charme Management S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.453
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.220
1.402
1.453
Le montant de deux millions cinquante-six mille euros (2.056.000,00 €), duquel un montant de treize mille huit cent
quarante-trois euros et soixante-quinze cents (13.843,75 €) est attribué au capital social et un montant de deux millions
quarante-deux mille cent cinquante-six euros et vingt-cinq cents (2.042.156,25 €) est attribué à la Réserve Libre de Prime,
est dès maintenant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été fournie au notaire soussigné, lequel le constate
expressément.
L’Actionnaire Commandité a décidé d’accepter la souscription et la libération de trois mille quatre cent quatre (3.404)
nouvelles Actions A et cinquante et une (51) nouvelles Actions B par un apport en nature effectué par FI.SVI. CINQUE
S.r.l. d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant total de huit cent cinquante mille euros (850.000,00 €) qu’il
détient envers la Société.
Conformément aux articles 26-1 (3) et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée, l’existence et la valeur de l’apport en nature ont été confirmés par un rapport daté du 15 juin 2010 établi par
M. Hanspeter KRÄMER, réviseur d’entreprises, demeurant au 30 rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.
La conclusion dudit rapport est la suivante:
«Sur base du travail réalisé, comme souligné ci-dessus, nous n’avons aucune observation à faire sur la valeur totale de
l’Apport en Nature qui est au moins égal à 3.404 actions A et 51 actions B d’une valeur nominale d’1,25 EUR chacune
devant être émises en échange de l’apport ensemble avec une prime d’émission totale de 845.681,25 EUR.»
Le rapport sera signé «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentaire et restera annexé au présent procès-
verbal pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
A la suite de cette augmentation de capital, les six premiers alinéas de l'article 5 des Statuts de la Société auront
désormais la teneur suivante:
Art. 5. Capital social. «La société a un capital émis de neuf cent soixante mille quatre cent douze euros et cinquante
cents (960.412,50 EUR) divisé en sept cent soixante-huit mille trois cent trente (768.330) actions, comprenant:
(i) six cent quatorze mille six cent soixante-quatre (614.664) Actions rachetables d’une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune (ci-après les “Actions A”);
(ii) soixante-seize mille huit cent trente-trois (76.833) Actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro et vingt-
cinq cents (1,25 EUR) chacune (ciaprès les “Actions B”);
(iii) soixante-seize mille huit cent trente-trois (76.833) (représentant à tout moment au moins dix pour cent (10%) du
capital émis de la Société) Actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, attribuées à
l’Actionnaire Commandité (ci-après les “Actions C”).
Les termes “Action” et “Actions” dans les présents Statuts englobent, sauf disposition implicite ou explicite contraire,
les Actions A, les Actions B et les Actions C.
En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de cent quarante-huit millions sept cent soixante-
soixante-six mille sept cent soixante-dix-huit euros et quarante cents (148.766.778,40 EUR) ont été payées sur les Actions
A. Le total des primes d’émission sera alloué à une réserve extraordinaire (ci-après la «Réserve Libre de Prime»), qui,
par décision de l’Actionnaire Commandité, pourra être distribuée aux Actionnaires ou utilisée par l’Actionnaire Com-
mandité de la Société pour racheter les Actions A.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l'augmentation
de capital qui précède, sont estimés à environ trois mille cent euros (€ 3.100,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande de la même comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Lemoine, Kesseler.
88847
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2010. Relation: EAC/2010/7490. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010097270/266.
(100109306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2010.
Hutchison Whampoa 3G Content S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 78.207.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094556/10.
(100104656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Hutchison Whampoa 3G IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 82.517.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094557/10.
(100104659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Hutchison 3G Austria Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 77.375.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010094558/10.
(100104654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Kohler Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.383.
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est
tenue en date du 28 Juin 2010, que les administrateurs suivants sont réélus pour une période se terminant à l'Assemblée
Générale Annuelle que se tiendra en 2016:
- M. Jean-Jacques Josset;
- M. Christophe Petit;
- M. Olivier Montfort;
- M. Daan den Boer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kohler Investment S.A.
Daan den Boer
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010094603/18.
(100104971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
88848
Alymere Investments S.à r.l.
Anthill S.A.
BMG RM Investments Luxembourg S.àr.l.
Cameco Luxembourg S.A.
Cattleya Investments
CD Participations S.àr.l.
CD Participations S.àr.l.
CD Private Equity Sicar S.à r.l.
CELSIUS EUROPEAN Lux 2 S.à r.l.
Charme Investments S.C.A.
Climalux S.A.
Computer Associates Luxembourg S.à r.l.
CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.
De Longhi Household S.A.
Ert Holding S.A.
European Logistics Feeder S.C.A.
Fides Capital Partners S.A.
Fides Capital Partners S.A.
Fiduciaire GLACIS S.àr.l.
Finalam S.A.
Fininfra
France Properties Invest S.A.
Freo Investment Management S.à r.l.
Fruit Invest S.A.
Fund Partners
GE Intelligent Platforms Europe S.A.
Gerim, s.à r.l.
Girst & Schneider S.àr.l.
Glasgore Sàrl
Glasgore Sàrl
Glasgore Sàrl
Global Care Solutions (GCS) S.A.
Global Care Solutions (GCS) S.A.
Global Partners
Greenmix S.A.
Green Way Arbitrage
Grenache
H&F Wings Lux 2 S.à r.l.
HICL Infrastructure 1 S.à r.l.
Hutchison 3G Austria Investments S.à r.l.
Hutchison Telecommunications International Finance S.à r.l.
Hutchison Telecommunications (Luxembourg) S.à r.l.
Hutchison Telecommunications (Vietnam) S.à r.l.
Hutchison Whampoa 3G Content S.à.r.l.
Hutchison Whampoa 3G IP S.à r.l.
Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.
Hutchison Whampoa Finance S.à r.l.
INVESCO Paris CDG Airport Hotel Investments S.A.
KBC Equity Fund (L) Conseil Holding S.A.
KBC Flexible
Kohler Investment S.A.
Nemus International
Repco 35 S.A.
Repco 36 S.A.
Repco 37 S.A.
Repco 38 S.A.
Repco 43 S.A.
Repco 45 S.A.
Société de Participations FILUNOR
The Private Equity Company SA
Thiel AS Logistics A.G.
Tower 3 S.à r.l.