logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1843

8 septembre 2010

SOMMAIRE

Alce Investment I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

88464

Azur France II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88464

BANA Swiss Funding S.à r.l. Limited . . . . .

88456

Barclays Capital Equity Luxembourg SI-

CAV SIF S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88462

C4U2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88463

Dandy Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

D.C.I. - D.C. International S.A.  . . . . . . . . . .

88422

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A.  . . . .

88420

QureInvest II Investments (SCA) SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88429

Regiconsult  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88454

Repco 15 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88422

Repco 18 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88422

Repco 19 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88422

Repco 22 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88456

Repco 23 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Repco 25 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Repco 26 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Repco 27 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88419

Repco 27 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Repco 28 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Repco 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88454

Repco 31 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Repco 32 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88428

Repco 33 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88428

Repco 34 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88428

Repco 35 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88429

Repco 36 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88429

Repco 37 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88454

Repco 38 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88456

Repco 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Repco 43 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88457

Repco 45 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88457

Repco 9 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88460

Reynolds Consumer Products (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88418

Rock Ridge RE 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88418

Rock Ridge RE 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88418

Rock Ridge RE 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88419

Rock Ridge RE 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88419

Rock Ridge RE 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88419

Rock Ridge RE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

Rock Ridge RE 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88420

Rooftop S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88460

Ross Troine Autocars S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

88418

Sailux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88429

SAJ S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88427

Sales-Lentz Participations  . . . . . . . . . . . . . .

88460

Sensient Holding Luxembourg S. à r.l.  . . .

88461

Sensient Technologies Luxembourg Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88461

Sival International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88461

S.L.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88418

Snack Ankara II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

88461

SOAK Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88454

Solideal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88457

Sopra SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88454

Strategy Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88462

Sword Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

88426

Symantec Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

88428

Taste of Africa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88463

Taste of Africa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88463

Taste of Africa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88463

Taste of Africa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88462

Tournan Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88461

Wilko Lux Enseignes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

88464

88417

L

U X E M B O U R G

Reynolds Consumer Products (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 148.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2010093786/12.
(100103594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rock Ridge RE 10, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 126.091.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093787/11.
(100104178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Ross Troine Autocars S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9772 Troine, 58, rue de Hoffelt.

R.C.S. Luxembourg B 95.215.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093830/9.
(100104062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rock Ridge RE 13, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.243.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093788/11.
(100104170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

S.L.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 49.878.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093831/9.
(100104049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88418

L

U X E M B O U R G

Rock Ridge RE 14, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.244.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093789/11.
(100104173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rock Ridge RE 17, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.247.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093790/11.
(100104175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 27 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 907.940,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.328.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 18 juin 2010 approvant les

<i>comptes de l'exercise clos le 31 décembre 2009

Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur

A;

2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, administrateur

A;

3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-

nistrateur A;

4. Monsieur Paul SHIELS, demeurant actuellement à 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne,

administrateur B;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos

en décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093814/22.
(100103946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rock Ridge RE 17, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.247.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093791/11.
(100104185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88419

L

U X E M B O U R G

Rock Ridge RE 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 121.754.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093792/11.
(100104184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rock Ridge RE 6, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.532.

Die Bilanz vom 31 Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Julien GOFFIN
<i>Authorised Signatory

Référence de publication: 2010093793/11.
(100104188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Dandy Consult S.A., Société Anonyme,

(anc. Hostellerie de la Bonne Auberge S.A.).

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 55.957.

L'an deux mil dix, le quinze juin.
Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme HOSTELLERIE DE LA BONNE AUBERGE,

ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en
date du 26 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 566 du 5 novembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février 2007, publié au Mémorial C
numéro 862 du 11 mai 2007 et inscrite au RCSL sous le numéro B 55.957.-

L'assemblée est présidée par Madame Christine CHARPENTIER, employée privée, demeurant à B-Arlon, qui désigne

comme secrétaire Madame Christine NOËL, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico SIMON, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les CENT (100) actions représentant l'intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Adaptation de divers articles des statuts, suite à la loi du 25 août 2006.
2.- Changement de dénomination et modification afférente du premier paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts.

3.- Transfert du siège social et modification afférente du deuxième paragraphe de l'article 1 

er

 des statuts.

4.- Modification de l'objet social et modification de l'article 2 des statuts.
5.- Révocation de l'entièreté du conseil d'adminsitration.
6.- Nomination d'un administrateur unique.
L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution.

En conformité de la loi du 25 août 2006, l'assemblée décide d'adapter les statuts comme suit:

88420

L

U X E M B O U R G

 Art. 1 

er

 .  il est inséré après le premier paragraphe, le paragraphe suivant:

"La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires".
- à la fin du dernier paragraphe sont ajoutés les mots suivants "ou de l'associé unique".

Art. 4. il est supprimé et remplacé par le suivant:
"Tant que la société ne compte qu'un associé unique, elle peut être administrée par un administrateur unique, qui n'a

pas besoin d'être l'associé unique de la société.

Si la société compte plus qu'un actionnaire, elle sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois

membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera considérée automatiquement comme une référence

à l'administrateur unique tant que la société ne compte qu'un seul associé.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent qui la repré-

sentera, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée."

Art. 5.
- au septième paragraphe, les mots "est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires

et" sont supprimés.

- le huitième paragraphe est supprimé et remplacé par le suivant:
"La société se trouve engagée valablement soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la

signature conjointe de deux administrateurs, soit encore par l'administrateur unique."

Art. 11. Il est ajouté un troisième paragraphe comme suit:
"Pour le cas où il n'existe qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues,

tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée."

<i>Deuxième résolution.

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société. En conséquence le premier paragraphe du premier article

des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

"Il existe une société anonyme sous la dénomination de "DANDY CONSULT S.A.".

<i>Troisième résolution.

L'assemblée décide de transférer le siège social de Diekirch à L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce. En consé-

quence, la deuxième phrase du premier article des statuts est supprimée et remplacée par la suivante:

"Le siège social est établi à Dudelange."

<i>Quatrième résolution.

L'assemblée décide de modifier l'objet social. En conséquence l'article deux des statuts est supprimé et remplacé par

le suivant:

"La société a pour objet le conseil, le secrétariat, l'accompagnement, le service envers les tiers dans le but de leur

permettre l'aboutissement de projets dans n'importe quel domaine.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, com-

merciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui
sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant
les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de. toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits
s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favo-
risent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

<i>Cinquième résolution.

L'assemblée décide de révoquer l'entièreté du conseil d'administration et de lui donner décharge pour sa mission

jusqu'à ce jour.

88421

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution.

L'assemblée décide de nommer Madame Christine CHARPENTIER, préqualifiée, comme administrateur unique, avec

tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ MILLE DEUX CENTS (1.200.-)

EUROS.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meure, ils ont signé les présentes avec le notaire,

Signé: CHARPENTIER - NOËL - SIMON - THOLL.

Enregistré à Mersch, le 17 juin 2010. Relation: MER/2010/1071. Reçu soixante-quinze euros 75.- €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): E. WEBER.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.

Mersch, le 30 juin 2010.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2010096979/103.
(100108228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

Repco 15 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 112.944.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093801/10.
(100103938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 18 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 112.979.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093802/10.
(100103875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 19 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 112.980.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093803/10.
(100103879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

D.C.I. - D.C. International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 32.190.

L'an deux mille dix, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

88422

L

U X E M B O U R G

s'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  «D.C.I.  –  D.C.  INTERNATIONAL

S.A.» (la «Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 180 rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 32 190,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 22 novembre 1989, publié au Mémorial C (le «Mémorial»), numéro 135
du 25 avril 1990.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale ordinaire de la

Société, tenue en date du 12 juillet 2000, lequel acte fut publié au Mémorial, le 06 février 2001, sous le numéro 86 et
page 4091.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Urbain DE DECKER, gérant de sociétés, demeurant à

B-Londerzeel.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Didier DE DECKER, gérant de sociétés, demeurant à B-Londerzeel.
L'assemblée élit aux fonctions de scrutatrice Madame Audrey DUMONT, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la Présidente déclare et demande au notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Transformation de la société, actuellement régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, en société de

gestion de patrimoine familial («SPF») conformément aux dispositions légales de la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

2) Modification de la première phrase de l'article 1 des statuts de la société comme suit: «Il existe une société de

gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «D.C.I. – D.C. INTERNA-
TIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial».»

3) Modification de la dernière phrase de l'article 1 des statuts de la société comme suit: «La durée de la société est

illimitée.»

4) Modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet de la société qui se lira dorénavant comme suit:

« Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tells

que les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et
avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra
détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra
toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son
objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création
d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

5) Suppression du dernier paragraphe de l'article 3 des statuts, relatif aux parts de fondateurs.
6) Ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 3 des statuts: «La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.»
7) Suppression de l'article 3.1. des statuts.
8) Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.»

9) Modification de l'article 5 des statuts qui se lira dorénavant comme suit:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

88423

L

U X E M B O U R G

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»

10) Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.»

11) Divers.
II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur la totalité des actions représentant l'entièreté du capital social émis

toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut de la Société qui n'aura plus désormais celui d'une

société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini
par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la première phrase de l'article 1 

er

 des statuts de la société

comme suit:

Art. 1 

er

 . (première phrase).  «Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société

anonyme sous la dénomination de «D.C.I. – D.C. INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial».»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société, relatif à son objet social,

comme suit:

Art. 2. «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale. La société pourra détenir
une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Elle prendra toutes
mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet
ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

88424

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société, relatif

aux parts de fondateurs.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 3 des statuts de la Société qui sera

conçu comme suit:

Art. 3. (nouvel alinéa). «La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer l'article 3.1. des statuts de la Société.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 4. «La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui se lira dorénavant comme

suit:

Art. 5. «Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

88425

L

U X E M B O U R G

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 11. «La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leur

nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Urbain DE DECKER, Didier DE DECKER, Audrey DUMONT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 juillet 2010. Relation: EAC/2010/8349. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010096024/189.
(100107983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

Repco 23 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.186.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093808/10.
(100103897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 25 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.188.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093811/10.
(100103967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 26 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.327.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093813/10.
(100103960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Sword Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.238.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

88426

L

U X E M B O U R G

Hesperange, le 12 juillet 2010.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2010093836/13.
(100103640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 27 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.328.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093815/10.
(100103950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 28 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.329.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093816/10.
(100104408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 110.471.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093817/10.
(100104363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 31 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.175.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093818/10.
(100104361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

SAJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 8, rue Siggy vu Letzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 107.124.

Le bilan de la société au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

88427

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Le Président de l'Assemblée

Référence de publication: 2010093839/13.
(100104375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 32 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.423.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093819/10.
(100104356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 33 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.174.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093820/10.
(100104330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 34 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.176.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093821/10.
(100104318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Symantec Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.750,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 121.095.

Il est à noter la nouvelle adresse du Gérant A, Kristen Laubscher comme suit:
- Kristen Laubscher, 1957 James Place, San José, CA 95125, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2010093837/14.
(100103993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88428

L

U X E M B O U R G

Sailux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 44.793.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à Luxembourg en date du 1 

er

 juin 2010 a nommé com-

missaire aux comptes pour un terme de 1 an:

<i>Commissaire aux comptes:

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7 Parc d'Activité Syrdall L-5365 Munsbach
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2010.

Cette décision est conforme à la décision prise lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Signature / Signature
<i>Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2010093838/17.
(100103632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 35 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 126.422.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093822/10.
(100104322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 36 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.235.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093823/10.
(100104325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

QureInvest II Investments (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 154.489.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the sixteenth day of the month of July.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) QureInvest, a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg with its registered office

at 231 Val des Bons-Malades, L2121 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg trade and companies
register, as managing general partner of QureInvest II Investments (SCA) SICAR;

here represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney dated 15 July 2010; and

2) QureInvest II (SCS) SICAR,a société en commandite simple (S.C.S.), organized as a société d'investissement en

capital à risque, incorporated under the laws of Luxembourg with its registered office at 231 Val des Bons-Malades, L-2121

88429

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg trade and companies register; represented by its ma-
naging general partner QureInvest, as limited partner;

here represented by Christoph Diesel, Rechtsanwalt with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney dated 15 July 2010. .

The proxies signed “ne varietur” by all the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation (the “Articles”) of a Company limited by shares (société en commandite par actions), which they form
between themselves:

Preamble - Definitions

The following definitions are part of the Articles.
“Articles” shall mean the articles of association of the Company pursuant to this deed.
“Assets” have the meaning ascribed to them in § 22 subsection (2).
“Associate” shall mean in relation to any individual or undertaking (“U”), a parent undertaking of U, a subsidiary

undertaking of U, a subsidiary undertaking of a parent undertaking of U, any undertaking directly or indirectly controlled
by U, or any undertaking which directly or indirectly controls U. Members of HS Life Sciences shall be considered to be
Associates of each other.

“Business Day” shall mean any day when banks in Luxembourg are open to the public.
“Capital Call” shall mean the written notification from the General Partner to the Shareholders to subscribe Shares

pursuant to their Capital Commitments upon not less than 10 Business Days advance notice.

“Capital Commitments” shall mean the maximum amount (denominated in Euro) contributed or agreed to be con-

tributed  to  the  Company  by  a  Shareholder  by  way  of  subscription  for  Limited  Partner  Shares  pursuant  to  such
Shareholder's Subscription Certificate.

“Cause” shall mean (i) the breach of the Prospectus or these Articles or any side letter by HS Life Sciences to the

detriment of the Company and/or the addressee of the side letter through gross negligence, willful misconduct, fraud,
bad faith or reckless disregard (ii) the insolvency, administration, involuntary reorganization and bankruptcy of the General
Partner (iii) or the failure by the General Partner to recommend a proposal on the future management of the Company
in case of departure of a Key Person.

“Classes” shall mean the different classes of Shares as might be issued by the Company.
“Commercial Companies Law” shall mean the law of the Grand Duchy of Luxembourg as of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended from time to time.

“CSSF“ shall mean the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg financial supervisory au-

thority.

“Company” shall mean QureInvest II Investments (SCA) SICAR, an investment company in risk capital formed as a

corporate partnership limited by shares in Luxembourg.

“Custodian” has the meaning ascribed to it in § 25.
“Final Closing” shall mean the end of the subscription period, being the earlier of (i) the first anniversary of the First

Closing and (ii) the date specified by the General Partner as the Final Closing.

“First Closing” shall mean the date when Capital Commitments in the aggregate amount of at least Euro 46.1 million

have been bindingly subscribed by investors to Fund SCS.

“Fund SCS” shall mean QureInvest II (SCS) SICAR and the parallel pools as defined in the Prospectus.
“General Partner” shall mean the managing general partner of the Company from time to time.
“HS Life Sciences” shall mean the General Partner, HS Life Sciences AG (Zurich), HS Life Sciences GmbH (Düsseldorf),

the Associates of the General Partner, HS Life Sciences AG (Zurich) and/or HS Life Sciences GmbH (Düsseldorf), any of
their respective members and employees as well as the Key Persons.

“Investment Period” shall mean the period commencing on the First Closing and terminating on the earlier of (i) the

fifth anniversary of the First Closing, or (ii) the date on which the General Partner decides to early terminate the Invest-
ment Period because (x) 75 % of the total Capital Commitments have been drawn down and legally bindingly committed
in writing or reserved for investments (including follow-on investments) in Portfolio Companies; provided that for pur-
poses  of  determining  the  date  of  expiration  of  the  Investment  Period  the  reservation  of  Capital  Commitments  for
investments (including follow-on investments) in excess of 10 % of the total Capital Commitments shall require the
approval of the Shareholders, or (y) changes in applicable law or regulations or business conditions make an early ter-
mination necessary or advisable in the reasonable discretion of the General Partner, or (iii) the date on which a proposal
for future management of the Company in case of departure of a Key Person is not approved with the required majority
(i.e. two thirds of the total Capital Commitments), and the Company shall be automatically dissolved unless the Share-
holders decide to continue the Company or (iv) the date on which Shareholders representing at least 80 % of the total

88430

L

U X E M B O U R G

Capital Commitments resolve on an early termination, or (v) HS Life Sciences receives profit priority shares for the
management or a similar compensation as consideration for managing or advising a Successor Fund.

“Key Persons” shall mean Karsten Henco, Edward Stuart and Justin Duckworth and their respective successors and

additional persons appointed with the approval of the Shareholders.

“Liabilities” have the meaning ascribed to them in § 22 subsection (3).
“Limited Partner Shares” shall mean any Shares in the Share Capital.
“Net Asset Value” shall mean the value of the Assets less the value of the Liabilities as defined in § 22 subsection (1).
“Non HS Life Sciences Shareholders” shall mean any Shareholder not being Fund SCS.
“Partners” shall mean the General Partner and the Shareholders.
“Portfolio Companies” shall mean companies the Company holds an equity or equity related investment in.
“Profits” shall mean the Company's balance sheet profits within the meaning of the Luxembourg law of December 19,

2002; the General Partner shall have the right to withdraw amounts from the capital reserves to increase the Company's
balance sheets profits according to the Commercial Companies Law if and to the extent necessary to make the allocations
pursuant to the Articles.

“Prohibited Person” shall mean any person as defined in § 15.
“Prospectus” shall mean the separate offering document as issued by the Company and approved by the CSSF.
“Purchase Notice” shall mean the notice to the Shareholders of purchase of their Shares according to § 15 subsection

(2) lit. d) no. (i).

“Purchase Price” shall mean the purchase price for Shares of a Shareholder according to § 15 subsection (2) lit. d) no.

(ii).

“Register” shall mean the register of Shares pursuant to § 6 subsection (4).
“Registrar and Transfer Agent” has the meaning ascribed to it in § 6 subsection (4).
“Shareholder” shall mean any owner of Limited Partner Shares.
“Shares” shall mean the fully paid-up shares of no par value representing the Share Capital, i.e. the Limited Partner

Shares.

“Share Capital” shall mean the capital of the Company pursuant to § 6 subsection (2).
“SICAR Law” shall mean the law of the Grand Duchy of Luxembourg as of June 15, 2004 on the investment company

in risk capital, as amended from time to time.

“Subscription Certificate” shall have the meaning ascribed to it in § 6 subsection (3).
“Successor Fund” shall mean a new private equity fund or other investment vehicle having an investment strategy

substantially similar with the Company and which is managed or advised by HS Life Sciences.

“Valuation Day” shall mean the day of calculation of the Net Asset Value per Share as defined in § 22 subsection (5).
“Well-Informed Investor” shall mean a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law. A

Well-Informed Investor shall be any:

(i) institutional investor, or
(ii) professional investor,
(iii) or any other investor who meets the following conditions:
(a) it has confirmed in writing that it adheres to the status of Well-Informed Investor; and
(b) either (i) invests a minimum of EUR 125,000 in the Company; or
(ii) he/she/it has obtained an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, an

investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC, or a management company within the meaning of Directive
2001/107/EC, certifying its expertise, its experience and its knowledge in adequately appraising an investment in risk
capital.

Art. 1. Formation of the Company.

§1. Formation, Commencement.
(1) Formation
There exists among the General Partner and the subscribers of the Limited Partner Shares and all those who may

become Partners in the future, an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque, SICAR),
organized in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions, SCA) (the “Com-
pany”), governed by the present Articles, the Commercial Companies Law and the SICAR Law.

(2) Commencement
The Company shall commence upon its incorporation.

§2. Name.
(1) The Company shall have the name:

88431

L

U X E M B O U R G

QureInvest II Investments (SCA) SICAR
(2) All documents drafted by the Company and destined to third parties, such as letters, invoices or publications, must

bear the registered name of the Company followed by “société en commandite par actions” or “SCA” qualifying as a
“société d'investissement en capital à risque” or “SICAR”, the address of the registered office of the Company and the
initials “RCS Luxembourg”, followed by the number under which the Company is registered with the Luxembourg trade
and companies register.

§3. Purpose of the Company. The Company's purpose is to invest its assets in securities and other assets representing

risk capital within the widest possible meaning as permitted under Article 1 of the SICAR Law in order to provide its
Partners with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk they incur in this respect.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Prospectus.
The Company may also carry out whatever transactions are deemed necessary in order to develop, administer manage

and control these participating interests. Subject to the provisions of the Prospectus, the Company may fund itself by
borrowing funds from affiliate companies and/or unrelated third party lenders and capital markets parties, entering into
loan and finance agreements, issuing bonds, notes or other debt or equity instruments (convertible or not) both in public
and private placements, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies.

In particular, the Company may use its funds whether borrowed or not for the creation, development and control of

any enterprise and the grant to companies in which the Company has a direct or indirect participating interest, and/or
to any affiliates of the group the Company is a member of and/or any parent company of the Company, of any financial
assistance, support, loans, advances, security or guarantees.

Further, the Company may take any measures and carry out any operation or transaction, which it may deem useful

in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the SICAR Law.

§4. Limitation of Purpose. The purpose of the Company shall be subject to the limitations set out in the Prospectus.

§5. Fiscal Year, Registered Office, Currency.
(1) Fiscal Year
The fiscal year of the Company shall be the calendar year. The first fiscal year of the Company shall commence on the

date on which the Company commenced pursuant to § 1 subsection (2) and shall terminate on December 31 of the
respective year.

(2) Registered Office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the General

Partner.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by

means of a resolution of a general meeting of Partners, but cannot be transferred abroad, except as otherwise provided
hereunder.

The  Company  may  have  offices,  branches  (whether  or  not  a  permanent  establishment)  and  subsidiaries  either  in

Luxembourg or abroad.

(3) Currency
The currency of the Company shall be the Euro.

Art. 2. Company and Company Assets.

§6. Partners, Capital.
(1) Partners
The Company exists between one or more general partner(s,) one of which shall be the managing general partner

(associé gérant commandité) of the Company, and the owners of the Limited Partner Shares, which shall be the limited
partners (actionnaires commanditaires) of the Company (the “Shareholders”). The Limited Partner Shares are exclusively
restricted to persons qualifying as a well-informed investor within the meaning of Article 2 of the SICAR Law, (a “Well-
Informed Investor”).

(2) Share Capital
The share capital of the Company (the “Share Capital”) shall be represented by fully paid-up shares of no par value

(the “Shares”) and shall at any time be equal the total net assets of the Company pursuant to § 22 hereof.

The minimum capital of the Company including share premium, if any, shall be EUR 1 million and must be achieved

within twelve months after the date on which the Company has been authorized as société d'investissement en capital à
risque by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), as required by the SICAR Law.

The share capital of the Company shall be represented by Limited Partner Shares only and which have been or will be

subscribed by Shareholders.

The Company has been incorporated with a subscribed share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided

into thirty-one (31) Limited Partner Shares of no par value. Upon incorporation, the Shares were fully paid-up.

88432

L

U X E M B O U R G

(3) Capital Commitments
The General Partner shall not have a capital commitment; the Shareholders shall be committed to subscribing Limited

Partner Shares as set out in the Prospectus.

Investors wishing to subscribe for Limited Partner Shares shall execute a subscription certificate (the “Subscription

Certificate”), which upon acceptance will be signed by the General Partner. Investors thus commit themselves to sub-
scribing and accepting Limited Partner Shares in accordance with the Articles as well as the terms and conditions set
forth  in  the  Prospectus.  The  subscription  of  a  Shareholder  shall  become  effective  in  relation  to  the  Company  upon
acceptance of the Subscription Certificate by the General Partner and the admission to the Company shall become
effective upon the issuance of Limited Partner Shares of the Company to the Shareholder.

The capital commitments of the Shareholders to the Company are hereinafter collectively referred to as “Capital

Commitments”. Capital Commitments shall be called by the General Partner (a “Capital Call”) in accordance with the
provisions in the Prospectus. Upon payment on the Capital Call the General Partner shall issue the equivalent Limited
Partner Shares to the Shareholders.

Capital Commitments can be called only during the Investment Period. After the expiration of the Investment Period,

Capital Commitments can be called only for the following purposes:

(i) to fund investments of the Company which were, as per the expiration of the Investment Period, committed or in

process according to a letter of intent already submitted prior to the expiration of the Investment Period, if such invest-
ments in process are consummated within 6 months of the expiration of the Investment Period.

(ii) to fund follow-on investments in Portfolio Companies of the Company in which the Company holds an investment

upon expiration of the Investment Period.

(iii) to fund the General Partner priority allocation out of Profits as described in the Prospectus;
(iv) to fund the fees, expenses, obligations and liabilities to be borne by the Company pursuant to the Prospectus.
The General Partner shall, subject to the approval of the Partners, have the right to finally fix the aggregate maximum

amount pursuant to (i) through

(iv) that can be drawn down from the Shareholders' uncalled Capital Commitments after expiration of the Investment

Period. If such right was exercised, Capital Calls requesting capital contributions exceeding such maximum amount shall
not be permitted and the aggregate sum of (x) all capital contributions made until the expiration of the Investment Period
and (y) such maximum amount shall constitute the Capital Commitments of the Shareholders for the purposes of these
Articles and the Prospectus.

(4) Form of Shares / Register of Shares
All Shares shall be issued in registered form.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shares (the “Register”) which shall be kept by

the General Partner or by an entity designated therefore by the Company (the “Registrar and Transfer Agent”) and shall
contain the name of each Partner, its residence, registered office or elected domicile, the number of Shares (and their
Class, if any) held by it, the amount paid in on each Share, banking references, and, if applicable, their date of transfer.

The registration of the Partner's name in the Register evidences its right of ownership over such registered Shares.

No Share certificates shall be issued.

Each Partner may change the data contained in the Register by notice to the General Partner. Any changed data shall

be authoritative for any action at least two weeks thereafter.

The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per Share. In the event that a

Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
Share until one person has been appointed or designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

§7. Issuance of Shares.
(1) General Rule
The General Partner is authorized to issue, in accordance with the Prospectus and § 6 hereof, an unlimited number

of Limited Partner Shares without reserving to the existing Partners a preferential right to subscribe for the Limited
Partner Shares to be issued. Subject to the Prospectus, the General Partner may decide on the issuance of Limited Partner
Shares  in  its  sole and  absolute discretion.  The Limited  Partner  Shares may only be  subscribed to by  Well-Informed
Investors. Each newly issued Limited Partner Share entitles its holder to the same rights and obligations of the holders
of existing Limited Partner Shares.

(2) Price, Payment, Additional Shareholders
The price per Limited Partner Share is fixed at one thousand Euros (EUR 1,000.-). This issue price per Limited Partner

Share shall be payable within a period as set in the Prospectus. The General Partner may delegate to any director, manager,
officer, or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the Limited
Partner Shares to be issued and to deliver them.

The General Partner may, in its sole discretion, admit additional Shareholders and permit existing Shareholders to

increase their Capital Commitments (additional Shareholders, as well as existing Shareholders in respect of the increase

88433

L

U X E M B O U R G

in their Commitments, referred to as “Additional Shareholder(s)”) at one or more subsequent closings (“Subsequent
Closings”) during the period following the First Closing and ending on the Final Closing.

On or after a Subsequent Closing the General Partner shall first draw down Capital Contributions from the Additional

Shareholders and continue to make such drawdowns from the Additional Shareholders up to and until such time as the
contributed capital of all Shareholders bears the same proportion to their respective Capital Commitments.

(3) No Contributions in Kind
The Company may not agree to issue Limited Partner Shares as consideration for a contribution in kind of securities.

§8. Share in the Company's Assets. Subject to the provisions in § 10 regarding allocations and distributions, the Sha-

reholders shall share in the Company pro rata in proportion to their Shares.

§9. Liability of Partners. The Shareholders are only liable up to the amount of their respective Capital Commitment

made to the Company.

The General Partner bears an unlimited and joint liability for the debts of the Company.

Art. 3. Distribution of Proceeds, Expenses and Fees.

§10. Allocations and Distribution of Proceeds. The Partners' meeting shall, upon proposal of the General Partner and

within the time limits provided by the Luxembourg laws and regulations, these Articles and the Prospectus, determine
how the results of the Company shall be disposed of and may declare, or may the General Partner authorize to declare,
distributions as well as decide, or authorize the General Partner to decide, to pay interim dividends in compliance with
the applicable law. The allocations and distributions shall be made in accordance with the provisions set forth in the
Prospectus and the results of the Company shall be distributed to the Shareholders pro-rata in their share in the Share
Capital in the Company.

No distribution may be made if after the declaration of such distribution the Net Asset Value of the Company would

fall below one million Euro (EUR 1,000,000).

Art. 4. Expenses and Costs.

§11. Expenses and Fees.
The Company shall bear the fees and expenses as provided for in the Prospectus.

Art. 5. Management and Representation.

§12. Management Authority.
(1) Basic Rule
The affairs of the Company shall be managed by the General Partner in accordance with the provisions and limitations

in this Articles and the Prospectus, and as may be otherwise required by mandatory law. The Shareholders of the Company
may not participate or interfere in the management of the Company.

The General Partner's remuneration for the management of the affairs of the Company shall consist in a priority

allocation out of Profits (profit priority share) and no other compensation or remuneration shall be due. The profit priority
share mentioned above shall be calculated and allowed in accordance with the provisions set forth in the Prospectus. In
general, all remunerations of the General Partner shall be described in the Prospectus.

(2) Management Authority-Power
Unless otherwise provided by Commercial Companies Law, the Prospectus or by these Articles, the General Partner

shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition of the Company.

All powers not expressly reserved by the Commercial Companies Law, the Prospectus or these Articles to the general

meeting of Partners shall be exercised by the General Partner.

In particular, subject to the restrictions contained in the Prospectus and the Commercial Companies Law, the General

Partner shall have the broadest powers to implement the investment strategy and borrowing restrictions, as well as the
course of conduct of the management and business affairs of the Company and to manage the investments for the account
of the Company with a view to achieving its investment strategy.

(3) Termination of Management Authority
The management authority of the General Partner shall terminate automatically upon its resignation or removal from

the Company.

Any change in the management or replacement of the General Partner will have to be agreed beforehand by the CSSF

(Commission de Surveillance du Secteur Financier).

(4) Delegation of Powers
The General Partner may, from time to time and always under its responsibility, appoint officers or agents of the

Company considered necessary for the operation and management of the Company, provided however that the Share-
holders may not act on behalf of the Company without risking their limited liability status.

88434

L

U X E M B O U R G

The General Partner may from time to time and under its responsibility subdelegate its power to perform specific

tasks to one or more ad hoc agent(s). In particular, the General Partner may, from time to time, appoint one or more
committees and delegate certain of its functions to such committees.

The General Partner will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and/or committees,

the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their appointment.

§13. Restrictions on Management Authority, Compliance.
(1) Basic Rule
The management authority of the General Partner shall be limited to Company assets.
(2) Investment Restrictions
The investments of the Company shall be restricted as described in the Prospectus.
(3) Conflict of Interest
No contract or other transaction between the Company and any other company or entity shall be affected or invali-

dated by the fact that the General Partner or any one or more of the Shareholders, managers, agents, affiliates, personnel
or officers of the General Partner is interested in, or is a partner, director, officer or employee of such other company
or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business. The General Partner or such officers
shall not by reason of such affiliation with such other company or entity be prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

§14. Representation. The Company shall be represented by the General Partner. The General Partner shall have

complete discretion and full power, authority and right to represent and bind the Company. The General Partner and its
board of managers may enter into any legal transactions on behalf of the Company with themselves.

The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the individual or

joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General
Partner shall determine in its discretion.

Art. 6. Withdrawal of Partners.

§15. Withdrawal of Partners.
(1) Redemption of Shares
Unless otherwise determined in the Prospectus or in applicable mandatory law, the Shareholders shall not be entitled

to require the redemption of their Limited Partner Shares by the Company. The General Partner may, at its discretion,
resolve to redeem Limited Partner Shares for distribution purposes. Subject to the provisions of the Prospectus, the
General Partner shall decide on the details of any redemption in its sole and absolute discretion. Any redemption request
shall be addressed to all the Shareholders.

(2) Restriction of Ownership
The General Partner on behalf of the Company may restrict or prevent any person (the “Prohibited Person”) to be

or become owner of Limited Partner Shares, if such person is not the General Partner, Fund SCS or a limited partner of
the Fund SCS and/or in the opinion of the General Partner such may be detrimental to the Company, may result in a
breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign or as a result thereof the Company may become exposed
to tax disadvantages that it would not have otherwise incurred. For such purposes the Company may:

a) decline to issue any Limited Partner Share and decline to register any transfer of a Limited Partner Share, where it

appears to it that such issuance or transfer would or might result in a Prohibited Person being the legal or beneficial
owner of such Limited Partner Shares; and

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register a transfer of Limited

Partner Share in the Register, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether such entry or registry will result in a Prohibited Person being the legal or beneficial
owner of Limited Partner Shares; and

c) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any Partners' meeting of the Company; and
d) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person

is a beneficial owner of Limited Partner Shares, direct such Shareholder to sell its Limited Partner Shares and to provide
to the Company evidence of the sale within 30 days of the notice. If such Shareholder fails to comply with the direction,
the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such Shareholder all Limited Partner Shares
held by such Shareholder in the following manner:

(i) The Company shall serve a second notice (the “Purchase Notice”) upon the Shareholder holding such Limited

Partner Shares or appearing in the Register as the owner of the Limited Partner Shares to be purchased, specifying the
Limited Partner Shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the Purchase Price will be calculated and the
name of the purchaser. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such Shareholder at its last address known to the Company or appearing in the Register. Imme-
diately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Shareholder shall cease to be the
owner of the Limited Partner Shares specified in such notice; its name shall be removed from the Register.

88435

L

U X E M B O U R G

(ii) The price at which each such Limited Partner Shares is to be purchased (the “Purchase Price”) shall be the Net

Asset Value of the relevant Class (if any) for redemption of such Limited Partner Shares on the last Valuation Day preceding
the date of the Purchase Notice.

(iii) Payment of the Purchase Price will be made available to the former owner of such Limited Partner Shares in Euro

and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified
in the Purchase Notice) upon final determination of the Purchase Price. Upon service of the Purchase Notice as aforesaid
such former owner shall have no further interest in such Limited Partner Shares or any of them, nor any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Purchase Price (without interest) from such
bank. Any redemption proceeds receivable by a Shareholder under this section, but not collected within a period of five
years from the date specified in the Purchase Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant Class
or Classes of Limited Partner Shares. The General Partner shall have power from time to time to take all steps necessary
to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

(iv) The exercise by the Company of the power conferred by this § 15 shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Limited Partner Shares by any person or that
the true ownership of any Limited Partner Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any
Purchase Notice, provided in such case the said powers were exercised in good faith.

§16. Removal of the General Partner.
a) Removal For Cause
In the event of Cause the Partners (with the positive vote of Non HS Life Sciences Shareholders (excluding HS Life

Sciences)) with a majority of more than 50 % of their votes expressed in a general meeting may resolve to remove the
General Partner from the Company and to appoint a successor.

Notice of a Partners' resolution resolving upon removal shall be given in writing and shall be served upon the removed

General Partner without undue delay by a representative to be appointed in the Partners' resolution. A removal shall
become effective as of the date specified in such notice, at the earliest on the date of service of the notice.

The management authority of the General Partner shall terminate as per the date specified in the notice. The General

Partner's entitlement to the profit priority share described in the Prospectus shall terminate as of the effective date of
revocation of the General Partner's management authority.

b) Removal Without Cause
Upon resolution to be passed by the a general meeting of Partners (with the positive vote of Non HS Life Sciences

Shareholders (excluding HS Life Sciences)) with a majority of at least 75 % of their votes, the General Partner may be
removed from the Company without Cause and a successor can be appointed. A removal can only be resolved upon if
the General Partner is removed from the Company and Fund SCS. The provisions in subsection (1) shall correspondingly
apply. The management authority of the General Partner shall terminate upon service of the removal resolution. The
General Partner shall still be entitled to such compensation as determined in the Prospectus.

§17. Transfer of Shares.
(1) Limited Partner Shares may be transferred only upon approval by the General Partner. Subject to the provisions

of the Prospectus, such approval shall only be given in the case of good cause on the side of the requesting Shareholder.

(2) Subject to the provisions of the Prospectus, transfers of Shares shall be effected by inscription of the transfer in

the Register.

Art. 7. Partners' Meetings.

§18. Partners' Meetings.
(1) Proceedings
The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice for,

and conduct of, the meetings of Partners of the Company, unless otherwise provided herein.

Meetings of the Partners of the Company shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at such place and time as

may be specified in the respective convening notices of the meetings.

If all the Partners of the Company are present or represented at a meeting of the Partners of the Company, and

consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without
prior notice.

A Partner may act at any meeting of the Partners of the Company by appointing another person (who need not be a

Partner) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Each Partner may also participate in any meeting of Partners of the Company by telephone or video conference call

or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.

Each Partner may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain the date

and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each proposed

88436

L

U X E M B O U R G

resolution,  three  boxes  allowing  the  shareholders  to  vote  in  favor,  against  or  abstain  from  voting  on  the  proposed
resolution. The voting forms must be sent by the shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to the registered
office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the time of the meeting
specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favor or against the proposed resolutions)
nor an abstention shall be void.

Except as otherwise required by Commercial Companies Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the

Partners of the Company duly convened will be adopted by a simple majority of those present or represented and voting,
regardless of the proportion of the Share Capital represented at such meeting.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one-half of the Share Capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If this quorum is not reached, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means
of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official
gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate
the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion
of the Share Capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-
thirds of the votes cast.

One Partners' meeting shall be held annually at the registered office of the Company or elsewhere as may be specified

in the notice of meeting on the first Business Day of June of each year.

A Partners' meeting will be called by the General Partner (i) whenever deemed necessary or advisable, or (ii) upon

request of Non HS Life Sciences Shareholders representing at least 10 % of their aggregate Shares of the Share Capital,
by giving at least 15 Business Days' advance notice in writing, which notice shall include the time and place of such meeting
and state the agenda for such meeting. The determination of the 15 Business Days period is to be made on the beginning
of the third Business Day after such notice is given. If the agenda is subsequently amended, such amended agenda must
be received by the Partners by the third day before the scheduled date of a Partners' meeting, and each Partners shall
have the right to request that the agenda shall be amended.

(2) Subject Matters
The Partners' meeting will inter alia resolve upon the following subjectmatters:
a) approval of the annual financial statements of the Company submitted by the General Partner;
b) discharge of the General Partner for its activities during the past fiscal year;
c) appointment of an auditor for the fiscal year's financial statements of the Company;
d) changes of, and amendments to, the Prospectus and these Articles and dissolution of the Company;
e) abandonment of the SICAR status of the Company; and
f) other subject-matters as provided for under the Prospectus or any mandatory law;
each time in accordance with the subject matter relevant mandatory quorum and voting requirements.
The Fund SCS shall not be entitled to vote on resolutions according to this subsection 2. lit. b) and § 16 (and any other

item as determined in the Prospectus) in order to avoid a potential conflict of interests. Unless as required by mandatory
law or otherwise provided for in these Articles, the General Partner shall abstain from voting at the Partners' meetings.

Subject to the provisions of these Articles and mandatory law, majority requirements shall be as follows: Partners'

resolutions shall be passed upon the simple majority of votes cast. The simple majority of votes cast shall mean more
than 50 % of votes cast.

Resolutions according to this subsection (2) lit. d) shall require a majority of at least 75 % of the Share Capital and

require in addition the consent of the General Partner. Resolutions according to subsection (2) lit. e) shall require the
unanimous consent of all Partners and the prior approval of the CSSF.

Any amendment of this subsection (2) shall require the unanimous consent of the Partners of the Company.
The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Partners may be increased only with the

unanimous consent of the Partners and bondholders.

The SICAR status may only be abandoned by the Company with the prior approval of the CSSF and the unanimous

consent of the Partners.

(3) Chairman, Minutes
The chairman of any meeting of the Partners shall be one of the managers of the General Partner who shall keep

written minutes of all the proceedings and votes in any such meeting. Copies of the minutes shall be sent by the General
Partner to the other Partners without undue delay after such meeting.

(4) Term of Preclusion
A Partner can object to Shareholders' resolutions within a period of four weeks after knowledge of the respective

resolution by initiating arbitration proceedings as provided for in the Prospectus.

88437

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Term, Termination, Dissolution.

§19. Term. The term of the Company shall commence as of the date specified in § 1 subsection (2) and shall continue

for a period ending on the earlier of:

a) the tenth anniversary of the Final Closing; provided that the General Partner may extend the term with the prior

approval of the Partners given in a general meeting, for two additional consecutive one-year periods and any such ex-
tension proposal shall be notified to the Partners three months in advance; or

b) the date of occurrence of any of the events set forth in § 20, subject to the provisions thereof.

§20. Early Termination.
(1) The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Partners deliberating as

prescribed for amendment of these Articles, with the consent of the General Partner.

(2) Notwithstanding the provisions of § 19 of this Articles, the Company shall dissolve upon the occurrence of any of

the following events: (a) dissolution of the General Partner; (b) commencement of insolvency proceedings over the assets
of the General Partner or rejection of a petition to commence such proceedings due to insufficient assets; or (c) removal
of the General Partner from the Company; provided that the Company shall not terminate if, within 90 days after such
an event, Partners holding at least 75 % of the total Shares in the Company elect to continue the business of the Company
and to appoint a successor, subject to prior CSSF approval.

§21. Dissolution.
(1) Liquidator
Upon dissolution of the Company, the General Partner shall be appointed as liquidator of the Company by the Partners

with a majority of more than 50 % of the total Shares in the Company, and shall liquidate all or any part of the assets of
the Company; provided that upon dissolution according to § 20 because of an event relating to the General Partner, the
Company shall be wound up by a liquidator appointed by the Partners with a majority of more than 50 % of the total
Shares in the Company.

Such appointed liquidator(s) must be approved by the CSSF and must provide all requisite guarantees of honorability

and professional skills.

(2) Allocation of Liquidation Proceeds
Profits and losses arising from the liquidation of the assets of the Company upon liquidation shall be allocated among

the Partners pursuant to the formula as set forth in the applicable subsection of § 10 of these Articles.

Art. 9. Valuation, Accounting and Reporting.

§22. Valuation of Company Assets.
(1) Valuation at Fair Value
The Assets of the Company shall be valued on the basis of the fair value. Such value (the “Net Asset Value”) shall be

the value of the Assets less the value of the Liabilities and shall be determined as follows:

(i) the value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at
after making such discount as the General Partner may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(ii) units, shares, stocks or equity interests will be valued in accordance with valuation principles consistent with the

international private equity and venture capital valuation guidelines as promoted by the European Venture Capital Asso-
ciation;

(iii) securities dealt in on a regulated market will be valued on the basis of their quoted mid-market price on the last

day of trading prior to the Valuation Date, subject to any discounts which in accordance with EVCA valuation guidelines
may be applicable due to the nature of such security, on the market which is normally the principal market for such
securities;

(iv) securities not dealt in on a regulated market, and securities dealt in on a regulated market for which the price as

determined pursuant to subparagraph (iii). is not representative of their fair market value, will be determined by an
independent appraiser, to be appointed by the General Partner, based on the requirements of the law;

(v) the value of Assets denominated in a currency other than Euro shall be determined by taking into account the rate

of exchange prevailing at the time of the determination of the net asset value; and

(vi) liquid Assets comprising cash, treasury bonds and regularly traded money market instruments will be valued at

their market value with interest accrued.

(vii) all other assets of any kind or nature will be valued at fair market value, as determined in good faith by or under

the  responsibility  of  the  General  Partner  in  accordance  with  generally  accepted  valuation  principles  and  procedures
prescribed by EVCA. For the purpose of determining the fair market value of the assets under this provision, the General
Partner may have regard to all factors that it reasonably considers relevant in relation to such assets which factors may
include (when applicable) inter alia: (i) the characteristics of and fundamental analytical data relating to the assets including

88438

L

U X E M B O U R G

the costs, size, current interest rate, period until next interest rate reset, maturity and lending rate of the assets, the
terms and conditions of the assets' debt structure; (ii) the nature and adequacy of the Company's rights, remedies and
interests; (iii) the creditworthiness of the assets business, cash flows, capital structure and future prospects; (iv) infor-
mation relating to recent relevant market transactions; (v) the reputation and financial condition of the and recent reports
relating to the assets; (vi) general economic market conditions affecting the fair value of the assets.

Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner is authorized to apply other fair valuation principles

for the Assets of the Company, when circumstances or market conditions so justify, but on a consistent basis. When
evaluating  any  Assets  which  are  held  subject  to  any  restriction  on  transfer  or  sales,  such  Assets  will  be  valued  at  a
reasonable discount. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and applied in accordance with
generally accepted accounting principles of Luxembourg.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value taken

by the General Partner or by any custodian, company or other organization which the General Partner may appoint for
the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and on its present, past or
future Partners.

(2) Assets
The assets of the Company (the “Assets”) shall include (without limitation):
(i) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(ii) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(iii) all shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial

instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjust-
ments with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);

(iv) all stock dividends, cash dividends and cash distributions received by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

(v) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

(vi) the liquidation value of all contracts and options the Company has an open position in;
(vii) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(viii) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
(3) Liabilities
The liabilities of the Company (the “Liabilities”) shall include (without limitation):
(i) all loans, bills and accounts payable;
(ii) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
(iii) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, custodian fees and any other agents' fees);
(iv) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

(v) an appropriate provision for future taxes based on capital and income on the accounting date, and other reserves

(if any) authorized and approved by the General Partner as well as such amount (if any) as the General Partner may
consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;

(vi) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature assessed in accordance with generally accepted

accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company pursuant to § 11 hereof. The Company may accrue administrative and other expenses of a
regular or recurring nature based on an estimated amount ratably for annual or other periods.

(4) Net Asset Value per Share
The Net Asset Value per Share shall be determined by dividing the Net Asset Value of the Company by the number

of Limited Partner Shares of the relevant Class (if any), issued at the date of valuation.

(5) Calculation of the Net Asset Value
The Net Asset Value per Share and the price for the issue, redemption and conversion of Shares shall be calculated

from time to time by the General Partner or any agent appointed thereto by the General Partner, at least once a year
on the last Business Day of each year, such date being referred to herein as the “Valuation Day”. The disclosure of each
valuation shall take place at the latest on the end of the second month after the end of the relevant year or month,
respectively. The Net Asset Value shall be made available at the registered office of the Company.

(6) Suspension of Calculation of the Net Asset Value
The General Partner may suspend calculation of the Net Asset Value when:
(i) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Company is

not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

88439

L

U X E M B O U R G

(ii) any period when any of the principal stock exchanges on which a substantial proportion of the Investments of the

Company are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted
or suspended; or

(iii) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned

by the Company would be impractical; or

(iv) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the

price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.

§23. Accounting. The administrative agent of the Company shall maintain complete and accurate books of account of

the Company's affairs at the Company's office, which books (i) will be open to inspection by any Partner or a Partner's
authorized representative – which can be an external adviser, bound by a legal confidentiality obligation – at any time
during ordinary business hours and (ii) will be preserved during the longer of (x) the periods required by law and (y) the
term of the Company and for a period of five years thereafter. Legal inspection rights of Partners under mandatory law
shall remain unaffected. The accounts of the Company shall be maintained in Euro. Within the time periods required by
law, the financial statements of the Company shall be prepared and audited in accordance with the provisions of the
general accounting principles accepted in Luxembourg and the Commercial Companies Law.

§24. Reporting.
(1) Annual Reports
Subject to the provisions of the Prospectus, the General Partner shall provide to the Partners annual reports of the

Company as required by the SICAR Law and the Commercial Companies Law.

(2) Other Information
The Company shall provide to the Partners the other information as set out in the Prospectus.

Art. 10. General Provisions.

§25. Custodian, Independent Auditor.
(1) Custodian
The Company has entered into a custodian agreement with a custodian bank, which shall satisfy the requirements of

the SICAR Law (the “Custodian”). All securities and cash of the Company are to be held by the Custodian or under its
responsibility by duly authorized agents appointed in good faith, who shall assume towards the Company and its Partners
the duties and responsibilities provided by the SICAR Law.

In the event of the Custodian desiring to retire the General Partner shall use its best endeavors to find a successor

to act as custodian within 2 (two) months of the effective date of such retirement and upon doing so the General Partner
shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The General Partner may terminate the
appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been
appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

The duties of the Custodian shall cease:
(i) in the case of the voluntary withdrawal of the Custodian or its removal by the Company; until it is replaced, the

Custodian shall take all necessary steps for the successful maintaining of the interests of the Partners; or

(ii) in the event that the Custodian or the Company have (a) been declared bankrupt, (b) obtained a suspension of

payments, (c) entered into a composition with creditors, (d) been placed under controlled management or any similar
proceedings, or (e) been put into liquidation; or

(iii) where the Luxembourg Supervisory Authority withdraws its authorization of the Custodian or the Company.
(2) Independent Auditor
The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one

authorized auditor (“réviseur d‘entreprises”), who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness
and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the SICAR Law. The auditor shall be elected
by the General Partner and continue to carry out its duties until its successor is elected.

§26. Indemnification. The Company shall provide indemnification to the General Partner, its respective partners, sha-

reholders, managers, employees, advisers and agents to the Partners as set out in the Prospectus.

§27. Amendments to the Articles, Governing Law
(1) These Articles may be amended from time to time by a meeting of Partners', subject to the quorum and majority

requirements of § 18, each time subject to the prior approval of the CSSF.

(2) These Articles shall be governed by law of the Grand Duchy of Luxembourg.

§28. Transitory Dispositions.
(1) The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2010.
(2) The first annual general meeting of Partners will be held in 2011.

88440

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Partner

Subscribed

Shares

Subscribed

Capital

QureInvest II (SCS) (SICAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31,000 EUR

Proof of such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at two thousand euro (EUR 2,000.-).

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the Commercial Companies Law, as

amended, have been observed.

<i>General meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolution by unanimous vote.

<i>Resolution

The registered office of the Company is fixed at 231 Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version, on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, surname, civil status

and residence, the said persons appearing signed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, am sechzehnten Tag des Monats Juli.
Vor UNS, Maître Martine Schaeffer Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) die QureInvest, eine société à responsabilité limitée, gegründet unter luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz

in der 231 Val des Bon Malades, L-2121 Luxemburg, Eintragung im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister
anhängig, als geschäftsführender Komplementär der Qureinvest II Investments (SCA) SICAR;

hier vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

welche am 15. Juli 2010 erteilt wurde; und

2) die QureInvest II SCS SICAR, eine société en commandite simple (S.C.S.), organisiert als eine société d'investisse-

ment en capital à risque, gegründet unter luxemburgischem Recht mit Gesellschaftssitz in der 231 Val des Bon Malades,
L-2121 Luxemburg, Eintragung im luxemburgischen Handels-und Gesellschaftsregister anhängig, vertreten durch ihren
geschäftsführender Komplementär Qureinvest;

hier vertreten durch Christoph Diesel, Rechtsanwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

welche am 15. Juli 2010 erteilt wurde.

Die Vollmachten unterzeichnet „ne varietur“, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichneten Notar

unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei den Registrierungsbehörden
einzureichen.

Die erschienenen Parteien, in der Funktion in welcher diese handeln, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die

Gründungsurkunde (die „Satzung“) einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) zu be-
urkunden, welche diese untereinander gründen:

Präambel - Definitionen

Die nachfolgenden Definitionen sind Bestandteil dieser Satzung.
„Satzung“ ist die Satzung der Gesellschaft gemäß dieser Urkunde.
„Vermögenswerte“ hat die Bedeutung gemäß § 22 Abs. (2).
„Verbundunternehmen“ bedeutet in Bezug auf eine natürliche Person oder ein Unternehmen („U“), ein Mutterunter-

nehmen  von  U,  ein  Tochterunternehmen  von  U,  ein  Tochterunternehmen  eines  Mutterunternehmens  von  U,  jedes

88441

L

U X E M B O U R G

Unternehmen, dass direkt oder indirekt von U kontrolliert wird oder jedes Unternehmen, dass U direkt oder indirekt
kontrolliert. Die Mitglieder von HS Life Sciences gelten untereinander als Verbundunternehmen.

„Geschäftstage“ sind diejenigen Tage, an denen die Banken in Luxemburg für den Publikumsverkehr geöffnet sind.
„Kapitalabruf“ bedeutet den schriftlichen Abruf durch den Komplementär an die Aktionäre, Aktien gemäß ihrer Ka-

pitalzusagen zu zeichnen mit einer Abruffrist von mindestens 10 Geschäftstagen.

„Kapitalzusage“ bedeutet Höchstbetrag (bezeichnet in Euro), der von einem Aktionär in die Gesellschaft eingezahlt

wurde oder zu dessen Einzahlung in die Gesellschaft sich der Aktionär verpflichtet hat, durch die Zeichnung von Kom-
manditaktien gemäß dem Zeichnungsschein dieses Aktionärs.

„Management-Verstoß“ bedeutet (i) eine grob fahrlässige, vorsätzliche, betrügerische, bösgläubige oder rücksichtslos

missachtende Schädigung der Gesellschaft und/oder eines Vertragspartners einer Nebenabrede durch eine Verletzung
des Prospektes oder dieser Satzung oder einer Nebenabrede durch HS Life Sciences, (ii) die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens oder die Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse über das Vermögen des Kom-
plementärs oder (iii) das Nichtunterbreiten eines Vorschlags über die zukünftige Geschäftsführung der Gesellschaft durch
den Komplementär im Falle des Weggangs einer Schlüsselperson.

„Klassen“ bedeutet die verschiedenen Aktienklassen, die durch die Gesellschaft ausgegeben werden können.
„Handelsgesellschaftengesetz“ bezeichnet das Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Form.

„CSSF“ bedeutet die Commission de Surveillance du Secteur Financier, die Luxemburger Aufsichtsbehörde für den

Finanzsektor.

„Gesellschaft“ bedeutet die QuerInvest II Investments (SCA) SICAR, eine Investmentgesellschaft in Risikokapital ge-

gründet als Kommanditgesellschaft auf Aktien in Luxemburg.

„Depotbank“ hat die Bedeutung gemäß § 25.
„Letzter Zeichnungsschluss“ bezeichnet das Ende der Zeichnungsperiode, welches beim früheren Eintreten von (i)

dem Jahrestag des Ersten Zeichnungsschlusses und (ii) am Tag, der vom Komplementär als Letzten Zeichnungsschluss
bestimmt wird, eintritt.

„Erster Zeichnungsschluss“ bedeutet den Tag, an dem Kapitalzusagen in dem Gesamtbetrag in Höhe von mindestens

Euro 46.1 Millionen verbindlich von den Investoren der Fonds SCS gezeichnet wurden.

„Fonds SCS“ bedeutet QureInvest II (SCS) SICAR und die Parallel-Pools, wie sie im Prospekt definiert sind.
„Komplementär“ bezeichnet den jeweiligen geschäftsführenden Komplementär der Gesellschaft.
„HS Life Sciences“ bedeutet den Komplementär, HS Life Sciences AG (Zürich), HS Life Sciences GmbH (Düsseldorf),

die jeweiligen Verbundunternehmen des Komplementär, HS Life Sciences AG (Zürich) und/oder HS Life Sciences GmbH
(Düsseldorf), sowie ihre jeweiligen Gesellschafter, Angestellten und die Schlüsselpersonen.

„Anlageperiode“ bedeutet den Zeitraum beginnend am Ersten Zeichnungsschluss der Gesellschaft und endend am

früheren der folgenden Ereignisse: (i) Der fünfte Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses oder (ii) der Tag, an dem der
Komplementär die Anlageperiode vorzeitig beendet, (x) weil entweder mindestens 75 % der Kapitalzusagen abgerufen
bzw. für Investitionen in Portfolio-Gesellschaften rechtsverbindlich, schriftlich zugesagt oder reserviert sind, wobei hin-
sichtlich der Bestimmung des Ablaufs der Anlageperiode die Reservierung von mehr als 10 % der gesamten Kapitalzusagen
für Investitionen (einschließlich Nachfolgeinvestitionen) die Zustimmung der Aktionäre bedarf, oder (y) weil nach der
vernünftigen Einschätzung des Komplementärs eine vorzeitige Beendigung wegen der Änderungen von Gesetzen, Ver-
waltungsvorschriften oder der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen notwendig oder sinnvoll ist oder (iii) der Tag, an dem
dem Vorschlag über zukünftigen Führung der Geschäfte der Gesellschaft im Fall des Weggangs einer Schlüsselperson
nicht mit der notwendigen Mehrheit (d.h. zwei Drittel der gesamten Kapitalzusagen) zugestimmt wurde und die Gesell-
schaft automatisch aufgelöst wird, soweit nicht Aktionäre die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen oder (iv) der Tag,
an dem die Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens 80 % der gesamten Kapitalzusagen eine vorzeitige Beendigung
der Anlageperiode beschließen oder (v) wenn HS Life Sciences einen Ergebnis-Vorab für die Geschäftsführung oder eine
vergleichbare Vergütung für die Führung der Geschäfte oder die Beratung eines Nachfolgefonds erhält.

„Schlüsselpersonen“ bedeutet die Herren Karsten Henco, Edward Stuart und Justin Duckworth sowie die mit Zu-

stimmung der Aktionäre bestellten Nachfolger bzw. weiteren Personen.

„Verbindlichkeiten“ hat die Bedeutung gemäß § 22 Abs. (3).
„Kommanditaktien“ bedeutet alle Aktien des Grundkapitals.
„Nettoinventarwert“ bedeutet den Wert der Vermögensgegenstände abzüglich des Wertes der Verbindlichkeiten wie

in § 22 Abs. (1) definiert.

„Nicht HS Life Sciences Aktionäre“ bedeutet alle Aktionäre mit Ausnahme der Fonds SCS.
„Gesellschafter“ bedeutet den Komplementär und die Aktionäre.
„Portfolio-Gesellschaften“ bedeuten die Unternehmen, in die die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar investiert

hat.

„Ergebnis-Vorab“ bedeutet den Gewinn der Handelsbilanz der Gesellschaft entsprechend des luxemburgischen Ge-

setzes vom 19. Dezember 2002; der Komplementär hat das Recht aus der Kapitalreserve der Gesellschaft Kapital zu

88442

L

U X E M B O U R G

entnehmen um den Gewinn der Handelsbilanz entsprechend des Handelsgesellschaftengesetzes und dieser Satzung zu
erhöhen.

„Unzulässige Person“ bezeichnet jede Person gemäß § 15.
„Prospekt“ bedeutet das separate Angebotsdokument, wie es durch die Gesellschaft ausgegeben und von der CSSF

genehmigt wurde.

„Ankaufserklärung“ bezeichnet die Erklärung gegenüber den Aktionären zum Ankauf ihrer Aktien gemäß § 15 Abs. (2)

lit. d) Nr. (i).

„Ankaufspreis“ bezeichnet den Kaufpreis für Aktien der Aktionäre gemäß § 15 Abs. (2) lit. d) Nr. (ii).
„Register“ bedeutet das Aktienregister gemäß § 6 Abs. (4).
„Registrierungs-und Umschreibungsstelle“ hat die Bedeutung gemäß § 6 Abs. (4).
„Aktionär“ bedeutet jeden Eigentümer von Kommanditaktien.
„Aktien“ bedeutet die voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert aus denen das Grundkapital besteht, d.h. die Kom-

manditaktien.

„Grundkapital“ bedeutet das Grundkapital der Gesellschaft gemäß § 6 Abs. (2).
„SICAR-Gesetz“ bedeutet das Gesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 15. Juni 2004 über Investmentgesell-

schaften in Risikokapital in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Zeichnungsschein“ hat die Bedeutung gemäß § 6 Abs. (3).
„Nachfolgefonds“ bedeutet einen neuen Private-Equity-Fonds oder ein anderes Investitionsvehikel, welches eine An-

lagestrategie verfolgt, die mit der Anlagestrategie der Gesellschaft im Wesentlichen übereinstimmt und durch HS Life
Sciences verwaltet oder beraten wird.

„Bewertungstag“ bedeutet den Tag der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie gemäß § 22 Abs. (5).
„Gut Informierter Investor“ bezeichnet einen gut informierten Investor im Sinne des Art. 2 des SICAR-Gesetzes. Ein

Gut Informierter Investor ist jeder:

(i) Institutionelle Investor, oder
(ii) professionelle Investor,
(iii) oder jeder Investor, der die folgenden Bedingungen erfüllt:
(a) er hat schriftlich bestätigt, das er den Status eines Gut Informierten Investors einhält; und
(b) entweder (i) investiert einen Minimalbetrag von Euro 125.000 in die Gesellschaft oder (ii) er/sie hat eine Beurteilung

eines Kreditinstitutes im Sinne der Verordnung 2006/48/EG oder einer Investmentgesellschaft im Sinne der Verordnung
2004/39/EG, oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Verordnung 2001/107/EG erhalten, die seine/ihre Expertise
und Wissen zur Einschätzung von Risikokapital bestätigt.

Art. 1. Errichtung der Gesellschaft.

§1. Errichtung, Beginn.
(1) Errichtung
Zwischen dem Komplementär und den Zeichnern von Kommanditaktien und allen, die in der Zukunft Gesellschafter

werden besteht eine Investmentgesellschaft in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) (die
„Gesellschaft“), in der Form einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions, SCA) nach
dieser Satzung, dem Handelsgesellschaftengesetz und dem SICAR-Gesetz.

(2) Beginn
Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Gründung.

§2. Firma.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
QureInvest II Investments (SCA) SICAR.
(2) Alle Dokumente der Gesellschaft, die sich an Dritte richten, wie Briefe, Rechnungen oder Veröffentlichungen,

müssen die eingetragene Firma der Gesellschaft tragen gefolgt von dem Zusatz „société en commandite par actions“ oder
„SCA“, welche als „société d'investissement en capital à risque“ oder „SICAR“ qualifiziert, die Adresse des eingetragenen
Sitzes der Gesellschaft und die Buchstaben „RCS Luxemburg“ gefolgt von der Nummer unter der die Gesellschaft im
Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister eingetragen ist.

§3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, ihre Vermögensgegenstände in Wertpapiere oder

andere Vermögenswerte, welche Risikokapital im weitesten Sinn gemäß Artikel 1 SICAR-Gesetz darstellen, um ihren
Gesellschaftern in den Genuss des Ergebnisses der Verwaltung dieser Vermögensgegenstände kommen zu lassen als
Gegenleistung für die Eingehung des diesbezüglichen Risikos.

Der Investitionsfokus und die Strategie der Gesellschaft sind umfangreicher im Prospekt beschrieben.
Die Gesellschaft kann jede Transaktion vornehmen, die als notwendig angesehen wird, um diese teilnehmenden Anteile

zu entwickeln, verwalten und zu kontrollieren. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospektes kann die Gesellschaft

88443

L

U X E M B O U R G

sich durch Darlehen von verbundenen Unternehmen und/ oder nicht-verbundenen Drittkapitalgebern und Kapitalmärkten
finanzieren, Schuld-und Finanzierungsvereinbarungen eingehen, (wandelbare und nicht wandelbare) Schuldverschreibun-
gen, Anleihen oder andere Fremd-und Eigenkapitalinstrument in öffentlichen und nicht-öffentlichen Platzierungen ausge-
ben, in als Inhaber-oder Registerpapier, zu jeden Nennwert und in jeder Währung.

Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen, egal ob kreditfinanziert oder nicht für die Gründung, Entwicklung

und die Kontrolle von allen Unternehmungen einsetzen und Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt
beteiligt ist, sowie allen verbundenen Unternehmen der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört sowie jeder Mutterge-
sellschaft der Gesellschaft jede Art finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorteile, Wertpapier oder Garantien gewähren.

Des Weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen und Geschäfte vornehmen, die sie für sinnvoll hält, um ihren

Unternehmenszweck im weitesten nach dem SICAR-Gesetz zulässigen Rahmen zu entwickeln und zu erfüllen.

§4. Begrenzung des Gesellschaftszwecks. Der Zweck der Gesellschaft steht unter den Beschränkungen, welche sich

aus dem Prospekt ergeben.

§5. Geschäftsjahr, Sitz, Währung.
(1) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft von

dem Tag, an dem die Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb gemäß § 1 Absatz 2 begonnen hat, und endet am 31. Dezember
des betreffenden Jahres.

(2) Sitz
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der Sitz durch Entscheidung des Komplementärs innerhalb der Grenzen der Stadt Luxemburg verlegt werden.
Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden, jedoch nicht ins Ausland, soweit nicht hierin anderweitig geregelt.

Die Gesellschaft kann Büros, Filialen (dauerhaft oder nicht) und Tochterunternehmen in Luxemburg und im Ausland

haben.

(3) Währung
Die Gesellschaft wird in der Währung Euro geführt.

Art. 2. Gesellschaft und Gesellschaftsvermögen.

§6. Gesellschafter, Kapital.
(1) Gesellschafter
Die Gesellschaft besteht zwischen einem oder mehreren Komplementären, von denen einer der geschäftsführende

Komplementär (associé gérant commandité) ist, und den Eigentümern der Kommanditaktien, welche die Kommanditak-
tionäre der Gesellschaft (die „Aktionäre“) sind. Die Kommanditaktien können nur von Personen gehalten werden, die
gut informierte Investoren im Sinne des SICAR-Gesetzes sind (ein „Gut Informierter Investor“).

(2) Grundkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft (das „Grundkapital“) setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Aktien ohne

Nennwert (die „Aktien“) und muss zu jeder Zeit gleich dem Nettoinventarwert der Gesellschaft gemäß § 22 sein.

Das Mindestkapital der Gesellschaft einschließlich etwaigem Agio beträgt Euro 1 Million und muss innerhalb von zwölf

Monaten nach dem Datum, an dem die Gesellschaft als société d'investissement en capital à risque von der CSSF zugelassen
wurde, erreicht werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus Kommanditaktien, welche nur von Aktionären gezeichnet

wurden und werden.

Die Gesellschaft wurde gegründet mit einem gezeichneten Grundkapital von einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000)

aufgeteilt in einunddreißig (31) Kommanditaktien ohne Nennwert. Bei Gründung der Gesellschaft waren die Aktien voll
eingezahlt.

(3) Kapitalzusagen
Der Komplementär hat keine Verpflichtung, Kapitaleinzahlungen zu leisten und hat keinen Kapitalanteil. Die Aktionäre

sind gemäß den Bestimmungen des Prospektes verpflichtet, Kommanditaktien zu zeichnen.

Investoren, die Kommanditaktien zeichnen wollen, füllen einen Zeichnungsschein (den „Zeichnungsschein“) aus, wel-

cher bei Annahme durch den Komplementär unterzeichnet wird. Damit verpflichten sich die Investoren, Kommanditak-
tien gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Prospektes zu zeichnen. Die Zeichnung wird wirksam im Verhältnis
zur Gesellschaft mit Annahme des Zeichnungsscheins des Kommanditaktionärs durch den Komplementär, und der Beitritt
zur Gesellschaft wird wirksam mit der Ausgabe von Kommanditaktien an den Aktionär.

Die übernommenen Kapitalzusagen der Aktionäre werden nachfolgend zusammen als die „Kapitalzusagen“ bezeichnet.

Kapitalzusagen werden, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Prospekts, durch den Komplementär abgerufen
(ein „Kapitalabruf“). Nach Zahlung des Kapitalabrufs wird der Komplementär den Gesellschaftern die entsprechende
Anzahl an Aktien ausgeben.

88444

L

U X E M B O U R G

Kapitalzusagen können nur während der Anlageperiode zur Einzahlung abgerufen werden. Nach Ablauf der Anlage-

periode können Kapitalzusagen nur für folgende Zwecke zur Einzahlung abgerufen werden:

(i) zur Finanzierung von Investitionen der Gesellschaft, die zum Ablauf der Anlageperiode bereits zugesagt oder nach

Abschluss einer Absichtsvereinbarung in Bearbeitung waren, wenn diese bearbeiteten Investitionen innerhalb von 6 Mo-
naten nach Ablauf der Anlageperiode getätigt werden;

(ii) zur Finanzierung von Nachfolge-Investitionen in Portfolio-Gesellschaften, an denen die Gesellschaft zum Ablauf der

Anlageperiode bereits eine Beteiligung hält;

(iii) zur Finanzierung der Vorabausschüttungen auf den Ergebnis-Vorab des Komplementärs gemäß dem Prospekt;
(iv) zur Finanzierung der von der Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu tragenden Kosten, Ausgaben, Verpflichtungen

und Verbindlichkeiten.

Mit Zustimmung der Gesellschafter kann der Komplementär den maximalen Gesamtbetrag festlegen, der nach Ablauf

der Anlageperiode von den abrufbaren Kapitalzusagen der Aktionäre für die Zwecke der vorstehenden Ziffern (i) bis (iv)
noch abgerufen werden kann. In diesem Fall sind Kapitalabrufe, die diesen maximalen Gesamtbetrag übersteigen nicht
zulässig und bildet die Summe aus (x) allen Kapitaleinzahlungen bis zum Ablauf der Anlageperiode und (y) diesem maxi-
malen Gesamtbetrag die Kapitalzusage der Investor-Partner für die Zwecke dieser Satzung und des Prospektes.

(4) Art der Aktien/ Aktienregister
Alle Aktien werden in registrierter Form ausgegeben.
Alle ausgegebenen Aktien sind im Aktienregister (das „Register“) einzutragen, welche vom Komplementär oder einer

von der Gesellschaft bestimmten Person geführt wird (die „Registrierungs-und Umschreibungsstelle“) und welches den
Namen, die Anschrift, den Sitz oder den Wohnort jedes Gesellschafters, die Anzahl seiner Aktien (und ihre Klassen,
soweit vorhanden), den auf jede Aktie eingezahlten Betrag, Bankverbindungen und – soweit einschlägig – das Übertra-
gungsdatum enthalten.

Die Eintragung des Namens des Gesellschafters im Register bezeugt sein Eigentum an den eingetragenen Aktien. Es

werden keine Aktienzertifikate ausgegeben.

Jeder Gesellschafter kann seine im Register eingetragenen Daten ändern durch Mitteilung an den Komplementär. Jede

Änderung ist ausschlaggebend für alle Handlungen spätestens zwei Wochen nach der Änderung.

Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, die Gesellschaft akzeptiert nur einen Eigentümer pro Aktie. Falls

eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, die mit
dieser Aktie verbunden sind, auszusetzen, bis die gemeinsamen Inhaber eine Person als alleinigen Eigentümer gegenüber
der Gesellschaft benannt haben.

§7. Ausgabe von Aktien.
(1) Allgemeine Regel
Der Komplementär ist gemäß dem Prospekt und § 6 berechtigt, eine unbeschränkte Anzahl von Kommanditaktien

auszugeben, ohne den bestehenden Gesellschaftern ein Vorzugsrecht einzuräumen, die auszugebenen Kommanditaktien
zu zeichnen. Vorbehaltlich der Regelungen des Prospektes entscheidet der Komplementär nach eigenem Ermessen über
die Ausgabe von Kommanditaktien. Die Kommanditaktien können nur von Gut Informierten Investoren gezeichnet wer-
den. Jede neue ausgegebene Kommanditaktie berechtigt ihren Inhaber mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die
Inhaber der bestehenden Kommanditaktien.

(2) Preis, Zahlung, Weitere Aktionäre
Der Preis pro Kommanditaktie ist auf eintausend Euro (EUR 1.000,00) festgelegt. Der Ausgabepreis pro Kommandit-

aktie ist innerhalb einer im Prospekt angegebenen Frist einzuzahlen. Der Komplementär kann an jeden Geschäftsführer,
Manager oder sonstigen Bevollmächtigten die Berechtigung delegieren, Zeichnungen anzunehmen, Zahlungen des Preises
für die auszugebenden Kommanditaktien entgegenzunehmen und die Kommanditaktien auszugeben.

Der  Komplementär  kann  nach  seinem  Ermessen  zu  einem  oder  mehreren  Terminen  (jeweils  ein  „Nachfolgender

Zeichnungsschluss“) während des Zeitraums vom ersten Zeichnungsschluss bis zum letzten Zeichnungsschluss weitere
Aktionäre in die Gesellschaft aufnehmen und bestehenden Aktionären das Recht einräumen, ihre Kapitalzusage zu erhö-
hen (weitere Aktionäre sowie bestehende Aktionäre in Bezug auf die Erhöhung ihrer Kapitalzusage werden bezeichnet
als „Weitere Aktionäre“).

Im Zeitpunkt oder nach dem Nachfolgenden Zeichnungsschluss ruft der Komplementär zunächst von den Weiteren

Aktionären Kapitalzusagen ab bis zu dem Zeitpunkt, in dem alle Aktionäre zum Kapital der Gesellschaft den gleichen
Anteil ihrer Kapitalzusage beigetragen haben.

(3) Keine Sacheinlagen
Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, Kommanditaktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage auszugeben.

§8. Anteile am Gesellschaftsvermögen. Vorbehaltlich der Regelungen in § 10 hinsichtlich Zuweisungen und Ausschüt-

tungen sind alle Aktionäre am Kapital der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Aktien beteiligt.

§9. Haftung der Gesellschafter. Die Gesellschafter haften nur bis zu dem Betrag ihrer jeweiligen Kapitalzusage gegen-

über der Gesellschaft.

88445

L

U X E M B O U R G

Der Komplementär trägt die unbeschränkte und gemeinschaftliche Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Art. 3. Ergebnisverteilung, Auslagen und Kosten.

§10. Ergebniszuweisung und -Verteilung. Auf Vorschlag des Komplementärs und innerhalb der nach den Luxemburger

Gesetzen und Vorschriften dieser Satzungen und dem Prospekt vorgegebenen Zeiträume beschließt die Gesellschafter-
versammlung über die Verteilung des Ergebnisses der Gesellschaft und kann Ausschüttungen beschließen oder kann den
Komplementär ermächtigen, Ausschüttungen zu beschließen oder kann beschließen oder den Komplementär ermächtigen
zu beschließen, Zwischendividenden zu zahlen, soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist. Die Zuweisung und
Ausschüttung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Prospektes und das Ergebnis der Gesellschaft ist an die
Aktionäre auszuschütten im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft.

Ausschüttungen sind unzulässig, soweit danach der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter eine Million Euro (EUR

1.000.000) fallen würde.

Art. 4. Auslagen und Kosten.

§11. Auslagen und Kosten. Die Gesellschaft trägt Auslagen und Kosten gemäß dem Prospekt.

Art. 5. Geschäftsführung und Vertretung.

§12. Geschäftsführungsbefugnis.
(1) Grundregel
Die Geschäfte der Gesellschaft werden vom Komplementär in Übereinstimmung mit den Beschränkungen dieser Sat-

zung und des Prospektes sowie des zwingend anwendbaren Gesetzesrecht geführt. Die Aktionäre der Gesellschaft sind
nicht berechtig, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen.

Der Komplementär hat Anspruch auf Vergütung für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft durch einen Vorab-

anteil am Ergebnis der Gesellschaft (Ergebnis-Vorab), eine andere Vergütung oder Entschädigung wird nicht geschuldet.
Der vorgenannte Ergebnis-Vorab wird berechnet und bezahlt gemäß den Regeln des Prospekts. Alle Vergütungen des
Komplementärs sind im Prospekt beschrieben.

(2) Geschäftsführungsbefugnis
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Handelsgesellschaftengesetzes, des Prospektes und dieser Satzung hat der Kom-

plementär die weitestgehenden Rechte zur Verwaltung der Gesellschaft.

Alle Rechte, die nicht nach dem Handelsgesellschaftengesetz ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten

sind, werden durch den Komplementär ausgeübt.

Insbesondere, jedoch vorbehaltlich der Beschränkungen gemäß Prospekt und Handelsgesellschaftengesetz, hat der

Komplementär die weitestgehenden Befugnisse, um die Investitionsstrategie, die Kapitalaufnahmebeschränkungen sowie
den Gang der Verwaltung und der Geschäfte der Gesellschaft umzusetzen und die Investitionen für die Gesellschaft zu
verwalten im Hinblick auf die Erreichung der Investitionsstrategie.

(3) Beendigung der Geschäftsführungsbefugnis
Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kommanditisten endet automatisch

mit ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft.

Jede Änderung in der Geschäftsführung oder Auswechslung des Komplementärs muss zuvor von der CSSF genehmigt

werden.

(4) Überragung von Befugnissen
Der Komplementär kann von Zeit zu Zeit und unter seiner Verantwortung Geschäftsführer und Bevollmächtigte der

Gesellschaft benennen, welche er für notwendig hält, um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen, vorausgesetzt jedoch,
dass die Aktionäre nicht für die Gesellschaft handeln dürfen ohne ihre beschränkte Haftung zu riskieren.

Der Komplementär kann von Zeit zu Zeit und unter seiner Verantwortung seine Befugnis, bestimmte Aufgaben zu

erfüllen, an einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte übertragen. Insbesondere kann der Komplementär von Zeit zu
Zeit ein oder mehrere Komitees benennen und bestimmte seiner Funktionen an solche Komitees übertragen.

Der Komplementär bestimmt die Befugnisse, Pflichten und über die Vergütung (soweit vorhanden) seiner Bevoll-

mächtigten und/oder Komitees, den Zeitraum ihrer Berufung und alle weiteren relevanten Bedingungen der Benennung.

§13. Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis.
(1) Grundsatz
Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kommanditisten ist auf das Gesell-

schaftsvermögen beschränkt.

(2) Anlagebeschränkungen
Die Investitionen der Gesellschaft sind gemäß den Regelungen des Prospekts beschränkt.
(3) Interessenkonflikte
Die Wirksamkeit der Verträge und sonstigen Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften

oder Unternehmen wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass der Komplementär oder einer oder mehrere seiner Aktionäre,

88446

L

U X E M B O U R G

Geschäftsführer, Bevollmächtigten, verbundenen Unternehmen, Angestellten oder Mitarbeiter einen Anteil halten oder
Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellte oder Mitarbeiter dieser anderen Gesellschaft oder dieses anderen Unter-
nehmens sind, mit welchem die Gesellschaft diesen Vertrag abgeschlossen hat oder anderweitig in Geschäftsbeziehung
steht. Der Komplementär und diese Angestellten sind nicht aufgrund der Verbundenheit mit jener anderen Gesellschaft
oder jenem anderen Unternehmen davon ausgeschlossen, sich mit solchen Verträgen oder anderen Geschäften zu be-
fassen, darüber abzustimmen oder sonst diesbezüglich tätig zu werden.

§14. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch den Komplementär vertreten. Der Komplementär hat freies Ermessen

und volle Berechtigung und Bevollmächtigung die Gesellschaft zu vertreten und zu verpflichten. Der Komplementär und
seine Geschäftsführung können jede rechtliche Transaktion als Bevollmächtigter der Gesellschaft mit sich selbst abschlie-
ßen.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des Komplementärs oder die alleinige oder gemein-

same Unterschrift solcher anderer Personen gebunden, denen der Komplementär diese Berechtigung nach seinem freien
Ermessen übertragen hat.

Art. 6. Ausscheiden und Kündigung von Gesellschaftern.

§15. Ausscheiden von Gesellschaftern.
(1) Einziehung von Aktien
Soweit nicht vom Prospekt oder dem zwingend anwendbaren Recht vorgeschrieben sind die Aktionäre nicht berechtigt

die Einziehung ihrer Kommanditaktien zu verlangen. Der Komplementär kann nach seinem Ermessen beschließen, Kom-
manditaktien einzuziehen, um Ausschüttungen vorzunehmen. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts entscheidet
der Komplementär nach seinem alleinigen Ermessen über die Details einer solchen Einziehung. Jede Einziehung ist ge-
genüber allen Aktionären zu erklären.

(2) Beschränkung der Inhaberschaft
Der Komplementär handelnd für die Gesellschaft kann beschränken oder verhindern, dass eine Person (die „Unzu-

lässige Person“) Eigentümer von Kommanditaktien ist oder wird, wenn eine solche Person nicht der Komplementär,
Fonds SCS oder ein Kommanditist von Fonds SCS ist und/oder wenn nach der Beurteilung des Komplementärs dieses
zum Nachteil für die Gesellschaft ist, zu einem Verstoß gegen Luxemburger oder ausländische Gesetze oder Vorschriften
führt, oder wenn die Gesellschaft in dessen Ergebnis steuerlichen Nachteilen ausgesetzt wäre, die anderenfalls nicht
aufgetreten wären. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

a) es ablehnen, Kommanditaktien auszugeben und es ablehnen, eine Übertragung einer Kommanditaktie einzutragen,

wenn es den Anschein hat, dass eine solche Ausgabe oder Übertragung möglicherweise dazu führt, dass eine Unzulässige
Person der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer dieser Kommanditaktie wird; und

b) zu jeder Zeit von jeder Person, die im Register eingetragen ist oder die eine Übertragung von Kommanditaktien im

Register eintragen lassen will, zu verlangen, ihr jede Information, unterstützt von eidesstattlicher Erklärung, zukommen
zu lassen, die sie für notwendig hält, um zu bestimmen, ob ein solcher Eintrag dazu führt, dass eine Unzulässige Person
der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer von Kommanditaktien wird oder ist; und

c) die Stimmabgabe jeder Unzulässigen Person auf jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ablehnen; und
d) wenn es für die Gesellschaft den Anschein hat, dass eine Unzulässige Person allein oder zusammen mit anderen

Personen der wirtschaftliche Eigentümer von Kommanditaktien ist, diesen Aktionär anweisen, seine Kommanditaktien
zu verkaufen und der Gesellschaft den Verkauf innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Hinweis nachzuweisen.
Wenn ein solcher Aktionär dieser Anweisung nicht nachkommt, kann die Gesellschaft alle Kommanditaktien, die von
diesem Aktionär gehalten werden, wie folgt einziehen:

(i) Die Gesellschaft übersendet dem Aktionär, der diese Kommanditaktien hält, oder der im Register als der Eigentümer

dieser Kommanditaktien erscheint, eine zweite Mitteilung (die „Ankaufserklärung“), in der die zu erwerbenden Kom-
manditaktien verzeichnet sind, die Art und Weise der Berechnung des Ankaufspreises und der Name des Käufers. Diese
Erklärung kann an den Aktionär durch Einschreiben an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse oder die Adresse,
welche im Register erscheint, gesandt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss des in der Ankaufserklärung genannten
Termins hört der Aktionär auf, Eigentümer der Kommanditaktien zu sein; sein Name ist aus dem Register zu löschen.

(ii) Der Preis, zu dem solche Kommanditaktien erworben werden (der „Ankaufpreis“) entspricht dem Nettoinven-

tarwert  der  jeweiligen  Klasse  zur  Einziehung  dieser  Kommanditaktien  am  letzten  Bewertungstag  vor  dem  Tag  der
Ankaufserklärung.

(iii) Die Zahlung des Ankaufspreises an den vorherigen Eigentümer dieser Kommanditaktien erfolgt in Euro und wird

durch die Gesellschaft zur Zahlung an diesen Eigentümer hinterlegt bei einer Bank in Luxemburg oder anderswo (wie in
der Ankaufserklärung angegeben) im Zeitpunkt der endgültigen Bestimmung des Ankaufspreises. Mit der Übermittlung
der Ankaufserklärung verliert der vorherige Eigentümer alle Rechte bezüglich der Kommanditaktien und er hat auch keine
weiteren Ansprüche gegen die Gesellschaft oder ihr Vermögen in Bezug auf die Kommanditaktien, mit Ausnahme des
Rechtes, den Ankaufspreis (ohne Zins) von einer solchen Bank zu erhalten. Alle Einziehungsvergütungen für einen Aktionär
nach diesem Abschnitt, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach dem in der Ankaufserklärung angegebenen Datum
eingefordert wurden, können danach nicht mehr eingefordert werden und sind der jeweiligen Klasse oder den jeweiligen

88447

L

U X E M B O U R G

Klassen von Kommanditaktien zuzuführen. Der Komplementär ist berechtigt, von Zeit zu Zeit alle notwendigen Schritte
vorzunehmen, um eine solche Rückführung vorzunehmen oder eine solche Handlung für die Gesellschaft vornehmen zu
lassen.

(iv)  Die  Ausübung  der Rechte nach  diesem  § 15  durch  die Gesellschaft kann nicht  in Frage gestellt  werden  oder

unwirksam gemacht werden dadurch, dass unzureichende Nachweise für die Eigentümerstellung an Kommanditaktien
durch irgendeine Person bestand oder dass die wahre Eigentümerstellung an den Kommanditaktien anders war, als es
der Gesellschaft erschien zum Zeitpunkt der Ankaufserklärung, soweit in diesem Fall die Rechte gutgläubig ausgeübt
wurden.

§16. Ausschluss des Komplementärs.
a) Ausschluss bei Management-Verstoß
Bei einem Management-Verstoß durch den Komplementär können die Aktionäre (mit der Zustimmung von Nicht HS

Life Sciences Aktionären (mit Ausnahme von HS Life Sciences)) mit einer Mehrheit von mehr als 50 % ihrer Stimmen in
einer Gesellschafterversammlung beschließen, den Komplementär aus der Gesellschaft auszuschließen und einen Nach-
folger bestimmen.

Der Beschluss der übrigen Gesellschafter über den Ausschluss ist dem auszuschließenden Komplementär schriftlich

unverzüglich nach Fassung des Beschlusses durch einen in dem Gesellschafterbeschluss zu benennenden Bevollmächtigten
anzuzeigen. Der Ausschluss wird wirksam zu dem in dem Beschluss angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch mit Zu-
stellung des Beschlusses.

Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs endet zu dem in dem Beschluss angegebenen Zeitpunkt. Der An-

spruch des Komplementärs auf den Ergebnis-Vorab endet mit Wirksamkeit des Erlöschens der Geschäftsführungsbefugnis.

b) Ausschluss ohne Management-Verstoß
Ohne Vorliegen eines Management-Verstoßes kann der Komplementär durch Beschluss der Gesellschafter (mit der

Zustimmung der Non HS Life Sciences Aktionäre (mit Ausnahme von HS Life Sciences)) mit einer Mehrheit von min-
destens 75 % ihrer Stimmen ausgeschlossen werden und können die Zeichnenden Kommanditisten mit der nämlichen
Mehrheit einen Nachfolger bestellen. Über den Ausschluss kann nur Beschluss gefasst werden, wenn der Komplementär
sowohl aus der Gesellschaft als auch aus Fonds SCS ausgeschlossen wird. Die Bestimmungen in Absatz (1) gelten ent-
sprechend.

Die  Geschäftsführungsbefugnis  des  Komplementärs  endet  mit  der  Zustellung  des  Ausschließungsbeschlusses.  Der

Komplementär bleibt zu den im Prospekt angegebenen Entschädigungen berechtigt.

§17. Verfügung über Gesellschaftsanteile.
(1) Kommanditaktien können nur mit Zustimmung des Komplementärs übertragen werden. Vorbehaltlich der Be-

stimmungen des Prospektes ist diese Zustimmung nur zu geben, wenn der Aktionär einen wichtigen Grund hat.

(2) Vorbehaltlich Übertragungen durch der Ein Bestimmungen tragung der Üb des ertragung Prospektes in das werden

Register vorgenommen.

Art. 7. Gesellschafterversammlungen.

§18. Gesellschafterversammlungen.
(1) Verfahren
Die Ladungsfristen, das Verfahren sowie das Diskussionsverfahren folgen den gesetzlichen Regelungen, soweit es nicht

abweichend hierin geregelt ist.

Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft werden im Großherzogtum Luxemburg an einem solchem Ort und zu

der Zeit abgehalten, wie sie sich aus der Einladung zu dieser Versammlung ergibt.

Wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und sie

sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert ansehen, kann die Versammlung ohne vorherige
Ankündigung stattfinden.

Ein Gesellschafter kann auf jeder Gesellschafterversammlung der Gesellschaft handeln, indem er eine andere Person

(welche kein Gesellschafter sein muss) als seinen Vertreter bestellt; die Bestellung muss schriftlich erfolgen, dies kann im
Original passieren oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail.

Jede Gesellschafter kann an den Gesellschafterversammlungen per Telefon oder Videokonferenz oder jeder andere

Kommunikationsmöglichkeit, die allen teilnehmenden Personen erlaubt einander zu identifizieren, zu hören und mitei-
nander  zu  sprechen,  teilnehmen.  Die  Teilnahme  an  einer  Gesellschafterversammlung mit Hilfe dieser Mittel wird als
gleichwertig zu einer persönlichen Teilnahme angesehen.

Jeder Gesellschafter kann auch mittels Abstimmungsformularen, welche von der Gesellschaft ausgegeben wurden,

abstimmen. Diese Abstimmungsformulare enthalten das Datum und den Ort der Gesellschafterversammlung. Die Ta-
gesordnung der Gesellschafterversammlung, den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse sowie für jeden vorgeschlagenen
Beschluss drei Kästen, welche es dem Aktionär erlauben, für oder gegen eine vorgeschlagenen Beschlussfassung zu stim-
men oder sich der Stimme zu enthalten. Die Abstimmungsformulare sind durch den Aktionär per Post, Telegramm, Telex,
Fax oder E-Mail an den Sitz der Gesellschaft zu senden. Die Gesellschaft akzeptiert nur solche Abstimmungsformulare,

88448

L

U X E M B O U R G

welche  sie  vor  dem  in  der  Einladung  zu  der  Gesellschafterversammlung  angegebenen  Termin  der  Gesellschafterver-
sammlung erhält. Abstimmungsformulare, welche weder eine Abgabe der Stimme (für oder gegen den vorgeschlagenen
Beschluss) noch eine Stimmenthaltung zeigen, sind nichtig.

Vorbehaltlich  dem  Handelsgesellschaftengesetz  und  den  weiteren  Regeln  dieser  Satzung  werden  Beschlüsse  einer

ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit der einfachen Mehrheit der Anwesenden
oder Vertretenen und Abstimmenden gefasst, unabhängig von dem Anteil des Grundkapitals, welches bei einer solchen
Versammlung vertreten ist.

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um irgendeine Bestimmung dieser Sat-

zung abzuändern, ist nicht beschlussfähig, soweit nicht mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist und die
Tagesordnung die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung enthält. Wenn dieses Quorum nicht erreicht ist, wird eine
zweite Versammlung einberufen in der Art und Weise, wie sie in der Satzung beschrieben ist, durch zweifache Veröf-
fentlichung  in  einem  Intervall  von  mindestens  15  Tagen  und  mindestens  15  Tagen  vor  der  Versammlung  in  dem
Luxemburger Anzeiger, dem Mémorial, und in zwei Luxemburger Zeitungen. Diese Einladung muss die Tagesordnung
und das Datum und Ergebnis der vorherigen Versammlung enthalten. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig unab-
hängig vom Anteil des vertretenen Grundkapitals. In beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, um angenommen zu
werden, die Unterstützung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erhalten.

Eine Gesellschafterversammlung ist jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einladung benannten Ort

abzuhalten am ersten Geschäftstag im Juni eines jeden Jahres.

Gesellschafterversammlungen werden durch den Komplementär mit der Ladungsfrist von mindestens 15 Geschäfts-

tagen schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung einberufen (i) wenn der Komplementär eine
Gesellschafterversammlung für notwendig oder sinnvoll erachtet, (ii) auf Verlangen von Nicht HS Life Sciences Aktionären,
die mindestens 10 % des Zeichnungskapitals auf sich vereinigen. Die Ladungsfrist von 15 Geschäftstagen beginnt zu laufen
mit Beginn des dritten Tags nach Absendung der Einladung. Soll die Tagesordnung ergänzt werden, muss die Ergänzung
den Gesellschaftern spätestens drei Tage vor Abhaltung der Gesellschafterversammlung zugehen; jeder Gesellschafter
hat das Recht, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen.

(2) Beschlussgegenstände
Die Gesellschafterversammlung beschließt über die folgenden Gegenstände:
a) Feststellung des von dem Komplementär erstellten Jahresabschlusses der Gesellschaft;
b) Entlastung des Komplementärs für seine Tätigkeiten im abgelaufenen Geschäftsjahr;
c) Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses;
d) Änderungen und Ergänzungen des Prospektes, dieser Satzung sowie die Auflösung der Gesellschaft;
e) Aufgabe des SICAR-Status; und
f) sonstige Beschlussgegenstände, soweit dies in dem Prospekt oder gemäß zwingendem deutschem Gesetzesrecht

vorgesehen ist;

jedes Mal gemäß den Anwesenheits-und Mehrheitsanforderungen für den jeweiligen Beschlussgegenstand.
Das Stimmrecht von Fonds SCS ist ausgeschlossen in Bezug auf Abstimmungen gemäß Absatz (2) Buchstabe b) sowie

§ 16 (und jede weitere Beschlussfassung gemäß Prospekt), um einen möglichen Interessenkonflikt zu vermeiden. Vorbe-
haltlich  zwingenden  Gesetzesrechtes  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  ist  der  Komplementär  vom  Stimmrecht
ausgeschlossen auf Gesellschafterversammlungen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß diesem Vertrag und zwingendem Gesetzesrecht gilt für die Mehrheitserfor-

dernisse Folgendes: Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die einfache
Mehrheit der Stimmen bedeutet mehr als 50% der abgegeben Stimmen.

Beschlüsse gemäß Absatz (2) Buchstabe d) bedürfen einer Mehrheit von mindestens 75 % des Grundkapitals sowie der

Zustimmung des Komplementärs. Beschlüsse gemäß Absatz (2) Buchstabe e) bedürfen der Zustimmung aller Gesell-
schafter und der vorherigen Genehmigung durch die CSSF.

Jede Änderung dieses Absatzes (2) bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter.
Die Nationalität der Gesellschaft kann nur geändert werden und die Kapitalzusagen der Gesellschafter können nur

erhöht werden mit der Zustimmung aller Gesellschafter und Anleihegläubiger.

Der SICAR-Status kann von der Gesellschaft nur mit der vorherigen Genehmigung der CSSF und der Zustimmung

aller Gesellschafter aufgegeben werden.

(3) Vorsitz, Niederschrift
Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung übernimmt einer der Geschäftsführer des Komplementärs, der über

den Gang der Gesellschafterversammlung eine schriftliche Niederschrift anzufertigen hat. Eine Kopie der Niederschrift
versendet der Komplementär an jeden Gesellschafter unverzüglich nach Abhaltung der Gesellschafterversammlung.

(4) Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen
Gesellschafter können Gesellschafterbeschlüsse durch Einleitung eines Schiedsverfahrens gemäß dem Prospekt inner-

halb von vier Wochen ab Kenntnis von der Fassung des Gesellschafterbeschlusses angefochten werden.

88449

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Laufzeit, Beendigung, Auflösung.

§19. Laufzeit.
Die Gesellschaft beginnt zu dem in § 1 Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt und endet mit Eintritt eines der nachfolgenden

Ereignisse:

a) am zehnten Jahrestag des Letzten Zeichnungsschlusses, wobei der Komplementär das Recht hat, mit Zustimmung

der Gesellschaft auf einer Gesellschafterversammlung die Laufzeit der Gesellschaft zwei Mal um jeweils ein Jahr zu ver-
längern; ein solcher Verlängerungsvorschlag ist den Gesellschaftern drei Monate zuvor bekanntzugeben; oder

b) bei Eintritt eines der Ereignisse gemäß § 20, vorbehaltlich der dort vorgesehenen Verlängerungsmöglichkeit.

§20. Vorzeitige Beendigung.
(1) Die Gesellschaft kann willentlich aufgelöst werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welche be-

schlussfähig ist gemäß den Vorschriften für die Abänderung dieser Satzung und der Zustimmung des Komplementärs.

(2) Ungeachtet der Bestimmungen in § 19 endet die Gesellschaft bei Eintritt eines der nachfolgenden Ereignisse: (a)

Auflösung  des  Komplementärs;  (b)  Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  über  das  Vermögen  des  Komplementärs  oder
Ablehnung der Eröffnung eines derartigen Verfahrens mangels Masse; oder (c) Ausschluss des Komplementärs. Trotz
Eintritts eines der vorstehenden Ereignisse endet die Gesellschaft vorzeitig nicht, wenn innerhalb von 90 Tagen nach
Eintritt eines der vorstehenden Ereignisse Gesellschafter, die mindestens 75% des Zeichnungskapitals der Gesellschaft
auf sich vereinigen, die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen und für den Ausscheidenden einen Nachfolger bestellen
vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der CSSF.

§21. Auflösung.
(1) Liquidator
Bei Auflösung der Gesellschaft wird der Komplementär durch Beschluss der Gesellschafter mit einer Mehrheit von

mehr als 50 % der gesamten Aktien der Gesellschaft zum Liquidator bestellt und liquidiert das Gesellschaftsvermögen.
Endet die Gesellschaft bei Eintritt eines der in § 27 bezeichneten Ereignisse in Bezug auf den Komplementär, wird die
Gesellschaft liquidiert durch einen Liquidator, der durch Beschluss der Gesellschafter bestellt wird, der mehr als 50% des
Zeichnungskapitals der Gesellschaft auf sich vereinigt.

Diese(r) Liquidator(en) müssen von der CSSF genehmigt werden und ihre Redlichkeit und ihre professionellen Fähig-

keiten müssen garantiert sein.

(2) Verteilung des Liquidationserlöses
Die Gewinne und Verluste bei Liquidation des Gesellschaftsvermögens werden auf die Gesellschafter verteilt in ent-

sprechender Anwendung der Bestimmungen in § 10 dieser Satzung.

Art. 9. Bewertung, Buchführung und Berichtswesen.

§22. Bewertung des Gesellschaftsvermögens.
(1) Bewertung zum Fair Value
Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden auf der Basis des fair value bewertet. Dieser Wert (der „Nettoinven-

tarwert“) entspricht dem Wert der Vermögenswerte abzüglich des Wertes der Verbindlichkeiten und wird wie folgt
ermittelt:

(i) der Wert der Barmittel oder Bareinlagen, Wechsel und Schuldscheine und Forderungen, der transitorischen Aktiva,

noch nicht vereinnahmten, wie vorstehend erklärten oder aufgelaufenen Bardividenden und Zinsen, ist mit dem vollem
Betrag anzusetzen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass der volle Betrag gezahlt bzw. vereinnahmt wird, in welchem
Fall der Wert davon nach Vornahme eines vom Komplementär zwecks Wiedergabe des wahren Werts als angemessen
erachteten Abschlags festgestellt wird;

(ii) Anteile, Aktien, Lagerbestände oder Kapitalzinsen werden gemäß der Bewertungsprinzipien in Übereinstimmung

mit den internationalen Bewertungsgrundlagen für Private Equity und Venture Capital entsprechend den von der European
Venture Capital Association vorgeschlagenen Richtlinien bewertet.

(iii) Wertpiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis ihres notierten mittleren Han-

delskurses am letzten Handelstag vor dem Bewertungstag bewertet, vorbehaltlich eventueller Abzüge die in Überein-
stimmung mit den EVCA Bewertungsrichtlinien angesichts der Art der Wertpapiere und des Marktes auf dem diese
gehandelt werden vorzunehmen sind.

(iv) Wertpapiere die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden, und Wertpapiere die an einem geregelten

Markt gehandelt werden, deren Preis nach dem vorherigen Absatz (iii). bestimmt wurde aber nicht dem fair market value
entspricht, werden durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, welcher durch den Komplementär entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften bestimmt wird, bewertet.

(v) Der Wert von Vermögenswerten in einer anderen Währung als Euro wird, unter Bezugnahme auf den Wechselkurs

zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwerts bewertet.

(vi) Liquide Vermögenswerte bestehend aus Bargeld, Schatzbriefen und regulierten Geldmarkt Instrumenten werden

entsprechend ihres Marktwertes mit angefallenen Zinsen bewertet.

88450

L

U X E M B O U R G

(vii) alle sonstigen Vermögenswerte gleich welcher Art oder Gattung werden zum üblichen Marktwert bewertet, dieser

wird in gutem Glauben durch oder unter der Verantwortung des Komplementärs unter Übereinstimmung mit den all-
gemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und Marktstandards wie durch die EVCA vorgegeben ermittelt. Zwecks
Ermittlung des üblichen Marktwertes der unter diese Bestimmung fallenden Vermögenswerte, kann der Komplementär
sämtlichen Faktoren Rechnung tragen, die er im Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten für relevant erachtet,
wobei diese Faktoren (falls anwendbar) unter anderem folgendes umfassen: (i) die Merkmale und grundlegenden analyti-
schen Daten dieser Vermögenswerte, einschließlich Kosten, Umfang, derzeitiger Zinssatz, Zeitraum bis zur nächsten
Zinssatzneufestsetzung, Fälligkeit und Lombardzinssatz der Vermögenswerte, Bedingungen und Modalitäten der Schul-
denstruktur  der  Vermögenswerte;  (ii)  die  Art  und  Angemessenheit  der  Rechte,  Rechtsbehelfe  und  Interessen  der
Gesellschaft; (iii) die Kreditwürdigkeit der Geschäfte in Verbindung mit den Vermögenswerten, Cashflow, Kapitalstruktur
und Zukunftsaussichten; (iv) Informationen zu jüngsten erheblichen Markttransaktionen; (v) den guten Ruf, die Finanzlage
und jüngste Berichte in Bezug auf die Vermögenswerte; (vi) allgemeine wirtschaftliche Marktbedingungen, welche den
üblichen Marktwert der Vermögenswerte beeinflussen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts, ist der Komplementär berechtigt andere Bewertungsgrundsätze auf

die Vermögenswerte der Gesellschaft anzuwenden, wenn die Marktumstände dies verlangen; dies hat jedoch auf einer
einheitlichen Grundlage zu geschehen. Wenn Vermögenswerte bewertet werden, die in ihrer Übertragbarkeit oder ihrem
Verkauf beschränkt sind, so werden diese Vermögenswerte mit einem angemessenen Abschlag bewertet. Alle Bewer-
tungsmethoden und Bestimmungen sind in Übereinstimmung mit den in Luxemburg grundsätzlich anerkannten Bewer-
tungsmethoden anzuwenden.

Außer im Falle von Bösgläubigkeit, Betrug oder einem offensichtlichen Fehler, ist jede Entscheidung des Komplementärs

in Bezug auf die Bewertung des Nettoinventarwerts oder durch die Depotbank, die Gesellschaft oder andere Organisa-
tion,  die  eventuell  durch  den  Komplementär  zur  Bewertung  des  Nettoinventarwerts  bestimmt  wurde,  für  die  die
Gesellschaft und ihre bestehenden oder zukünftigen Gesellschafter abschließend und bindend.

(2) Vermögenswerte
Die Vermögenswerte der Gesellschaft (die „Vermögenswerte“) beinhalten (nicht abschließend):
(i) sämtliche verfügbaren Barbestände oder Kontoguthaben, inklusive der darauf aufgelaufenen Zinsen;
(ii) sämtlichen Rechnungen und Zahlungsaufforderungen und Forderungen (einschließlich der Erlöse aus verkauften

aber noch nicht ausbezahlten Wertpapieren);

(iii) sämtliche Anteile, Lagerbestände, Obligationen, Pfandbriefe, Zeichnungsrechte, Optionsscheine und andere Wert-

papiere,  Finanzinstrumente  und  ähnliche  Vermögenswerte  die  im  Eigentum  oder  in  einem  Vertragsverhältnis  zur
Gesellschaft stehen (unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft Anpassungen in Bezug auf die Änderung des Markt-
wertes  der  Wertpapiere  hervorgerufen  durch  den  Handel  mit  ehemaligen  Dividenden  oder  Rechten  oder  ähnliche
Praktiken vornehmen kann);

(iv) sämtliche Aktiendividenden, Bardividenden und Barausschüttungen die die Gesellschaft erhalten hat, in dem Maß,

in dem die Gesellschaft hierüber Kenntnis hat;

(v) sämtliche fälligen Zinsen oder zinsbringenden Vermögenswerte im Vermögen der Gesellschaft, ausgenommen in

dem Umfang, wie diese bereits im Grundkapital dieser Vermögenswerte enthalten sind oder darin wiedergegeben werden;

(vi) den Liquidationserlös aus sämtlichen Verträgen und Optionen, in welcher die Gesellschaft offene Positionen hat;
(vii) die primären Ausgaben der Gesellschaft soweit dies nicht abgeschrieben sind; und
(viii) sämtliche anderen Vermögenswerte jeder Art und Weise einschließlich vorausbezahlter Ausgaben.
(3) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (die „Verbindlichkeiten“) beinhalten (nicht abschließend):
(i) sämtliche Darlehen, Rechnungen und Abrechnungsverbindlichkeiten;
(ii) sämtliche angefallenen Zinsen auf Darlehen der Gesellschaft (einschließlich angefallener Gebühren oder Verpflich-

tungen für solche Darlehen);

(iii) sämtliche angefallene Kosten (einschließlich Verwaltungskosten, Depotbankgebühren und jeglichen anderen Agen-

tengebühren);

(iv) sämtliche bekannten Verbindlichkeiten, sowohl gegenwärtige als auch zukünftige, einschließlich vertraglich gereifter

Verpflichtungen für Geld-und Besitzzahlungen, einschließlich des Betrages eventueller nicht ausgezahlter durch die Ge-
sellschaft erklärter Dividenden;

(v) eine angemessene Vorhaltung für zukünftige Steuern, basierend auf Kapital und Einkommen der Gesellschaft am

Bewertungstag und andere Reserven (soweit vorhanden) gestattet und bestätigt durch den Komplementär, sowie einen
Betrag (soweit vorhanden) welchen der Komplementär als angemessene Rücklage in Bezug auf mögliche weitere Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen erachtet;

(vi) sämtliche weiteren Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art und Weise bemessen nach den grundsätzlich

anerkannten Bewertungsmassstäben. Bei der Feststellung des Betrages dieser Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft die
zu zahlenden Ausgaben entsprechend § 11 dieser Satzung in Betracht zu ziehen. Die Gesellschaft kann verwaltungstech-

88451

L

U X E M B O U R G

nische und andere Ausgaben laufender oder periodisch wiederkehrender Art in Höhe eines geschätzten Wertes für
jährliche oder andere Zeiträume im Voraus berechen.

(4) Nettoinventarwert pro Aktie
Der Nettoinventarwert pro Aktie wird ermittelt, indem der Nettoinventarwert der Gesellschaft durch die Anzahl der

Kommanditaktien der jeweils relevanten Klasse (soweit vorhanden) die am Tag der Bewertung ausgegeben sind, geteilt
wird.

(5) Berechnung des Nettoinventarwerts
Der Nettoinventarwert pro Aktie und der Preis für die Ausgabe, Rücknahme und Umwandlung von Aktien wird von

Zeit zu Zeit vom Komplementär oder von einem durch den Komplementär beauftragten Agenten mindestens einmal im
Jahr am letzten Geschäftstag eines Jahres, fortan als „Bewertungstag“ bezeichnet, berechnet. Die Auskunft über die je-
weilige Bewertung wird spätestens am Ende des zweiten Monats nach Ende des jeweils relevanten Jahres erfolgen. Der
Nettoinventarwert wird am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

(6) Ausetzung von der Berechnung des Nettoinventarwerts
Der Komplementär kann die Berechnung die Nettoinventarwerts aussetzen wenn:
(i) zu jedem Zeitpunkt, an dem nach Ansicht des Komplementärs eine angemessene Bewertung der Vermögenswerte

der Gesellschaft aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Komplementärs liegen, nicht möglich ist; oder

(ii) zu jedem Zeitpunkt, an dem eine Börse, bei welcher ein wesentlicher Teil der Investitionen der Gesellschaft notiert

ist, geschlossen ist (außer an regulären Feiertagen) oder während Abwicklungen darauf beschränkt oder ausgesetzt wer-
den; oder

(iii) wenn Umstände vorliegen, welche einen Notfall begründen, aufgrund dessen eine Bewertung der Vermögenswerte

der Gesellschaft nicht möglich ist; oder

(iv) während der Dauer eines Ausfalles oder einer Nutzungsbeschränkung der Kommunikationsmittel, die zur Be-

stimmung des Preises oder Wertes der Investitionen oder der Währungspreise oder -Werte an maßgeblichen Börsen
üblicherweise verwendet werden.

§23. Buchführung. Die Verwaltungsstelle führt die Bücher der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter

oder ein gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Beauftragter, einschließlich externer Berater, hat das Recht
zur  jederzeitigen  Einsichtnahme  in  die  Geschäftsbücher  zu  den  regulären  Geschäftszeiten.  Die  Geschäftsbücher  sind
während der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume aufzubewahren, mindestens jedoch während der Dauer der Ge-
sellschaft und fünf Jahre danach. Die zwingenden gesetzlichen Einsichtsrechte der Gesellschafter bleiben unberührt. Die
Bücher der Gesellschaft werden in Euro geführt. Der Jahresabschluss wird innerhalb der gesetzlichen Fristen nach den
allgemein anerkannten Luxemburger Rechtsvorschriften und dem Handelsgesellschaftengesetz aufgestellt und geprüft.

§24. Berichtswesen.
(1) Jahresbericht
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts legt der Komplementär des Gesellschafters einen Jahresbericht der

Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des SICAR-Gesetzes und des Handelsgesellschaftengesetzes vor.

(2) Sonstige Informationen
Die Gesellschaft stellt den Gesellschaftern die weiteren Informationen gemäß Prospekt zur Verfügung.

Art. 10. Schlussbestimmungen.

§25. Depotbank, Unabhängiger Wirtschaftsprüfer.
(1) Depotbank
Die Gesellschaft hat einen Depotbankvertrag mit einer Depotbank abgeschlossen, welche den gesetzlichen Bestim-

mungen  des  SICAR-Gesetzes  genügen  muss  (die  „Depotbank“).  Sämtliche  Wertpapiere und  Gelder  der Gesellschaft
werden von der Depotbank oder in deren Verantwortung durch die in gutem Glauben ordnungsgemäß ernannten Agenten
gehalten, welche gegenüber der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern die ihnen durch das SICAR-Gesetz vorgesehenen
Aufgaben übernehmen sollen.

Falls die Depotbank ihren Dienst beenden möchte, bemüht sich der Komplementär nach Kräften, innerhalb von 2

(zwei) Monaten nach Inkrafttreten dieses Rücktritts einen Nachfolger zu finden und ernennt diesen anschließend anstelle
der ausscheidenden Depotbank. Der Komplementär kann die Bestellung der Depotbank beenden, darf sie jedoch nicht
abberufen, bis ein Nachfolger gemäß dieser Bestimmung ernannt wurde, um an ihre Stelle zu treten.

Die Pflichten der Depotbank erlöschen:
(i) im Falle eines freiwilligen Rückzugs der Depotbank oder ihrer Abberufung durch die Gesellschaft; bis sie ersetzt ist,

muss die Depotbank alle notwendigen Maßnahmen im Interesse der Gesellschafter weiterführen; oder

(ii) im Falle, dass die Depotbank oder die Kommanditgesellschaft (a) Konkurs angemeldet haben, (b) eine Zahlungs-

einstellung erwirkt haben, (c) einen Vergleich mit Gläubigern eingegangen sind, (d) unter Zwangsverwaltung oder ein
ähnliches Verfahren gestellt wurden, oder (e) liquidiert wurden; oder

(iii) wenn die CSSF der Depotbank oder der Gesellschaft die Zulassung entzieht.

88452

L

U X E M B O U R G

(2) Unabhängiger Wirschaftsprüfer
Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation einschließlich der Bücher der Gesellschaft werden von

einem genehmigten Buchprüfer („réviseur D‘entreprises“) überwacht welcher die Luxemburger gesetzlichen Anforde-
rungen hinsichtlich Redlichkeit und professioneller Erfahrung und die im SICAR-Gesetz vorgeschriebenenen Pflichten
erfüllen soll. Der Prüfer wird durch den Komplementär ausgewählt und hat seine Verpflichtungen zu erfüllen, bis ein
Nachfolger gewählt wurde.

§26. Freistellung. Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Gesellschafter, Geschäftsführer, Angestellten, Be-

rater und Bevollmächtigten der Gesellschafter frei gemäß den Bestimmungen des Prospekts.

§27. Änderungen der Satzung, Anwendbares Recht.
(1) Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit abgeändert werden durch eine Gesellschafterversammlung unter Einhaltung

der Anforderungen hinsichtlich Quorum und Mehrheiten gemäß § 18, jedoch vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung
der CSSF.

(2) Auf diesen Vertrag findet Luxemburger Recht Anwendung.

§28. Übergangsbestimmungen.
(1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2010.
(2) Die erste jährliche Gesellschafterversammlung findet im Jahr 2011 statt.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichnenden haben eine Anzahl an Aktien gezeichnet und diese wie nachfolgend aufgeführt in bar eingezahlt:

Partner

Subscribed

Shares

Subscribed

Capital

QureInvest II (SCS) (SICAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31,000 EUR

Der Nachweis für die Einzahlung wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Grün-

dung entstehen, betragen ungefähr zweitausend Euro (EUE 2.000,-).

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 Handelsgesellschaftengesetz in seiner jeweils geltenden

Fassung vorgesehenen Bestimmungen aufgehoben wurden.

<i>Versammlung der Gesellschafter

Die oben genannten Personen, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und sich als ordnungsgemäß einbe-

rufen betrachten, halten unmittelbar im Anschluss eine außerordentliche Gesellschafterversammlung.

Nachdem zunächst beglaubigt wurde, dass die Gesellschaft ordnungsgemäß gegründet wurde, fassen diese einstimmig

den folgenden Beschluss.

<i>Beschluss

Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in der 231 Val des Bons-Malades, L-2121 Luxemburg bestimmt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Parteien die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Nachdem das Dokument den erschienenen Personen, deren Namen, Nachnamen, Zivilstand und Wohnort dem Notar

bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die vorgenanten Personen unterzeichnet.

Signé: Ch. Diesel et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juillet 2010. Relation: LAC/2010/32253. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2010.

Référence de publication: 2010101868/1352.
(100114280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2010.

88453

L

U X E M B O U R G

Repco 37 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.234.

Les comptes annuels au 31 Decembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093824/10.
(100104314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Sopra SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.434.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOPRA S.A.
Société Anonyme
Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
<i>Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2010093842/13.
(100104295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 110.475.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093804/10.
(100104407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

SOAK Trust S.A., Société Anonyme,

(anc. Regiconsult).

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 72.901.

L'an deux mille dix, le premier juillet.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 'REGICONSULT" (numéro

d'identité 1999 22 31 745), avec siège social à L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 72.901, constituée sous la dénomination de "JD FARRODS CONSULTING LUXEMBOURG" suivant acte reçu par le
notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro
88 du 26 janvier 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Frank BADEN, en date
du 19 février 2002, publié au Mémorial C, numéro 898 du 13 juin 2002, suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 27 juin 2003, publié au Mémorial C, numéro 808 du 1 

er

 août 2003, ledit

acte contenant changement de la dénomination sociale en "REGICONSULT", suivant acte reçu par le notaire André
SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire Joseph ELVINGER, de résidence à
Luxembourg, empêché, dépositaire de la minute, en date du 20 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro 142 du 20
janvier 2006 et suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph ELVINGER, en date du 14 février 2006, publié au Mémorial
C, numéro 1410 du 21 juillet 2006.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul DEFAY, comptable, demeurant à Soleuvre.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Claude LANG, employé privé, demeurant à Rumelange.

88454

L

U X E M B O U R G

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société de "REGICONSULT" en "SOAK Trust S.A.".
2) Transfert du siège social de L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean à L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre

Michels.

3) Modifications subséquentes des statuts.
4) Modification du deuxième alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obliga-

toirement celle d'un administrateur-délégué soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites
de ses pouvoirs."

5) Administrateurs - commissaire.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de "REGICONSULT" en "SOAK Trust S.A.".

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean à L-4243 Esch-sur-Alzette, 97,

rue Jean-Pierre Michels.

<i>Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article

er

 et l'article 11 des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 . Al. 1 et 2.  Il existe une société anonyme, sous la dénomination de SOAK Trust S.A.

Le  siège  social  est  établi  à  Esch-sur-Alzette.  Il  peut  être  créé  par  simple  décision  du  conseil  d'administration  des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.";

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Esch-sur-Alzette indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi de mai, à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Al. 2. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs

dont obligatoirement celle d'un administrateur-délégué soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans
les limites de ses pouvoirs."

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Madame Franchie BETTENDORFF et de Monsieur Pitt DEFAY comme

administrateurs et de Madame Claudine GATTI comme commissaire aux comptes de la société et de leur donner décharge
pour l'exercice de leurs mandats.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Claude LANG, employé privé, né à Esch/Alzette le 12 octobre 1953, demeurant à L-3733 Rumelange, 45,

Cité Kiirchbierg;

b) Madame Claudine GATTI, employée privée, née à Esch-sur-Alzette le 1 

er

 décembre 1967, demeurant à L-4382

Ehlerange, 73, rue de Sanem.

Par dérogation à l'article 6 des statuts, l'assemblée décide de nommer Monsieur Claude LANG, préqualifié, en qualité

de second administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.

Les mandats des administrateurs, respectivement administrateur-délégué ainsi nommés expireront immédiatement

après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

88455

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de renouveler les mandats de l'administrateur, respectivement administrateur-délégué Monsieur

Jean-Paul DEFAY, lesquels mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2016.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes la société anonyme "ACA - ATELIER

COMPTABLE &amp; ADMINISTRATIF S.A.", ayant son siège social à L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 99.368.

Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des

présentes, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: DEFAY, LANG, J.M.WEBER, A.WEBER.

Enregistré à Capellen, le 02 juillet 2010. Relation: CAP/2010/2268. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des

Sociétés.

Bascharage, le 12 juillet 2010.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2010097103/98.
(100108348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

Repco 22 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.185.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093807/10.
(100103891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 38 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 128.188.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010093825/10.
(100103851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

BANA Swiss Funding S.à r.l. Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.020.000,00.

Siège de direction effectif: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 135.185.

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société en date du 25 juin 2010

En date du 25 juin 2010, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- De renommer en tant que réviseur d’entreprise de la Société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. avec effet au 25 juin

2010 et jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

88456

L

U X E M B O U R G

- De nommer en tant que gérant de classe A de la Société, avec effet au 25 juin 2010 et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Lawrence Faccini, né le 28 novembre 1965 à New York aux États-Unis d’Amérique avec adresse profes-

sionnelle au 100, North Tryon Street, NC 28255 Charlotte, Etats-Unis d’Amérique.

* Monsieur Brian W. Morris, né le 4 septembre 1973 à New Bern, North Carolina, aux Etats-Unis d’Amérique, avec

adresse professionnelle au 100, North Tryon Street, NC 28255 Charlotte, Etats-Unis d’Amérique.

- De nommer en tant que gérant de classe B de la Société, avec effet au 25 juin 2010 et pour une durée indéterminée:
* Monsieur Faruk Frank Durusu, né le 20 juin 1978 à Yildizeli en Turquie avec adresse professionnelle au 102, rue des

Maraichers, L-2124 Luxembourg.

L’adresse de Monsieur Matthew Fitch a changé et est désormais au: 4, Albert Borschette, L1246 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

Depuis cette date le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

<i>Gérant de classe A:

Mr. Douglas Hassman
Mr. Paul Baalman
Mr. Lawrence Faccini
Mr. Brian W. Morris

<i>Gérant de classe B

Mlle. Christel Damaso
Mr. Faruk Frank Durusu
Mr. Matthew Scott Fitch

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2010.

Référence de publication: 2010095475/34.
(100106399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2010.

Repco 43 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 131.082.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093826/10.
(100103856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Repco 45 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 131.081.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093827/10.
(100103871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Solideal Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 24.961.

L'an deux mille dix,
Le six juillet,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOLIDEAL HOLDING S.A.",

avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée sous la dénomination sociale de "VANGUARD
INTERNATIONAL S.A.", suivant acte reçu par le notaire Lucien SCHUMAN, alors de résidence à Luxembourg, en date

88457

L

U X E M B O U R G

du 30 septembre 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 347 du 13 décembre 1986,
modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire SCHUMAN, en date du 24 mars 1988, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 164 du 16 juin 1988, modifiée suivant acte reçu par le notaire Marc ELTER, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 16 janvier 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
261 du 4 juillet 1991, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire ELTER, en date du 13 mars 1992, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 371 du 29 août 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph
ELVINGER, de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 1052 du 22 novembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 21 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 962 du 25 juin 2002,
modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire BADEN, en date du 11 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 1063 du 14 octobre 2003, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire ELVINGER,
en date du 29 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 588 du 8 juin 2004, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 24.961.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Olga MILYUTINA, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine GASHONGA, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Annulation du capital autorisé et modification subséquente de l'article 3 des statuts.
2. Détermination de la langue de rédaction qui prévaut en cas de divergence entre les versions anglaise et française.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite; l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer l'autorisation de capital autorisé contenue à l'article trois des statuts, et de

modifier subséquemment l'article trois, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à douze millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 12.500.000,00),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi."

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide que le français sera dorénavant la langue officielle des statuts de la société, et qu'en cas

de divergence entre les versions anglaise et française des statuts, la version française primera, et elle décide d'ajouter un
article quatorze aux statuts, ayant la teneur suivante:

Art. 14. En cas de divergences entre les textes français et anglais des statuts de la société, la version française fera

foi."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d'une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

88458

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and ten,
On the sixth day of July,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "SOLIDEAL HOLDING S.A.", a corporation under

Luxembourg Law, having its registered offices in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated under the name
of "VANGUARD INTERNATIONAL S.A.", by deed of notary Lucien SCHUMAN, then residing in Luxembourg, on 30
September 1986, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 347 of 13 December 1986,
modified by deed of the said notary SCHUMAN, on 24 March 1988, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C", number 164 of 16 June 1988, modified by deed of notary Marc ELTER, then residing in Luxembourg, on
16 January 1991, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 261 of 4 July 1991, modified
by deed of the said notary ELTER, on 13 March 1992, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C", number 371 of 29 August 1992, modified by deed of notary Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, on 30 March
2001, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 1052 of 22 November 2001, modified
by deed of notary Frank BADEN, residing in Luxembourg, on 21 March 2002, published in the "Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C", number 962 of 25 June 2002, modified by deed of the said notary BADEN, on 8 May 2003,
published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 598 of 2 June 2003, modified by deed of the
said notary BADEN, on 11 September 2003, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number
1063 of 14 October 2003, modified by deed of the said notary ELVINGER, on 29 March 2004, published in the "Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C", number 588 of 8 June 2004, registered at the Trade and Companies' Register in
Luxembourg-City under section B and number 24,961.

The meeting was opened with Mrs Olga MILYUTINA, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg,

412F,route d'Esch, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Sandrine GASHONGA, private employee, residing professionally in L-2086 Luxem-

bourg, 412F, route d'Esch.

The meeting elected as scrutineer Mr Ahcène BOUHLAIS, private employee, residing professionally in L-2086 Lux-

embourg, 412F, route d'Esch.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Cancellation of the authorized share capital and subsequent modification of article three of the Articles of Incor-

poration.

2. Determination of the writing language that will prevail in case of discrepancy between the English and the French

versions.

3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed "ne

varietur" by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting decides to suppress the authorized share capital held in article three of the Articles of Incorpo-

ration, and to amend subsequently article three, which will from now on have the following wording:

Art. 3. The corporate capital is fixed at twelve million five hundred thousand dollars of the United States of America

(USD 12,500,000.00), represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares without a nominal par value.

All the shares are and shall remain registered shares.
The company may repurchase its own shares under the provisions foreseen by law."

88459

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution:

The general meeting decides that the official language of the company's Articles of Incorporation will from now on be

the French, and that in case of divergences between the French and the English version, the French version will prevail,
and decides to ad an article 14 to the Articles of Incorporation, with the following wording:

Art. 14. In case of divergences between the French and the English texts of the Articles of Incorporation of the

company, the French text will be prevailing."

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will be prevailing.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and

residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Signé: O. Milyutina, S. Gashonga, A. Boulhais, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 juillet 2010. Relation: LAC / 2010 / 30092. Reçu soixante-quinze euros

75,00€

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 19 juillet 2010.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2010097140/142.
(100108334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2010.

Repco 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 110.727.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010093828/10.
(100104250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Rooftop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6170 Godbrange, 12A, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 116.797.

Les comptes annuels au 31-12-2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Claude REDING
<i>Le gérant

Référence de publication: 2010093829/11.
(100104351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Sales-Lentz Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 78.631.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010093832/9.
(100104042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88460

L

U X E M B O U R G

Sensient Holding Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SENSIENT HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2010093833/11.
(100103587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Tournan Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 140.865.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010093845/13.
(100103982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Sensient Technologies Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 63.680.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

John L. Hammond / Jeffrey T. Makal
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010093834/11.
(100103591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Snack Ankara II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 22, route de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 86.944.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010093841/10.
(100104259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Sival International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 88.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

88461

L

U X E M B O U R G

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010093840/12.
(100103932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Barclays Capital Equity Luxembourg SICAV SIF S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme

d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Capital social: GBP 10.000.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.496.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions adoptées par l'Associé unique de la Société le 14 juillet 2010

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société au siège social en date 1 

er

 juillet

2010 qu'il a été décidé de réélire, en qualité de réviseur d'entreprise de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l.,
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Le mandat du réviseur d'entreprise ainsi réélu expirera immédiatement après l'Assemblée Générale des Associés de

la Société devant se tenir en l'année 2011 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice ayant débuté
le 1 

er

 janvier 2010.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
Manfred Zisselsberger

Référence de publication: 2010094444/21.
(100104728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.023.

Le Bilan au 31/12/2009 ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>POUR STRATEGY FUND
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signature

Référence de publication: 2010093843/15.
(100103939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Taste of Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 107.919.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010093846/13.
(100103579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

88462

L

U X E M B O U R G

C4U2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 111.875.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 22 juin 2010.

Il résulte du procès-verbal dudit conseil d'administration qu'à l'unanimité des voix, le conseil a pris les résolutions

suivantes

1. Le conseil d'administration a accepté la démission de Monsieur Philippe JANSSENS, demeurant professionnellement

au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, du poste d'administrateur et d'administrateur délégué de la société;

2. Les administrateurs restants ont coopté Monsieur Filip DE WILDE demeurant professionnellement au 63-65 Rue

de Merl, L-2146 Luxembourg, en qualité d'administrateur au sein du Conseil d'Administration. Monsieur Filip DE WILDE
terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, qui viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
C4U2 S.A
Signatures
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010094492/21.
(100104834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Taste of Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 107.919.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010093847/13.
(100103580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Taste of Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 107.919.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010093848/13.
(100103581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Taste of Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.

R.C.S. Luxembourg B 107.919.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

88463

L

U X E M B O U R G

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47 route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2010093849/13.
(100103582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Wilko Lux Enseignes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 169, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.049.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 13.07.2010.

Fiduciaire S.à r.l.
CabexcO
Centre Helfent
1, rue Pletzer - L-8080 Bertrange
Signature

Référence de publication: 2010093868/15.
(100103605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Alce Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.635.

<i>Extrait des décisions prises par les associé es en date du 9 juillet 2010

1. M. Vincent TUCCI a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Nathalie VAZQUEZ, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 11 mai 1983, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une
durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 juillet 2010.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Alce Investment I S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010093877/16.
(100104455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Azur France II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2336 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 153.917.

EXTRAIT

En date du 29 juin 2010, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La nomination de Robert-Jan Foortse, né à s-Gravenhage, Pays-Bas, le 5 janvier 1967, ayant l'adresse au Gustav

Mahlerplein 3, 1082 MS, Amsterdam, The Netherlands en tant que gérant est acceptée avec effet au 29 juin 2010 et ce
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 13 Juillet 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010093890/15.
(100104508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

88464


Document Outline

Alce Investment I S.à r.l.

Azur France II S.à r.l.

BANA Swiss Funding S.à r.l. Limited

Barclays Capital Equity Luxembourg SICAV SIF S.à r.l.

C4U2 S.A.

Dandy Consult S.A.

D.C.I. - D.C. International S.A.

Hostellerie de la Bonne Auberge S.A.

QureInvest II Investments (SCA) SICAR

Regiconsult

Repco 15 S.A.

Repco 18 S.A.

Repco 19 S.A.

Repco 22 S.A.

Repco 23 S.A.

Repco 25 S.A.

Repco 26 S.A.

Repco 27 S.A.

Repco 27 S.A.

Repco 28 S.A.

Repco 2 S.A.

Repco 31 S.A.

Repco 32 S.A.

Repco 33 S.A.

Repco 34 S.A.

Repco 35 S.A.

Repco 36 S.A.

Repco 37 S.A.

Repco 38 S.A.

Repco 3 S.A.

Repco 43 S.A.

Repco 45 S.A.

Repco 9 S.A.

Reynolds Consumer Products (Luxembourg) S.à r.l.

Rock Ridge RE 10

Rock Ridge RE 13

Rock Ridge RE 14

Rock Ridge RE 17

Rock Ridge RE 17

Rock Ridge RE 3

Rock Ridge RE 6

Rooftop S.à r.l.

Ross Troine Autocars S.A.

Sailux S.A.

SAJ S.A.

Sales-Lentz Participations

Sensient Holding Luxembourg S. à r.l.

Sensient Technologies Luxembourg Sàrl

Sival International S.A.

S.L.A.

Snack Ankara II S.à r.l.

SOAK Trust S.A.

Solideal Holding S.A.

Sopra SA

Strategy Fund

Sword Technologies S.A.

Symantec Luxembourg S.à r.l.

Taste of Africa S.à r.l.

Taste of Africa S.à r.l.

Taste of Africa S.à r.l.

Taste of Africa S.à r.l.

Tournan Holding

Wilko Lux Enseignes S.à r.l.