This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1464
16 juillet 2010
SOMMAIRE
Advent Dahlia Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70240
Advent Dahlia (Luxembourg) S.à. r.l. . . . .
70240
Bantleon Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70268
Boxford Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
70226
BPER International Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
70267
BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated
company of JSC BTA Bank . . . . . . . . . . . . .
70237
Car Testing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70254
Colombo Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70236
Crediinvest SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70255
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70261
Credit Suisse Prime Capital (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70262
Dorn Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70272
EECF Beta Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70245
Ektornet Latvia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70236
Ektornet Lithuania S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70236
Ektornet Nordic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70236
ERE III - N°2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70272
Euro China Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
70266
Financière Cavour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70267
First Foods S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70266
Gaming VC Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
70241
Geldilux-TS-2008 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70266
Hayfin Opal Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
70247
Illor II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70245
Illor I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70245
Immobilière Orion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70268
Immo Steichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70267
Innova S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70245
Jaz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70267
KEIF Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
70268
KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l. . . . . . . . .
70268
Klepierre Meteores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70269
Kumkuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70262
Landmark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70269
LMC German Investments . . . . . . . . . . . . . .
70271
Magic Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70270
Ma.Lo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70246
Melio Luxembourg International S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70269
Motorinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70246
Navlink S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70271
Navlink S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70246
Nile Capital II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70226
Office Rental Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
70237
Op der Gänn SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70262
Placeholder 25 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70271
Placeholder 25 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70271
Principia Verwaltungs GmbH . . . . . . . . . . .
70255
Quoniam Funds Selection SICAV . . . . . . . .
70272
Raiffeisen-Wuere-Genossenschaft . . . . . . .
70246
Rapid-Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70272
Riviera Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70247
Russian Mortgage Backed Securities
2008-1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70247
Saposa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70240
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l. . . .
70270
Sifraso S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70247
V.K. S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70265
70225
L
U X E M B O U R G
Boxford Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R.C.S. Luxembourg B 147.876.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour BOXFORD INVESTMENT S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2010064300/13.
(100079911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Nile Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 153.567.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the eighteenth day of May,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, a Cayman Islands exempted partnership having its registered office
at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and registered under the number 36427, itself
represented by its general partner, LCG Holdings, LLC
represented by Etienne de Crépy, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 17, 2010.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration
authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that two hundred thousand (200,000) shares par value of USD 0,1 each of Luxor Capital Partners Offshore Fund,
Ltd., a company limited by shares incorporated under the laws of the Cayman Islands, with statutory seat in Cayman
Islands and having its business address at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (the Company) representing the entirety of the share capital of the Company, are
duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the
agenda, hereinafter reproduced.
II. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company.
III. By resolutions validly adopted on May 17, 2010 by the Sole Shareholder, acting in accordance with the articles of
association of the Company, it was resolved to deregister the Company in the Cayman Islands and to register it by way
of continuation (and thus with full corporate and legal continuance) in Luxembourg pursuant to Article 193 of the Cayman
Island Company's Amended and Restated Articles of Association of the Company and in accordance with Section 206 of
the Companies Law (2009 Revision). Furthermore by written resolutions validly adopted on May 17, 2010 by all the
directors of the Company, acting in accordance with the Cayman Island Company's Amended and Restated Articles of
Association of the Company, it was resolved that with effect from the Company becoming a private limited liability
company (“société à reponsabilité limitée”) under the laws of Luxembourg, the registered office of the Company be
changed from the Cayman Islands to Luxembourg and the business address / principal establishment / central adminis-
tration of the Company be changed from c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands to 65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg as from the date hereof without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal
continuance. All formalities required under the laws of the Cayman Islands to give effect to that resolution have been
duly performed or will be duly performed today. A copy of said resolutions shall remain annexed to the present deed.
IV. that it results from (i) an interim balance sheet of the Company dated May 17, 2010 that, as of May 17, 2010, the
net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate
of the management of the Company dated May 17, 2010, that since the date of the balance sheet and as May 17, 2010,
no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the
financial statements as per May 17, 2010 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the
70226
L
U X E M B O U R G
Company's situation as of the date hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne
varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to
the present deed and shall be filed with such deed with the registration authorities.
Thereupon, the Sole Shareholder requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the transfer of the registered office of the Company from the Cayman
Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and of the transfer of the principal establishment and central
administration of the Company from Grand Cayman, Cayman Islands to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with
immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.
The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of Cayman Islands to give effect to
such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) with the name ”Nile Capital II S.à r.l.'', accepts the Luxembourg nationality and shall as from the
date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the functional currency of the Company from United States Dollars (USD)
to euro (EUR).
The Sole Shareholder further resolves to convert the amount of the share capital of the Company into an amount
expressed in euro (EUR). For rounding purposes, the subscribed share capital shall be set at twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500), the exchange rate being the official rate of the European Central Bank as of as of 17 May 2010 (i.e.
USD 1,2349 = EUR 1) with any conversion excess being allocated to a reserve account of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Company's (interim) closing balance sheet in the Cayman Islands as of
May 17, 2010, being the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg as at the date hereof, a copy of which
shall remain attached to the present deed.
The Sole Shareholder notes that it results from the balance sheet of the Company that, as of May 17, 2010, the net
assets of the Company correspond at least to the nominal value of the share capital of the Company.
The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership
in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments.
<i>Fifth resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Company's
Memorandum and articles of association in the form presented to the Sole Shareholder so as to conform them to
Luxembourg laws at the occasion of the transfer of the Company and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.
The restated articles of association of the Company shall read as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Nile
Capital II S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
70227
L
U X E M B O U R G
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal
of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The Company may also contract loans and grant
all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or
which are members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by two
hundred and fifty (250) shares in registered form, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder, or as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of Shares to non-shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers, composed of at least one A manager and two B managers,
appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their
office. The manager(s) need not to be shareholder(s). The majority of the managers will at all times consist of persons
resident of Luxembourg.
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the single manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
70228
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of all its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
9.8. The meeting of the board of managers must be held in Luxembourg.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of at
least an A manager and at least a B manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum – Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager, or as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
70229
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The single shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders has discretionary power to
dispose of the surplus . It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve
or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting
of the shareholders;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the
Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VII. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2010.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Mr. Don Seymour,
Mr. Christian Leone, and Mr. Aldo Ghisletta as directors of the Company and (ii) to grant each of them full discharge for
the performance of their respective mandate from the date of their appointment until the date of their resignation.
Furthermore the Sole Shareholder resolves to appoint as members of the Management Board of the Company, effective
as of the date hereof and for an unlimited period of time the following persons:
(a) Norris Nissim, company director, born in Hong Kong SAR (China), on 24 December 1966, residing at 07631 New
York (United States of America), Broad Avenue 269, Englewood, as class A manager;
(b) Elena Cimador, company director, born in Ohio (United States of America) on June 1, 1972, residing at 10552
New York (United States of America), Brookfield Road, 82 Mount Vernon, as class A manager;
(c) Hugo Froment, company director, born in Laxou (France), on February 22, 1974, professionally residing at 65, bvd
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager;
(d) Sébastien André, company director, born in Metz (France), on October 29, 1974, professionally residing at 65, bvd
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager; and
(e) Cédric Carnoye, company director, born in Charleroi (Belgium), on September 14, 1982, professionally residing
at 65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, the principal establishment and central administration
of the Company at 65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg as of May 18, 2010.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason this deed, are estimated at approximately
two thousand two hundred euro (€ 2,200.-).
70230
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the
English and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, une société des îles Caïmans soumise au régime fiscal d'exemption
(Cayman Islands exempted partnership) ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
les îles Caïmans et immatriculée sous le numéro 36427, elle-même représentée par son actionnaire commandité LCG
Holdings LLC
représentée par Etienne de Crépy, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 mai
2010.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que deux cent mille (200.000) d'actions ayant une valeur nominale de USD 0,1 chacune de Luxor Capital Offshore
Fund, Ltd., une société par actions constituée selon les lois des îles Caïmans, avec siège social aux îles Caïmans et ayant
son adresse professionnelle à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, les îles Caïmans, (la Société) représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées
à la présente assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour,
reproduits ci-après.
II. la partie comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de la Société.
III. Par des résolutions valablement adoptées le 17 mai 2010 par l'Associé Unique, conformément aux statuts de la
Société, il a été décidé de désimmatriculer la Société aux îles Caïmans et de l'immatriculer par continuation (avec pleine
continuation de la personnalité morale et juridique de celle-ci par conséquent) à Luxembourg en vertu de l'article 193
des Statuts Reformulés et Modifiés de la Société des îles Caïmans et conformément à la Section 206 de la Loi sur les
Sociétés (Modification de 2009). Par ailleurs, par résolutions écrites valablement adoptées le 17 mai 2010 par tous les
administrateurs de la Société, conformément aux Statuts Reformulés et Modifiés de la Société des îles Caïmans, il a été
décidé qu'avec effet à compter du moment où la Société devient une société à responsabilité limitée selon les lois lu-
xembourgeoises, le siège social de la Société soit transféré des îles Caïmans à Luxembourg et l'adresse professionnelle/
l'établissement principal/l'administration centrale de la Société de c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, les îles Caïmans au 65, bvd Grande-Duchesse-Charlotte, L1331 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date des présentes sans dissolution de la Société mais au contraire avec
pleine continuation de sa personnalité morale et juridique. Toutes les formalités requises selon les lois des îles Caïmans
afin d'appliquer cette décision ont été dûment accomplies ou seront dûment accomplies aujourd'hui. Une copie desdites
résolutions restera annexée au présent acte.
IV. qu'il ressort (i) d'un bilan de la Société daté du 17 mai 2010 qu'à compter du 17 mai 2010, les actifs nets de la
Société correspondent au moins à la valeur du capital social de la Société, et (ii) d'un certificat de gestion de la Société
daté du 17 mai 2010, que depuis la date du bilan et au 17 mai 2010, aucun changement matériel concernant l'activité de
la Société et ses affaires qui aurait entraîné que les bilans financiers au 17 mai 2010 soient devenus matériellement
incorrects et ne reflètent pas une vision réelle et juste de la situation de la Société à la date des présentes ne s'est produit.
Une copie de ce bilan et de ce certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
Sur ce, l'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver le transfert du siège social de la Société des îles Caïmans à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, et le transfert de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société de Grand
Cayman, les îles Caïmans à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société
mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique. L'Associé Unique déclare par ailleurs
70231
L
U X E M B O U R G
que toutes les formalités requises selon les lois des îles Caïmans en vue de faire entrer en vigueur ce transfert ont été
dûment accomplies.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination
"Nile Capital II S.à r.l.", accepte la nationalité luxembourgeoise et sera à compter de la date du présent acte soumise aux
lois du Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la devise fonctionnelle de la Société des dollars américains (USD) en euros (EUR).
L'Associé Unique décide ensuite de convertir le montant du capital social de la Société en un montant libellé en euros
(EUR). Afin d'arrondir, le capital social souscrit sera fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), le taux de change
étant le taux officiel de la Banque Centrale Européenne au 17 mai 2010 (soit USD 1,2349 = EUR 1) avec tout excédent
de conversion étant affecté au compte de réserve de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver le bilan de clôture (intérimaire) de la Société aux îles Caïmans à compter du 17
mai 2010, étant le bilan d'ouverture au Grand-Duché de Luxembourg à compter de la date du présent acte, dont une
copie restera annexée au présent acte.
L'Associé Unique prend note qu'il ressort du bilan de la Société qu'à compter du 17 mai 2010, les actifs nets de la
Société correspondent au moins à la valeur nominale du capital social de la Société.
L'Associé Unique déclare que tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, restent la propriété intégrale de
la Société, qui possède toujours ses actifs et est toujours tenue par toutes ses dettes et engagements.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier et de reformuler intégralement le
Mémorandum et les statuts de la Société sous la forme présentée à l'Associé Unique afin de les rendre conformes aux
lois de Luxembourg suite au transfert de la Société et à sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg.
Les statuts coordonnées de la Société auront la teneur suivante:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Nile Capital II S.à r.l.» (ci-
après la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
les limites de la commune par décision du gérant unique, ou selon le cas, du conseil de gérance de la Société. Le siège
social peut ensuite être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé
unique, ou selon le cas, de l'assemblée générale des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du gérant unique, ou selon le cas, du conseil de gérance de la Société. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estiment que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont pro-
duits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être
transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social,
restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion, le renforcement et la cession de participations,
tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut
également contracter des emprunts et accorder toutes sortes de soutiens, prêts, avances et garanties aux sociétés, dans
lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe.
Elle peut ouvrir des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et céder tous les autres titres par souscription, achat, échange, vente ou autres.
Elle peut également acquérir, renforcer et céder les brevets et licences, ainsi que les droits dérivés de ceux-ci ou les
compléter.
En outre, la société peut acquérir, gérer, renforcer et vendre l'immobilier situé à Luxembourg ou à l'étranger.
En général, la Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières et industrielles, que ce soit con-
cernant des titres ou le secteur immobilier, susceptibles de renforcer ou de compléter l'objet social susmentionné.
70232
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par deux cent
cinquante (250) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinquante euro (EUR 50) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de
l'associé unique, ou selon le cas, de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les modalités requises pour la
modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale donne droit au détenteur à une fraction des actifs sociaux et des bénéfices de la Société en
proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, dans la mesure où un seul propriétaire par part
sociale est reconnu. Les propriétaires indivis doivent nommer une seule personne afin de les représenter envers la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique, aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des Parts Sociales à des non-associés est soumise à l'accord préalable
de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Pour tous les autres points, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté à la demande de chaque associé.
6.5. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites exposées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est administrée par un conseil de gérance, composé d'au moins un gérant A et deux gérants B, nommés
par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s). La majorité des gérants sera composée à tout moment de
personnes résidentes à Luxembourg.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum (avec ou sans motif).
Art. 8. Pouvoirs du Conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant unique ou, si la Société est administrée par plusieurs gérants, du conseil de gérance, qui
aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le gérant unique à un ou plusieurs agents, associés ou
non, pour des tâches spécifiques, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent ou sur convocation d'un
gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette
urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion du conseil de gérance.
9.3 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou
représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés, et avoir une parfaite connaissance de l'ordre du
jour de la réunion. Chaque membre du conseil de gérance de la Société peut également renoncer à la convocation à une
réunion en donnant son consentement par écrit, que ce soit en original, par télégramme, télex, fax ou courrier électro-
nique.
9.4 Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du conseil
de gérance.
9.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix exprimées. Les décisions
70233
L
U X E M B O U R G
du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à
la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou visioconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier,
de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à
cette réunion.
9.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un
document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être envoyées par lettre ou par fax.
9.8 La réunion du conseil de gérance doit être tenue à Luxembourg.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes
d'au moins un gérant A et au moins un gérant B de la Société ou par les signatures conjointes ou individuelles de toutes
personnes à qui ces pouvoirs de signature ont été délégués conformément à l'article 8.2 des présents Statuts.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux présents Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
IV. Assemblées générales des Associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels à son actionnariat.
12.3 Chaque associé peut nommer toute personne ou entité comme son mandataire en vertu d'une procuration écrite
donnée par lettre, télégramme, télex, fax ou courrier électronique, afin de le représenter aux assemblées générales des
associés.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Si le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être prises par résolution
circulaire, dont le texte sera envoyé à tous les associés par écrit, que ce soit en original ou par télégramme, télex, fax ou
courrier électronique. Les associés exprimeront leurs voix en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être
envoyées par lettre ou par fax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par les associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Cependant, les résolutions relatives à la modification des Statuts ou à la dissolution et à la liquidation de la Société
ne peuvent être adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque
année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le gérant unique, ou selon le cas, le conseil de gérance, doit préparer
le bilan et le compte de résultats de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société,
avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des gérants, du ou des commissaire(s) aux
comptes (le cas échéant) et des associés envers la Société.
14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan ci-dessus au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les bénéfices bruts de la Société qui figurent sur les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissement et dépenses représentent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à la réserve statutaire, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
15.2. L'associé unique, ou selon le cas, l'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de décider de
l'affectation du solde. Il/Elle peut affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le
reporter.
15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par au moins un gérant;
(ii) ces comptes intérimaires indiquent un bénéfice comprenant les bénéfices reportés ou transférés à une réserve
extraordinaire;
(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes est prise par l'associé unique, ou selon le cas, par l'assemblée
générale des associés;
70234
L
U X E M B O U R G
(iv) la décision ci-dessus est prise après que la Société ait obtenu la certitude que les droits des créanciers de la Société
ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs
et rémunération. Sauf décision contraire de l'associé ou des associés ou de la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société sera versé à l'associé,
ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Disposition générale
17. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et prendra fin le 31 décembre 2010.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide (i) de prendre acte de la démission, en vigueur à la date du présent acte, de M. Don Seymour,
M. Christian Leone, et M. Aldo Ghisletta en qualité de gérants de la Société et (ii) d'accorder à chacun d'eux pleine
décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs à compter de la date de leur nomination jusqu'à la date de leur
démission.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide de nommer en qualité de membres du Conseil de Gérance de la Société, avec
effet à la date des présentes et pour une durée indéterminée, les personnes suivantes:
- Norris Nissim, administrateur de sociétés, né à Hong Kong SAR (Chine) le 24 décembre 1966, demeurant à 07631
New York (Etats-Unis d'Amérique), Broad Avenue 269, Englewood, en qualité de gérant de classe A;
- Elena Cimador, administrateur de sociétés, né à Ohio (Etats-Unis d'Amérique) le 1
er
juin 1972, demeurant à 10552
New York (Etats-Unis d'Amérique), Brookfield Road, 82 Mount Vernon, en qualité de gérant de classe A;
- M. Hugo Froment, administrateur de sociétés, né à Laxou (France) le 22 février 1974, de résidence professionnelle
au 65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de classe
B;
- Sébastien André, administrateur de sociétés, né à Metz (France) le 29 octobre 1974, de résidence professionnelle au
65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de classe
B; et
- Cédric Carnoye, administrateur de sociétés, né à Charleroi (Belgique) le 14 septembre 1982, de résidence profes-
sionnelle au 65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant
de classe B.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'établir le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société au
65, bvd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg à compter du 18 mai 2010.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent à environ deux mille deux cents euros (€ 2.200,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, qu'à la requête de la partie comparante
ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, ladite partie comparante a signé, ensemble avec le
notaire, le présent acte.
Signé: Etienne de Crépy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 mai 2010. Relation: EAC/2010/6049. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M.-N. Kirchen.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2010068764/527.
(100083117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.
70235
L
U X E M B O U R G
Ektornet Latvia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.317.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/06/2010.
TOM BERNARDY.
Référence de publication: 2010064348/10.
(100079899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Ektornet Lithuania S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.321.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/06/2010.
PADDOCK FUND ADMINISTRATION S.A.
TOM BERNARDY
Référence de publication: 2010064349/12.
(100079900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Ektornet Nordic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.318.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/06/2010.
TOM BERNARDY.
Référence de publication: 2010064350/10.
(100079901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Colombo Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 65.500.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 10 mai 2010 a décidé de renouveler les mandats:
<i>- des administrateurs:i>
M. Patrick Kurt Oesch, avocat, Am Schanzengraben 29, CH-8002 Zürich
M. Kurt H. Oesch, directeur de sociétés, Am Schanzengraben 29, CH-8002 Zürich
M. Ryan Rudolph, avocat, Am Schanzengraben 29, CH-8002 Zürich
Mme. Annette Müller, avocat, Am Schanzengraben, 29, CH-8002 Zürich
<i>- du commissaire aux comptesi>
Fidex Audit S.à r.l., 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.
<i>Pour COLOMBO HOLDINGS S.A.
i>Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2010071376/22.
(100079909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70236
L
U X E M B O U R G
Office Rental Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 101.273.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juni 2010i>
Zum Aufsichtskommissar wird AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxemburg, gewählt. Sein Mandat
endet ebenfalls anlässlich der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2012 zu beschließen hat.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, den 7. Juni 2010.
Unterschriften.
Référence de publication: 2010064434/12.
(100079894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.100.
In the year two thousand and ten, on the twenty-fifth day of May,
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (hereinafter "Lu-
xembourg"), undersigned,
THERE APPEARED:
1) JSC BTA Bank, a company incorporated under the laws of Kazakhstan, with registered address at 97, Dzholdasbekov
str, Samal-2, 050051, Almaty, Kazakhstan hereby represented by Mr. Jan Krupski, a lawyer, professionally residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Almaty, Kazakhstan, on 21 May 2010; and
2) The Bank of New York Depository (Nominees) Limited, a company incorporated under the laws of England, with
registered address at One Canada Square, London EI4 51J, United Kingdom, hereby represented by Ms. Julie Fourriere,
a private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, United Kingdom, on 24
May 2010
collectively, hereafter referred to as the "Shareholders".
The appearing parties have requested the undersigned notary to act that:
I. The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned
notary, shall be appended to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing parties declare that they currently hold the entire share capital of BTA Finance Luxembourg S.A.
affiliated company of JSC BTA Bank, a public limited liability company (société anonyme) organised and existing under the
laws of Luxembourg, with its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.100, incorporated by a deed of Maître Paul
Bettingen, notary residing in Niederanven, on 22
nd
November 2005, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1335 on 6
th
December 2005 (the "Company"). The Company's articles of association (the "Articles
of Association") have last been amended by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxemburg on 28
th
April 2008, published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2629 on 28
th
October 2008.
III. Out of the 28.800 shares are present or represented only 26.255 shares, being 91,16%. The appearing parties, duly
represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1) To amend Articles 37, 7.2.4. and 35 of the Articles of Association;
2) Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to document the following resolutions, where 36 shares have voted against
and 26.219 shares in favour:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Article 37 (Definitions) of the Articles of Association by inserting a paragraph
immediately after the definition of "Replacement Instruments", which reads as follows:
""Restructuring Law" means the Law of the Republic of Kazakhstan No. 18S-IV ZRK dated 11 July 2009 on Amendments
and Additions to Certain Legislative Acts on Money Payments and Transfers, Accounting and Financial Reporting, Banking
Activities, the National Bank of Kazakhstan and Other Legislation."
70237
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Article 7.2.4. of the Articles of Association by adding a sentence at its end, which
reads as follows:
"For the avoidance of doubt, no Distributions shall be declared and paid on the Securities after a restructuring plan
has become binding on the financial creditors of the Bank under the Restructuring Law."
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Article 35 of the Articles of Association by adding a paragraph at the end of its
paragraph (I), which reads as follows:
"Notwithstanding the availability of sufficient assets of the Company to pay any Liquidation Distribution to the Holders,
if, at the time such Liquidation Distribution is to be paid, a restructuring plan has become binding on the financial creditors
of the Bank under the Restructuring Law, the Liquidation Distribution per Security paid to Holders thereof shall be equal
to a proportionate share of the cash and/or securities and/or other entitlement which the Issuer receives under or as a
result of such restructuring plan, which cash and/or securities and/or other entitlement shall, if the Board of Directors
so elects, be distributed directly by the Bank to the Holders."
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Article 35 of the Articles of Association by inserting a sentence immediately after
the first sentence of paragraph (V), which reads as follows:
"For the avoidance of doubt, if a restructuring plan has become binding on the financial creditors of the Bank under
the Restructuring Law, under which plan the Bank Subordinated Loan has been restructured or cancelled, the Company
may permit or take any action that would or might cause the liquidation or dissolution of the Company, subject only to
the approval or non-objection by the FMSA (if then required)."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result
of this document are estimated at approximately EUR 1.000.- (one thousand Euro).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who is proficient in English, states herewith that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies
between the English and the French text, the English text will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the mandatory of the appearing parties, who are known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) (ci-après
"Luxembourg"),
ONT COMPARU:
1) JSC BTA Bank, une société constituée selon les lois de Kazakhstan, ayant son siège social à 97, Dzholdasbekov str.,
Samal-2, 050051, Almaty, Kazakhstan, représentée par Monsieur Jan Krupski, avocat, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée à Almaty, Kazakhstan, le 21 mai 2010;
et
2) The Bank of New York Depository (Nominees) Limited, une société constituée selon les lois d'Angleterre, ayant
son siège social à One Canada Square, London EI4 51J, Royaume-Uni, représentée par Madame Julie Fourriere, employée
privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration
donnée à Londres, Angleterre, le 24 mai 2010, désignés ci-après, conjointement les "Associés".
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit:
I. Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Les comparants déclarent qu'ils détiennent la totalité des actions dans le capital social de BTA Finance Luxembourg
S.A. affiliated company of JSC BTA Bank, une société anonyme établie et constituée selon les lois du Grand-duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.100, constituée par acte du notaire Maître Paul Bettingen,
notaire, résidant à Niederanven, en date du 22 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1335 du 6 décembre 2005 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte
70238
L
U X E M B O U R G
du notaire Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg en date du 28 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2629 du 28 octobre 2008 (les "Statuts").
III. Des 28.800 actions émises, seulement 26.255 actions sont présentes ou représentées, soit 91,16%. Les comparants,
représentés comme mentionnés ci-dessus, reconnaissent être entièrement informés des résolutions à prendre sur base
de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Modification des articles 37, 7.2.4. et 35 des Statuts;
2) Divers.
A requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante avec 36 votes contre et 26.219 votes pour:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 37 (Définitions) des Statuts en insérant un paragraphe immédiatement après
la définition des "Instruments Financiers de Remplacement", qui se lit comme suit:
"La "Loi de Restructuration" signifie la Loi de la République du Kazakhstan No. 18S-IV ZRK datée du 11 juillet 2009
sur les Modifications et les Ajouts à Certains Actes Législatifs sur les Paiements et les Transferts d'Argent, les Informations
Comptables et Financières, les Activités Bancaires, le Banque Nationale du Kazakhstan et Autre Législation."
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 7.2.4 des Statuts en ajoutant une phrase à la fin de celui-ci, qui se lit comme
suit:
"Afin d'éviter tout doute, aucune Distribution ne doit être déclarée et payée sur les Titres après qu'un plan de res-
tructuration sur les créditeurs financiers de la Banque soit entré en vigueur selon la Loi sur la Restructuration."
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 35 des Statuts en insérant un paragraphe à la fin de son paragraphe (I), qui
se lit comme suit:
"Malgré la disponibilité de suffisamment d'actifs de la Société pour payer une Distribution de Liquidation aux détenteurs,
si, au moment où une telle Distribution de Liquidation est à payer, un plan de restructuration est devenu obligatoire pour
les créanciers financiers de la Banque en vertu de la loi sur la restructuration, la Distribution de Liquidation par Titre
payés aux Détenteurs de ceux-ci est égale à une part proportionnelle de la trésorerie et/ou de valeurs mobilières et / ou
autres droits dont l'émetteur reçoit en vertu ou en raison de plan de restructuration, dont l'encaisse et/ou de valeurs
mobilières et / ou autre droit, si le conseil d'administration en décide ainsi, être distribués directement par la Banque aux
Détenteurs."
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 35 des Statuts en insérant une phrase, immédiatement après la première
phrase du paragraphe (V), qui se lit comme suit:
"Afin d'éviter tout doute, si un plan de restructuration est devenu obligatoire pour les créanciers financiers de la Banque
en vertu de la loi sur la restructuration, selon lequel le régime de la Banque de prêt subordonné a été restructuré ou
annulé, la Société peut permettre ou prendre toute action qui entraînerait ou pourrait entraîner la liquidation ou la
dissolution de la Société, sous la seule réserve de l'approbation ou de la non-objection de la FMSA (si alors nécessaire)."
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de ce document
sont estimés à environ EUR 1.000.- (mille euros).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux mandataires des sociétés comparantes connus du notaire
instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Krupski, J. Fourriere et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mai 2010. Relation: LAC/2010/23559. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
70239
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations..
Luxembourg, le 8 juin 2010.
M. SCHAEFFER.
Référence de publication: 2010070610/150.
(100083103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.
Saposa S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 148.521.
Il est porté à la connaissance de tous que l’adresse de du gérant de classe A, à savoir madame Sabine Clerc a fait l’objet
d’un changement.
La nouvelle adresse est la suivante:
Madame Sabine Clerc: villa La Mandragore, 924 Corniche Général de Gaulle, 83000 Toulon, France.
Luxembourg, le 8 juin 2010.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010064473/16.
(100079878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Advent Dahlia (Luxembourg) S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.250.000,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 139.650.
<i>Rectificatif du dépôt du 30 Mars 2010 (No L100045268.04)i>
Les comptes annuels modifiés de la Société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg en lieu et place de la version déposée le 30 mars 2010 sous le numéro L100045268.04.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2010.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010065084/15.
(100079896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Advent Dahlia Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 397.550,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 140.620.
<i>Rectificatif du dépôt du 30 Mars 2010 (No L100045265.04)i>
Les comptes annuels modifiés de la Société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg en lieu et place de la version déposée le 30 mars 2010 sous le numéro L100045265.04.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2010.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010065085/15.
(100079898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70240
L
U X E M B O U R G
Gaming VC Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 104.348.
In the year two thousand ten, on the twenty-first day of May.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of the public limited liability company
(société anonyme) “GAMING VC HOLDINGS S.A.” (the Company), having its registered office at L-1931 Luxembourg,
13-15, Avenue de la Liberté, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (RCS) under number B 104.348, incorporated by a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in
Niederanven, on November 30, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on February 9,
2006, number 117.
The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated November 3, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on March 2, 2006, number 453.
The Meeting was opened by Richard Cooper, residing in the United Kingdom, being in the chair, who appointed as
secretary Gregory Beltrame, Avocat, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Aurore Dargent from ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A., residing in
Luxembourg (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).
The Bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders represented at the Meeting and the number of shares for which they will take part in the votes
are indicated on an attendance list signed by the proxyholder of the shareholders represented, the members of the Bureau
and the undersigned notary; the said attendance list as well as the proxies from the shareholders represented at the
present Meeting will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
II.- It results from such attendance list that shareholders owning 16,627,146 shares for which they will take part in the
votes proposed at the Meeting, representing 53.4% per cent of the share capital of the Company are present or repre-
sented at the Meeting which is therefore duly constituted and may validly deliberate on its agenda for which the Meeting
was convened, reproduced thereby;
III.- The agenda of the present Meeting is the following:
1. Subject to Resolution 2 being passed, all of the assets and liabilities of the Company (other than shares held by the
Company in GVC Holdings PLC (and certain arrangements such as those with certain professional advisers) be transferred
by the Company to GVC Holdings PLC, a wholly owned subsidiary of the Company incorporated in the Isle of Man under
the Isle of Man Companies Act 2006 for new shares in GVC Holdings PLC (the Transfer);
2. Subject to Resolution 1 being passed and immediately following the Transfer being effective, the Company be dis-
solved and put into liquidation (the Liquidation) and for the purpose of giving effect to the Liquidation and Transfer:
(a) KPMG ADVISORY shall be approved as liquidator of the Company (the Liquidator);
(b) The powers and duties of the Liquidator of the Company shall be defined in accordance with article 144 of the
Luxembourg law of August 1915 on commercial companies, as amended (the Law);
(c) The liquidator shall be authorized to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article
145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders; in particular,
to pay all debts of the Company in cash (if available or resulting from the realization of assets of the Company) or in
kind be transferring assets of the Company to the Creditors of the Company in repayment of any such debts;
(d) The Liquidator shall be authorized under his sole responsibility, to delegate his powers for specific defined opera-
tions or tasks, to one or several persons or entities; and
(e) The Liquidator shall be authorized in his sole discretion, to make advance payments of the liquidation proceeds
(boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law by transferring to
the shareholders of the Company shares that the Company will hold in GVC Holdings PLC following the Transfer;
(f) Any lawyer of Loyens & Loeff and any employee of ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. shall be appointed
and authorized on behalf of the Company to perform in the Grand Duchy of Luxembourg all acts and formalities in
connection with the Transfer and Liquidation (except those powers conferred to the Liquidator but including carrying
out any filings, applications or other formalities required by the Luxembourg Register of Commerce and Companies).
3. The GVC Holdings PLC 2010 Long Term Incentive Plan (LTIP), a summary of the principal provisions of which is
set out in part II of the Circular to Shareholders dated 19 April 2010 enclosed with this Notice, shall be approved by the
Company (as parent company of GVC Holdings PLC) and that the directors of the Company (who are also directors of
GVC Holdings PLC) be authorized do all other acts and things necessary or desirable to establish and carry the LTIP into
effect.
70241
L
U X E M B O U R G
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting, duly represented, unanimously
resolves after deliberation on the following:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the Transfer.
The Meeting recalls that, to be validly adopted, such Transfer (First Resolution) must be carried by a simple majority
of the votes cast of the shareholders of the Company present or represented at the Meeting.
This First Resolution has been approved by 16,241,876 votes cast representing 97.68 % per cent of the votes cast at
the Meeting, the Meeting resolves to acknowledge that this First Resolution has been successfully passed, thus allowing
the Meeting to resolve upon the Second Resolution in accordance with the condition precedent set out in the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Meeting having acknowledged that the First Resolution has been successfully past and conditioning the present
resolution to the Transfer being effective, resolves to dissolve the Company and put it into liquidation (defined as the
Liquidation), and for such purpose resolves to:
- Approve KPMG ADVISORY, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with
registered office at 9, Allée Sheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 50.597 as liquidator of the Company (the Liquidator), such Liquidator to have the powers
and duties as defined in accordance with article 144 of the Law;
- Authorize the Liquidator to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of
the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders; in particular, to pay all debts of the
Company in cash (if available or resulting from the realization of assets of the Company) or in kind be transferring assets
of the Company to the Creditors of the Company in repayment of any such debts;
- Authorize the Liquidator under his sole responsibility, to delegate his powers for specific defined operations or tasks,
to one or several persons or entities;
- Authorize the Liquidator in his sole discretion, to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de
liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law by transferring to the share-
holders of the Company shares that the Company will hold in GVC Holdings PLC following the Transfer;
- Appoint and authorize any lawyer of Loyens & Loeff and any employee of ATC Corporate Services (Luxembourg)
S.A. on behalf of the Company to perform in the Grand Duchy of Luxembourg all acts and formalities in connection with
the Transfer and Liquidation (except those powers conferred to the Liquidator but including carrying out any filings,
applications or other formalities required by the Luxembourg Register of Commerce and Companies).
The Meeting recalls that to be validly adopted such Second Resolution must be carried by at least two thirds (2/3) of
the votes cast by the shareholders of the Company present or represented at the Meeting with a quorum of at least fifty
(50) per cent of the entire issued share capital being represented.
This Second Resolution, having being approved by 16,241,876 votes cast representing 97.68 % per cent of the votes
cast, the Meeting resolves to acknowledge that this Second Resolution has been successfully passed, thus allowing the
First Resolution to have been validly passed with effect prior to the Second Resolution.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to approve in the name and on behalf of the Company and to the extent applicable in its capacity
as parent of GVC Holdings PLC, the LTIP, and to acknowledge and to the extent necessary to approve that the directors
of the Company (who are also directors of GVC Holdings PLC) shall be and are hereby authorized do all other acts and
things necessary or desirable to establish and carry the LTIP into effect.
This Third Resolution, having being approved by 14,841,876 votes cast representing 89.26 % per cent of the votes
cast, the Meeting resolves to acknowledge that this Third Resolution has been successfully passed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed
is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille dix, le vingt-et-un mai.
70242
L
U X E M B O U R G
Par-devant le notaire instrumentant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de la société anonyme "GAMING
VC HOLDINGS S.A." (la Société), ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (RCS) sous le numéro
B 104.348, constituée suivant un acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, le 30 novembre
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 février 2006, numéro 117.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu des résolutions du
conseil d’administration de la Société, suivant un acte daté du 3 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 2 mars 2006, numéro 453.
L’Assemblée a été ouverte par Richard Cooper, de résidence au Royaume-Uni, président, qui a nommé comme se-
crétaire Gregory Beltrame, Avocat de résidence professionnelle à Luxembourg.
L’Assemblée a choisi comme scrutateur Aurore Dargent, d’ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. de résidence
à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formant le Bureau de l’Assemblée).
Le Bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions par lesquelles ils ont pris part aux votes
sont indiqués sur une liste de présence signée par le mandataire des actionnaires représentés, les membres du Bureau et
le notaire instrumentant; ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés à la présente
Assemblée resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
II. Il résulte de cette liste de présence que les actionnaires détenant
16.627.146 actions par lesquelles ils ont pris part aux votes proposés à l’Assemblée, représentant 53,4 % du capital
social sont présents ou représentés à l’Assemblée qui, par conséquent est dûment constituée et peut valablement déli-
bérer sur cette agenda pour lequel l’Assemblée a été convoquée, reproduit ici.;
III. L’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Sous réserve de l’adoption de la Résolution 2, la totalité des actifs et passifs de la Société (autres que les actions
détenues par la Société dans GVC Holdings PLC (et certains accords tels que ceux conclus avec certains professionnels)
sera cédé par la Société à GVC Holdings PLC, une filiale de la Société détenue à 100% constituée à l’île de Man selon la
Loi sur les Sociétés de l’île de Man de 2006 pour les nouvelles actions dans GVC Holdings PLC (le Transfer);
2. Sous réserve de l’adoption de la Résolution 1 et immédiatement après le Transfert en vigueur, la Société sera dissoute
et mise en liquidation (la Liquidation) et afin de donner effet à la Liquidation et au Transfert: a) KPMG ADVISORY sera
nommé en qualité de liquidateur de la Société (le Liquidateur);
b) Les pouvoirs et fonctions du Liquidateur de la Société seront définis conformément à l’article 144 de la loi luxem-
bourgeoise d’août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);
c) Le Liquidateur sera autorisé à conclure tous les actes et à réaliser toutes les opérations, en ce compris et men-
tionnées à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires; en particulier, à
payer toutes les dettes de la Société en numéraire (si disponible ou suite à la réalisation des actifs de la Société) ou en
nature en cédant les actifs de la Société aux créanciers de la Société en remboursement de ces dettes;
d) Le Liquidateur sera autorisé sous sa seule responsabilité, à déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou tâches
spécifiques et déterminées, à une ou plusieurs personnes ou entités;
e) Le Liquidateur sera autorisé à sa seule discrétion, à faire des avances sur boni de liquidation aux actionnaires de la
Société, conformément à l’article 148 de la Loi en cédant aux actionnaires de la Société les actions que la Société détiendra
dans GVC Holdings PLC suite au Transfert; et
f) Tout avocat de Loyens & Loeff ainsi que tout employé de ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. sera nommé
et autorisé au nom et pour le compte de la Société à accomplir au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et
formalités en relation avec le Transfert et la Liquidation (sauf ceux des pouvoirs conférés au Liquidateur mais comprenant
la réalisation de tous dépôts, requêtes ou autres formalités exigées par le Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg).
3. Le "Long Term Incentive Plan"(LTIP) de GVC Holdings PLC daté de 2010, un résumé des dispositions principales
qui est exposé à la section II de la Circulaire aux Associés datée du 19 avril 2010, sera approuvé par la Société (en tant
que société mère de GVC Holdings PLC) et les administrateurs de la Société (qui sont également administrateurs de
GVC Holdings PLC) seront autorisés à réaliser tous les autres actes et actions nécessaires ou souhaitables en vue d’établir
et de mettre en œuvre le LTIP.
Ces faits ayant été exposés et reconnus comme étant vrais par l’Assemblée, l’Assemblée, dûment représentée, décide
ce qui suit à l’unanimité après délibération:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver le Transfert.
L’Assemblée décide de prendre note que, afin d’être valablement adoptée, la Première Résolution doit être effectuée
à la majorité simple des votes exprimés par les actionnaires de la Société présents ou représentés à l’Assemblée.
70243
L
U X E M B O U R G
La Première Résolution a été approuvée par 16.241.876 des votes exprimés à l’Assemblée représentant 97,68 % des
votes exprimés, l’Assemblée décide de prendre acte que cette Première Résolution a été adoptée avec succès, ce qui
permet donc à l’Assemblée de statuer sur la Seconde Résolution conformément à la condition préalable exposée à l’ordre
du jour.
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée ayant pris acte que la Première Résolution a été adoptée avec succès et qui était une condition préalable
pour que le Transfert soit effectif, décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation (la Liquidation, telle que
définie) et à cette fin décide de:
- D’approuver KPMG ADVISORY, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 9, Allée Sheffer, L2540 Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 50.597 en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur), ce Liquidateur devant avoir les pouvoirs et fonctions
tels que définis conformément à l’article 144 de la Loi;
- D’autoriser le Liquidateur à conclure tous les actes et à réaliser toutes les opérations, en ce compris mentionnées
à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires; en particulier, à payer toutes
les dettes de la Société en numéraire (si disponible ou suite à la réalisation des actifs de la Société) ou en nature en cédant
les actifs de la Société aux créanciers de la Société en remboursement de ces dettes;
- D’autoriser le Liquidateur sous sa seule responsabilité, à déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spé-
cifiques et déterminées, à une ou plusieurs personnes ou entités;
- D’autoriser le Liquidateur à sa seule discrétion, à faire des avances sur boni de liquidation aux actionnaires de la
Société, conformément à l’article 148 de la Loi en cédant aux actionnaires de la Société les actions que la Société détiendra
dans GVC Holdings PLC suite au Transfert;
- De nommer et de donner pouvoir à tout avocat de Loyens & Loeff ainsi qu’à tout employé de ATC Corporate
Services (Luxembourg) S.A. au nom et pour le compte de la Société afin d’accomplir au Grand-Duché de Luxembourg
tous les actes et formalités en relation avec le Transfert et la Liquidation (sauf ceux des pouvoirs conférés au Liquidateur
mais comprenant la réalisation de tous dépôts, requêtes ou autres formalités exigées par le Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg).
L’Assemblée décide de prendre note que, afin d’être valablement adoptée, la Seconde Résolution doit être approuvée
par au moins les deux-tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires de la Société présents ou représentés à l’As-
semblée et avec un quorum d’au moins cinquante (50%) pour cent de la totalité du capital social émis étant représenté.
La Seconde Résolution, étant approuvée par 16.241.876 des votes exprimés et représentant 97,68 % des votes ex-
primés, l’Assemblée décide de prendre acte que cette Seconde Résolution a été adoptée avec succès, ce qui permet donc
à la Première Résolution d’avoir été valablement adoptée avant cette Seconde Résolution.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver au nom et pour le compte de la Société et si applicable en sa capacité de société
mère de GVC Holdings PLC, le LTIP, et de prendre acte et d’approuver si nécessaire que les administrateurs de la Société
(qui sont également administrateurs de GVC Holdings PLC) seront et sont autorisés par la présente à réaliser tous les
autres actes et actions nécessaires ou souhaitables en vue d’établir et de mettre en œuvre le LTIP.
La Troisième Résolution a été approuvée par 14.841.876 des votes exprimés à l’Assemblée représentant 89,26 % des
votes exprimés, l’Assemblée décide de prendre acte que cette Première Résolution a été adoptée avec succès.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-)
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes, elles ont signé avec le notaire, le présent acte original.
Signé: R. Cooper, G. Beltrame, A. Dargent, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 mai 2010. Relation: LAC/2010/23144. Reçu douze euros (EUR 12,).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2010.
Référence de publication: 2010068670/224.
(100082757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.
70244
L
U X E M B O U R G
EECF Beta Manager, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.974.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2010.
<i>Pour EECF Beta Manager
i>Représenté par: M. Matthijs BOGERS
<i>Administrateur Mid Europei>
Référence de publication: 2010065146/13.
(100079886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Illor I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 64.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010065180/10.
(100079908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Illor II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 64.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010065181/10.
(100079910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Innova S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert Ier.
R.C.S. Luxembourg B 16.290.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 7 mai 2010 que:
sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012:
- Monsieur Alphonse SERRIG, Directeur de Sociétés, demeurant 63 rue Michel Rodange à L-7248 Bereldange;
- Monsieur Ernst KELLER, Conseiller Financier, demeurant à Gessnerallee 36, CH-2001 Zurich
- Madame Joëlle PIERRET, Maître en droit, demeurant professionnellement au 26B rue Albert 1
er
L-1117 Luxembourg;
Et que,
est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012.
- FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.L, ayant son siège social 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig
Luxembourg, le 4 juin 2010.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2010071428/21.
(100079864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70245
L
U X E M B O U R G
Ma.Lo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 48.326.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2010.
<i>Pour Ma.Lo S.A.
i>Représenté par M. Julien FRANCOIS
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2010065219/13.
(100079885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Motorinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 87.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010065221/10.
(100079903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Raiffeisen-Wuere-Genossenschaft, Société Coopérative.
Siège social: L-8550 Noerdange, 7, Dikrecherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 130.563.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28.5.2010.
Signature.
Référence de publication: 2010065247/10.
(100079882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Navlink S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 76.772.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 29 avril 2010 à 11.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'Administrateur de Mr Koen LOZIE, 61 Grand Rue,
L - 8510 Redange-sur-Attert et de COSAFIN SA. représentée par M. Jacques Bordet, 10, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg et de nommer Mr Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L - 5960 Itzig, Administrateur de la Société.
Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT S.à r.l.,
Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2009.
Extrait sincère et conforme
NAVLINK S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010071486/21.
(100079740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70246
L
U X E M B O U R G
Russian Mortgage Backed Securities 2008-1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 141.133.
Le Bilan au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010065251/10.
(100079877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Riviera Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 52.218.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010065257/10.
(100079912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Sifraso S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 129.325.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010065270/10.
(100079892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Hayfin Opal Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 153.583.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the fourth day of June.
Before, Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
THERE APPEARED:
HayFin Opal Holdings Limited, an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with its
registered address at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002;
here represented by Marc Tkatcheff, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal;
said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Hayfin
Opal Luxco 1 S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
(i) to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the adminis-
tration, management, control and development of those participations, (ii) the investment or participation in, or the
acquisition of debt, debt securities, receivables, or other monetary obligations, equity, equity securities, warrants, options,
or any instrument convertible into equity, and (iii) the administration, management, control and development of its asset
portfolio.
70247
L
U X E M B O U R G
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from
time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable,
and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option,
securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The
Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to any persons
including without limitation, subsidiaries and/or affiliates of the Company and companies which are part of the same group
of companies as the Company.
The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and companies which
are part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or
all its assets.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder/an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the
municipality by a resolution of the sole manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro), represented by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro)
per share each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these articles of association (the
Articles).
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of Company's shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of Company's shares inter vivos to third parties must be authorised
by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company.
No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles shall apply in
accordance with article 15 of these Articles.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the Shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
70248
L
U X E M B O U R G
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his/her powers for specific tasks to
one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers. Such quorum cannot exist if there is a
preponderance of managers physically present in one country unless that country is the Grand Duchy of Luxembourg.
A chairman pro tempore of the board of managers, which must be physically present in the Grand Duchy of Luxem-
bourg, may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is
appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers
will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented
at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) before such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting
of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are present or
represented, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of
the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place (in the Grand Duchy of Luxembourg) and
time as may be specified in the respective notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of Company's shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
70249
L
U X E M B O U R G
However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning
at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by una-
nimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July and ends on 30 June of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to the end of the financial year, the Company's accounts shall
be established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
commensurate to his/their share holding in the Company.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Internal auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by an internal auditor (commissaire) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external
auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the
Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial
accounts of companies, as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these Articles.
<i>Subscription and Paymenti>
HayFin Opal Holdings Limited, prenamed, hereby declares to subscribe and hereby subscribes to the entirety of the
issued share capital amounting to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by one hundred and
twenty-five (125) shares of one hundred (100) Euro each.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, amounting to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro) which shall be entirely allocated to the Company's nominal share capital account.
The sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which
has been given to the undersigned notary.
The blocking certificate, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party, and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 June 2010.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company have
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at five (5).
The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Michel Warmerdam, born on 13 February 1960 in Noordwijk (the Netherlands) and whose personal address is van
Galenlaan 40, 3941 VD Doorn (the Netherlands);
- John Molloy, born on 9 March 1962 in Gaillimh/Galway (Ireland) and whose personal address is 6, rue du Château,
L-6961 Senningen (Grand Duchy of Luxembourg);
- David Harris, born on 17 June 1974 in Canberra (United Kingdom) and whose personal address is 26, Montée de la
Pétrusee, L-2327 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
- Filippo Cardini, born on 11 October 1969 in Milan (Italy) and whose personal address is 4, Constable Close, London
NW116TY (United Kingdom); and
- Jennifer Glassman, born on 17 October 1970 in Missouri (U.S.A.) and whose professional address is 144 W 18
th
St
Apt 7W, New York, NY 10011 (U.S.A.).
70250
L
U X E M B O U R G
2. The registered office is established at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
3. The Company will incorporate on the same day two new Luxembourg private limited liability companies (Sociétés
à Responsabilitié Limitée) to be named Hayfin Opal Luxco 2 S.à r.l. and Hayfin Opal Luxco 3 S.à r.l.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le quatre juin.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente
minute.
A COMPARU:
HayFin Opal Holdings Limited, une "exempted company" constituée selon les lois des Iles Cayman et ayant son siège
social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002;
ici représentée par Marc Tkatcheff, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé;
ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Hayfin Opal Luxco 1 S.à
r.l." (ci-après, la Société).
Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directe-
ment ou indirectement à (i) la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque
forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, (ii) l'inves-
tissement dans, la participation ou l'acquisition de dettes ou titres de dettes ou autres obligations monétaires, titres, titres
participatifs ou autres instruments convertibles en titres et (iii) l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ses portefeuilles d'actifs.
La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie
d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières pour en disposer par voie de vente, transfert, échange
ou autrement et pour les développer.
La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme
nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts
et/ou émissions de valeurs mobilières, à toute personne incluant, sans limitation, ses filiales ou sociétés affiliées.
La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité
à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties.
Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique/d'une
assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du
gérant/conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
70251
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 euros)
représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euro (100 euro) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts (les Statuts).
Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale de la Société donne droit à une fraction, proportionnelle au
nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales de la Société sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter
auprès de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts en
vertu de l'article 15 des Statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des Associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture
de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront
un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la
moitié du capital social.
L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer
le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.
Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et
d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect
des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance. Un tel quorum ne peut être atteint
s'il existe une majorité de gérants physiquement présents dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg.
Un président pro tempore du conseil de gérance, qui doit être physiquement présent au Grand-Duché de Luxembourg,
peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un
président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance
désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de
gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), avant la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être
convoquée par tout gérant.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
70252
L
U X E M B O U R G
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Responsabilité des gérant(s). Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se
tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit du Luxembourg ou de l’étranger à préciser dans la convocation
à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux (au Grand-Duché de
Luxembourg) et heures indiqués dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes devront être arrêtés et, suivant le
cas, le gérant ou le conseil de gérance devront dresser un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Commissaire - Réviseur d'entreprises agréé. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit
être contrôlée par un commissaire seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises agrée
doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée n'est pas applicable.
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
HayFin Opal Holdings Limited, susmentionnée, souscrit à l’entièreté du capital social s'élevant à 12.500 euros (douze
mille cinq cents euros) qui est représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de 100 euros (cent euros) chacune.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500 EUR (douze
mille cinq cents euros) est intégralement allouée au compte du capital social nominal de la société.
70253
L
U X E M B O U R G
La somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
Le certificat de blocage, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante, et le notaire soussigné,
restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 30 juin 2010.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.500,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a
pris les résolutions suivantes:
1. les gérants sont au nombre de cinq (5).
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Michel Warmerdam, né le 13 février 1960 à Noordwiijk (Pays-Bas) et dont l'adresse personnelle est van Galenlaan
40, 3941 VD Doorn (Pays-Bas);
- John Molloy, né le 9 mars 1962 à Gaillimh/Galway (Irelande) et dont l'adresse personnelle est au 6, rue du Château,
L-6961 Senningen (Grand-Duché de Luxembourg);
- David Harris, né le 17 juin 1974 à Canberra (Royaume-Uni) et dont l'adresse personnelle est au 26, Montée de la
Pétrusee, L-2327 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Filippo Cardini, né le 11 octobre 1969 à Milan (Italie) et dont l'adresse personnelle est au 4, Constable Close, London
NW116TY (Royaume-Uni); et
- Jennifer Glassman, née le 17 octobre 1970 dans le Missouri (USA) et dont l'adresse professionnelle est au 144 W 18
th
St Apt 7W, New York, NY 10011.
2. Le siège social de la société est établi au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
3. La Société va constituer ce même jour deux nouvelles sociétés à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui
seront nommées Hayfin Opal Luxco 2 S.à r.l. et Hayfin Opal Luxco 3 S.à r.l.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. TKATCHEFF et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juin 2010. Relation: LAC/2010/25055. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 juin 2010.
Référence de publication: 2010068679/397.
(100083638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.
Car Testing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 89.762.
En date du 18 mai 2010, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société, de l'ancienne
adresse au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, à sa nouvelle adresse au 38, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
70254
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 3 juin 2010.
Sabrina Charny
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010071364/14.
(100079730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Crediinvest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 98.745.
<i>Extraits des Résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2010i>
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 27 avril 2010, que Messieurs
Xavier Cornella Castel, Agusti Garcia Puig, Iain Macleod, José Luis Dorado et Sergi Martin Amoros ont été réélus en leur
qualité d'administrateur de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en
2011 et que KPMG Audit S.à r l. Luxembourg a été réélu en sa qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une
période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2011. Monsieur David Claus (résidant au 113-115
Bld St. Michel, B-1040 Bruxelles, Belgique) a été élu administrateur de la société pour une période d'un an se terminant
lors de l'assemblée générale se tenant en 2011.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour CREDIINVEST SICAV
i>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Signature / Luc Biever
Référence de publication: 2010071381/20.
(100079680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Principia Verwaltungs GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 153.565.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendzehn, am vierten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxem-
burg,
ist erschienen:
Principia S.A., eine Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 20. Mai 2010, noch nicht eingetragen im Han-
delsregister des Großherzogtums Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Charles Meyer, geschäftsansässig in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer am 4. Juni 2010 erteilten privatschriftlichen Vollmacht.
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vertreter der Erschienenen und den am-
tierenden Notar, vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben zeitgleich einregistriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie zuvor dargelegt, ersuchte den unterzeichneten Notar, Folgendes zu beurkunden:
I. Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin der Principia Verwaltungs GmbH (ehemals: Kronen tausend547
GmbH) (nachfolgend die „Gesellschaft“), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Geschäftsadresse Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, Deutschland, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 62271.
II. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) eingeteilt in fünfundzwanzig-
tausend (25.000) Anteile mit einem Nennbetrag von je einem Euro (EUR 1).
III. Folgende Dokumente wurden dieser Versammlung vorgelegt:
(1) Eine beglaubigte Kopie der aktuellen Statuten der Gesellschaft;
(2) Eine beglaubigte Kopie des amtlichen Handelsregisterauszugs der Gesellschaft;
(3) Eine Kopie der durch die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft am 3. Juni 2010 gefassten Beschlüsse;
(4) Eine Zwischenbilanz der Gesellschaft zum heutigen Tage;
70255
L
U X E M B O U R G
(5) Ein Rechtsgutachten, erstellt von einem deutschen Notar, welches bestätigt, dass die Gesellschaft ihren tatsächli-
chen Verwaltungssitz unter Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit von Deutschland in das Großherzogtum Luxemburg
verlegen kann;
(6) Ein Nachweis, dass das Stammkapital der Gesellschaft bei ihrer Gründung in Deutschland eingezahlt wurde. Alle
zuvor aufgelisteten Dokumente wurden durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten Notar paraphiert
und vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben zeitgleich einregistriert zu werden.
IV. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
(1) Zur Kenntnisnahme der Verlegung des tatsächlichen Verwaltungssitzes der Gesellschaft von Deutschland in die
Gemeinde Luxemburg des Großherzogtums Luxemburg.
(2) Annahme der Rechtsform einer Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité
limitée“) (aus der Sicht des Luxemburger Rechts) sowie die Annahme der Luxemburger Nationalität;
(3) Annahme der Statuten der Gesellschaft;
(4) Bestätigung des existierenden Geschäftsführers der Gesellschaft und Ernennung eines weiteren, in Luxemburg
ansässigen Geschäftsführers;
(5) Festlegung der Luxemburger Adresse der Gesellschaft wie folgt: 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg;
(6) Verschiedenes.
V. Die Gesellschafter der Gesellschaft haben, wie oben unter Punkt III (3) angeführt, am Juni 2010 beschlossen, den
tatsächlichen Verwaltungssitz der Gesellschaft mit Wirksamkeit zum 4. Juni 2010 von Deutschland in die Gemeinde
Luxemburg des Großherzogtums Luxemburg zu verlegen.
In diesem Zusammenhang fasste die Erschienene durch ihren Vertreter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Soweit erforderlich, genehmigt und bestätigt die Erschienene die Entscheidung den tatsächlichen Verwaltungssitz der
Gesellschaft mit Wirksamkeit zum oben genannten Datum von Deutschland in die Gemeinde Luxemburg des Großher-
zogtums Luxemburg zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Erschienene beschließt (aus der Sicht des Luxemburger Rechts), mit Wirksamkeit zum oben genannten Datum
die Rechtsform einer Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) anzunehmen
und somit zum gleichen Zeitpunkt auch die Luxemburger Nationalität anzunehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Erschienene beschließt, die folgenden Statuten der Gesellschaft mit Wirksamkeit zum oben genannten Datum
anzunehmen:
§ 1. Firma und Sitz.
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: Principia Verwaltungs GmbH.
(2) Der Satzungssitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. Der Verwaltungssitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg
(Luxemburg).
(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und die Verwaltung, das Manage-
ment und die Finanzierung von Gruppen- und Beteiligungsgesellschaften und die Übernahme der persönlichen Haftung
und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Übernahme der Funktion als persönlich haftende
Gesellschafterin der Principia GmbH & Co. KG.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in Zusammenhang
stehen oder diesen fördern. Sie ist berechtigt, Unternehmens-und Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften
abzuschließen. Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassungen errichten.
§ 3. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtau-
send). Es ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils Euro 1,00 (in Worten: Euro ein) mit den
Nrn. 1 25.000. Die Einlagen auf die Geschäftsanteile sind in bar vollständig erbracht.
§ 4. Organe der Gesellschaft. Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversamm-
lung.
§ 5. Übertragung und Belastung von Geschäftsanteilen. Die Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen ist nur mit
schriftlicher Zustimmung aller Gesellschafter und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften zulässig.
70256
L
U X E M B O U R G
§ 6. Gesellschafterversammlungen und -beschlüsse.
(1) Die von dem Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Bestimmungen und Entschei-
dungen erfolgen durch Beschlußfassung in der Gesellschafterversammlung unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorschriften.
(2) Gesellschafterversammlungen finden am Satzungs- oder Verwaltungssitz der Gesellschaft oder an einem anderen,
in der Einberufung bestimmten Ort statt.
(3) Eine Beschlussfassung kann auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen durch schriftlich, mündlich, telefo-
nisch, per Telefax oder E-Mail übermittelte Stimmabgabe erfolgen, sofern die Gesellschaft weniger als 25 (fünfundzwanzig)
Gesellschafter hat.
(4) Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, eine Gesellschafterversammung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schrift-
lich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder E-Mail und muss den Zeitpunkt, den Ort und die Tagesordnung angeben. Die
Einberufung muss mindestens eine Woche vor dem Tag der Gesellschafterversammlung bzw. der Beschlussfassung zu-
gegangen sein. Der Tag der Versammlung ist hierbei nicht mitzuzählen.
(5) Über Gesellschafterbeschlüsse hat der (alleinige) Gesellschafter unverzüglich eine unterschriebene Niederschrift
zu fertigen.
(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist oder hierauf wirksam
verzichtet wurde. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine weitere Gesellschafterversammlung fristgemäß
einzuberufen, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist, hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen.
§ 7. Geschäftsführung.
(1) Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern. Es existieren Geschäftsführer der Ka-
tegorie A und der Kategorie B. Sollen mehrere Geschäftsführer bestellt werden, haben diese den Kategorien A und B
anzugehören.
(2) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
(3) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer gemeinschaft-
lich, wobei jeweils ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B angehören muss,
vertreten. Auch bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer kann die Gesellschafterversammlung einzelnen Geschäfts-
führern, unabhängig davon, welcher Kategorie der Geschäftsführer angehört, Einzelvertretungsbefugnis erteilen; ebenso
kann sie einem oder mehreren Geschäftsführern gestatten, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so ist dieser
einzelvertretungsberechtigt.
(4) Die Geschäftsführer sind nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder beider Kategorien anwesend oder
vertreten ist. Ein Geschäftsführer kann sich durch einen anderen Geschäftsführer, leitenden Mitarbeiter seines Unter-
nehmens, Angehörigen eines gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten rechts-, wirtschafts- oder steuerbera-
tenden Berufs oder einen sonstigen Dritten, vertreten oder begleiten lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax
oder E-Mail erteilt werden.
(5) Eine Beschlussfassung der Geschäftsführer kann auch außerhalb von Sitzungen durch telefonische Stimmabgabe
oder per E-mail erfolgen. In diesen Fällen wird der telefonisch teilnehmende bzw. seine Stimme per E-mail abgegebende
Geschäftsführer als in Luxemburg anwesend angesehen. In dringenden Fällen sind die Geschäftsführer berechtigt, Bes-
chlüsse in Schriftform zu fassen, welche von allen Geschäftsführern genehmigt und unterzeichnet werden müssen.
Derartige Beschlüsse stehen den in Sitzungen gefassten Beschlüssen gleich.
(6) Der oder die Geschäftsführer führt/führen die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Bestimmungen, diesem Gesellschaftsvertrag, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns.
§ 8. Geschäftsjahr/Jahresabschluß/Zwischendividende.
(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Januar eines jeden Jahres bis zum 31. Dezember desselben Jahres.
(2) Der Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) - sowie, soweit gesetzlich vorgesehen,
der Lagebericht der Gesellschaft - ist durch die Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen nach den gesetzlichen
Gliederungs- und Bewertungsvorschriften und, soweit handelsrechtlich zulässig, unter Berücksichtigung der steuerlichen
Vorschriften über die Gewinnermittlung, aufzustellen und der Gesellschafterversammlung zum Zwecke des Feststellung
vorzulegen.
(3) Die Gesellschafterversammlung beschließt über den Jahresabschluß und die Verwendung des Ergebnisses unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.
(4) Die Ausschüttung von Zwischendividenden ist zulässig, wenn sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
ordnungsgemäß beschlossen wurde und bis zum nächsten Bilanzstichtag kein Verlust entsteht. Das Entstehen eines Ver-
lustes ist auflösende Bedingung für die Vorabdividende. In diesem Fall entfällt der Rechtsgrund für die Zahlung mit der
Folge, dass der Gesellschafter die empfangenen Leistungen an die Gesellschaft zurückzugewähren hat.
§ 9. Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger für die
Bundesrepublik Deutschland sowie im elektronischen Bundesanzeiger („Mémorial“) des Großherzogtums Luxemburg.
70257
L
U X E M B O U R G
§ 10. Gründungsaufwand. Die mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundenen Kosten (Notar, Gerichts- und
Veröffentlichungskosten) sowie die Kosten, die mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages und der Neubestellung der
Geschäftsführung zur Aufnahme aktiver Geschäftstätigkeit verbunden sind (Notar-, Gerichts- und Veröffentlichungskos-
ten), trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von Euro 2.000,00 (in Worten: Euro zweitausend).
§ 11. Schlussbestimmungen. Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren oder sollte sich in diesem Gesell-
schaftsvertrag eine Regelungslücke herausstellen, werden die Wirksamkeit und Durchführbarkeit aller übrigen Bestim-
mungen dieses Gesellschaftsvertrages davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung wird der Gesellschafter eine angemessene Regelung vereinbaren, die, soweit rechtlich zulässig, dem von dem
Gesellschafter mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten
kommt. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke.
<i>Vierter Beschlussi>
Die folgende Person wird als Geschäftsführer der Gesellschaft in seinem Amt bestätigt und wird Kategorie A Ge-
schäftsführer:
<i>Geschäftsführer der Kategorie A:i>
- Herr Hasan Gurhan Berker, Geschäftsmann, geboren am 8. September 1957 in Tokat, Türkei, mit Amtssitz in Strateji
Menkul Degerler A.S., Buyukdere Cad No: 100-102, Maya Akar Center, 26. Stock, Esentepe 34394 Istanbul, Türkei. Die
folgende Person wird zum Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
<i>Geschäftsführer der Kategorie B:i>
- Herr Charles Meyer, Angestellter, geboren am 19. April 1969 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit Amts-
sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Erschienene legt mit Wirksamkeit zum oben genannten Datum die Luxemburger Adresse der Gesellschaft wie
folgt fest: 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der
Verlegung ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes zu tragen sind, werden auf einen Betrag von ungefähr tausend Euro
geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die deutsche und die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Antrag
der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt voneiner englischen Überse-
tzung. Auf Antrag derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen
Fassung ist der deutsche Text maßgebend.
Daraufhin wurde, die vorliegende notarielle Urkunde an dem eingangs genannten, Datum in Munsbach errichtet.
Nachdem die Urkunde dem Vertreter der Erschienenen vorgelesen wurde, hat dieser gemeinsam mit dem Notar diese
Originalurkunde unterschrieben.
Follows the English version of the preceding text:
In the year two thousand and ten, on the fourth day of the month of June.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Principia S.A., a Luxembourg joint stock company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pur-
suant to a notarial deed enacted on Mai 20, 2010, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Mr. Charles Meyer, with professional address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
by virtue of a proxy given on June 4 2010.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of Principia Verwaltungs GmbH (formerly: Kronen tausend547 GmbH),
a private limited liability company existing and incorporated under German laws, having its registered office at Graf-Adolf-
Platz 15, 40213 Düsseldorf, Germany and registered with the Trade Register of the district court of Düsseldorf under
number HRB 62271 (the ”Company”).
70258
L
U X E M B O U R G
II. The Company’s issued share capital is fixed at twenty five thousand Euro (EUR 25.000) represented by twenty five
thousand (25,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.
III. The following documents were submitted to the meeting:
(1) A certified copy of the current articles of association of the Company;
(2) A certified copy of the official trade register extract of the Company;
(3) A copy of the resolutions of the Company’s sole shareholder dated June 3, 2010;
(4) An interim balance sheet of the Company as of today;
(5) A legal opinion issued by a German notary certifying that the Company may transfer its effective management seat
from Germany to the Grand Duchy of Luxembourg;
(6) A proof that the share capital of the Company has entirely been paid up upon the incorporation of the Company.
All the above listed documents initialed by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
IV. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
(1) To take note of the transfer of the Company’s central administration from Germany to the municipality of Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Decision to adopt the corporate form of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”) and to adopt the Luxembourg nationality;
(3) Acceptance of the Company’s articles of association;
(4) Confirmation of the existing manager of the Company and appointment of a new Luxembourg resident manager;
(5) Decision to fix the address of the central administration of the Company at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(6) Miscellaneous.
V. The Company’s sole shareholder resolved on June, 2010 as referred to in III (3) above, to transfer the Company’s
central administration with effective date as at June 4, 2010 from Germany to the municipality of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
In this context, the appearing party, through its proxy holder, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The appearing party approves and confirms as far as this is necessary the decision to transfer, with effect as at the
above mentioned date, the Company’s central administration from Germany to the municipality of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The appearing party decides, with effect as at the above mentioned date, to adopt and confirm (for the purposes of
Luxembourg law) the corporate form of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
and therefore to adopt the Luxembourg nationality as of the same date.
<i>Third resolutioni>
The appearing party resolves, with effect as at the above mentioned date, to accept the following articles of association
of the Company:
§ 1. Company Name/Registered Seat.
(1) The name of the Company is Principia Verwaltungs GmbH.
(2) The registered seat of the Company is located in Düsseldorf. The seat of the Company’s management is located
in Luxembourg (Luxembourg).
(3) The Company is established for an indefinite period of time.
§ 2. Business Purpose of the Company.
(1) The business purpose of the Company is the acquisition and sale, the holding and administration, the management
and financing of affiliated companies and subsidiaries, as well as the management and the assumption of liability of com-
mercial enterprises; in particular the assumption of the capacity as general partner of Principia GmbH & Co. KG.
(2) The Company may carry out all business activities which are associated with the business purpose of the Company.
The Company is authorized to enter into enterprise agreements or cooperation agreements. The Company may establish
branches.
§ 3. Share Capital. The share capital of the Company amounts to Euro 25,000.00 (in words: Euro twenty five thousand).
It consists of 25,000 shares each in the nominal amount of Euro 1.00 (in words: Euro one) with numbers 1 through 25,000.
The contributions to the shares have been made in cash and are fully paid up.
70259
L
U X E M B O U R G
§ 4. Institutions of the Company. Institutions of the Company are the management and shareholder´s meeting.
§ 5. Transfer and Encumbrances/Amortization and Amalgamation of Shares. The transfer or encumbrance of shares
or any portions thereof is subject to the applicable laws and requires the prior written approval of all shareholders.
§ 6. Shareholders' Meetings/Resolutions.
(1) Resolutions and directions to be issued by the shareholder affecting the affairs of the Company shall be made
pursuant to a resolution to be passed in the shareholder´s meeting in accordance with the applicable laws.
(2) Shareholder´s meetings may be held at the Company’s registered seat or the Company’s management seat or at
any other location as provided for in the convocation.
(3) Shareholders’ resolutions can also be adopted by casting votes in writing, orally, by telephone, facsimile or e-mail,
if the Company has less than 25 (twenty five) shareholders.
(4) Each Managing Director is entitled to convene a shareholder´s meeting. A shareholder´s meeting can be convened
in writing, orally, by telephone, facsimile or e-mail. The convocation shall provide for the meeting agenda, the location
and time of the shareholder´s meeting. The convocation of the meeting must be received by the shareholder at least one
week before the date of the shareholder´s meeting. The date of the meeting shall not be included in this one week period.
(5) Shareholder´s meeting minutes must be drawn-up and signed by the (sole) shareholder without undue delay.
(6) The shareholder´s meeting can pass resolutions if it has been duly convened or if such due convocation has been
waived validly. If the meeting cannot pass resolutions, another shareholder´s meeting which can pass resolutions in any
case is to be duly convened; this circumstance has to be announced in the convocation.
§ 7. Management.
(1) The Company’s management shall consist of one or more Managing Directors. Managing Directors belong to
category A and B. In the event that more than one Managing Directors are appointed, they have to belong to both
categories.
(2) Managing Directors shall be appointed and revoked by the shareholder´s meeting.
(3) In the event that more than one Managing Directors are appointed (i) the Company shall be represented jointly
by two Managing Directors of different categories and (ii) the shareholder´s meeting may grant power of sole represen-
tation to a Managing Director irrespective of its category, and/or may grant an exemption from the restrictions of self-
contracting when legally acting in the name of the company towards him-/herself or third parties represented by him/her
to individual Managing Directors belonging to category A. If only one Managing Director is appointed, he/she is authorized
to represent the Company solely.
(4) The Managing Directors can pass resolutions only if the majority of both categories is present or represented. Each
Managing Director can be represented or accompanied by another Managing Director, a member of the management of
the company a member of a profession obliged by law to maintain professional secrecy (lawyer, auditor or tax consultant)
or any other third party. The power of attorney may be granted in writing, via facsimile or e-mail.
(5) Resolutions of the Managing Directors can also be adopted by casting votes orally by telephone or by e-mail. If so,
the Managing Director casting his/her vote orally (e.g. via telephone) or by e-mail is deemed to be present in the Managing
Directors´ meeting held in Luxembourg. In case of urgency resolutions of the Managing Directors can also be adopted
by casting votes in writing. In this event, Managing Directors´ meeting minutes must be approved and signed by all Managing
Directors. Those resolutions are equivalent of resolutions of the Managing Directors which have been adopted in a
meeting.
(6) The Managing Directors conduct the Company’s business with the diligence of a prudent businessman and while
observing statutory provisions, the provisions of these Articles of Association as well as the shareholder´s resolutions.
§ 8. Fiscal Year/Annual Accounts/Interim Dividends.
(1) The fiscal year shall run from January 1 through December 31 of each year.
(2) The management of the Company shall within the statutory periods and in accordance with the statutory classifi-
cation and valuation provisions – and, to the extent commercially permitted, taking into consideration the tax regulations
concerning determination of profits - draw up the annual accounts (balance sheet and profit and loss account and notes)
– and, if required by law, the management report - and present those to the shareholder´s meeting for adopting purposes.
(3) The shareholder´s meeting shall resolve upon the annual accounts and the appropriation of the annual result in
accordance with the applicable laws.
(4) The Company may distribute interim dividends if resolved thereupon in accordance with the applicable laws and
no losses occur until the next balance sheet cut-off date. Any occurrence of losses shall be deemed as a resolving condition
of the interim dividend payment(s). Since the legal basis no longer exists in such event, the shareholder shall be obliged
to repay any such interim dividends.
§ 9. Publications. Publications of the Company shall only be made in the electronic Federal Gazettes for Germany and
Luxembourg.
70260
L
U X E M B O U R G
§ 10. Formation Costs. Costs associated with this deed and its implementation (notary fees, and costs for courts and
registration with the commercial registry) as well as costs, associated with the change of articles of association and the
appointment of the management for the start of the operative business (notary fees, and costs for courts and registration
with the commercial registry), shall be borne by the Company up an amount of Euro 2,000.00 (in words: Euro two
thousand).
§ 11. Final Provisions. Should any provision of these Articles of Association be or become invalid, ineffective or un-
enforceable in whole or in part, the validity, effectiveness and enforceability of the remaining provisions shall not be
affected thereby. The shareholder shall agree upon such valid, effective and enforceable provision as comes closest to
the economic intent and purpose of the invalid, ineffective or unenforceable provision. The afore-said shall apply mutatis
mutandis to any gap in these Articles of Association.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder confirms that the following person is the Company’s manager and becomes category A manager:
<i>Category A manager:i>
- Mr. Hasan Gurhan Berker, businessman, born on September 8, 1957 in Tokat, Turkey, with professional address at
Strateji Menkul Degerler A.S., Buyukdere Cad No: 100-102, Maya Akar Center, floor 26, Esentepe 34394 Istanbul, Turkey.
The following person is appointed as the Company’s category B manager:
<i>Category B manager:i>
- Mr. Charles Meyer, employee, born on April 19, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional
address at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
The appearing party decides, with effect as at the above mentioned date, to fix the Luxembourg address of the Company
at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the transfer of its central administration are estimated at thousand euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks German and English, states herewith that on request of the
appearing party, the present deed is worded in German, followed by an English translation. On request of the same
appearing party and in case of divergences between the German and the English text, the German version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, he signed together with the notary the
present deed.
Gezeichnet: C. MEYER, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 8 Juni 2010. Relation: EAC/2010/6762. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): SANTIONI.
Référence de publication: 2010068773/337.
(100083062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 250.100,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 142.990.
En date du 28 mai 2010, les associés ont décidé de nommer Monsieur Carlo Arsi, avec adresse professionnelle au 3,
via Santa Margherita, I-20121 Milan, Italie, en tant que gérant avec effet au 17 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 juin 2010.
<i>Pour la société
i>TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2010071367/15.
(100079836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70261
L
U X E M B O U R G
Credit Suisse Prime Capital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: ZAR 362.048,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 149.389.
En date du 28 mai 2010, les associés ont décidé de nommer Monsieur Carlo Arsi, avec adresse professionnelle au 3,
via Santa Margherita, I-20121 Milan, Italie, en tant que gérant avec effet au 17 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 juin 2010.
<i>Pour la société
i>TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2010071369/15.
(100079847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Op der Gänn SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3918 Mondercange, 1, route d'Ehlerange.
R.C.S. Luxembourg B 80.513.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2010082925/11.
(100073886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.
Kumkuat, Société Anonyme.
Siège social: L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs.
R.C.S. Luxembourg B 153.556.
STATUTS
L'an deux mille dix, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
1.- Elodie DECONINCK née ROBERT, employée privée, née à Saint-Saulve/Nord (France), le 6 septembre 1983,
demeurant à F-54150 Avril, 4, rue du Muguet;
2.- Patrick EVERARD, employé privé, né à Esch-sur-Alzette le 30 janvier 1980, demeurant à L-3790 Tétange, 4, rue de
Volmerange,
3.- Daniel GONÇALVES ALMEIDA, employé privé, né à Luxembourg, le 21 octobre 1976, demeurant à L-8051 Ber-
trange, 28, rue Attert.
Les comparants ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et
dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par
les présents statuts dénommée: KUMKUAT.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et
même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.
Le siège social pourra être transféré dans la même localité par simple décision du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.
70262
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 4. La société a pour objet toutes prestations de services dans les domaines du commerce, du commerce élec-
tronique, de l'informatique, de la communication et de la publicité au sens le plus large.
La société a également pour objet l'activité d'intermédiaire commercial ainsi que l'importation, l'exportation, l'activité
de grossiste et de détaillant concernant divers types d'articles légalement commercialisables sur Internet. La société a
encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière, immo-
bilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets
similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.
Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille (33.000.-) euros, représenté par trois cent trente (330) actions
de cent (100.-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
Dans le cas où la société compte plusieurs actionnaires, chacun bénéficiera d'un droit de préemption sur les actions
de la société. Avant toute vente d'actions à des tiers non associés, l'actionnaire cédant tout ou partie de ses actions devra
les proposer par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres actionnaires. En cas d'acceptation de l'offre
par plus d'un actionnaire endéans la quinzaine, les actions leur seront attribuées au prorata de leur participation antérieure.
A défaut d'acceptation de l'offre dans les quinze jours de sa réception, l'actionnaire cédant pourra céder ses actions
à des tiers.
Outre le droit de préemption, les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs à des tiers non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de refus d'agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter un autre acquéreur. La société
peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non et qui élit un président dans son sein. Le président du conseil d'administration n'aura pas voix
prépondérante en cas de partage des voix.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les
affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est dé sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes
aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en
cas de pluralité d'administrateurs, par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de
l'administrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n'excédant pas six années.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d'avril à 15.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
70263
L
U X E M B O U R G
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires
et prend les décisions par écrit.
Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Elodie DECONINCK née ROBERT, employée privée, née à Saint-Saulve/Nord (France), le 6 septembre 1983,
demeurant à F-54150 Avril, 4, rue du Muguet, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.- Patrick EVERARD, employé privé, né à Esch-sur-Alzette le 30 janvier 1980, rue de Volmerange, cent dix
actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.- Daniel GONÇALVES ALMEIDA, employé privé, né à Luxembourg, le 21 octobre 1976, demeurant à L-8051
Bertrange, 28, rue Attert, cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent
de sorte que la somme de trente-trois mille (33.000.-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent cinquante (1.150.-) euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2010.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2011.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateur:
1.- Elodie DECONINCK née ROBERT, employée privée, née à Saint-Saulve/Nord (France), le 6 septembre 1983,
demeurant à F-54150 Avril, 4, rue du Muguet;
2.- Patrick EVERARD, employé privé, né à Esch-sur-Alzette le 30 janvier 1980, demeurant à L-3790 Tétange, 4, rue de
Volmerange,
3.- Daniel GONÇALVES ALMEIDA, employé privé, né à Luxembourg, le 21 octobre 1976, demeurant à L-8051 Ber-
trange, 28, rue Attert.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
THE CLOVER, société anonyme avec siège social à L-4963 Clemency, 8, rue Haute, inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 149 293.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2015.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs.
70264
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la
localité du siège social statutaire.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Deconinck née Robert, Everard, Gonçalves Almeida et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 27 mai 2010. Relation: EAC/2010/6250. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Kirchen.
Suit copie d'annexe:
KUMKUAT, société anonyme
siège social: L-3446 Dudelange
20, rue Mathias Cungs.
<i>Réunion du Conseil d'Administrationi>
A l'instant,
Elodie DECONINCK née ROBERT, employée privée, née à Saint-Saulve/Nord (France), le 6 septembre 1983, de-
meurant à F-54150 Avril, 4, rue du Muguet, Patrick EVERARD, employé privé, né à Esch-sur-Alzette le 30 janvier 1980,
demeurant à L-3790 Tétange, 4, rue de Volmerange et Daniel GONÇALVES ALMEIDA, employé privé, né à Luxembourg,
le 21 octobre 1976, demeurant à L-8051 Bertrange, 28, rue Attert, administrateurs de la société anonyme KUMKUAT
avec siège social à L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs, se sont réunis en conseil d'administration et, sur ordre du
jour conforme, nomment jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social 2015, Elodie
DECONINCK née ROBERT, préqualifiée, président du conseil d'administration et administrateur-délégué avec pouvoir
de signature conjoint avec un autre administrateur.
Dudelange, le 17 mai 2010.
Signé: Deconinck née Robert, Everard et Gonçalves Almeida.
NE VARIETUR
Signé: Deconinck née Robert, Everard, Gonçalves Almeida et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 27 mai 2010. Relation: EAC/2010/6250. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Kirchen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 4 juin 2010.
F. MOLITOR.
Référence de publication: 2010070730/167.
(100083020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.
V.K. S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 35.247.
L'assemblée générale tenue le 4 juin 2010 a reconduit les mandats de:
M. Alain van Kasteren demeurant professionnellement à L-8041 Bertrange, 209 rue des Romains, en tant qu'adminis-
trateur et administrateur délégué et l'a nommé président du conseil d'administration;
Mme Christiane van Gucht demeurant professionnellement à L-8041 Bertrange, 209 rue des Romains, en tant qu'ad-
ministrateur;
M. Jean Reuter demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en tant qu'administrateur;
jusqu'à l'assemblée se tenant en 2015.
La même assemblée a nommé M. Carlo Meis, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison
en tant que commissaire, en remplacement de M. Marc Steines, jusqu'à l'assemblée se tenant en 2015.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2010071562/19.
(100079670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70265
L
U X E M B O U R G
Euro China Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 126.956.
En date du 22 avril 2010, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société, de l'ancienne
adresse au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, à sa nouvelle adresse au 38, Avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg
et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 2010.
Sabrina Charny
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010071386/14.
(100079737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
First Foods S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 116.137.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2010i>
En date du 26 mai 2010, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé comme suit:
- de renouveler le mandat de M. Carlos SCHVARTZMAN, demeurant professionnellement au 416 avenue Louise,
B-1050 Bruxelles, en tant qu'administrateur de la Société, et ce avec effet rétroactif au 7 mai 2007. Son mandat expirera
à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2012.
- d'accepter le renouvellement de mandat de M. Carlos SCHVARTZMAN, demeurant professionnellement au 416
avenue Louise, B-1050 Bruxelles, en tant qu'administrateur-délégué de la Société. Son mandat expirera à l'issue de l'as-
semblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2012.
- de renouveler le mandat de M. Koichi YANAGIZAWA, demeurant professionnellement au 4271 Chaumont Rd.,
USA-90013 Woodland Hills, (CA), Etats Unis d'Amérique et Mme Tsunemi TAKIGUCHI, demeurant professionnellement
au 4271 Chaumont Rd., USA-90013 Woodland Hills, (CA), Etats Unis d'Amérique, en tant qu'administrateurs de la Société
avec effet immédiat. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31
décembre 2012.
- de renouveler le mandat de M. Marcel STEPHANY, demeurant professionnellement au 23 Cité Aline Mayrisch, L-7268
Bereldange, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de
l'assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2010.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010071398/27.
(100079749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Geldilux-TS-2008 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 141.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
Référence de publication: 2010082906/13.
(100073895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.
70266
L
U X E M B O U R G
Financière Cavour S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 32.085.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juini>
<i>2010i>
Monsieur DE BERNARDI Angelo est nommé Président du Conseil d'administration. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.
Pour extrait sincère et conforme
FINANCIERE CAVOUR S.A.
Angelo DE BERNARDI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010071403/15.
(100079887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Immo Steichen, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 109.428.
<i>Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Immo Steichen société anonyme für das am 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahri>
In der ordentlichen Generalversammlung der Immo Steichen société anonyme am 31. Mai 2010 wurde die Deloitte
S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer der Immo Steichen société anonyme für das am
31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr bestellt. Die Bestellung endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung im Jahre 2011.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Immo Steichen
Société anonyme
Unterschriften
Référence de publication: 2010071425/16.
(100079862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Jaz Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 139.903.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le 25 mai 2010 à 14:00 heuresi>
L'Assemblée Générale décide de nommer la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, RCS B 60.219, demeurant au 63-65,
rue de Merl à L-2146 Luxembourg comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement de International Con-
sulting S.A., RCS B 51.992, demeurant au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, avec expiration du mandat lors de
l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2010071432/15.
(100079835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
BPER International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.517.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010084285/9.
(100074861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.
70267
L
U X E M B O U R G
Immobilière Orion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 93.725.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 mai 2010 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
"Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Mo-
hammed Mounir EL MAJIDI, Monsieur Mohcine BENYAGOUB et FIDUPAR représentée par M. Noël DIDIER, 10,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à.r.l, 18A, boulevard de la Foire, Luxem-
bourg en tant que Commissaire aux Comptes.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31/12/2010."
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Présidenti>
Référence de publication: 2010071426/20.
(100079731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Bantleon Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 72.580.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010084286/9.
(100074862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.
KEIF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 943.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 118.846.
Veuillez noter que la dénomination de l'associé unique Kenmore European Industrial Fund Limited a changé et devient
à présent Tamar European Industrial Fund Limited.
Luxembourg, le 3 juin 2010.
<i>Pour la société
i>Polyxeni Kotoula / Jorge Perez Lozano
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2010071435/14.
(100079856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 278.575,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 119.739.
Veuillez noter que la dénomination de l'associé unique Kenmore European Industrial Fund Limited a changé et devient
à présent Tamar European Industrial Fund Limited.
70268
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 3 juin 2010.
<i>Pour la société
i>Polyxeni Kotoula / Jorge Pérez Lozano
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2010071436/14.
(100079891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Klepierre Meteores, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.973.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue le mercredi 5 mai 2010 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Messieurs Laurent
MOREL; 21 avenue Kléber F-75016 Paris, Jean-Michel GAULT, 21 avenue Kléber F-75016 Paris, Joseph WINANDY, et
de la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, pour
une période venant à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes au 31/12/2010.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler FIDUCIAIRE HRT au poste de Commissaire aux
Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes de
l'exercice clôturant au 31/12/2010.
Pour extrait
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010071449/20.
(100079734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Landmark S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.905.
<i>Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Landmark S.A. für das am 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahri>
In der ordentlichen Generalversammlung der Landmark S.A. am 31. Mai 2010 wurde die Deloitte S.A., 560, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer der Landmark S.A. für das am 31. Dezember 2010 endende Ge-
schäftsjahr bestellt. Die Bestellung endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre
2011.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Landmark S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2010071462/15.
(100079879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Melio Luxembourg International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.500.001,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 81.078.
En date du 31 mai 2010, les associés ont décidé de nommer Monsieur Carlo Arsi, avec adresse professionnelle au 3,
via Santa Margherita, I-20121 Milan, Italie, en tant que gérant avec effet au 17 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
70269
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 4 juin 2010.
<i>Pour la société
i>TMF Management Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2010071472/15.
(100079819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.055.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 148.400.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 11 mai 2010.i>
En date du 11 mai 2010 l'associé unique de la Société a décidé comme suit
- d'accepter la démission de Allen Mistysyn en tant que gérant A de la Société et ce avec effet immédiat.
- d'accepter la démission de Eric Vanderkerken en tant que gérant B de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Lawrence James Boron, employé, né le 12 février 1959 à Ohio, Etats-Unis d'Amérique, demeurant
professionnellement au 648 Treeside Lane, Avon Lake, Ohio 44012, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant A de la
Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Jean Gil Pires, employé, né le 30 novembre 1969 à Luxembourg, Luxembourg, demeurant profession-
nellement au 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, Luxembourg en tant que gérant B de la Société pour une
durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
- Lawrence James Boron
- Howard Hargreaves
<i>Gérants B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Paul Lamberts
Pour mention aux fins de publication aux Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2010.
Richard Brekelmans
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2010071512/30.
(100079774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Magic Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 75.789.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 avril 2010i>
<i>Résolution:i>
A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de nommer M. Joseph WINANDY, Président du Conseil d'Admi-
nistration de la Société
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010071479/14.
(100079751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
70270
L
U X E M B O U R G
LMC German Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 140.584.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010082955/11.
(100073934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.
Navlink S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 76.772.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 avril 2010i>
<i>Résolution:i>
A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de nommer M. Joseph WINANDY, Président du Conseil d'Admi-
nistration de la Société
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010071487/14.
(100079740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Placeholder 25 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 148.070.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 09 octobre 2009, la démission de Mme
Elisabeth Verri du poste de gérant unique avec effet immédiat, et la nomination de Mr Patrick Steinhauser en remplace-
ment, avec effet au 09 octobre 2009.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Patrick Steinhauser
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2010071498/16.
(100079682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Placeholder 25 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 148.070.
EXTRAIT
Le Gérant Unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 7,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 9 octobre 2009.
70271
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Patrick Steinhauser
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2010071499/15.
(100079682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Dorn Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 118.967.
Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010084300/9.
(100075319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.
Quoniam Funds Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.455.
<i>Abschlussprüfer der Gesellschafti>
In der ordentlichen Generalversammlung am 2. Dezember 2009 haben die Aktionäre einstimmig beschlossen, die
KPMG Audit S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, zum Abschlussprüfer für das am 30. September 2010 endende
Geschäftsjahr zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Quoniam Funds Selection SICAV
Maria Löwenbrück / Rudolf Kessel
Référence de publication: 2010071502/14.
(100079855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Rapid-Press, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 10.735.
<i>Procès verbal de l' assemblée générale extraordinaire du du 28/05/2010i>
- Démission de Monsieur Marc Hoenen en sa qualité de gérant administratif:
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marc Hoenen prenant effet le 30 juin 2010.
- Nomination d'un nouveau gérant administratif:
L'Assemblée procède au report de la nomination d'un nouveau gérant administratif.
<i>Pour la société
i>Alain Chauveheid
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010071504/15.
(100079812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
ERE III - N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 137.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010082785/10.
(100073967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
70272
Advent Dahlia Luxembourg Holding S.à r.l.
Advent Dahlia (Luxembourg) S.à. r.l.
Bantleon Invest S.A.
Boxford Investment S.A.
BPER International Sicav
BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank
Car Testing S.A.
Colombo Holdings S.A.
Crediinvest SICAV
Credit Suisse Capital (Luxembourg) S.à r.l.
Credit Suisse Prime Capital (Luxembourg) S.à r.l.
Dorn Immo S.A.
EECF Beta Manager
Ektornet Latvia S.A.
Ektornet Lithuania S.A.
Ektornet Nordic S.A.
ERE III - N°2 S.à r.l.
Euro China Ventures S.A.
Financière Cavour S.A.
First Foods S.A.
Gaming VC Holdings S.A.
Geldilux-TS-2008 S.A.
Hayfin Opal Luxco 1 S.à r.l.
Illor II S.A.
Illor I S.A.
Immobilière Orion S.A.
Immo Steichen
Innova S.A.
Jaz Holding S.A.
KEIF Luxembourg S.à r.l.
KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l.
Klepierre Meteores
Kumkuat
Landmark S.A.
LMC German Investments
Magic Finance S.A.
Ma.Lo S.A.
Melio Luxembourg International S.à.r.l.
Motorinvest S.A.
Navlink S.A.
Navlink S.A.
Nile Capital II S.à r.l.
Office Rental Luxembourg S.A.
Op der Gänn SA
Placeholder 25 S.à r.l.
Placeholder 25 S.à r.l.
Principia Verwaltungs GmbH
Quoniam Funds Selection SICAV
Raiffeisen-Wuere-Genossenschaft
Rapid-Press
Riviera Property S.A.
Russian Mortgage Backed Securities 2008-1 S.A.
Saposa S.à r.l.
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l.
Sifraso S.A.
V.K. S.A.H.