logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1449

15 juillet 2010

SOMMAIRE

AG Fiduciaire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69547

Aon Re Canada Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

69545

Aviabel Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69543

Bâloise Fund Invest (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . .

69540

Carbone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69550

CLT-UFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69549

Cofinimmo Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

69542

Collineo Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69544

Compagnie de Banque Privée  . . . . . . . . . . .

69550

Damire International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

69539

Dominus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69545

Durante Business S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69545

EDM International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69552

Fongesco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69552

FR Acquisition Subco (Luxembourg), S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69539

Francilienne Investments II S.à r.l.  . . . . . . .

69544

Graphing Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69546

Heron Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69550

Heron Les Mesnuls S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69551

Heron Nointel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69551

Hippocampus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69548

Hippocampus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69548

Hoertässelesch Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69549

Immo-Agence Florida S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

69547

Innisfree ISF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69506

Jupiter Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

69543

Kashyk S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69545

LaSalle Torius S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69544

Lettrage Reding Nico S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

69547

Librairie Am Pullewe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

69546

LIM Advisory Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69545

LPOV Holdings 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69544

LPOV Holdings 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

69544

Lux-Aerospace S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69547

Mastertec Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69542

Microfinance Enhancement Facility SA, SI-

CAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69540

Mobile Telesystems Finance S.A.  . . . . . . . .

69531

Monarchy Enterprises S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

69550

Mondo Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

69551

Morgan Stanley Investment Funds  . . . . . . .

69516

N.A.S. Aviation S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69548

N.A.S. Aviation S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69548

Novalex Holding S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69539

O'Neill Brand S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69516

Orocash Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69541

Orocash Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69541

PIN H. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69545

Prentice S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69541

Prorest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69549

Regus plc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69540

RTL Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69549

Safer Holdings S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69550

Satalux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69551

SFDC Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69548

SmartStream Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . .

69541

Sogeimm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69543

Sogeimm S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69546

S.R.E.T. Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69549

Stëftung Hëllef Doheem  . . . . . . . . . . . . . . . .

69531

Stone River S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69540

Turk Real Estate Management S.àr.l.  . . . .

69546

Weather Investors S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

69542

Weather V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69543

Weather X S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69542

69505

L

U X E M B O U R G

Innisfree ISF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.570.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-first of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Innisfree Nominees Limited, with registered office at 7 

th

 Floor, Abacus House, 33, Gutter Lane, London EC2V 8AS,

United Kingdom and registered with the Companies House under number 3565361, here represented by Mrs Rachel
UHL, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal dated 6 May 2010.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "Innisfree ISF

S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by
the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present

articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Art. 3. Object.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg  or  foreign  entities,  by  any  means  and  to  administrate,  develop  and  manage  such  holding  of  interests  or
participations.

3.2 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means

including real estate related investments.

3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company  or  any  company  belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  "Connected
Companies"), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged
in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.4 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the

69506

L

U X E M B O U R G

performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg Law.

3.5 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

4. Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twenty-thousand Canadian Dollars (CAD 20,000.-) represented by:
1. Nineteen thousand one hundred (19,100) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
2. One hundred (100) class "A" shares (the "Class A Shares"),
3. One hundred (100) class "B" shares (the "Class B Shares"),
4. One hundred (100) class "C" shares (the "Class C Shares"),
5. One hundred (100) class "D" shares (the "Class D Shares"),
6. One hundred (100) class "E" shares (the "Class E Shares"),
7. One hundred (100) class "F" shares (the "Class F Shares"),
8. One hundred (100) class "G" shares (the "Class G Shares"),
9. One hundred (100) class "H" shares (the "Class H Shares"),
10. One hundred (100) class "I" shares (the "Class I Shares"),
with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.
The Class A to I Shares are together referred to as the "Specific Class of Shares" and the Ordinary Shares and shares

of Specific Class of Shares are together referred to as the "Shares". The holders of the Shares are together referred to
as the "Shareholders", and each a "Shareholder".

5.2 The features of the different classes of Shares are outlined in the present Articles.
5.3 In addition to the share capital, the Company shall have share premium accounts, one for each class of Shares, into

which any premium paid on any class of Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has
exclusive entitlement to. The share premium accounts are at the free disposal of the Shareholders without prejudice to
article 15.3.

5.4 The Company shall also have freely available reserve accounts (each, a “Reserve Account”), one for each class of

Shares, the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to. The Reserve Accounts are at
the free disposal of the Shareholders without prejudice to article 15.3.

5.5 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the applicable legal principles

and the present Articles.

5.6 In the case of repurchase and cancellation of Shares, such repurchase and cancellation shall be made in respect of

one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es)
of Shares. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares,
such class of Shares gives right to the holder(s) thereof, (i) firstly, to the nominal value of such class of Shares plus the
amount of the share premium allocated to such class of Shares in the relevant class of share premium account and the
amount of the funds allocated to the relevant Reserve Account, and (ii) secondly, to any funds arising from each connected
Specific Asset (as defined under clause 15) at the disposal of the Company in excess of the amounts under (i) above to
the extent that they are freely distributable in accordance with the Law and the Articles as determined by the Board of
Managers and approved by the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant interim accounts (the sum
of such amounts being the "Cancellation Value"). Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class
of Shares, the Cancellation Value shall become due and payable by the Company.

5.7 The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters

of the share capital at least.

6. Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is

admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

69507

L

U X E M B O U R G

Chapter III. - Management

8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

one manager, he/it will be referred to as the “Sole Manager”. In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers (“conseil de gérance”) (hereafter the “Board of Managers”). The Board of Managers may be composed of
class A managers and class B managers.

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by

a resolution of the shareholder(s).

9. Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of one class A
manager and one class B manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of
a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by one class A manager and one class B manager.

11. Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, one class A manager and one class B manager may delegate

its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, one class A manager and one class B manager will determine

any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other
relevant conditions of its agency.

12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board

of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. Any Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by one class A Manager and one class B

Manager.

12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the

Board of Managers.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s)  Votes.
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'

meeting and takes the decisions in writing.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

69508

L

U X E M B O U R G

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V. - Business year

14. Art. 14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on the 1 

st

 April and ends on the 31 

st

 March of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be compulsorily allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent (10%) of the
corporate capital of the Company.

15.2 The general meeting of Shareholders shall allocate the annual profit or loss as follows:
15.2.1 Each class of Shares shall confer on the holder(s) of such class the right to participate in profits of the Company

arising from any asset whose acquisition by the Company (or any entity in which the Company has an interest) was funded
(in whole or in part) by the subscription proceeds corresponding to such class of Shares (such asset being a "Specific
Asset" in relation to such class of Shares) and all losses relating to a Specific Asset shall be attributable only to the
corresponding Shares class (and to no other class of Shares).

15.2.2 Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to each Specific Class of Shares for

accounting and tax purposes as if each Specific Asset to which they refer were the sole investment held by the Company
(each, a “Specific Profit and Loss Account”). All expenses and incomes connected to a Specific Asset shall be credited to
or debited from the corresponding Specific Profit and Loss Account.

15.2.3 The balance of each Specific Profit and Loss Account shall then be allocated to the corresponding Reserve

Account.

15.2.4 If and insofar that legal reserves have to be formed or their balances have to be increased by the Company in

any financial year, the positive balances of the Specific Profit and Loss Accounts shall be used for this purpose. If and
insofar as is possible, such a reserve shall be formed or increased to the charge of each Specific Profit and Loss Account
in proportion to the percentage representing the positive balance of each Specific Profit and Loss Account over the profit
shown by the annual accounts.

15.2.5 If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the

Specific Profit and Loss Account(s) against which the legal reserve was formed or increased.

15.2.6 Dividends may be paid out of each Specific Profit and Loss Account and out of the share premium account

corresponding to the Specific Class of Shares concerned and out of the Reserve Account corresponding to the Specific
Class of Shares concerned only to the holders of the Specific Class of Shares concerned.

15.2.7 The Ordinary Shares shall confer upon the holder(s) the remainder of the Company's profit for any given financial

year, but no dividends will be paid to the holder(s) of the Ordinary Shares until all rights to dividends of the holder(s) of
the Specific Class of Shares of the current year have been paid.

15.2.8 Distribution shall be done by virtue of a resolution of the general meeting of Shareholders.
15.2.9 In any case, dividends can only be distributed and Shares redeemed to the extent that the Company has distri-

butable sums within the meaning of the Law.

15.3 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends on each class of Shares to the Shareholder(s) before the end of the financial
year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that (i) the amount to be distributed shall be determined in accordance with the present article 15 and may not exceed,
where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according
to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
shall be reimbursed by the Shareholder(s).

69509

L

U X E M B O U R G

Chapter VI. - Liquidation

16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable law

17. Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 March

2011.

<i>Subscription - Payment

Innisfree Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,100 Ordinary Shares,

100 Class A Shares,

100 Class B Shares,

100 Class C Shares,

100 Class D Shares,

100 Class E Shares,

100 Class F Shares,

100 Class G Shares,
100 Class H Shares,

100 Class I Shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000 Shares

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twenty-thousand Canadian Dollars (CAD 20,000.-) cor-

responding to a share capital of twenty-thousand Canadian Dollars (CAD 20,000.-) is forthwith at the free disposal of
the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined period.
1. Tim Kashem, born on 10 June 1970 in Manchester, United Kingdom, professionally residing at 7 

th

 Floor, Abacus

House, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, United Kingdom, fund manager as class A manager;

2. James Ward, born on 25 April 1952 in Bolton, United Kingdom, professionally residing at 7 

th

 Floor, Abacus House,

33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, United Kingdom, fund manager as class A manager;

3. Jean-Jacques Josset, born on 12 June 1974 in Saint-Quentin, France, professionally residing at 46A, av. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, private employee as class B manager; and

4. Gérald Welvaert, born on 15 July 1977 on Uccle, Belgium, professionally residing at 46A, av. Kennedy, L-1855

Luxembourg, private employee as class B manager.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

69510

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Innisfree Nominees Limited, ayant son siège social au 7 

th

 Floor, Abacus House, 33, Gutter Lane, Londres EC2V 8AS,

Royaume-Uni et immatriculé auprès de la Companies House sous le numéro 3565361 ici représenté par Madame Rachel
UHL, juriste, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 6 mai 2010.

Laquelle procuration paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte comme

suit des statuts d'une société à responsabilité limitée:

Titre I 

er

 . - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Innisfree

ISF S.à r.l." qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ciaprès la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après les «Statuts»).

2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à

transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être  transféré  provisoirement  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales;  cette  mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

3. Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations

dans des entités luxembourgeoises ou étrangères par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer la détention
de ces intérêts et participations.

3.2 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir, acquérir, détenir ou disposer de toutes sortes

d'avoirs par tous moyens y compris des investissements liés à l'immobilier.

3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après
reprises comme les «Sociétés Apparentées»), étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait
qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment mais non limitativement, par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre
et autres instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec, ou souscrire à ou acquérir tout instrument de dette,

avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.

3.5 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

69511

L

U X E M B O U R G

4. Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Parts sociales

5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à vingt mille dollars canadiens (20.000 CAD) représenté par:
1. Dix-neuf mille cent (19.100) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»),
2. Cent (100) parts sociales de catégorie «A» (les «Parts Sociales de Catégorie A»),
3. Cent (100) parts sociales de catégorie «B» (les «Parts Sociales de Catégorie B»),
4. Cent (100) parts sociales de catégorie «C» (les «Parts Sociales de Catégorie C»),
5. Cent (100) parts sociales de catégorie «D» (les «Parts Sociales de Catégorie D»),
6. Cent (100) parts sociales de catégorie «E» (les «Parts Sociales de Catégorie E»),
7. Cent (100) parts sociales de catégorie «F» (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
8. Cent (100) parts sociales de catégorie «G» (les «Parts Sociales de Catégorie G»),
9. Cent (100) parts sociales de catégorie «H» (les «Parts Sociales de Catégorie H»),
10. Cent (100) parts sociales de catégorie «I» (les «Parts Sociales de Catégorie I»),
ayant chacune une valeur nominale d'un dollar canadien (1 CAD).
Les parts sociales de Catégorie A à I sont ci-après reprises comme les «Parts Sociales de Catégorie Spécifique» et les

Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Catégorie Spécifique sont ci-après reprises comme les «Parts Sociales».
Les détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble ci-après comme les «Associés», et chacun individuellement
comme un «Associé».

5.2 Les caractéristiques des différentes catégories de Parts Sociales sont détaillées dans ces Statuts.
5.3 En plus du capital social, la Société aura des comptes de prime d'émission, un pour chaque catégorie de Parts

Sociales sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute catégorie de Parts Sociales sera transférée et sur lesquels
chaque détenteur a un droit exclusif. Les comptes de prime d'émission sont à la libre disposition des Associés sans
préjudice de l'article 15.3.

5.4 La Société aura également des comptes de réserves disponibles (chacun, un «Compte de Réserve»), un pour chaque

catégorie de Parts Sociales, sur lesquels chaque détenteur a un droit exclusif. Les Comptes de Réserve sont à la libre
disposition des Associés sans préjudice de l'article 15.3.

5.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites prévues par la Loi et les présents

Statuts.

5.6 En cas de rachat et d'annulation des Parts Sociales, un tel rachat et une telle annulation se feront, relativement à

une ou plusieurs catégories de Parts Sociales, par voie de rachat ou d'annulation de l'ensemble des Parts Sociales émises
dans la (les) catégorie(s) de Parts Sociales concernée(s). En cas de réduction du capital social suite au rachat et à l'annu-
lation d'une catégorie de Parts Sociales, cette catégorie de Parts Sociales donnera droit au(x) détenteur(s) de celles-ci,
(i) premièrement, à la valeur nominale d'une telle catégorie de Parts Sociales plus le montant de la prime d'émission
allouée à cette catégorie de Parts Sociales dans le compte de prime d'émission correspondant ainsi que le montant des
fonds alloués au Compte de Réserve correspondant, et (ii) deuxièmement, aux fonds découlant de chaque Elément d'Actif
Spécifique (tel que défini sous la clause 15) à la disposition de la Société en supplément des montants dont il est fait
référence sous (i) dans la mesure où ces fonds sont librement distribuables conformément à la Loi et les présents Statuts
et tels que déterminés par le Conseil de Gérance et approuvés par l'assemblée générale des Associés sur base d'un bilan
intérimaire (la somme de ce montant étant la «Valeur d'Annulation»). Après le rachat et l'annulation des Parts Sociales
des catégories de Parts Sociales concernées, la Valeur d'Annulation sera exigible et due par la Société.

5.7 Le capital social peut être modifié à tout moment par l'accord d'une majorité d'associés représentant au moins

trois quarts du capital social.

6. Art. 6. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul

propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

7. Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales de la Société détenues par celui-ci sont librement

transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

69512

L

U X E M B O U R G

Titre III. - Gérance

8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des Associé(s). Dans le cas d'un

seul gérant, il est défini ci-après comme le «Gérant Unique». En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil
de gérance (ci-après le «Conseil de Gérance»). Le Conseil de Gérance peut être composé de gérant A et de gérant B.

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou

sans motif, par décision des associé(s).

9. Art. 9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous

les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

10. Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement

engagée par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un
gérant A et d'un gérant B ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant
Unique, par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par un gérant A et un gérant B.

11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant A et un gérant B peu(ven)t déléguer ses (leurs)

pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant A et un gérant B détermine(ent) les responsabilités

et la rémunération (le cas échéant) de tout mandataire ad hoc, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.

12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil

de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les

gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux exigences et formalités de convocation.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via la vidéo ou le téléphone.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du

Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par un gérant A et un gérant B.
12.8 Des extraits seront certifiés par tout Gérant ou toute personne nommée par tout gérant ou lors de la réunion

du Conseil de Gérance.

Titre IV. - Assemblée générale des Associés

13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des Associés  Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors des réunions à convoquer

conformément aux dispositions légales applicables.

69513

L

U X E M B O U R G

13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote par écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises qu'à la condition que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que
par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve de toutes
autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

Titre V. - Exercice social

14. Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de
Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

15. Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront obligatoirement alloués pour la constitution de

la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

15.2 L'assemblée générale des associés doit alloué les profits et pertes comme suit:
15.2.1 Chaque catégorie de Parts Sociales conférera au détenteur de cette catégorie le droit de participer aux profits

de la Société découlant de tout actif dont l'acquisition par la Société (ou toute entité dans laquelle la Société a un intérêt)
a été financée (entièrement ou partiellement) à partir des produits de la souscription à cette catégorie de Parts Sociales
(cet actif étant l'"Actif Spécifique" relatif à la catégorie de Parts Sociales) et toutes pertes relatives à un Actif Spécifique
seront attribuées uniquement à la catégorie de Parts Sociales correspondante (et à aucune autre catégorie de Parts
Sociales).

15.2.2 Chaque année, la Société doit déterminer les profits et pertes attribuables aux Parts Sociales de Catégorie

Spécifique pour des raisons comptables et fiscales, comme si chaque Actif Spécifique auxquels elles se rapportent était le
seul investissement détenu par la Société (le «Compte de Résultats Spécifiques»). Toutes les dépenses et revenus liés aux
Actifs Spécifiques doivent être crédités ou débités du Compte de Résultats Spécifique correspondant.

15.2.3 Le solde de chaque Compte de Résultats Spécifique devra ainsi être alloué au Compte de Réserve correspondant.
15.2.4 Si et pour autant que des réserves légales doivent être formées ou que leurs soldes doivent être augmentés par

la Société lors d'une année sociale, les soldes positifs des Comptes de Résultats Spécifiques doivent être utilisés pour ce
but. Si et pour autant que possible, cette réserve devra être formée ou augmentée aux frais de chaque Compte de Résultats
Spécifique, en proportion du pourcentage représentant le solde positif de chaque Compte de Résultats Spécifique sur les
profits montrés par les comptes annuels.

15.2.5 Si et pour autant qu'une réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté

au(x) Compte(s) de Résultats Spécifique(s) en vertu duquel la réserve légale a été formée ou augmentée.

15.2.6 Des dividendes peuvent être payés à partir de chaque Compte de Résultats Spécifique et du compte de prime

d'émission correspondant aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique concernées et à partir du Compte de Réserve
correspondant aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique concernées uniquement aux propriétaires des Parts Sociales
de Catégorie Spécifique concernées.

15.2.7 Les Parts Sociales Ordinaires conféreront à leur détenteur(s) le reste des profits de la Société pour toute année

sociale donnée, mais aucun dividende ne sera payé au(x) détenteurs de Parts Sociales Ordinaires jusqu'à ce que les droits
aux dividendes de(s) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie Spécifique de l'année en cours n'aient été payés.

15.2.8 Les distributions doivent toujours être faites en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des Associés.
15.2.9 Dans tous les cas, les dividendes ne peuvent être distribués et les Parts Sociales rachetées que dans la mesure

où la Société a des sommes distribuables au sens de la Loi.

15.3 Nonobstant les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires sur chaque catégorie de Parts Sociales aux Associé(s) avant la fin de
l'année sociale sur la base d'un état des comptes montrant que suffisamment de fonds sont disponibles pour distribution,
sachant que (i) le montant devant être distribué doit être déterminé conformément à cet article 15 et ne doit pas dépasser,
lorsque applicable, les profits réalisés depuis la fin de la dernière année sociale, augmenté par les profit reportés en avant
et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées en avant et des sommes devant être allouées à la réserve
établie en vertu de la Loi ou de ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux profits
en fait réalisés doivent être remboursées par les Associé(s).

69514

L

U X E M B O U R G

Titre VI. - Liquidation

16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite

de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec les dispositions légales

applicables.

16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII. - Loi applicable

17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2011.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:

Innisfree Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dix-neuf mille cent (19.100) Parts Sociales

Ordinaires,

Cent (100) Parts Sociales de Catégorie A,
Cent (100) Parts Sociales de Catégorie B,
Cent (100) Parts Sociales de Catégorie C,
Cent (100) Parts Sociales de Catégorie D,
Cent (100) Parts Sociales de Catégorie E,

Cent (100) Parts Sociales de Catégorie F,

Cent (100) Parts Sociales de Catégorie G,
Cent (100) Parts Sociales de Catégorie H,

Cent (100) Parts Sociales de Catégorie I.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000 Parts Sociales

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées , de telle façon que la somme de vingt mille dollars canadiens

(20.000 CAD) correspondent au capital social de vingt mille dollars canadiens (20.000 CAD) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ trois mille Euro.

<i>Assemblée générale de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social

souscrit, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés Gérants de la Société pour une période indéterminée:
1. Tim Kashem, né le 10 juin 1970 à Manchester, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 

th

 Floor, Abacus

House, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS, Royaume Uni, gérant de fond en tant que gérant A,

2. James Ward, né le 25 avril 1952 à Bolton, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 

th

 Floor, Abacus

House, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS, Royaume Uni, gérant de fond en tant que gérant A,

3. Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à Saint-Quentin, France, ayant son adresse professionnelle au 46A, av. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, employé privé, en tant que gérant B, et

4. Gérald Welvaert, né le 15 juillet 1977 à Uccle, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 46A, av. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, employé privé, en tant que gérant B.

2) Le siège social de la Société est établi au 46A, av. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande du comparant le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de cette même personne comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date et l'heure donnée en tête.

69515

L

U X E M B O U R G

Le document ayant été lu au mandataire du comparant, ladite mandataire a signé, avec le notaire, le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2010. Relation: LAC/2010/23425. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010068699/545.
(100083154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2010.

Morgan Stanley Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 29.192.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010082818/10.
(100074222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

O'Neill Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 153.237.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the seventh day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Inter-Him N.V., a company limited by shares incorporated under the laws of the Netherlands Antilles, with registered

office at Curacao, the Netherlands Antilles and its business address at professor Kernkampweg 8A, the Netherlands
Antilles, registered with the Commercial Register of Curacao under number 23748;

represented  by Mr.  Alexander  Koch,  attorney-at-law,  with professional  address  in  Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), by virtue of a proxy;

and
Goldman Sachs &amp; Co., a limited partnership incorporated under the laws of the New York State, with registered office

at 85 Broad Street, New-York, NY 10004, United States of America;

represented by Mrs. Carole Noblet, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Lu-

xembourg), by virtue of a proxy.

The said proxies, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxies holders and the undersigned

notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such parties, acting in the hereinabove stated capacity, have requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which they declare to establish as
follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become

owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended,
and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "O'Neill Brand S.à r.l.".

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the

case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the
municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company

69516

L

U X E M B O U R G

at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons
abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer
of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the acquisition, assignment, development, ownership and

exploitation of patents, licenses, designs, trademarks, protections, concessions and other rights of intellectual property
as well as the exercise of all rights deriving from or pertaining to any of the aforesaid.

This includes, but is not limited to the registration, protection, maintenance of the intellectual property rights as well

as registering the trademarks and other the intellectual property rights, controlling such registration and their terms and
use as well as the identification of any intellectual property infringement of intellectual property rights.

The Company shall also be in charge of the strategic management of the intellectual property portfolio including but

not limited to the management of the relationship with all existing and prospective licensees and the management of the
sub-licensing contracts and activities.

The Company shall invoice, collect and disburse royalties.
The Company shall further accomplish, in Luxembourg or abroad, in its own name and on its own behalf or in the

name and on behalf of third parties all operations which are directly or indirectly related to the purchase and sale,
importation and exportation, trade, fabrication, transformation and repair of all fashion material and accessories.

In general, the Company may carry out any industrial, commercial or financial operations and engage in such other

activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accom-
plishment and development of the foregoing.

The Company may acquire any real or immovable property, both in Luxembourg and abroad, irrespective of whether

such property is directly or indirectly related to its corporate purpose.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of

indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may, in any manner, acquire an interest in or co-operate or merge with any association, business,

enterprise or company having an identical, similar or related purpose or one that is liable to facilitate its business and /
or develop the sale of its services.

The Company may realize its object in any manner and in accordance with such terms as it finds suitable.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-)

divided into one hundred and twenty-four (124) shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each (the
"Shares").

In addition to the share capital a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition

to the nominal value is transferred. The amount of the premium account may, amongst others, be used to provide for
the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares and transfers of shares. All the shares will be and remain in registered form.
When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst share-

holders. Subject to the transfer restrictions set out in Article 8, the shares may be transferred to non-shareholders only
with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance
with article 190 of the Law and 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the

Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital and Pre-emption rights with respect to the Shares. The subscribed

share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder
or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these
Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.

Any creation, allotment or issue of any share or any other security, or grant of an option or right to subscribe for or

to convert any instrument into shares or securities, proposed to be made by the Company (such shares or other securities
being the "Additional Securities") shall first be offered for subscription to the shareholders in the proportion that the
number of issued shares for the time being held by each such person bears to the total number of such shares in issue.

69517

L

U X E M B O U R G

Such offer shall be made by notice in writing specifying the number of Additional Securities to which the relevant holder

is entitled and limiting a time (being not less than thirty (30) calendar days) within which the offer (if not accepted) will
be deemed to have been declined. Such offers are not transferable, cannot be split or consolidated and can be accepted
in full or in part.

Shareholders who accept the offer shall be entitled to indicate that they would accept, on the same terms, the Addi-

tional Securities (specifying a maximum number of parcels) which have not been accepted by other shareholders (the
"Excess Additional Securities"). Any Excess Additional Securities shall be allotted to shareholders who have indicated they
would accept Excess Additional Securities. Excess Additional Securities shall be allotted pro rata to the aggregate number
of shares held by shareholders accepting the Excess Additional Securities (provided that no such holder shall be allotted
more than the maximum number of Excess Additional Securities such holder has indicated he is willing to accept).

After the expiration of the time specified pursuant to the above, or upon receipt by the Company of an acceptance

or refusal of every offer so made, the Board of Managers shall be entitled to dispose of any Additional Securities so
offered, and which are not required to be allotted in accordance with the third paragraph of this article, in each case on
the same terms as such Additional Securities were offered to the Shareholders pursuant to the second paragraph of this
article.

If, owing to the inequality of the number of new Additional Securities to be issued and the number of Shares held by

shareholders entitled to receive the offer of new Additional Securities, any difficulties shall arise in the apportionment of
any such new Additional Securities amongst the holders, such difficulties shall be determined by the Committee (as defined
in Article 17).

Art. 8. Transfer Restrictions. Any transfer of Shares shall be subject to the transfer restrictions set out in any agreement,

present or future, which is entered into by and between Goldman Sachs &amp; Co ("GS"), Inter-Him N.V. or its successors
and assigns ("IH"), and/or any other company which is a member of the same group of companies as the Company.

Chapter III. Management, Board of managers, Auditors

Art. 9. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the

"Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of
Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of share-

holders, which will determine their number, their remuneration, provided that (an amendment of the remuneration
payable to any Manager will, in addition, require the approval of the relevant Manager, and the limited or unlimited duration
of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of
their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as
the case may be, of the general meeting of shareholders.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental

to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise

the power granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman. The Chairman will preside at all meetings of the

Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore
by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of
the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his

representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In

case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

69518

L

U X E M B O U R G

A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a duly convened

and held meeting of the Board of Managers.

Such a decision can be constituted of a single document or of several separate documents all having the same content

and each of them signed by one or several Managers.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as

the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at
the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board

of Managers or by any two Managers.

Art. 12. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with

the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal
nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to
the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers

and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a
Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the
Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and

determine their composition and purpose.

Art. 14. Representation of the Company. Should only one Manager have been appointed, the Company will be bound

toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any
person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Should the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards

third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person
(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other
company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company,
including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm
with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically
prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the

Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company,
concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of
any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of share-
holders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party,
other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Com-
pany's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is
conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

Art. 16. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and her/his heirs, executors and administrators,

for expenses reasonably incurred by her/him in connection with any action, suit or procedure to which s/he may be made
a party by reason of her/his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor and by which s/he is not entitled to be indemnified, except for such
action, suit or procedure in relation to matters for which s/he be held liable for gross negligence or misconduct. In the
event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal
counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the relevant person may be entitled.

Art. 17. Advisory Committee. The Company shall have an advisory committee (the "Committee") consisting of a

minimum of one member and a maximum of five members (the "Member(s)"). Subject to the below, the appointment and
removal of Members will be determined from time to time by a Company Shareholder Majority (as defined in Article 22).

The shareholders agree that one Member of the Committee shall be appointed upon binding nomination by GS. The

other Members of the Committee (up to a maximum of four persons) shall be appointed upon binding nomination by the
IH.

69519

L

U X E M B O U R G

The GS shall be entitled at any time to propose that the Members of the Committee nominated by it in accordance

with the above shall be dismissed or resign. As soon as a Member of the Committee appointed upon the nomination of
the GS pursuant to the above, is no longer in office, the GS shall have the right to nominate a new Member and the last
sentence of the above paragraph shall apply mutatis mutandis.

Meetings of the Committee of the Company shall be held at least every three months at such place as the majority of

the Members may decide. A schedule of meetings of the Committee of the Company will be agreed upon by 30 November
of each year for the following year. In the event that a schedule of meetings is not so agreed for any year, meetings shall
be held on the first Business Day of March, June, September and December in such year.

Additional meetings of the Committee of the Company may be convened by any one Member giving to the other

Members (if any) not less than 10 (ten) business days' notice designating the time, place and agenda of the meeting.

The quorum for meetings of the Committee of the Company shall be the majority of the Members in office being

present in person or by telephone. A Member may appoint another Member to act as his proxy in relation to specific
matters. The Committee of the Company shall adopt resolutions by simple majority.

The Committee of the Company may adopt resolutions outside a meeting provided that such resolutions are adopted

in writing and that all Members have provided written confirmation to the Company that they are in favour of such
resolutions.

Art. 18. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be if the Company has more

than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of

shareholders, which will determine the number of auditors, if applicable, the remuneration of the auditor and the duration
of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of
their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as
the case may be, of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than

twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be
specified in the notice convening the meeting on the first Monday of June of each year, at 2 p.m.

If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be

convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s),
if any, or by shareholders owning more than twenty-five percent (25%) of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not

compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretion

of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

Art. 22. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the

case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share
capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the date, time, place and agenda of the

meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his

proxy who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled

in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the chairman of the Board of Managers or, in his absence,

by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

69520

L

U X E M B O U R G

The chairman of the meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form

the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the

name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the
case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.
The Shareholders agree that the following matters:
(a) Amend the articles of association;
(b) Issue any further shares of the Company (the "Shares") or any other security, or grant any options or rights to

subscribe for or to convert any instrument into Shares;

(c) Exclude or limit pre-emption rights;
(d) Legal merger and legal division;
(e) Submit a filing by one or more of the Company and the Company's direct and indirect subsidiaries from time to

time (the "Group Companies") for bankruptcy;

(f) Redeem or repurchase Shares or re-transfer treasury shares;
(g) Liquidate any Group Company;
(h) Make any compromise or settlement agreement and/or make any composition or scheme of arrangement with

creditors of the Group Companies;

(i) Request that one or more of the Group Companies be granted a moratorium of payments;
(j) Enter into financing agreements whereby any Group Company is granted a loan or credit facility or becomes a

primary or secondary debtor or a guarantor;

(k) Supply and/or draw money loans, not including withdrawals to the charge of a credit facility granted to the Company

which has previously been approved by a Company Shareholder Majority (as defined below);

(l) Enter into permanent direct or indirect collaboration with any other enterprise and/or discontinue or substantially

alter any such collaboration;

(m) Take a direct or indirect interest in any other corporate entity or company and/or make any change in or dispose

of any such interest;

(n) Establish, relocate or close down branch offices;
(o) Extend the Company's business by a new line of business;
(p) Create or permit the creation of any encumbrance over its beneficial title to the O'Neill brand;
(q) Sell, offer for sale, transfer or grant an option over its beneficial title to the O'Neill brand;
(r) Enter into any agreement regarding the O'Neill brand, other than in the ordinary course of business;
(s) Sell, transfer or assign or close any of the business or businesses carried on by the Group Companies;
(t) Sell, transfer, assign or encumber any of the shares in the Company's direct and indirect subsidiaries;
(u) Appoint and dismiss the Members of the Committee in accordance with Article 17;
(v) Make distributions to shareholders in accordance with Article 26
shall require the prior approval of a majority of shareholders representing at least seventy five percent (75 %) of the

voting rights capable of being cast in respect of the entire issued share capital of the Company (a "Company Shareholder
Majority") by way of any of the following (save to the extent that applicable law or regulation requires any resolution to
be passed in a certain manner): (a) a resolution to that effect passed at a general meeting of the Company with Company
Shareholder Majority; (b) a written resolution to that effect executed by a Company Shareholder Majority.

For the avoidance of doubt, no resolution of the Board of Managers of the Company in relation to any of the above

matters shall be taken without the prior approval of a Company Shareholder Majority.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by the majority

of shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at
the first meeting, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be
adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Art. 23. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may
be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general

meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of
Managers or by any two Managers.

69521

L

U X E M B O U R G

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of February and ends on the

last day of the month of January of the following year.

Art. 25. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager or,

as the case may be, the Board of Managers, draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit
and loss account of the Company in accordance with the Law and submits them to the sole shareholder or, as the case
may be, to the general meeting of shareholders and, as the case may be, the auditor(s), for approval.

Each shareholder or its/her/his representative may inspect these financial documents at the registered office of the

Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised
within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to

the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The respective entitlement of shareholders to participate in dividend payments by the Company from time to time

will be pro rata to their shareholdings in the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It

may decide to use the whole or part of the remainder to existing losses, if any, to carry it forward to the next following
financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Art. 27. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim

dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the
Company has sufficient available funds for such a distribution.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the Company

Art. 28. Dissolution. Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case

may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these
Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining

to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro
rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 29. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the ap-

plicable Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed the number of shares

mentioned hereafter and fully paid these shares and the respective share premium mentioned hereafter in cash:

Shareholders

Number

of shares

Subscribed

capital

(EUR)

Share

premium

(EUR)

Inter-Him N.V., mentioned above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Shares

8,600.-

69.33

Goldman Sachs &amp; Co., mentioned above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Shares

3,800.-

30.67

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

2,400.-

100.-

Proof of such payments in the total amount of EUR 12,500.- has been given to the undersigned notary who states that

the conditions set forth in article 183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of this deed are estimated at approximately 1,600.- Euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 January 2011.

<i>Extraordinary general meeting

The abovementioned shareholders, representing the entire subscribed capital, immediately held a first general meeting

of shareholders and passed the following resolutions:

69522

L

U X E M B O U R G

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following persons as

Managers for an unlimited period:

- Mr. Raymond Hegarty, company director, born on 21 July 1964 in Ireland, with professional address at 17, rue

Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Gert van Noord, company director, born in Punta Cardon (Venezuela) on 27 November 1952, with professional

address at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Victor Hoogstraal, born in Zurich (Switzerland) on 10 December 1951, with professional address at 26, Heuels-

trasse, 8032 Zurich, Switzerland.

2. Resolved to set at 1 (one) the number of statutory auditor and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2015:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established

and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 400, route d'Esch, L-1014
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

3. Resolved that the registered office shall be at 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above persons,

the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of
discrepancies between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons present, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendzehn, am siebten Mai.
Vor Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Inter-Him N.V., eine nach dem Recht der Niederländischen Antillen gegründete Aktiengesellschaft mit eingetragenem

Sitz in Curaçao, Niederländische Antillen, und mit Geschäftsadresse Professor Kernkampweg 8A, Niederländische An-
tillen, eingetragen im Handelsregister von Curaçao unter der Nummer 23748,

vertreten durch Herrn Alexander Koch, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

aufgrund einer Vollmacht;

und
Goldman Sachs &amp; Co., eine nach dem Recht des Staates New York gegründete Kommanditgesellschaft, mit eingetra-

genem Sitz in 85 Broad Street, New York, NY 10004, Vereinigte Staaten von Amerika;

vertreten durch Frau Carole Noblet, Rechtsanwältin, berufsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), auf-

grund einer Vollmacht;

Die genannten Vollmachten, die, nach Paraphierung und Unterzeichnung "ne varietur" durch die Bevollmächtigten und

den unterzeichnenden Notar, zur Eintragung an die vorliegende Urkunde angeheftet wird.

Diese Parteien, in der vorgenannten Eigenschaft handelnd, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die folgende

Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) auszufertigen, die, wie
sie erklären, folgendermaßen lautet:

Kaptiel I. Form, Firma, eingetragener Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Firma. Es wird hiermit von den Zeichnern und all denjenigen, die Eigentümer der hiernach begebenden

Geschäftsanteile werden mögen, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) gegründet (die "Gesellschaft"), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, und insbesondere
der geänderten Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 bzgl. Handelsgesellschaften (das "Gesetz"), der geänderten
Fassung des Artikels 1832 des Zivilgesetzbuches und der vorliegenden Satzung unterliegen wird (die "Satzung").

Die Gesellschaft besteht unter der Firma "O'Neill Brand S.à r.l.".

Art. 2. Eingetragener Sitz. Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in Luxemburg-Stadt. Die Einzelgeschäftsführung

bzw. Gesamtgeschäftsführung ist berechtigt, die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Ge-
meinde des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft zu ändern.

Zweigstellen oder andere Geschäftsstellen können entweder in dem Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland

durch Beschluss der Einzelgeschäftsführung bzw. Gesamtgeschäftsführung errichtet werden.

Falls nach Ansicht der Einzelgeschäftsführung bzw. Gesamtgeschäftsführung außergewöhnliche politische, wirtschaft-

liche oder soziale Entwicklungen auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der
Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die Verständigung mit besagtem Sitz oder zwischen besagtem Sitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen würden, kann diese vorübergehend den eingetragenen Sitz ins Ausland verlegen,

69523

L

U X E M B O U R G

bis zum Ende dieser ungewöhnlichen Umstände. Solche vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die
Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des eingetragenen Sitzes, eine dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand. Gesellschaftsgegenstand ist der Erwerb, die Abtretung, die Entwicklung, der Besitz

und die Verwertung von Patenten, Lizenzen, Mustern, Marken, Schutzgütern und anderen Rechten an geistigem Eigentum
sowie die Ausübung aller aus dem Vorstehendem abgeleiteten oder betreffenden Rechte.

Dies schließt den Schutz, die Verwaltung der Rechte an geistigem Eigentum sowie die Registrierung von Marken und

anderen Rechten an geistigem Eigentum, die Kontrolle solcher Registrierung und ihrer Bedingungen und den Gebrauch
wie auch die Ermittlung jedweden Verstoßes gegen Rechte an geistigem Eigentum ein, ohne jedoch darauf beschränkt zu
sein.

Die Gesellschaft ist zudem zuständig für das strategische Management des Portfolios an geistigem Eigentum einschließ-

lich, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, des Managements der Beziehungen zu allen bestehenden und zukünftigen
Lizenznehmern und des Managements der Unterlizenzverträge und der Tätigkeiten bzgl. der Unterlizenzen.

Die Gesellschaft wird Lizenzgebühren in Rechnung stellen, einziehen und ausbezahlen.
Die Gesellschaft wird des Weiteren, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung oder im Namen und auf Rechnung

Dritter, alle Tätigkeiten, in Luxemburg und im Ausland, durchführen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den Kauf
und Verkauf, Import und Export, Handel, Herstellung, Umwandlung und Ausbesserung jedweder Modeartikel und Ac-
cessoires beziehen.

Allgemein kann die Gesellschaft jedwede industrielle, gewerbliche oder Finanztätigkeiten ausüben und solch anderen

Tätigkeiten betreiben wie sie die Gesellschaft für notwendig, ratsam, dienlich für, zusammenhängend mit, oder nicht
unvereinbar mit, dem Erreichen und der Entwicklung des Vorhergehenden hält.

Die Gesellschaft kann bewegliches oder unbewegliches Eigentum, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, erwerben,

unabhängig davon, ob solches Eigentum mittelbaren oder unmittelbaren Bezug zu ihrem Gesellschaftszweck hat.

Die Gesellschaft kann Pfand geben, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von

Sicherheiten sowie jede Form von Haftungsfreistellung gewähren, hinsichtlich ihrer eigenen Verpflichtungen und Schulden.

Die Gesellschaft kann, auf jede beliebige Art, Beteiligungen an jedweder Vereinigung, jedwedem Geschäft, Unterneh-

men oder jedweder Gesellschaft mit identischem, ähnlichem oder verwandtem Zweck, oder an einer bzw. einem solchen,
die bzw. das ihr Geschäft zu erleichtern und / oder den Verkauf ihrer Dienstleistungen zu fördern geeignet ist erwerben
oder mit einer bzw. einem solchen zusammenarbeiten oder fusionieren.

Die Gesellschaft kann ihren Zweck auf jede beliebige Art und in Einklang mit den Bedingungen, die sie für angemessen

hält, umsetzen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum errichtet.

Kapitel II. Stammkapital, Anteile

Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), un-

terteilt in einhundertvierundzwanzig Euro (124) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-), (die
"Anteile).

Zusätzlich zu dem Stammkapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf welches das auf jedweden Anteil über

den jeweiligen Nennwert hinaus gezahlte Aufgeld überwiesen wird. Der Betrag des Aufgeldkontos kann unter anderem
zur Bezahlung jedweder Anteile, die die Gesellschaft von ihrem (ihren) Anteilseigner(n) zurückkauft, zur Aufrechnung mit
realisierten Nettoverlusten, zu Ausschüttungen an die Anteilseigner oder zur Zuteilung an die gesetzliche Rücklage ver-
wendet werden.

Art. 6. Anteile und Anteilsübertragung. Alle Anteile sind und bleiben in eingetragener Form.
Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, kann der Alleingesellschafter seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, können die Anteile nur unter den Gesellschaftern frei über-

tragen werden. Vorbehaltlich Übertragungsbeschränkungen gemäß Artikel 8, können Anteile an Nichtgesellschafter nur
mit Genehmigung der Gesellschafterhauptversammlung, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft
vertreten, übertragen werden.

Die Übertragung der Anteile erfolgt durch notarielle oder Privaturkunde. Eine solche Übertragung bindet die Gesell-

schaft  und  Dritte  nur,  wenn  die  Gesellschaft  von  ihr  ordnungsgemäß  benachrichtigt  oder  sie  von  der  Gesellschaft
akzeptiert wurde, gemäß Artikel 190 des Gesetzes und Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs.

Jeder Anteil ist unteilbar, insoweit es die Gesellschaft betrifft. Miteigentümer müssen gegenüber der Gesellschaft durch

einen gemeinsamen Bevollmächtigten, ob unter ihnen ernannt oder nicht, vertreten werden. Die Gesellschaft ist berech-
tigt, die Ausübung aller Rechte bezüglich des jeweiligen Anteils auszusetzen, bis ein gemeinsamer Bevollmächtigter ernannt
worden ist.

Art. 7. Erhöhung und Reduzierung des Stammkapitals und Vorzugsrechte bzgl. der Anteile. Das gezeichnete Stamm-

kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleingesellschafters bzw. der Gesellschafterhauptversammlung, die mit

69524

L

U X E M B O U R G

dem Quorum und den Mehrheitsregeln gemäß dieser Satzung bzw. des Gesetzes bzgl. der Änderung dieser Satzung
abstimmt, ein- oder mehrmalig erhöht oder reduziert werden.

Jede Schaffung, Zuteilung oder Ausgabe von jedwedem Anteil oder jedem anderen Wertpapier, oder die Gewährung

einer Option oder eines Rechts, jedes beliebige Instrument zu zeichnen oder in Anteile oder Wertpapiere umzuwandeln,
auf Vorschlag der Gesellschaft (diese Anteile oder anderen Wertpapiere sind die "Zusätzlichen Wertpapiere"), werden
zuerst den Gesellschaftern in dem Verhältnis zur Zeichnung angeboten, dass die Zahl der ausgegebenen Anteile, die zu
der Zeit von jeder solchen Person gehalten werden, der Gesamtzahl dieser auszugebenden Anteile entspricht.

Ein solches Angebot wird mittels schriftlicher Benachrichtigung, die die Zahl der Zusätzlichen Wertpapiere, zu der der

maßgebliche Gesellschafter berechtigt ist, bestimmt und eine zeitliche Befristung (nicht unter dreißig (30) Kalendertagen)
festlegt, nach der das Angebot (falls nicht angenommen) als abgelehnt gilt. Diese Angebote sind nicht übertragbar, können
nicht aufgeteilt oder zusammengelegt werden und können ganz oder zum Teil angenommen werden.

Gesellschafter, die das Angebot angenommen haben, sind zu der Angabe berechtigt, dass sie, unter den gleichen Be-

dingungen, die Zusätzlichen Wertpapiere (unter Benennung der Höchstzahl der Pakete) annehmen würden, die nicht von
anderen Gesellschaftern angenommen worden sind (die "Überschüssigen Zusätzlichen Wertpapiere"). Jede Überschüs-
sigen Zusätzlichen Wertpapiere werden Gesellschaftern zugeteilt, die angegeben haben, dass sie Überschüssige Zusätz-
liche Wertpapiere annehmen würden. Überschüssige Zusätzliche Wertpapiere werden anteilig der aggregierten Zahl der
Anteile, die von Gesellschaftern gehalten werden, die die Überschüssigen Zusätzlichen Wertpapiere annehmen, zugeteilt
(vorausgesetzt, dass keinem dieser Gesellschafter mehr als die Höchstzahl der Überschüssigen Zusätzlichen Wertpapiere
zugeteilt werden, als dieser Gesellschafter anzunehmen angegeben hat).

Nach Ablauf der nach dem Vorgenannten festgelegten Frist, oder nach Erhalt seitens der Gesellschaft einer Annahme

oder Ablehnung eines jeden so gemachten Angebots, ist die Gesamtgeschäftsführung berechtigt, jede so angebotenen
Zusätzlichen Wertpapiere zu veräußern, und welche nicht gemäß dem dritten Absatz dieses Artikels zugeteilt werden
müssen, in jedem Einzelfall unter den gleichen Bedingungen, unter denen die Zusätzlichen Wertpapiere den Gesellschaf-
tern gemäß dem zweiten Absatz dieses Artikels angeboten wurden.

Falls, infolge der Ungleichheit zwischen der Zahl der zu begebenden neuen Zusätzlichen Wertpapiere und der Zahl

der Anteile, die von Gesellschaftern, die berechtigt sind, das Angebot zu neuen Zusätzlichen Wertpapieren zu erhalten,
gehalten werden, Schwierigkeiten entstehen in der Aufteilung irgendwelcher dieser neuen Zusätzlichen Wertpapiere
unter den Gesellschaftern, wird über solche Schwierigkeiten durch das Komitee (wie in Artikel 17 definiert) entschieden.

Art. 8. Übertragungsbeschränkungen. Jede Übertragung von Anteilen ist den Übertragungsbeschränkungen unterwor-

fen, die in jedwedem Vertrag, gegenwärtig oder zukünftig, der zwischen Goldman Sachs &amp; C ("GS"), Inter-Him N.V. oder
ihrer Rechtsnachfolger ("IH"), und/oder jeder anderen Gesellschaft, die Teil der gleichen Gesellschaftsgruppe wie die
Gesellschaft ist, geschlossen wird, enthalten sind.

Kapitel III. Geschäftsführung, Gesamtgeschäftsführung, gesetzliche Buchprüfer

Art. 9. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem (die "Einzelgeschäftsführung" oder der "Alleingeschäftsfüh-

rer") oder mehreren Geschäftsführern geleitet, ob Gesellschafter oder nicht (der/die "Geschäftsführer"). Wenn mehrere
Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer ein Leitungsgremium (die "Gesamtgeschäftsführung").

Der (Die) Geschäftsführer wird (werden) von dem Alleingesellschafter bzw. von der Gesellschafterhauptversammlung

ernannt, der bzw. die ihre Anzahl, ihre Vergütung, mit der Maßgabe, dass eine Änderung der an einen jeden Geschäfts-
führer  zu  bezahlenden  Vergütung  zusätzlich  die  Zustimmung  des  betreffenden  Geschäftsführers  erfordert,  und  die
befristete oder unbefristete Dauer ihres Mandats festlegt. Die Geschäftsführer üben ihr Mandat bis zur Wahl ihrer Nach-
folger aus. Sie können am Ende ihres Mandats wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss
des Alleingesellschafters bzw. der Gesellschafterhauptversammlung der abgelöst werden.

Der bzw. die Geschäftsführer sind auch nach Ablauf ihres Mandats gehalten, Informationen über die Gesellschaft, die

den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, nicht offen zu legen, außer wenn eine solche Offenlegung gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Art. 10. Sitzungen der Gesamtgeschäftsführung. Wenn die Gesellschaft aus einem Alleingeschäftsführer besteht, übt

dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesamtgeschäftsführung einräumt.

Die Gesamtgeschäftsführung ernennt unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Sie kann zudem

einen Schriftführer ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Protokollierung der Sitzungen
der Gesamtgeschäftsführung und der (des) Gesellschafter(s) ist.

Die Gesamtgeschäftsführung versammelt sich nach Mitteilung durch den Vorsitzenden. Der Vorsitzende führt den

Vorsitz bei allen Sitzungen der Gesamtgeschäftsführung. In seiner/ihrer Abwesenheit kann die Gesamtgeschäftsführung
durch Mehrheitswahl der bei dieser Sitzung Anwesenden oder Vertretenen einen anderen Geschäftsführer als Vorsit-
zenden pro tempore ernennen.

Außer bei Dringlichkeit oder bei vorheriger Zustimmung aller zur Teilnahme Berechtigter, ist über Sitzungen der

Gesamtgeschäftsführung  mit  einer  Frist  von  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  schriftlich  mitzuteilen.  Jede  solche
schriftliche Mitteilung gibt den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung an.

69525

L

U X E M B O U R G

Auf die Mitteilung kann durch einstimmiges schriftliches Einverständnis aller Geschäftsführer in der Sitzung oder an-

derweitig verzichtet werden. Eine gesonderte Mitteilung ist nicht notwendig für Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten
abgehalten werden, die in einem durch Beschluss der Gesamtgeschäftsführung vorher genehmigten Zeitplan enthalten
sind.

Jede Sitzung der Gesamtgeschäftsführung ist in Luxemburg oder an dem in der Einladung angegebenen Ort abzuhalten.
Jeder Geschäftsführer kann auf jeder Sitzung der Gesamtgeschäftsführung handeln, indem er/sie schriftlich einen an-

deren Geschäftsführer als seinen/ihren Vertreter ernennt.

Die Gesamtgeschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer

anwesend oder vertreten ist.

Gesamtgeschäftsführungsbeschlüsse werden mit Stimmemehrheit der an der jeweiligen Sitzung anwesenden oder ver-

tretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Die Teilnahme einer oder mehrerer Geschäftsführer an einer Sitzung per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder

ähnlichem Kommunikationsmittel, das eine simultane Verständigung der daran teilnehmenden Personen miteinander ge-
währleistet, ist zulässig. Diese Arten der Teilnahme stehen einer physischen Anwesenheit in der Sitzung gleich..

Ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss ist zulässig und wirksam wie wenn er bei einer

ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung der Gesamtgeschäftsführung gefasst worden wäre. Ein solcher Be-
schluss kann entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren gesonderten Dokumenten, die alle den gleichen
Inhalt haben und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben werden, festgehalten werden.

Art. 11. Protokoll der Sitzung der Gesamtgeschäftsführung. Das Sitzungsprotokoll der Gesamtgeschäftsführung bzw.

die schriftlichen Beschlüsse des Alleingeschäftsführers werden von allen bei der Sitzung anwesenden Geschäftsführern
bzw. dem Alleingeschäftsführer aufgesetzt und unterzeichnet. Sämtliche Vollmachten bleiben daran angeheftet.

Kopien davon oder Auszüge daraus werden von dem Alleingeschäftsführer bzw. vom Vorsitzenden der Gesamtge-

schäftsführung oder zweier beliebiger Geschäftsführer beglaubigt.

Art. 12. Allgemeine Befugnisse der Geschäftsführer. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung hat

die weitesten Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handeln und um sämtliche Verwaltungs- oder Verfügungs-
maßnahmen durchzuführen oder dazu zu ermächtigen, die notwendig oder nützlich zur Erreichung des Gesellschaftsge-
genstandes  sind.  Sämtliche  Befugnisse,  welche  nicht  ausdrücklich  vom  Gesetz  oder  durch  diese  Satzung  dem
Alleingesellschafter bzw. der Gesellschafterhauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Al-
leingeschäftsführers bzw. der Gesamtgeschäftsführung.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung kann jedem Mitglied

bzw. Mitgliedern der Gesamtgeschäftsführung oder jeder (jedweden) anderen Person(en), die nicht Geschäftsführer oder
Gesellschafter der Gesellschaft sein muss (müssen), allein oder gemeinsam handelnd, bestimmte Befugnisse übertragen
und/oder spezielle Mandate erteilen, unter den Bedingungen und mit den Befugnissen, wie sie der Alleingeschäftsführer
bzw. die Gesamtgeschäftsführung festlegt.

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung kann zudem ein oder mehrere Beratungskomitees ernen-

nen und deren Zusammensetzung und Zweck festlegen.

Art. 14. Vertretung der Gesellschaft. Im Falle der Ernennung eines Alleingeschäftsführers wird die Gesellschaft Dritten

gegenüber durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift
jedweder Person(en), der (denen) der Geschäftsführer eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat, in den Grenzen dieser
Vollmacht, verpflichtet.

Im Falle der Leitung der Gesellschaft durch eine Gesamtgeschäftsführung wird die Gesellschaft Dritten gegenüber

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige
Unterschrift jedweder Person(en), der (denen) die Gesamtgeschäftsführung eine solche Zeichnungsvollmacht erteilt hat,
in den Grenzen dieser Vollmacht, verpflichtet.

Art. 15. Interessenkonflikt. Verträge oder sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und jeder anderen Ge-

sellschaft oder jedem anderen Unternehmen werden nicht durch die bloße Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass
ein oder mehrere ordnungsgemäß ermächtigte(r) Vertreter der Gesellschaft, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu
sein, jedes Geschäftsführers, ein persönliches Interesse an genannter anderer Gesellschaft oder genanntem anderen Un-
ternehmen hat oder deren ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter ist. Vorbehaltlich anderer nachstehender Regelungen
ist jeder ordnungsgemäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, jedes
Geschäftsführers, der als ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter der anderen Gesellschaft oder des anderen Unterneh-
mens, gegenüber der sich die Gesellschaft vertraglich verpflichtet oder mit der oder dem sie anderweitig Geschäfte tätigt,
dient, nicht automatisch einzig aufgrunddessen von der Beratung an und Beschlussfassung über sowie von Handlungen
hinsichtlich jedweder Angelegenheit mit Bezug zu diesem Vertrag oder diesen anderen Geschäften ausgeschlossen.

Ungeachtet des Vorstehenden muss ein Geschäftsführer, falls er/sie ein persönliches Interesse an jedweder Transak-

tion,  an  der  die  Gesellschaft  beteiligt  ist,  ausgenommen  solcher  Transaktionen,  die  in  den  Bereich  der  täglichen
Geschäftsführung  der  Gesellschaft  fallen,  unter  normalen  Umständen  und  zu  Marktbedingungen  getätigt  werden,  die
Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und darf nicht an der Beratung oder an der

69526

L

U X E M B O U R G

Beschlussfassung über eine solche Transaktion teilnehmen. Eine solche Transaktion und ein solches Interesse des Ge-
schäftsführers daran werden dem Alleingesellschafter bzw. der nächsten Hauptversammlung der Gesellschafter mitgeteilt.

Falls die Gesellschaft einen Alleingeschäftsführer hat, ist jede Transaktion, an der die Gesellschaft beteiligt ist, ausge-

nommen solche Transaktionen, die in den Bereich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, unter normalen
Umständen und zu Marktbedingungen getätigt werden, und an der der Alleingeschäftsführer ein persönliches Interesse
hat, das mit dem Interesse der Gesellschaft daran in Widerspruch steht, von dem Alleingesellschafter bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter zu genehmigen.

Art. 16. Entschädigung. Die Gesellschaft entschädigt jeden Geschäftsführer und seine/ihre Erben, Testamentsvollstre-

cker und Nachlassverwalter für Aufwendungen, die er/sie vernünftigerweise in Verbindung mit einem Verfahren, einer
Klage oder einem sonstigem Rechtsstreit erlitten hat, an dem/der er/sie Streitpartei wurde aufgrund seiner/ihrer Stellung
als amtierender oder ehemaliger Geschäftsführer oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, an der
die Gesellschaft Gesellschafter oder gegenüber der sie Gläubiger ist und gegenüber der er/sie kein Recht auf Entschädigung
hat,  ausgenommen  solcher  Verfahren,  Klagen  oder  sonstigem  Rechtsstreit  bezüglich  Angelegenheiten,  für  die  er/sie
rechtskräftig verurteilt wird wegen grober Fahrlässigkeit oder schuldhaftem Verhalten. Im Falle eines Vergleichs wird
Entschädigung nur für Angelegenheiten geleistet, in Bezug auf die die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistandes beraten
wurde, dass keine Pflichtverletzung seitens des zu Entschädigenden vorliegt. Das vorstehende Entschädigungsrecht schließt
andere der jeweiligen Person zustehende Rechte nicht aus.

Art. 17. Beratungskomitee. Die Gesellschaft hat ein Beratungskomitee (das "Komitee"), bestehend aus mindestens

einem Mitglied und höchstens fünf Mitgliedern (das (die) "Mitglied(er)"). Vorbehaltlich des Nachfolgenden bestimmt sich
die Ernennung und Entlassung von Mitgliedern mitunter durch ein Gesellschaftermehrheit der Gesellschaft (gemäß Defi-
nition in Artikel 22).

Die Gesellschafter stimmen zu, dass ein Mitglied des Komitees auf verbindlichen Vorschlag von GS ernannt wird. Die

anderen Mitglieder des Komitees (bis zu vier Personen) werden auf verbindlichen Vorschlag von IH ernannt.

GS ist berechtigt, jederzeit vorzuschlagen, dass die von ihm im Einklang mit dem Vorstehenden ernannten Mitglieder

des Komitees entlassen werden oder zurücktreten. Sobald ein auf Vorschlag von GS gemäß dem Vorstehenden ernanntes
Mitglied des Komitees sein Mandat nicht mehr ausübt, hat GS das Recht, ein neues Mitglied vorzuschlagen und der letzte
Satz des obigen Absatzes findet entsprechende Anwendung.

Sitzungen des Komitees der Gesellschaft werden wenigstens alle drei Monate an dem Ort abgehalten, den die Mehrheit

der Mitglieder festlegt. Es wird ein Terminplan der Sitzungen des Komitees der Gesellschaft bis zum 30. November jeden
Jahres für das nachfolgende Jahr beschlossen. Falls ein Terminplan der Sitzungen nicht demgemäß für ein bestimmtes Jahr
beschlossen ist, werden die Sitzungen am ersten Werktag im März, Juni, September und Dezember des entsprechenden
Jahres abgehalten.

Weitere Sitzungen des Komitees der Gesellschaft können von jedem Mitglied durch Benachrichtigung der übrigen

Mitglieder innerhalb von nicht weniger als 10 (zehn) Werktagen unter Angabe von Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der
Sitzung einberufen werden.

Zur Beschlussfähigkeit der Sitzungen des Komitees der Gesellschaft ist die Mehrheit der persönlich oder telefonisch

anwesenden amtierenden Mitglieder notwendig. Ein Mitglied kann ein anderes Mitglied ernennen, um in Bezug auf eine
bestimmte Angelegenheit als sein Stellvertreter zu handeln. Das Komitee der Gesellschaft beschließt mit einfacher Mehr-
heit.

Art. 18. Abschlussprüfer. Mit der Überwachung der Tätigkeiten der Gesellschaft kann/können und, falls die Gesellschaft

mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss/müssen ein oder mehrere Abschlussprüfer betraut werden.

Die Abschlussprüfer, falls vorhanden, werden von dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesell-

schafter ernannt, der bzw. die die Anzahl der Abschlussprüfer, gegebenenfalls die Bezahlung der Abschlussprüfer und die
Dauer ihres Amtes festsetzt bzw. festsetzen. Die Abschlussprüfer führen ihr Mandat bis zur Wahl ihrer Nachfolger fort.
Am Ende ihrer Amtszeit können sie wiedergewählt werden, und sie können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
Beschluss des Alleingesellschafters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter, entlassen werden.

Kapitel IV. Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 19. Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung, abzuhalten falls die Gesellschaft mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen in der Einladung
angegebenen Ort am ersten Montag im Juni jeden Jahres um 14.00 Uhr abgehalten.

Falls dieser Tag kein Werktag in dem Großherzogtum Luxemburg ist, wird die Versammlung am ersten darauffolgenden

Werktag abgehalten.

Art. 20. Weitere Hauptversammlungen der Gesellschafter. Die Gesellschafter können Gesellschafterhauptversamm-

lungen abhalten, die gemäß dem Gesetz von dem Alleingeschäftsführer bzw. der Gesamtgeschäftsführung, von dem (den)
Abschlussprüfer(n), falls vorhanden, oder von Gesellschaftern, die mehr als fünfundzwanzig Prozent (25%) des Stamm-
kapitals der Gesellschaft besitzen, einberufen werden.

69527

L

U X E M B O U R G

Falls  sich  die  Gesellschaft  aus  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschaftern  zusammensetzt,  sind  Hauptver-

sammlungen  der  Gesellschafter  nicht  zwingend,  und  die  Gesellschafter  können  über  die  vorgeschlagenen  Beschlüsse
schriftlich abstimmen.

Hauptversammlungen der Gesellschafter, einschließlich der Jahreshauptversammlung, können im Ausland nur dann

abgehalten werden, wenn, nach dem Ermessen des Alleingeschäftsführers bzw. der Gesamtgeschäftsführung Umstände
höherer Gewalt dies erfordern.

Art. 21. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung ver-

tritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die ihr durch das Gesetz und diese Satzung übertragenen Befugnisse.

Art. 22. Verfahren. Stimmrecht. Die Hauptversammlung der Gesellschafter wird durch Benachrichtigung durch den

Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung, durch den (die) Abschlussprüfer, falls vorhanden, oder durch
Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gemäß dem Gesetz und der vorlie-
genden Satzung einberufen.

Die gemäß dem Gesetz an die Gesellschafter verschickte Benachrichtigung gibt das Datum, die Zeit, den Ort und die

Tagesordnung der Versammlung an.

Falls alle Gesellschafter bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie

bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, kann diese ohne vorherige
Benachrichtigung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann auf jeder Hauptversammlung der Gesellschafter Handlungen vornehmen durch schriftliche

Ernennung eines Stellvertreters, der nicht notwendigerweise Gesellschafter sein muss, oder durch dessen Ernennung per
Fax.

Ein oder mehrere Gesellschafter kann oder können an Versammlungen per Konferenzschaltung, Videokonferenz oder

ähnlicher Kommunikationsmittel, die die simultane Verständigung mehrerer daran teilnehmender Personen miteinander
ermöglichen, teilnehmen. Diese Teilnahme steht einer körperlichen Anwesenheit bei der Versammlung gleich.

Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die erfüllt sein

müssen, um an einer Hauptversammlung der Gesellschafter teilzunehmen.

Jeder Hauptversammlung der Gesellschafter sitzt der Vorsitzende der Gesamtgeschäftsführung oder, in seiner Abwe-

senheit, jede andere von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannte Person vor.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung ernennt einen Schriftführer.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter ernennt einen oder mehrere Wahlprüfer.
Der Vorsitzende der Hauptversammlung der Gesellschafter bildet zusammen mit dem so ernannten Schriftführer und

dem (den) so ernannten Wahlprüfer(n) das Büro der Hauptversammlung.

Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Gesellschafter, die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile, und gegebe-

nenfalls der Name ihrer Vertreter angibt, wird vom Büro der Hauptversammlung der Gesellschafter bzw. ihrer Vertreter
erstellt und unterzeichnet.

Jeder Anteil verfügt über eine Stimme, außer das Gesetz ist anderslautend.
Die Gesellschafter stimmen überein dass die folgenden Angelegenheiten:
(a) Abänderung der Satzung;
(b) Ausgabe weiterer Gesellschaftsanteile (die "Anteile") oder anderer Wertpapiere, oder Gewährung von Optionen

oder Rechten zur Zeichnung von oder Umwandlung von jedwedem Wertpapier in Anteile;

(c) Ausschluss oder Begrenzung von Vorkaufsrechten;
(d) Gesetzmäßige Fusion und gesetzmäßige Abspaltung;
(e)  Einreichung  eines  Insolvenzantrags  seitens  der  Gesellschaft  und  von  einem  oder  mehreren  unmittelbaren  und

mittelbaren Tochtergesellschaften ("Gruppengesellschaft");

(f) Rücknahme oder Rückkauf von Anteilen oder Weiterübertragung von zurückgekauften Aktien;
(g) Auflösung von jeder Gruppengesellschaft;
(h) Abschluss von Vergleichen oder Abfindungsvereinbarungen und/oder Vergleichsabschlüsse oder Vergleichsvor-

schläge mit Gläubigern der Gruppengesellschaften;

(i) Antrag auf Zahlungsaufschub für eine oder mehrere Gruppengesellschaften;
(j) Abschluss von Finanzierungsabkommen, mittels derer jedwede Gruppengesellschaft ein Darlehen oder eine Kre-

ditfazilität erhält oder erstrangiger oder zweitrangiger Schuldner oder Sicherungsgeber wird;

(k) Bereitstellung und/oder Ziehen von Gelddarlehen, ausschließlich Inanspruchnahme von Kreditfazilitäten, die der

Gesellschaft gewährt wurde und bereits von der Gesellschaftermehrheit der Gesellschaft (wie unten definiert) bewilligt
worden ist;

(l) Eintritt in dauerhafte unmittelbare oder unmittelbare Zusammenarbeit mit jedem anderen Unternehmen und/oder

Abbruch oder substantielle Änderung solcher Zusammenarbeit;

69528

L

U X E M B O U R G

(m) Unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an jeder anderen Kapitalgesellschaft oder Gesellschaft und/oder jede

Änderung an oder Veräußerung einer solchen Beteiligung;

(n) Einrichtung, Verlegung oder Schließung von Zweigstellen;
(o) Ausdehnung des Geschäfts der Gesellschaft durch einen neuen Geschäftsbereich;
(p) Jedwede Belastung oder Erlaubnis jedweder Belastung des Rechts an der Marke O'Neill;
(q) Verkauf, Verkaufsangebot, Übertragung oder Bewilligung einer Kaufoption auf das Recht an der Marke O'Neill;
(r) Abschluss jedweden Vertrags bzgl. der Marke O'Neill, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs;
(s) Verkauf, Übertragung oder Abtretung oder Schließung jedweden Geschäfts oder jedweder Geschäfte, das oder die

von den Gruppengesellschaften betrieben werden;

(t) Verkauf, Übertragung, Abtretung oder Belastung jedweder Anteile in den unmittelbaren und mittelbaren Tochter-

gesellschaften der Gesellschaft;

(u) Ernennung und Entlassung der Mitglieder des Komitees gemäß Artikel 17;
(v) Dividendenzahlungen an Gesellschafter gemäß Artikel 26
der vorherige Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimm-

rechte, die bzgl. des gesamten begebenden Stammkapitals abgegeben werden können, vertreten (die "Gesellschafter-
mehrheit der Gesellschaft"), bedürfen, auf einer der folgenden Art und Weisen (unbeschadet insoweit als anwendbares
Recht oder anwendbare Gesetzgebung die Beschlussfassung auf bestimmte Art vorschreibt): (a) ein diesbezüglicher auf
einer Hauptversammlung der Gesellschaft mit Gesellschaftermehrheit der Gesellschaft gefasster Beschluss; (b) ein dies-
bezüglicher schriftlicher, von der Gesellschaftermehrheit der Gesellschaft unterzeichneter Beschluss.

Um Zweifel zu vermeiden, wird kein Beschluss der Gesamtgeschäftsführung der Gesellschaft bzgl. der obenstehenden

Angelegenheiten ohne vorhergehende Zustimmung der Gesellschaftermehrheit der Gesellschaft gefasst.

Außer das Gesetz oder die vorliegende Satzung schreibt etwas anderes vor, werden alle anderen Beschlüsse von der

Mehrheit  der  Gesellschafter,  die  mehr  als  die  Hälfte  des  Stammkapitals  der  Gesellschaft  vertreten,  gefasst.  Falls  das
Quorum nicht in der ersten Versammlung erreicht wird, werden die Gesellschafter, mittels eingeschriebenem Brief, ein
zweites Mal versammelt oder hinzugezogen, und Entscheidungen werden von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
getroffen, ungeachtet der Anteils der vertretenen Kapitals.

Art. 23. Protokoll der Gesellschafterbeschlüsse. Das Protokoll der schriftlichen Entscheidungen des Alleingesellschaf-

ters bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter werden von dem Alleingesellschafter bzw. dem Büro der Haupt-
versammlung aufgesetzt und unterzeichnet.

Kopien der oder Auszüge aus dem Protokoll der vom Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesell-

schafter gefassten Beschlüsse werden von dem Alleingesellschafter bzw. dem Vorsitzenden der Geschäftsführung oder
zweier beliebiger Geschäftsführer beglaubigt.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Dividenden

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Februar und endet am 31. Januar des darauf-

folgenden Jahres.

Art. 25. Verabschiedung des Jahresabschlusses. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen,

der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung stellt ein Inventar der Aktiva und Passiva, die Bilanz und das
Gewinn- und Verlustkonto der Gesellschaft gemäß dem Gesetz auf und legt sie dem Alleingesellschafter bzw. der Haupt-
versammlung der Gesellschafter und gegebenenfalls dem (den) Abschlussprüfer(n) zur Billigung vor.

Jeder Gesellschafter oder sein Vertreter kann in diese Finanzunterlagen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft Einblick

nehmen. Falls sich die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern zusammensetzt, kann dieses Recht
nur innerhalb von fünfzehn Tagen vor dem für die Jahreshauptversammlung der Gesellschafter gesetzten Zeitpunkt aus-
geübt werden.

Art. 26. Verteilung des Gewinns. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die

Bildung der vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklage bereitgestellt. Diese Bereitstellung wird nicht mehr verlangt, sobald
und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

Das jeweilige Anrecht der Gesellschafter, an gelegentlichen Dividendenzahlungen der Gesellschaft teilzuhaben, besteht

anteilig ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmt, wie der Restbetrag des jährlichen Nettogewinns verteilt wird.

Er bzw. sie kann entscheiden, den gesamten Restbetrag oder einen Teil davon für bestehende Verluste, falls vorhanden,
zu verwenden, zum nächstfolgenden Geschäftsjahr vorzutragen oder als Dividende an die Gesellschafter auszuschütten.

Art. 27. Zwischendividende. Der Alleingeschäftsführer bzw. die Gesamtgeschäftsführung ist berechtigt, Zwischendi-

videnden ausschütten, vorausgesetzt, dass die aktuellen Zwischenkonten erstellt worden sind und besagte Zwischen-
konten zeigen, dass die Gesellschaft ausreichend verfügbare Mittel für eine solche Ausschüttung hat.

69529

L

U X E M B O U R G

Kapitel VI. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Art. 28. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch Entscheidung des Alleingesellschafters bzw. der Haupt-

versammlung der Gesellschafter mit demselben Quorum und derselben Mehrheit, die für die Änderung dieser Satzung
gelten, aufgelöst werden, außer das Gesetz schreibt etwas anderes vor.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt,

die von dem Alleingesellschafter bzw. der Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt, der bzw. die deren Aufgaben
und Vergütung festsetzt.

Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden der und Forderungen gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und

Kosten des Liquidationsprozesses, wird das verbleibende Nettovermögen der Gesellschaft gleichmäßig unter den Ge-
sellschaftern anteilig der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile verteilt.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 29 Anwendbares Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Gegenstände werden gemäß dem anwend-

baren Gesetz bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nachdem die Satzung folglich von den erschienenen Parteien erstellt worden ist, haben diese Parteien die hiernach

genannte Anzahl von Aktien gezeichnet und diese Aktien sowie das hiernach genannte jeweilige Aufgeld vollständig in bar
einbezahlt:

Gesellschafter

Anzahl der

Anteile

Gezeichnetes

Kapital

(EUR)

Aufgeld

(EUR)

Inter-Him N.V., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Anteile

8.600,-

69,33

Goldman Sachs &amp;Co., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Anteile

3.800,-

30,67

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

12.400,-

100,-

Nachweis dieser Zahlungen in Höhe von insgesamt EUR 12.500,- ist dem unterzeichnenden Notar gegenüber erbracht

worden, der bestätigt, dass die Voraussetzungen des Artikel 183 des Gesetzes erfüllt sind und ausdrücklich ihre Erfüllung
bezeugt.

<i>Kosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen jedweder Art, die von der

Gesellschaft als Folge dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf schätzungsweise 1.600,- Euros veranschlagt.

<i>Übergangsvorschriften

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tag und endet zum 31. Januar 2011.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter

Die obengenannten Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, hielten unmittelbar eine erste au-

ßerordentliche Hauptversammlung ab und verabschiedeten folgende Beschlüsse:

1. Beschloss, die Zahl der Geschäftsführer auf 3 (drei) festzusetzen und beschloss weiter, die Nachfolgenden als Ge-

schäftsführer für unbegrenzte Zeit zu ernennen:

- Herr Raymond Hegarty, Geschäftsführer, geboren am 21. Juli 1964 in Irland, berufsansässig in der 17, rue Beaumont,

L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Gert van Noord, Geschäftsführer, geboren in Punta Cardon (Venezuela) am 27. November 1952, berufsansässig

in der 17, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

- Herr Victor Hoogstraal, geboren in Zürich (Schweiz) am 10. Dezember 1951, berufsansässig in der Heuelstrasse 26,

8032 Zürich, Schweiz.

2. Beschloss, die Zahl der gesetzlichen Abschlussprüfer auf 1 (eins) festzusetzen und beschloss weiter, die Nachfolgende

als gesetzliche Abschlussprüferin bis zur im Jahre 2015 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung zu ernennen:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") er-

richtet und organisiert gemäß den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in der 400, route
d'Esch, L-1014 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

3. Beschloss, dass der eingetragene Sitz in der 17, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ist.

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der English versteht und spricht, bestätigt hiermit, das auf Antrag der obengenannten Person

diese  notarielle  Urkunde  in  Englisch  verfasst  wurde,  mit  einer  deutschen  Übersetzung  im  Anschluss;  auf  Antrag  der
gleichen Person ist im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text
maßgeblich.

69530

L

U X E M B O U R G

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die anwesenden Personen, die dem Notar nach Namen, Vorn-

amen, Personenstand und Wohnort bekannt sind, haben diese Personen zusammen mit dem Notar diese Originalurkunde
unterschrieben.

Signé: A. KOCH, C. NOBLET, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 10 mai 2010. Relation: lac/2010/20651. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Référence de publication: 2010082589/823.
(100074330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Mobile Telesystems Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.895.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT AGRICOLE Luxembourg
CONSEIL S.A.
3, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010082837/14.
(100074315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Stëftung Hëllef Doheem, Fondation.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 48A, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg G 51.

<i>Fondation d'utilité publique

<i>Comptes annuels révisés au 31 décembre 2009

Contenu

Page(s)

Rapport de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 - 5

Rapport du Réviseur d'entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 - 7

Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 - 9

Compte de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Notes aux comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 20

<i>Rapport de gestion 2009

L'année 2009 a débuté avec la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle devenue inévitable suite à une

année financière 2008 très difficile. A l'égard de notre interprétation des évolutions économiques à l'échelle luxembour-
geoise et mondiale, ainsi qu'en prévision prudentielle des répercussions de la crise financière et économique sur les
moyens budgétaires de l'Etat qui financent majoritairement les prestations de la Stëftung Hëllef Doheem, une gestion
anticipative et socialement responsable des moyens et ressources de ta fondation, et une exécution disciplinée et suivie
de décisions et de projets ont été plus que jamais de mise durant l'année 2009.

Durant tout ce processus, tant les collaborateurs que les clients étaient continuellement au centre de nos préoccu-

pations par une disponibilité et présence accrue des membres de la direction générale et une communication permanente
et transparente.

Suite au règlement grand-ducal de décembre 2008, la fondation a pris en charge les premiers clients dans le cadre du

PAE (Projet d'Action Expérimentale) "gardes de nuit à domicile" à partir du mois de mars 2009. La loi sur les soins palliatifs,
donnant à tout citoyen le droit aux soins palliatifs et le choix de pouvoir mourir à domicile ou dans une institution, est
en vigueur depuis le 16 mars 2009. Le financement via la CNS (Caisse Nationale de Santé) ne se réalisera qu'en 2010.
Dès lors, le Ministère de la Famille a agréé a continuer sa participation financière, tout comme les dernières années, et
permettant ainsi à la fondation de continuer d'offrir des soins palliatifs à domicile complétant par ce biais les prestations
d'aide et de soins traditionnelles, les tâches domestiques et le téléalarme.

Après une baisse sensible de l'activité assurance dépendance en 2008, celle-ci a de nouveau progressé de 2% en 2009

et l'activité assurance maladie a augmenté de 8%. Tant les présences dans les foyers de jour que la clientèle téléalarme
ont évolué chacune de 8 % et les activités spécialisées ont connu une progression au niveau des heures prestées de 3%.
Les activités de proximité ont augmenté leur clientèle de 17%, progression due principalement à une approche de cen-

69531

L

U X E M B O U R G

tralisation organisationnelle se traduisant par le transfert de clients et de personnel des CAS vers le service des Activités
de Proximité, à savoir "Propper Doheem".

Alors que le volume des activités a fortement progressé, le nombre de clients distincts pris en charge en 2009 est

resté presque stable et dépasse le nombre de 16.000. Cette évolution se traduit par une augmentation des heures de
prestation par client entraînant une diminution des charges administratives, de coordination et de transport. A l'opposé,
le nombre de collaborateurs n'a pas suivi totalement l'augmentation des heures prestées dû à une très grande prudence
en matière d'engagement par les Centres d'Aide et de Soins, conséquence logique après le vécu de 2008. Il en résulte
une dis-relation entre la forte variation des ventes de prestations de service et la variation modérée des frais de personnel.

A la fin de l'année 2009, la Stëftung Hëllef Doheem renseigne un chiffre d'affaires de 73.040.694,90€ représentant une

augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Les prestations de service se composent essentiellement des
prestations fournies dans le cadre de l'assurance dépendance (73%), dont les créanciers sont majoritairement la Caisse
Nationale de Santé (CNS), le Ministère de la Famille et les clients, ainsi que des prestations fournies dans le cadre de
l'assurance maladie (20%), opposables à la CNS.

Les  frais  de  fonctionnement  ont  baissé  de  presque  4%  et  se  chiffrent  à  11.450.273,56€  à  la  fin  de  l'année.  Cette

diminution provient, d'une part, d'une économie au niveau des frais administratifs et, d'autre part, d'une mise en attente
des commandes de nouvelles voitures de service suite à un nouveau "tendering". S'en est suivi un nouveau partenaire et
un changement de modèle de voiture répondant mieux aux critères d'excellence en matière d'écologie auxquels la Stëftung
Hëllef Doheem s'est engagée dans sa culture RSE (Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises).

De plus, la mise en œuvre de la nouvelle structure ayant impacté un grand nombre de notre personnel dirigeant a eu

un effet de ralentissement sur le volume des heures de formations, entrainant une forte diminution de cette charge à
l'opposé des estimations budgétaires.

En conséquence de l'approche très prudente en matière d'engagement, expliquée ci-dessus, les frais salariaux se chif-

frant à 58.589.617,50 € à la fin de l'année ont progressé uniquement de 2%. La provision concernant les négociations en
cours en matière de CCT SAS pour 2009 de 1.5% a un impact global de 897.468,96 €. Au résultat d'exploitation positif
de 1.807.444,95€ s'ajoute un résultat financier positif de 21.587,32 € et un résultat exceptionnel positif de 234.209,41 €.
La Stëftung Hëllef Doheem clôture l'année 2009 avec un résultat excédentaire de 2.063.241,68 €.

<i>Perspectives 2010

En 2010, la Stëftung Hëllef Doheem se concentrera prioritairement sur le financement des soins palliatifs, le dialogue

avec la CNS en matière d'adaptation de la nomenclature des actes infirmiers et de la fixation de normes en matière
d'assurance dépendance.

Pour satisfaire continuellement les besoins changeants des clients, la fondation étendra l'offre de ses services et im-

plémentera de nouveaux standards complètement adaptés aux nouvelles techniques médicales.

L'accompagnement et le soutien continu et régulier des collaborateurs ainsi que leur formation continue resteront

des priorités absolues pour la fondation. La motivation des collaborateurs est importante pour effectuer un travail de
haute qualité selon les lignes directrices de Hëllef Doheem. Suite à l'évaluation de l'enquête de satisfaction réalisée en fin
2009, la fondation établira un plan d'action pour répondre aux "fils rouge" des besoins exprimés par les collaborateurs.

Finalement, un accent particulier sera mis sur l'automatisation, l'adaptation et la simplification des différents processus,

procédures et tâches quotidiennes.

Il n'y a pas eu d'évènements significatifs après le 31 décembre 2009 qui nécessiteraient une information supplémentaire

ou une modification aux comptes annuels.

Luxembourg, le 13 avril 2010.

Robert Theissen / Paul-Henri Meyers
<i>Directeur général / Président

<i>Rapport sur les comptes annuels

Nous  avons  effectué l'audit des  comptes  annuels  ci-joints  de Stëftung Hellef  Doheem, comprenant  le  bilan au  31

décembre 2009, le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2009 et l'annexe contenant
un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

<i>Responsabilité du Conseil d'Administration dans l'établissement et la Présentation des comptes annuels

Le Conseil d'Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de principes et méthodes comptables appropriés; ainsi
que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

69532

L

U X E M B O U R G

<i>Responsabilité du Réviseur d'entreprises

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons

effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et réaliser l'audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d'entre-
prises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le Réviseur d'entreprises prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et
du caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que l'appréciation
de la présentation d'ensemble des comptes annuels.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

<i>Opinion

A notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de Stëftung

Hellef Doheem au 31 décembre 2009, ainsi que des résultats pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2009, con-
formément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en
vigueur au Luxembourg.

Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que les décomptes finaux de la Caisse

Nationale de Santé relatifs aux exercices 2007, 2008 et 2009 ne sont pas encore disponibles et de ce fait les comptes
annuels ne comprennent pas les ajustements qui pourraient devenir nécessaires suite à l'obtention de ces décomptes.
Les comptes annuels comprennent des estimations raisonnables pour couvrir les décomptes finaux.

<i>Rapport sur d'autres obligations légales ou réglementaires

Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d'Administration, est en concordance avec les comptes

annuels.

Luxembourg, le 13 avril 2010.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
<i>Réviseur d'entreprises
Représentée par Pierre Krier

<i>Bilan au 31 décembre 2009

<i>(Exprime en Euro)

ACTIF

NOTES

31.12.09

31.12.08

C.

ACTIF IMMOBILISE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 113 568,81

4 521 339,38

1.

Immobilisations incorporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1,3

325 212,67

372 689,28

2.

Concessions, brevets, licences, marques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325 212,67

372 689,28

II.

Immobilisations corporelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1,4

4 788 356,14

4 148 650,10

1.

Terrains et constructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 759 115,56

1 801 323,25

2.

Installations techniques et machines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 295,05

156 592,46

3.

Autres installations, outillage et machines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 968 834,97

2 190 734,39

4.

Immobilisations corporelles en cours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

932 110,56

0,00

D.

ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109 346 116,47 68 240 588,30

II.

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

105 185 443,08 63 623 904,27

1.

Créances résultant de l'exploitation

5

103 002 786,31 62 364 485,58

4.

Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 182 656,77

1 259 418,69

IV.

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques
et en caisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 160 673,39

4 616 684,03

E.

COMPTES DE REGULARISATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

393 676,63

385 035,80

TOTAL ACTIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114 853 361,91 73 146 963,48

Les notes en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels

69533

L

U X E M B O U R G

<i>Bilan au 31 décembre 2009

<i>(Exprime en Euro)

PASSIF

NOTES

31.12.09

31.12.08

A.

Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 299 712,68

7 174 420,97

I.

Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 511 227,90

5 755 429,96

a.

Dotation initiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 578,70

49 578,70

e.

Libéralités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5,6

6 461 649,20

5 705 851,26

IV. Réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

572 248,87

3 922 005,57

4.

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7,8

572 248,87

3 922 005,57

V.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

11 079,40

11 079,40

VI. Excédent /(déficit) de l'exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 063 241,68 (3 349 756,70)

VII. Subventions d'investissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4,9

1 141 914,83

835 662,74

B.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  . . . . . . . . . . . . . . . .

3 007 530,86

1 331 764,82

3.

Autres provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3 007 530,86

1 331 764,82

C.

DETTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3

101 546 118,37 64 640 777,69

2.

Dettes envers des établissements de crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 629 397,82

807 659,32

4.

Dettes sur ventes et prestations de service  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

96 430 526,90 60 578 392,09

8.

Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité
sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

3 486 193,65

3 254 726,28

TOTAL PASSIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114 853 361,91 73 146 963,48

Les notes en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels

<i>Compte de profits et Pertes pour l'exercice

<i>Clôture au 31 décembre 2009

<i>(Exprime en Euro)

NOTES

31.12.09

31.12.08

A.

PRODUITS D'EXPLOITATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 129 746,90 68 371 758,68

Ventes de prestations de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 040 694,90 66 396 675,29

Subventions d'exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6

667 069,50

646 788,20

Reprises sur amortissements et provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . .

339 301,85

445 421,36

Autres produits d'exploitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 082 680,65

882 873,83

A'.

CHARGES D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(73 322

301,95)

(71 821

812,99)

Autres achats et charges externes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11 446

345,52)

(11 895

421,55)

Impôts, taxes et versements assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3 928,04)

(7 605,27)

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

(58 589

617,50)

(57 648

658,30)

Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(51 194

497,98)

(51 080

518,52)

Charges sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7 302 013,92) (6 456 817,32)

Autres frais de personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(93 105,60)

(111 322,46)

Dotations aux amortissements et aux provisions  . . . . . . . . . . . .

(3 282 410,89) (2 270 127,87)

Sur immobilisations: dotations aux amortissements  . . . . . . . . . .

(1 022 095,29) (1 108 634,77)

Sur actif circulant: dotations aux provisions  . . . . . . . . . . . . . . . .

(245 247,71)

(310 701,24)

Sur risques et charges: dotations aux provisions  . . . . . . . . . . . . .

10

(2 015 067,89)

(850 791,86)

A.-A'. RESULTAT D'EXPLOITATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 807 444,95 (3 450 054,31)

C.

PRODUITS FINANCIERS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 961,93

124 081,78

Autres intérêts et produits assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 961,93

124 081,78

C'. CHARGES FINANCIERES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12 374,61)

(38 090,98)

Intérêts et charges assimilées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12 374,61)

(38 090,98)

C-C'. RESULTAT FINANCIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 587,32

85 990,80

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 829 032,27 (3 364 063,51)

RESULTAT COURANT APRES IMPOTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 829 032,27 (3 364 063,51)

E.

PRODUITS EXCEPTIONNELS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

500 514,46

322 409,90

69534

L

U X E M B O U R G

E'.

CHARGES EXCEPTIONNELLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

(266 305,05)

(308 103,09)

E.-E'.

RESULTAT EXCEPTIONNEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234 209,41

14 306,81

TOTAL DES PRODUITS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 664 223,29 68 818 250,36

TOTAL DES CHARGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(73 600

981,61)

(72 168

007,06)

EXCEDENT / (DEFICIT) DE L'EXERCICE  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 063 241,68 (3 349 756,70)

Les notes en annexe font partie intégrante de ces comptes annuels

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2009

Note 1 

er

 . Généralités.  La Fondation Stëftung Hëllef Doheem (ci-après "La Fondation") a été créée le 9 septembre

1999 par:

- la Congrégation des Frères de Charité;
- la Congrégation des Sœurs du Tiers-Ordre Régulier de Notre Dame du Mont Carmel;
- les Chanoinesses régulières de Saint Augustin de la Congrégation de Notre Dame;
- la Congrégation des Soeurs de la Doctrine Chrétienne;
- la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde;
- la Congrégation des Sœurs du Pauvre Enfant Jésus;
- la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sainte Elisabeth;
- l'association Aide Familiale-Aide Senior;
- l'association Foyers Seniors.
La Fondation a comme objet la promotion du bien-être psychique, physique et social ainsi que l'autonomie des per-

sonnes âgées, dépendantes, malades et / ou handicapées. A cette fin elle promeut, coordonne, assure, gère et organise
des services ambulatoires en faveur du maintien à domicile, des établissements stationnaires et semi-stationnaires et des
institutions spécialisées apportant des aides, des soins et des activités de conseil et de soutien. Les statuts de la Fondation
"Stëftung Hëllef Doheem" ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1999.

La Fondation a repris avec effet au 1 

er

 janvier 2000 les activités des associations suivantes:

- le patrimoine net de Hëllef Doheem Krankefleg a.s.b.l., créé en 1980 par les congrégations religieuses qui dispensaient

depuis le 19ième siècle des aides et des soins à travers le pays principalement dans le cadre de l'assurance maladie, a été
transférée entièrement à la Fondation dans le cadre de sa liquidation;

- les associations "Foyers Seniors a.s.b.l." et "Aide Familiale - Aide Senior a.s.b.l." actives dans le domaine des prestations

de soins à domicile dans le cadre de l'assurance dépendance, ont cédé une partie de leurs activités à la Fondation.

La Fondation "Stëftung Hëllef Doheem" a conclu des contrats de sous-traitants avec d'autres prestataires intervenant

dans le cadre de l'assurance maladie et / ou dans le cadre de l'assurance dépendance. C'est la Fondation qui facture à
l'Union des Caisses de Maladie. Conformément aux termes du contrat elle leur reverse leur dû.

Note 2. Résumé des principales politiques comptables. Suite au contrat signé entre la Fondation et l'organisme ges-

tionnaire de l'assurance dépendance, la Fondation est tenue de respecter les principales politiques comptables suivantes:

2.1 Actifs immobilisés
Les actifs immobilisés sont évalués au prix d'acquisition historique. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais

accessoires au prix d'achat. Le prix d'acquisition des actifs immobilisés dont l'utilisation est limitée dans le temps est
diminué des amortissements calculés de manière à amortir la valeur de ces éléments sur leur durée d'utilisation estimée.

En cas de dépréciation durable, les éléments immobilisés dont l'utilisation est ou non limitée dans le temps font l'objet

de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces
corrections de valeur sont extournées lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessées d'exister.

2.1.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles figurent au prix d'acquisition et sont amorties sur une base linéaire selon leur durée

d'utilisation estimée. Les durées d'amortissement sont entre 2 à 4 ans.

Les immobilisations incorporelles en cours ne sont pas amorties.
2.1.2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles figurent au coût d'acquisition. A l'exception du terrain qui n'est pas amorti, les im-

mobilisations corporelles sont amorties sur une base linéaire selon leur durée de vie estimée.

Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement entre 3 et 10 ans à l'exception des constructions dont la

durée d'amortissement est de 50 ans.

Les immobilisations corporelles de faible valeur sont intégralement prises en charge lors de l'acquisition.
2.2 Créances

69535

L

U X E M B O U R G

Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont enregistrées sur décision

du Conseil d'Administration, afin de tenir compte des risques de non-recouvrement. Les corrections de valeur sont
déduites des postes d'actif concernés.

Les prestations des sous-traitants relatives à des clients en régime transitoire n'ont pas été comptabilisées. Ces pres-

tations ne seront enregistrées et facturées à l'Union des Caisses de Maladies par la Stëftung Hëllef Doheem que si les
clients obtiennent une décision positive.

2.3 Dettes
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement.
2.4 Subventions d'investissement
Les subventions destinées au financement d'immobilisations sont amorties au compte de profits et pertes en tenant

compte de la durée de vie économique des immobilisations auxquelles elles se rapportent.

2.5 Dons d'exploitation
Les dons reçus pendant l'exercice sont affectés systématiquement au passif comme libéralités.
2.6 Subventions d'exploitation
Les subventions d'exploitation sont comptabilisées directement dans le compte de profits et pertes.
2.7 Affectation du résultat de l'exercice
Le résultat de l'exercice, après approbation des comptes annuels, est systématiquement affecté aux fonds propres.
2.8 Conversion des soldes en devises
Les opérations conclues en devises sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs,

autres que les actifs immobilisés, et passifs en devises sont convertis en EURO aux taux en vigueur à la clôture de l'exercice.
Les gains et pertes non-réalisés calculés au moment de la conversion sont comptabilisés dans le compte de profits et
pertes.

Note 3. Immobilisations incorporelles.
L'évolution du compte "Immobilisations incorporelles" est résumée comme suit:

Immobilisations

incorporelles

EURO

Valeur brute au 01.01.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 748 960,51

Acquisitions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176 702,82

Cessions et transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(0,00)

Valeur brute au 31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 925 663,33

Amortissements au 01.01.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 376 271,23)

Amortissements de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(224 179,43)

Reprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Amortissements cumulés au 31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 600 450,66)

Valeur nette au 31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325 212,67

Valeur nette au 31.12.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

372 689,28

Le compte "Immobilisations incorporelles" est constitué de logiciels informatiques.

Note 4. Immobilisations corporelles. L'évolution du poste "Immobilisations corporelles" est résumée comme suit:

Constructions

EURO

Installations

techniques

et machines

EURO

Autres

installations,

outillage et

machines

EURO

Acomptes
versés sur

immobilisations

corporelles

en cours

EURO

Total EURO

Valeur brute au
01.01.2009 . . . . . . . . . . . . . .

2 141 006,62

442 580,11

7 698 123,58

0,00 10 281 710,31

Acquisitions . . . . . . . . . . . . .

0,00

34 655,72

495 206,22

932 110,56 1 461 972,50

Cessions/
Désinvestissements . . . . . . .

(0,00)

(29,08)

(316 270,95)

(0,00)

(316 300,03)

Valeur brute au
31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . .

2 141 006,62

477 206,75

7 877 058,85

932 110,56 11 427 382,78

Amortissements cumulés
au 01.01.2009 . . . . . . . . . . .

(339 683,37)

(285 987,65)

(5 507 389,19)

(0,00)

(6 133

060,21)

Amortissements

(42 207,69)

(62 953,13)

(692 755,04)

(0,00)

(797 915,86)

69536

L

U X E M B O U R G

de l'année . . . . . . . . . . . . . .
Reprises . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

29,08

291 920,35

0,00

291 949,43

Amortissements cumulés
au 31.12.2009 . . . . . . . . . . .

(381 891,06)

(348 911,70)

(5 908 223,88)

(0,00)

(6 639

026,64)

Valeur nette au
31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . .

1 759 115,56

128 295,05

1 968 834,97

932 110,56 4 788 356,14

Valeur nette au
31.12.2008 . . . . . . . . . . . . . .

1 801 323,25

156 592,46

2 190 734,39

0,00 4 148 650,10

Note 5. Créances résultant de l'exploitation.
Le poste "Créances résultant de l'exploitation" s'analyse comme suit au 31 décembre 2009:

Créances

d'exploitation

EURO

Créances Union des Caisses de Maladie 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 786 869,56

Créances Ministère de la Famille 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 152 055,32

Créances clients 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 242,08

Autres créances clients (Téléalarme,..) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

864 660,51

Créances Union des Caisses de Maladie 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 788 252,59

Créances Ministère de la Famille 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 565,40

Créances clients 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 700,32

Créances Union des Caisses de Maladie 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 142 382,40

Créances Ministère de la Famille 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258 475,48

Créances clients 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 211,78

Créances Union des Caisses de Maladie 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 770,87

Provision pour créances douteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1 309 400,00)

Solde net au 31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 002 786,31
Solde net au 31.12.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 364 485,58

Note 6. Libéralités. Le compte "libéralités" a évolué comme suit:

Libéralités

2009 EURO

Libéralités

2008 EURO

Dons d'exploitation à la création de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556 430,29

556 430,29

Affectation des dons années antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 581 189,95 3 992 364,09
Affectation des dons de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

568 231,02

588 825,86

Affectation des dons de l'année encours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

755 797,94

568 231,02

6 461 649,20 5 705 851,26

Note 7. Résultats reportés. Le compte "Résultats reportés" a évolué comme suit:

Résultats

reportés

EURO

Résultats reportés au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 079,40

Résultat de l'exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 349 756,70)
Apurement par affectation au poste des autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 349 756,70

Résultats reportés à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 079,40

Note 8. Autres réserves. L'évolution du poste "Autres réserves" est résumée comme suit:

Autres

réserves

2009 EURO

Autres

réserves

2008 EURO

Apport des actifs nets à la création de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 371 939,94 1 371 939,94
Excédents cumulés années antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 550 065,63

649 170,31

Affectation du résultat de l'année précédente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3 349

756,70)

1 900 895,32

Autres réserves à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

572 248,87 3 922 005,57

Note 9. Subventions d'investissement. L'évolution du poste "Subventions d'investissement" est résumée comme suit:

Subventions

69537

L

U X E M B O U R G

d'investissement

EURO

Montant à l'ouverture de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835 662,74

Dotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374 064,15

Amortissements de l'année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(67 812,06)

Valeur nette au 31.12.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 141 914,83

Valeur nette au 31.12.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

835 662,74

Note 10. Autres provisions. Le poste "Autres provisions" est principalement composé d'une provision pour les ré-

troactivités relatives aux années 2007, 2008 et 2009 liés aux négociations de la CCT SAS entamées en 2007 pour un
montant de EURO 1 881 131,93, d'une provision pour heures supplémentaires, jours fériés, dimanche et congé pour un
montant de EURO 1 001 398,93.

Note 11. Autres dettes. Le poste "Autres dettes" s'analyse comme suit:

Autres dettes

EURO

Sécurité sociale et dettes envers l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 351 154,54
Dettes envers le personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 620,61

Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 418,50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 486 193,65

Note 12. Dettes sur ventes et Prestations de service. Le poste "dettes sur ventes et prestations de service", est

principalement composé des avances reçues pour les prestations non encore décomptées auprès de la Caisse Nationale
de Santé.

Note 13. Comptes de régularisation actif. Dans les comptes de régularisation actifs sont enregistrées des charges

payées d'avance et des charges à répartir sur plusieurs exercices.

Note 14. Personnel. La Fondation employait à la fin de l'exercice 1 578 personnes (2008: 1 572) dont 721 ouvriers

(2008: 701) et 857 employés (2008: 871).

Note 15. Produits exceptionnels. Le poste "Produits exceptionnels" se décompose comme suit:

Produits

exceptionnels

EURO

Revenus liés à des prestations sur les années antérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325 995,64

Revenus liés à des ventes d'immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 500,00

Indemnité assurance incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 366,57

Autres produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 890,44

Quote-part des subventions d'investissement transférée au résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . .

105 761,81

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 514,46

Note 16. Charges exceptionnelles. Dans le compte "Charges exceptionnelles", la Fondation a enregistré des charges

liées à des exercices antérieures mais régularisés durant l'exercice 2009 pour un montant de EURO 123 144,69 ainsi que
des pertes sur créances irrécouvrables pour un montant EURO 33 103,69.

Note 17. Jetons de présence. Pendant l'exercice 2009, la Fondation n'a pas alloué aux membres du Conseil d'Admi-

nistration des jetons de présence.

Note 18. Engagements financiers hors bilan. Les engagements non encore échus se chiffrent à EURO 7 372 536,90. Ils

sont relatifs à des contrats leasing de 623 voitures pour un montant de EURO 7 153 447,65, l'acquisition d'un immeuble
à Pétange pour un montant total de EURO 207 689,25 et des garanties bancaires pour un montant total de EURO 11
400,00. La fondation détient également des obligations d'une valeur estimée à EURO 41 448,51.

<i>Proposition d'affectation du résultat 2009

<i>(approuvé par le Conseil d'Administration en date du 13/04/2010)

Résultat de l'exercice 2009: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 2 063 241,68 €

Affectation du résultat en réserves: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 2 063 241,68 €

Résultat de l'exercice après affectation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 €

<i>Budget 2010 - Consolide

DEPENSES

01.01.2010

-31.12.2010

RECETTES

01.01.2010

-31.12.2010

69538

L

U X E M B O U R G

A Frais du personnel . . . . . . . . . . . . . . 63'383'473.37 A Prestations en relation avec la Sécurité

Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70'578'137.62

B Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . 11'135'163.71 B Autres prestations  . . . . . . . . . . . . . . .

3'940'499.46

C Provisions pour créances
irrécupérables et autres . . . . . . . . . . . .

0.00

D Autres dépenses . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

Total des Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . 74'518'637.08 Total des Recettes  . . . . . . . . . . . . . . . .

74'518'637.08

Référence de publication: 2010082743/424.
(100074519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

FR Acquisition Subco (Luxembourg), S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 133.365.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082831/11.
(100074154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Damire International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 56.509.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 06 mai 2010.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 8-10,

rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, et de Madame Sandrine Pellizzari, employée privée, avec adresse professionnelle
8-10, rue Jean Monnet à L-2180. Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2015.

L'Assemblée renouvelle également le mandat, de Président du Conseil d'administration et d'administrateur de Mon-

sieur Pierfrancesco Ambrogio, employé privé, avec adresse professionnelle 8-10, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société ALTER AUDIT S.à r.l., ayant son siège

social 69, rue de la Semois à L-2533 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes
de l'exercice 2015.

Luxembourg, le 18 mai 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010084067/23.
(100075138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Novalex Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 92.817.

Le Bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.G.A. SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2010082836/11.
(100074316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69539

L

U X E M B O U R G

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.746.

Suite à la décision prise en assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 septembre 2009 de nommer

Monsieur Tassilo Hendus en tant que nouveau membre du conseil d'administration de Microfinance Enhancement Facility
SA, SICAV-SIF sous condition et avec effet de l'approbation écrite de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
il est noté que Monsieur Tassilo Hendus est nommé membre du conseil d'administration à compter du 9 novembre 2009.

Par conséquent, le conseil d'administration de la société se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de l'assemblée

générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2012:

- M. Roland Siller, Administrateur Classe K
Palmengartenstrasse 5-9, F-60325 Frankfurt am Main
- Mme Monika Beck, Administrateur Classe K
Palmengartenstrasse 5-9, F-60325 Frankfurt am Main
- M. Martin Holtmann, Administrateur Classe I
2121 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. 20433, United States of America
- Mme Mamta Shah, Administrateur Classe I
2121 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. 20433, United States of America
- Mme Andrea Hagmann, Membre du Conseil d'Administration
Strauchgasse 3, A-1011 Wien
- M. Tassilo Hendus, Administrateur Classe L
100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Jacqueline Siebenaller / Daniel Breger

Référence de publication: 2010084066/29.
(100075130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Stone River S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.344.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082840/10.
(100074247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Bâloise Fund Invest (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 80.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010082839/10.
(100074252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Regus plc, Société Anonyme.

Siège de direction effectif: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.159.

<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la société en date du 7 décembre 2010

M. John Waylett Matthews ayant son adresse personelle à Limpley Crest, Limpley, Stoke, Bath BA2 7GW, Royaume

Uni, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 18 mai 2010.

69540

L

U X E M B O U R G

M. Anthony Martin Robinson ayant son adresse personalle à 7 Oakfield Road, Harpenden, Hertfordshire, AL5 2NF,

Royaume Uni, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 18 mai 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2010.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010083944/16.
(100075225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Orocash Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 145.447.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082841/10.
(100074246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Orocash Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 72.689.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082842/10.
(100074244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

SmartStream Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082847/14.
(100074393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Prentice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 65.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010082843/13.
(100074434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69541

L

U X E M B O U R G

Cofinimmo Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.044.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Cofinimmo
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010082844/13.
(100074415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Mastertec Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.261.

Le bilan au 31 Décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2010.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010082846/12.
(100074396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Weather Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,11.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082849/14.
(100074391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Weather X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082850/14.
(100074377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69542

L

U X E M B O U R G

Jupiter Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 128.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082851/14.
(100074365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Aviabel Re, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 48.216.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société AVIABEL RE
Aon Captive Services Group (Europe)
Signature

Référence de publication: 2010082860/12.
(100074470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Weather V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,24.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2010.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082852/14.
(100074361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Sogeimm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.008.

<i>Rectificatif du dépôt du 07/07/2009 (No L090099244)

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010082854/14.
(100074439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69543

L

U X E M B O U R G

LaSalle Torius S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082855/10.
(100074490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Collineo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.421.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Außerordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2010

Die Amtsniederlegung des Herrn Ralf Baukloh als Geschäftsführer mit Wirkung zum 30.04.2010 ist angenommen.
Als sein Nachfolger wird Herr Manfred Uthoff, Angestellter, geboren am 19.06.1957 in Köln, Deutschland, geschäft-

sansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ernannt. Sein Mandat läuft auf eine unbegrenzte Zeit.

Luxemburg, den 20. Mai 2010.

Für beglaubigten Auszug
Collineo Holding S.à r.l.
Christoph Kossmann / Jörg Mucke

Référence de publication: 2010083961/16.
(100074868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Francilienne Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 105.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082856/10.
(100074488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

LPOV Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.052.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082857/10.
(100074484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

LPOV Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.444.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082858/10.
(100074481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69544

L

U X E M B O U R G

LIM Advisory Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.374.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082859/10.
(100074478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Dominus S.A., Société Anonyme,

(anc. Durante Business S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 111.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DOMINUS S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Référence de publication: 2010082864/14.
(100074445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Aon Re Canada Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.782.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société Aon Re Canada Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2010082861/10.
(100074466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Kashyk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 125.122.

<i>Rectificatif du dépôt du 31/12/2009 (No L090202338)

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KASHYK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2010082862/13.
(100074452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

PIN H. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 150.743.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69545

L

U X E M B O U R G

PIN H. S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signatures

Référence de publication: 2010082863/12.
(100074450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Graphing Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 100.593.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 28 mai 2010

Le mandat des administrateurs, à savoir, Monsieur Jacques CUGNY, né le 14 avril 1935 à Ferreyres (Suisse), demeurant

au 10, route de Commugny, CH-1296 COPPET (SUISSE), Monsieur Hervé POLLET, né le 7 juin 1961 à Genève (Suisse),
demeurant au 7, Chemin Prédèrès, CH-1276 GINGINS (SUISSE) et Madame Tanya TAMONE née le 03 août 1961 à
Paisley (UK), demeurant à Chemin du Communet 10b, CH-1196 Gland (Suisse) ainsi que le mandat de commissaire aux
comptes de la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie S.à.r.l. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée de 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
GRAPHING CONSULT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010083941/19.
(100075306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Sogeimm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.008.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A.
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010082865/13.
(100074443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Librairie Am Pullewe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3543 Dudelange, 4, rue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.662.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082868/10.
(100074379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Turk Real Estate Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.364.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

69546

L

U X E M B O U R G

Xavier De Cillia
<i>Gérant

Référence de publication: 2010082866/12.
(100074120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

AG Fiduciaire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7217 Bereldange, 114, rue de Bridel.

R.C.S. Luxembourg B 16.743.

<i>Gefasste Beschlüsse im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2010

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den aktuellen Kommissar Herrn Robert Elvinger mit sofortiger Wirkung abzu-

wählen und Herrn Dr. Hans Gerd Meister, Rechtsanwalt, wohnhaft Bussardweg 5, D-40670 Meerbusch, Deutschland,
zum neuen Kommissar für eine Periode von 6 (sechs) Jahren zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll.
Aufgenommen zu Luxemburg.
Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten das vorliegende Protokoll unterschrieben.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2010083949/19.
(100074956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Lettrage Reding Nico S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6B, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 62.671.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082869/10.
(100074378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Lux-Aerospace S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 44.882.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082870/10.
(100074375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Immo-Agence Florida S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3419 Dudelange, 26, rue Alphonse Benoit.

R.C.S. Luxembourg B 41.939.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082871/10.
(100074374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69547

L

U X E M B O U R G

N.A.S. Aviation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5337 Moutfort, 11, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 38.712.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082872/10.
(100074373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

SFDC Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 279.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.269.

Les comptes annuels au 31 janvier 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2010082902/14.
(100073903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

N.A.S. Aviation S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5337 Moutfort, 11, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 38.712.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082873/10.
(100074371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Hippocampus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 46, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 50.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082875/10.
(100074343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Hippocampus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 46, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 50.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082876/10.
(100074342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69548

L

U X E M B O U R G

CLT-UFA, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 6.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 Mai 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082877/12.
(100074339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

RTL Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 10.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2010.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010082878/12.
(100074337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Hoertässelesch Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5671 Altwies, 2, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 143.167.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082879/10.
(100074491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Prorest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 7-9, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 141.367.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082880/10.
(100074489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

S.R.E.T. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 17, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 103.132.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082881/10.
(100074474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69549

L

U X E M B O U R G

Monarchy Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.119.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MONARCHY ENTERPRISES S.à r.l.
Ruth BRAND / Jean-Christophe Dauphin
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010082882/12.
(100074070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Carbone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CARBONE S.à r.l.
Jean-Christophe DAUPHIN / Georges Scheuer
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010082883/12.
(100074069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Safer Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 132.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Safer Holdings S.à r.l.
Mikaël GUTIERREZ RUIZ / Philippe TOUSSAINT

Référence de publication: 2010082884/11.
(100074063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Compagnie de Banque Privée, Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 117.963.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082885/10.
(100074249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Heron Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 146.870.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082886/10.
(100074229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

69550

L

U X E M B O U R G

Mondo Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 7.500.000,00.

Siège social: L-3895 Foetz, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 16.619.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 28 mai 2010 que:
- les actionnaires ont pris note et accepté les démissions de Monsieur Fernando Elio Stroppiana en tant qu'adminis-

trateur de la Société avec effet au 26 janvier 2010 et de Madame Alessandra Stroppiana en tant qu'administrateur de la
Société avec effet au 7 avril 2010;

- les actionnaires ont décidé de nommer Madame Stefania Stroppiana, née le 23 février 1980 à Alba (Italie), demeurant

à I-12051 Alba, Frazione Gallo, 15, Strada Santa Maria, Monsieur Federico Stroppiana, né le 15 janvier 1970 à Alba (Italie),
demeurant à H2V 2V8 Outremont, Québec (Canada), Monsieur David Weijber, né le 13 mars 1976 à Bjorkvik (Suède),
demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, Zone Industrielle, et Monsieur Marco Stroppiana, né le 11 janvier 1981
à Alba (Italie), demeurant à I-12051 Alba, Frazione Gallo, 15, Strada Santa Maria, en tant qu'administrateurs de la Société
avec effet immédiat, pour un mandat se terminant à l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société de l'année 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire
Signature

Référence de publication: 2010084102/23.
(100074974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Heron Les Mesnuls S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 148.011.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082887/10.
(100074227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Heron Nointel S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 148.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010082888/10.
(100074225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Satalux, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2010084243/13.
(100074966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

69551

L

U X E M B O U R G

Fongesco S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 29.741.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 14 mai 2010 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Lu-

xembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.
L'assemblée générale du 14 mai 2010 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Aloyse SCHERER, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 14 mai 2010.

<i>Pour FONGESCO S.A.
Société anonyme holding
Signature

Référence de publication: 2010083969/22.
(100074644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

EDM International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.523.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 25 mai 2010
-a renouvelé le mandat de Messieurs
Eusebio Diaz Morera (Chairman)
EDM Holding S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1-SP 08008 Barcelona
Juan Diaz Morera
Law Practice Diaz-Morera, Travessera de Gracia, 29, 4, 1 -SP 08021 Barcelona
Lluis Fortuny
EDM Servicios Financieros, S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
Antoni Estabanell Buxo
EDM Holding S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
Jordi Pascual
EDM Servicios Financieros, S.A., Avenue Diagonal, 399, 3, 1 -SP 08008 Barcelona
Nicolaus P.Bocklandt
MDO Services S.A., 19 rue de Bitbourg, L - 1273 Luxembourg
à la fonction d'administrateurs de la société pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire

de mai 2011.

-a également nommé à la fonction de Réviseur d'Entreprises,
Deloitte S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour une période d'un an.

<i>Pour EDM INTERNATIONAL
SICAV
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2010082771/30.
(100073988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

69552


Document Outline

AG Fiduciaire S.A.

Aon Re Canada Holdings S.à r.l.

Aviabel Re

Bâloise Fund Invest (Lux)

Carbone S.à r.l.

CLT-UFA

Cofinimmo Luxembourg S.A.

Collineo Holding S.à r.l.

Compagnie de Banque Privée

Damire International S.A.

Dominus S.A.

Durante Business S.A.

EDM International

Fongesco S.A.

FR Acquisition Subco (Luxembourg), S. à r.l.

Francilienne Investments II S.à r.l.

Graphing Consult S.A.

Heron Holding S.A.

Heron Les Mesnuls S.A.

Heron Nointel S.A.

Hippocampus S.à r.l.

Hippocampus S.à r.l.

Hoertässelesch Sàrl

Immo-Agence Florida S.à r.l.

Innisfree ISF S.à r.l.

Jupiter Acquisitions S.à r.l.

Kashyk S.A.

LaSalle Torius S.à.r.l.

Lettrage Reding Nico S.à.r.l.

Librairie Am Pullewe S.à r.l.

LIM Advisory Services

LPOV Holdings 1 S.à r.l.

LPOV Holdings 2 S.à r.l.

Lux-Aerospace S.A.

Mastertec Invest S.A.

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF

Mobile Telesystems Finance S.A.

Monarchy Enterprises S.à r.l.

Mondo Luxembourg S.A.

Morgan Stanley Investment Funds

N.A.S. Aviation S.à.r.l.

N.A.S. Aviation S.à.r.l.

Novalex Holding S.C.A.

O'Neill Brand S.à r.l.

Orocash Capital S.A.

Orocash Holding S.A.

PIN H. S.à r.l.

Prentice S.A.

Prorest Sàrl

Regus plc

RTL Group S.A.

Safer Holdings S. à r.l.

Satalux

SFDC Luxembourg

SmartStream Acquisitions S.à r.l.

Sogeimm S.A.

Sogeimm S.A.

S.R.E.T. Sàrl

Stëftung Hëllef Doheem

Stone River S.A.

Turk Real Estate Management S.àr.l.

Weather Investors S.à r.l.

Weather V S.à r.l.

Weather X S.à r.l.