This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1375
5 juillet 2010
SOMMAIRE
3W Power Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
65976
Arten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65974
Becker & Zaccagnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65955
Blamar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65972
BNL International Investments . . . . . . . . . .
66000
Business Investor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65973
Caravaggio Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65973
Centocinquantacinque S.A. . . . . . . . . . . . . .
65999
C.F. Marazzi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66000
Compagnia Atlantica Holding S.A. . . . . . . .
65999
Compagnie Industrielle et Financière des
Produits Amylacés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65997
Conseil Transaction Négoce (en abrégé:
CTN) Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65998
Daulby S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65962
Dero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65954
De Wending S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65997
Dockland Development S.A., SICAR . . . . .
65975
Donatello Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65974
EAVF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65966
ESCO Interamerica Ltd S.à r.l. . . . . . . . . . .
65955
EuroRidge Solar Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
65967
Fagus Multimanager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65998
Finagra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65973
Finantel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65954
G.I.TE.N. Groupe International des Tech-
nologies Naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65997
Green Cross Equity S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
65957
Harsco Interamerica Limited S.à r.l. . . . . .
65955
Holteide Investissement S.A. . . . . . . . . . . . .
65998
I.T. Türk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65999
Karsira Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65999
Lagomar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65998
Marc Lefèbvre, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65975
Marwil Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
65976
MezzVest Luxembourg II S. à r.l . . . . . . . . .
65975
MezzVest Luxembourg I S.à.r.l. . . . . . . . . .
65975
Monjoint L.L.C. - Luxembourg Branch . . .
66000
Murex International Luxembourg S.A. . . .
65997
NATIXIS Luxembourg Investissements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65974
Phoenix Holdco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
65963
Rakis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65999
Sabone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65962
SBRE Capmark Holdco . . . . . . . . . . . . . . . . .
65966
SBRE Neighbourhood Centre . . . . . . . . . . .
65962
SBRE Waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65966
SBRE West German Portfolio Luxco . . . .
65963
Sogestaf S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65957
Solum Parc Rischard S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
65957
Trade-Match.com S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
65963
Vertex Commodities Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
65954
Watercreek Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
66000
65953
L
U X E M B O U R G
Dero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 65.112.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 06 mai 2010.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A.
SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg est nommé représentant permanent pour la société S.G.A. SERVICES S.A.;
Monsieur Vincenzo CAVALLARO, né le 18 mars 1976 à Catania (I), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.
Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire
aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
<i>Pour la société
i>DERO S.A.
Référence de publication: 2010060394/20.
(100075328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.
Finantel S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 49.316.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2010i>
Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A. Monsieur Daniel FELLER,
né le 23 mars 1956 à Bruxelles (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommé re-
présentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A. dont le siège est au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
<i>Pour la société
i>FINANTEL S.A.
Référence de publication: 2010060403/14.
(100075329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.
Vertex Commodities Sàrl, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-6677 Mertert, 2, rue Sandkaul, Centre Mercado.
R.C.S. Luxembourg B 111.306.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement du 06 mai 2010, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant sur requête de Monsieur le Procureur d'Etat, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation
conformément à l'article 203 de la loi du 10 août 1905 concernant les sociétés commerciales, de la société VERTEX
COMMODITIES S.àr.l.
Ce même jugement a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et nommé juge-
commissaire Monsieur Jean-Paul MEYER, premier juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur
Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Les déclarations de créances sont à déposer au
greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Pour Extrait conforme
Me Céline BOTTAZZO
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010076677/20.
(100070266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65954
L
U X E M B O U R G
Harsco Interamerica Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ESCO Interamerica Ltd S.à r.l.).
Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue de Volmerange.
R.C.S. Luxembourg B 150.574.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 58762 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010061107/11.
(100075686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juin 2010.
Becker & Zaccagnini, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 41, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 123.599.
L'an deux mil dix, le vingt-et-un mai,
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Attert,
Ont comparu:
1. Monsieur Jeannot BECKER, employé privé, né le 12 mars 1969 à Esch/Alzette, demeurant à L-8612 PRATZ, 42, rue
Principale,
2. Madame Olivia Maria ZACCAGNINI, employée privée, née le 16 février 1973 à Arlon, demeurant à B-6741 VANCE,
53b, rue des Gamelles,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Les parties comparantes déclarent être les associés uniques - et ce à raison de 250 parts pour chacune des deux parties
comparantes - de la société à responsabilité
Becker & Zaccagnini
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro B 123.599
constituée suivant acte de constitution de société reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 20 décembre 2006,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 19 mars 2007, numéro 402, page
19.274,
et dont le capital social est de 12.500.- euros représenté par 500 parts sociales,
Renonçant à toute formalité de convocation et déclarant avoir connaissance de l'ordre du jour, les parties comparantes
déclarent se constituer en assemblée générale extraordinaire, et ont prié le notaire instrumentant à acter les décisions
qu'elles ont prises à l'unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
Les associés décident à l'unanimité des voix de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-8510
REDANGE/ATTERT, 41 Grand Rue.
Par conséquent et afin de mettre les statuts en conformité avec cette décision, les associés décident à l'unanimité des
voix de changer l'article 5 alinéa 1
er
des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Redange/Attert".
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident à l'unanimité des voix d'augmenter le capital social de la société qui est actuellement de 12.500.-
euros à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000.-), le tout moyennant l'émission de MILLE CINQ CENT (1.500)
parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de VINGT-CINQ (25.-) euros par part sociale, ces parts sociales donnant
donnant les mêmes droits et avantages que les anciennes parts sociales.
Les parts sociales ainsi nouvellement émises sont souscrites comme suit:
Monsieur Jeannot BECKER, employé privé, né le 12 mars 1969 à Esch/Alzette, demeurant
à L-8612 PRATZ, 8, rue Principale, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 parts sociales
Madame Olivia Maria ZACCAGNINI, employée privée, née le 16 février 1973 à Arlon,
demeurant à B-6741 VANCE, 53b, rue des Gamelles, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts sociales
65955
L
U X E M B O U R G
Les MILLE CINQ CENT (1.500) parts sociales nouvellement émises ont été entièrement libérées par un versement
en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-SEPT MILLE CINQ CENT (37.500.-) EUROS se trouve dès maintenant
à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précédemment prise, les associés décident à l'unanimité
des voix de changer l'article 6 des statuts de ladite société pour lui conférer dorénavant le contenu suivant:
" Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000.-) représenté par deux mille (2.000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement souscrit et libéré.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales."
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident à l'unanimité des voix de changer l'objet social et en lui ajoutant l'activité d'architecture d'inté-
rieur, le tout conformément au nouveau texte de l'article 3 des statuts, ci-après reproduit.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précédemment prise, les associés décident à l'unanimité
des voix de changer l'article 3 des statuts de la dite société pour lui conférer dorénavant le contenu suivant:
" Art. 3. La société a pour objet la conception, la création, la visualisation et la réalisation de designs dans son acceptation
la plus large du terme sous quelques formes que se soit, ceci pour personnes privées, bureaux d'études, artisans, com-
merçants, organisations et chaque autre partie ayant besoin des services.
La société a par ailleurs comme activité l'architecture d'intérieur dans son sens le plus large.
Elle pourra avoir recours à des entreprises sous-traitantes pour les travaux qui ne correspondent pas à son objet
social, mais qui sont indispensables pour la réalisation globale dont elle dirige les travaux.
Elle pourra réaliser son objet social tant pour elle-même que pour des tiers.
Elle pourra vendre des articles de décoration et des articles d'aménagement.
La société a en outre pour objet les prestations de conseil, d'études et d'expertises liées à son objet social, notamment
en matière d'aménagement d'intérieur.
Elle a encore pour objet le conseil, l'assistance ainsi que la création de marques déposées ainsi que dans le domaine
des brevets européens.
La société a par ailleurs pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
De plus, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à condition que celle-ci ne soit pas spécialement
réglementée.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-
cières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus."
<i>Sixième résolutioni>
Les associés uniques décident de nommer gérante Madame Olivia Maria ZACCAGNINI, employée privée, née le 16
février 1973 à Arlon, demeurant à B-6741 VANCE, 53b, rue des Gamelles pour ce qui est du domaine relatif à l'archi-
tecture d'intérieur.
Pour tous les autres domaines, les pouvoirs de signature restent inchangés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent cinquante euros (950.- euros).
Toutes les parties comparantes s'obligent toutefois de façon solidaire à l'égard du notaire instrumentant en ce qui
concerne le paiement des frais relatifs aux présentes.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par son nom, prénom,
état et demeure, les parties comparantes ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Becker, Zaccagnini, Reuter.
65956
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Redange/Attert, le 25 mai 2010. Relation: RED/2010/665. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associaitons.
Redange/Attert, le 3 juin 2010.
K. REUTER.
Référence de publication: 2010065113/102.
(100079525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
Green Cross Equity S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 112.563.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2010i>
- Les démissions des gérants actuels (Monsieur Grégory Mathieu né à Huy (Belgique) le 28/10/1977; Monsieur Stéphane
Weyders né à Arlon (Belgique) le 02/01/1972 et Monsieur Romain Leroy né à Moyeuvre-Grande (France) le 23/06/1981)
sont acceptées.
- M. Geert DIRKX (né à Maaseik (Belgique) le 10/10/1970) avec adresse professionnelle au 62, avenue de la Liberté à
L-1930 Luxembourg, est nommé nouveau gérant unique de la Société en remplacement des gérants démissionnaires
susmentionnés. Son mandat viendra à l'échéance à la prochaine assemblée générale délibérant sur les états financiers du
31 décembre 2009.
- Le siège social de la Société est transféré du 22, rue Goethe à L-1637 Luxembourg au 62, avenue de la Liberté à
L-1930 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 2010.
Certifié sincère et conforme
GREEN CROSS EQUITY S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2010076667/21.
(100070537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Solum Parc Rischard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 273, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 132.913.
Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077688/10.
(100070172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Sogestaf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 153.450.
STATUTS
L'an deux mille dix, le sept juin.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Fethi BOUDOUR, agent commercial, né à Ben Gardane (Tunisie) le 8 novembre 1964, demeurant à F-57290
Fameck, 94, rue du Général Henry.
La partie comparante a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qui est ainsi constituée:
65957
L
U X E M B O U R G
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "SOGESTAF S.à r.l." (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1.L'objet de la Société est l'exploitation d'un commerce et de succursales ainsi que la gestion d'agences commerciales
dans le domaine des produits de presse, des livres, des produits alimentaires et non alimentaires, des produits de tabac
et de services divers aux clients. La Société peut notamment négocier et conclure tous contrats d'achat, de vente, de
location, de travail ou de prestation de services et tous autres contrats qui directement ou indirectement, favorisent ou
se rapportent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
3.2. La Société a également pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite
restauration.
3.3. La Société peut prendre directement ou indirectement des participations de tous genres dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet identique, semblable ou apparenté au sien ou dont la coopération avec la société est de nature
à favoriser les affaires de celle-ci. D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à
la réalisation et au développement de son objet social.
3.4. La Société peut également effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les
transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rappor-
tent à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
65958
L
U X E M B O U R G
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de n'importe quel gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en
principe, est au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature d'un gérant.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
65959
L
U X E M B O U R G
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2.Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par
la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
65960
L
U X E M B O U R G
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2010.
<i>Souscription et Libérationi>
Monsieur Fethi BOUDOUR déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500),
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à € 1.000.-.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Fethi BOUDOUR, agent commercial, né à Ben Gardane (Tunisie) le 8 novembre 1964, demeurant à F-57290
Fameck, 94, rue du Général Henry, pré-qualifié.
2. Le siège social de la Société est établi à L-4011 Esch-sur-Alzette, 35, rue de l'Alzette.
<i>Déclarationi>
Fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent
acte.
Signé: F. Boudour, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 juin 2010. Relation: EAC/2010/6723. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
65961
L
U X E M B O U R G
Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2010.
Référence de publication: 2010064998/229.
(100080516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2010.
Daulby S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 48.201.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 6 mai 2010, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société
DAULBY S.A., dont le siège social à L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été dénoncé
en date du 25 janvier 2008, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48201;
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Nathalie WEBER-FRISCH, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 mai 2010 au greffe de la sixième Chambre
de ce Tribunal.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Pour extrait conforme
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2010076678/24.
(100070208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Sabone, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 123.314.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010078318/9.
(100070245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
SBRE Neighbourhood Centre, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.129.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg concernant:
- SBRE Capmark Holdco, associé unique de la Société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2010.
<i>Pour SBRE Neighbourhood Centre
i>Signatures
Référence de publication: 2010076736/16.
(100070196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65962
L
U X E M B O U R G
SBRE West German Portfolio Luxco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.533.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg concernant:
- SBRE Capmark Holdco, associé unique de la Société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2010.
<i>Pour SBRE West German Portfolio Luxco
i>Signatures
Référence de publication: 2010076737/16.
(100070186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Phoenix Holdco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.589.
AUSZUG
Aus einem Anteilsübertragungsvertrag vom 17. Mai 2010 zwischen der SECHEP INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l.,
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 117.239, einerseits, und der CORESTATE
CAPITAL AG, einer Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 19, Dammstrasse, CH-6301 Zug,
eingetragen beim Handelsregister vom Kanton Zug unter der Nummer CH-020.3.030.000-1, andererseits, geht hervor,
dass die SECHEP INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l. mit sofortiger Wirkung 6 Anteile an der Gesellschaft, mit einem
Nennwert von je EUR 100, an die CORESTATE CAPITAL AG übertragen hat.
Die SECHEP INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l. hält demnach mit Wirkung zum 17. Mai 2010 insgesamt 119 Anteile
an der Gesellschaft, während die CORESTATE CAPITAL AG mit Wirkung zum 17. Mai 2010 insgesamt 6 Anteile an der
Gesellschaft hält.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2010078398/22.
(100070667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Trade-Match.com S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 70.639.
L'an deux mil dix, le cinq mai,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
ont comparu:
1.- La société anonyme WORLD WIDE TRADE MATCH S.A.
avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.536,
ici dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 avril 2010,
2.- Monsieur Jordi COSTA, salarié, né à Angles (Espagne), le 11 mars 1957, demeurant à MC-98000 Monaco, 11,
boulevard du Jardin Exotique;
ici dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
65963
L
U X E M B O U R G
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 avril 2010,
3.- Monsieur Jérôme KUEHN, salarié, né à Strasbourg (France), le 28 mai 1967, demeurant à F-78610 Les Bréviaires,
1, route de Vilpert,
ici dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 avril 2010,
4.- Monsieur Sébastien CRUSSOL, salarié, né à Bourges (France), le 22 mars 1971, demeurant à F-77250 Moret-sur-
Loing, 52, avenue Georges Clémenceau,
ici dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 avril 2010
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées en même temps.
Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce
qui suit:
I.- Les comparants sub 1) - 3) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TRADE-MATCH.com S.à
r.l., avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, constituée suivant acte notarié en date du
24 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 719 du 28 septembre 1999, dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié, en date du 12 septembre 2001,
publié au Mémorial C, numéro 215 du 7 février 2002, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la
section B et le numéro 70.639.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000) ayant une contre-valeur en euros
de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000) ayant une contre-valeur en euros de vingt-quatre euros
soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:
1) à la société WORLD WIDE TRADE MATCH S.A. préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
2) à Monsieur Jordi COSTA, préqualifié, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3) à Monsieur Jérôme KUEHN, préqualifié, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
III.- Les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant le
taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de
vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32)
en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de
la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominal de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.
La présente augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par les associés préqualifiés, au moyen d'un
versement en espèces, de sorte que la somme de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) se trouve dès à
présent à la disposition de la société, tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de cinq mille trois cent cinquante euros (EUR 5.350),
pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) au montant de dix-sept mille huit
cent cinquante euros (EUR 17.850) par l'émission de deux cent quatorze (214) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, majorée d'une prime d'émission de quarante-quatre mille six cent cin-
quante euros (EUR 44.650), soit une prime d'émission de deux cent huit euros et soixante-cinq cents (EUR 208,65) par
part sociale nouvellement émise de sorte que le capital social sera désormais de dix-sept mille huit cent cinquante euros
(EUR 17.850) représenté par sept cent quatorze (714) parts sociales d'une valeur nominal de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune.
65964
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription, libérationi>
La présente augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée à parts égales par l'associé actuel ci-dessous
et le nouvel associé, comparant prénommé sub 4) ci-dessus:
- la société WORLD WIDE TRADE MATCH S.A. préqualifiée, par la conversion d'une créance pour un montant de
vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) pour la souscription de cent sept (107) parts sociales nouvelles;
La réalité de la créance a été prouvée au notaire soussigné par un bilan intérimaire au 28 février 2010.
- Monsieur Sébastien CRUSSOL, préqualifié, au moyen d'un versement en espèces d'un montant total de vingt-cinq
mille euros (EUR 25.000) pour la souscription de cent sept (107) parts sociales nouvelles.
Le montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) qui se trouve dès à présent à la disposition de la société, tel qu'il
a été démontré au notaire soussigné.
Suite aux augmentations de capital ci-dessus, les parts sociales appartiennent désormais aux associés comme suit:
1) la société anonyme WORLD WIDE TRADE MATCH, S.A. avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue
Jean-Pierre Pescatore, immatriculée au RCS Luxembourg, sous le numéro B 66.536, cinq cent quatre-vingt-dix-
sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
2) Monsieur Jordi COSTA, salarié, né à Angles, (Espagne), le 11 mars 1957, demeurant à MC-98000 Monaco,
11, boulevard du Jardin Exotique, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3) Monsieur Jérôme KUEHN, salarié, né à Strasbourg (France), le 28 mai 1967, demeurant à F-78610
Les Bréviaires, 1, route de Vilpert, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4) Monsieur Sébastien CRUSSOL, salarié, né à Bourges (France), le 22 mars 1971, demeurant à F-77250
Moret-sur-Loing, 52, avenue Georges Clémenceau, cent sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Total: sept cent quatorze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les augmentations de capital qui précèdent, les associés décident de
modifier l'article 6 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à dix-sept mille huit cent cinquante euros (EUR 17.850) représenté par sept cent
quatorze (714) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune. Chaque part sociale donne
droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 2 des statuts de la société relatif à son objet social pour lui donner désormais
la teneur suivante:
" Art. 3. La Société a pour objet d'effectuer la gestion, le développement de licences dans le domaine des logiciels et
des procédés et produits électroniques sur Internet ainsi que leur promotion et leur commercialisation. La Société a
également pour objet la fourniture de services à valeur ajoutée tels que le marketing et le web marketing, l'intermédiation,
le négoce ou l'organisation et la coordination d'événements, ainsi que l'exercice d'activités ou la conclusion d'accords
permettant de réaliser, de protéger ou de tirer avantage du potentiel de ces logiciels, produits ou services.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rap-
portant à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies et prendre des participations dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant
un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise."
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ mille huit cents euros (EUR 1.800).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé ensemble avec
le notaire le présent acte.
Signé: F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2010. LAC/2010/21426. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2010.
J. BADEN.
Référence de publication: 2010065286/124.
(100079897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
65965
L
U X E M B O U R G
SBRE Capmark Holdco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.954.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg concernant:
- SBRE Luxco, associé unique de la Société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch, L-1030
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2010.
<i>Pour SBRE Capmark Holdco
i>Signatures
Référence de publication: 2010076738/16.
(100070188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
EAVF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 118.851.
EXTRAIT
En date du 9 avril 2010, la société EAVF LP, en tant qu'associé unique de EAVF S.à r.l., a approuvé de renouveler le
mandat de:
- Pascal Aujoux
- Jean-Louis Camuzat
- lan Chappell
- Laurent Jacquemin
- Michael Kidd
- Alessio Lucentini
dans leur fonction de gérants de la Société avec effet au 01.01.2010 pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAVF S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2010078422/20.
(100070116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
SBRE Waren, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.124.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg concernant:
- SBRE Capmark Holdco, associé unique de la Société, dont le siège social est désormais situé au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2010.
<i>Pour SBRE Waren
i>Signatures
Référence de publication: 2010076739/16.
(100070191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65966
L
U X E M B O U R G
EuroRidge Solar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 153.134.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the thirteenth day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1.- SOLAR CAL, L.L.C., a Delaware limited liability company, with registered office in 32 W Loockerman Street, Dover,
Delaware 19904, United States of America,
2.- Mr. Jean-Marie Rochefort, residing in Switzerland, 1 Chemin de Varney, 1299 Crans-Près-Céligny,
3.- Mr. Michel Palandjian, residing in Finland, Pursimiehenkatu 27B5, 00150 Helsinki,
all here represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, with professional address in L- 1319 Luxembourg,
101, rue Cents, by virtue of three proxies, given on March 17 ,2010 respectively on 8 April 2010.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as well as by
the present articles (hereafter the "Company").
Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and
development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of
sale, exchange or otherwise.
The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, development, as well
as the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those participations, aimed at the photovoltaic business which includes establishing and operating
business activities based on photovoltaic power in the downstream market, and investing in- or incorporating of companies
with similar purposes.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, real estate operation, including any ope-
ration related to the photovoltaic downstream industry, which is directly or indirectly connected with its corporate
purpose or which may favor its development
The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or
shareholder's loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any
support, loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form
of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription or by
any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name EuroRidge Solar Holding S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
65967
L
U X E M B O U R G
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) repre-
sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision by partner(s) representing two thirds (2/3) of the capital
or by the decision of the shareholders meeting with two thirds (2/3) majority in accordance with article 14 of these
articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than fifty per cent
(50%) of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
signature of any two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub
delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. A manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be
deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in
minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the chairman of the board of managers.
Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolution and signed by each and every manager. The date of
such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such
circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended.
65968
L
U X E M B O U R G
Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners
or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
1.- SOLAR CAL, L.L.C., three hundred (300) shares
2.- Mr. Jean-Marie Rochefort, one hundred fifty shares (150)
3.- Mr. Michel Palandjian, fifty (50) shares
TOTAL: five hundred (500) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum Twelve Thousand Five Hundred euros (€
12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December, 2010.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1) The number of managers is set at one. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period
of time:
Mrs. Géraldine SCHMIT, born on 12
th
November 1969 in Messancy (Belgium), residing professionally 67, rue Erme-
sinde, L- 1469 Luxembourg.
2) The registered office is established in L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg-Ville, Luxembourg, on the years and day first above
written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille dix, le treize avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg
ONT COMPARU:
1.- SOLAR CAL, L.L.C., une limited liability company du Delaware, ayant son siège social au 32 W. Loockerman Street,
Dover, Delaware 19904, Etats-Unis d'Amérique,
2.- Monsieur Jean-Marie Rochefort, ayant son adresse 1 Chemin de Varney, 1299 Crans-Près-Céligny, Suisse,
3.- Monsieur Michel Palandjian, ayant son adresse Pursimiehenkatu 27B5, 00150 Helsinki, Finlande,
65969
L
U X E M B O U R G
tous ici représentés par Madame Solange Wolter-Schieres, emplyée privée, avec adresse professionnelle à L-1319
Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu de trois procurations données le 17 mars 2010 respectivement le 8 avril 2010.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par
la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute
autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la
mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de
vente, échange ou autrement.
La Société peut effectuer toutes les transactions appartenant directement ou indirectement à l'acquisition, le déve-
loppement, et l'acquisition de participations quelle que soit la forme et l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations orientées vers le domaine photovoltaïque, y compris établir et exploiter des activités
liées au domaine photovoltaïque, y compris la l'investissement dans et la création de sociétés ayant un objet social similaire.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels
et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société peut effectuer n'importe quelle opération commerciale, industrielle, financière, personnelle, immobilière, y
compris n'importe quelle opération liée à l'industrie photovoltaïque, qui est directement ou indirectement connecté avec
son but d'entreprise ou qui peut favoriser son développement.
La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non
un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre
forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription
ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats
d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de EuroRidge Solar Holding S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) euros chacune.
Art. 7. Le capital social pourra être modifié à tout moment moyennant une décision des associés représentant deux
tiers (2/3) du capital social ou moyennant une décision de l'assemblée des actionnaires avec deux tiers (2/3) de la majorité,
conformément à l'article 14 des présents statuts
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
65970
L
U X E M B O U R G
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil
de Gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50
%) du capital social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature conjointe de deux membres quelconques du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses
membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le
cadre des compétences du Conseil de gérance.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen de communication permettant tous les Gérants de prendre part à la réunion en
entendant les autres gérants. La participation par un gérant à une réunion du Conseil de Gérance par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion.
Les décisions du Conseil de Gérance seront enregistrées dans des minutes qui seront conservées au siège social de la
Société et signées du président du Conseil de Gérance. Le cas échéant, les procurations seront attachées aux minutes
de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du Conseil de Gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
65971
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par:
1.- SOLAR CAL, L.L.C., trois cents (300) parts sociales
2.- Monsieur Jean-Marie Rochefort, cent cinquante (150) parts sociales
3.- Monsieur Michel Palandjian, cinquante (50) parts sociales
Total: cinq cents (500) parts sociales
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de Douze Mille Cinq
Cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2010.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200,-
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit
a pris les résolutions suivantes:
1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de un. Est nommée membre du conseil de gérance pour une
durée indéterminée:
- Madame Géraldine SCHMIT, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique),
résidant professionnellement à L- 1469 Luxembourg, 67 rue Ermesinde.
2. Le siège social de la société est établi à 67, rue Ermesinde, L- 1469 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: SCHIERES - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 avril 2010. Relation: LAC/2010/17587. Reçu soixante-quinze euro 75,00
EUR
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
-POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.-
Luxembourg, le vingt mai de l'an deux mille dix.
Henri HELLINCKX.
Référence de publication: 2010078477/308.
(100070922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Blamar S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 62.980.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 avril 2010 à 15.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant qu'Administrateur:
Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig
- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de:
Koen LOZIE, 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert
COSAFIN S.A., 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
représentée par Monsieur Jacques BORDET, 10, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant que Commissaire aux Comptes:
THE CLOVER, 8, rue Haute, L-4963 Clémency
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.
65972
L
U X E M B O U R G
Pour copie conforme
K. LOZIE / COSAFIN S.A.
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010076760/21.
(100070348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Business Investor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 55.513.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 avril 2010 à 15.30 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutions:i>
- L'Assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Koen Lozie, 61 Grand-Rue, L-8510
Redange-sur-Attert, Jérôme Vigneron et de nommer Monsieur Joseph WINANDY , 92, rue de l'horizon, L-5960 ITZIG,
au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean QUINTUS.
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels arrêtés au 30.11.2010.
- L'Assemblée décide de renouveler la société Fiduciaire HRT en tant que Commissaire aux comptes. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30.11.2010.
Pour Extrait Conforme
Signatures
Référence de publication: 2010076761/18.
(100070355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Caravaggio Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 99.092.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
CARAVAGGIO SICAV
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010077656/15.
(100070041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Finagra S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 24.500.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16 septembre 2009 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de reconduire les mandats d'Administrateur de M. Jean Quintus, 11, rue
Fischbach, 7391 Blaschette, M. Joseph Winandy, 92, rue de l'Horizon, 5960 Itzig et de la société COSAFIN S.A., 23, avenue
de la Porte-Neuve, 2227 Luxembourg, représentée par M. Jacques Bordet, 10, boulevard Royal, 2449 Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui examinera les comptes clôturés au 30
juin 2010.
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de V.O. Consulting Lux. S.A., 8, rue Haute, L-4963
Clémency en tant que Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale
qui examinera les comptes clôturés au 30 juin 2010.
65973
L
U X E M B O U R G
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010078395/19.
(100070364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Arten, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 90.288.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ARTEN SICAV
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010077658/14.
(100070039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Donatello Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 106.552.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DONATELLO SICAV
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010077659/14.
(100070037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
NATIXIS Luxembourg Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 107.132.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société à Luxembourg le 19 mai 2010:i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 19 mai 2010 qu'il
a été décidé de:
1. révoquer le mandat de délégué à la gestion journalière de la Société de Monsieur Alain DEVRESSE;
2. élire en tant que délégué à la gestion journalière de la Société Monsieur Vincent Goy, né le 16 juin 1955 à Dudelange,
et résidant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2010.
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2010078400/17.
(100070610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65974
L
U X E M B O U R G
MezzVest Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 78.731.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
MezzVest Luxembourg I S.à r.l.
Robert van 't Hoeft
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010077661/14.
(100070035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Marc Lefèbvre, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 147.599.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010078352/9.
(100070264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
MezzVest Luxembourg II S. à r.l ., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 110.227.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
MezzVest Luxembourg II S.à r.l.
Robert van 't Hoeft
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010077663/14.
(100070034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Dockland Development S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en
Capital à Risque.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 131.573.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 17 mai 2010i>
A/ L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivants, jusqu'à
l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010:
- Mr Janis Leimanis, ayant son adresse professionnelle au Valnu Street 4-5, Riga, LV-1050, Latvia;
- Mr Edgars Leimanis, ayant son adresse professionnelle au 3-1A, Zala iela, Riga, Latvia;
- Mr Michael Lange, ayant son adresse professionnelle au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
B/ De plus, l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de ne pas reconduire le mandat d'Ernst & Young Luxem-
bourg en tant que réviseur d'entreprises.
C/ L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer en tant que réviseur d'entreprises, BDO Audit S.A.,
ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les
comptes annuels de la société au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
65975
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 19 mai 2010.
<i>Pour Dockland Development S.A., SICAR
i>S G G S.A.
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
<i>Un mandataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010078571/26.
(100071126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Marwil Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 60.590.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Marwil Luxembourg I S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2010077667/15.
(100070033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
3W Power Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.423.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the seventh day of May,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of shareholders of 3W Power Holdings Limited, a company incorporated
under the laws of Guernsey, with registered office at Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter Port, Guernsey,
registered with the trade register of Guernsey under number 48933.
The meeting is opened at 11.00 a.m. with Mr Michael Julian, General Counsel AEG Power Solutions, residing profes-
sionally in Paris, in the chair,
who appoints as secretary Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Jeanne Laurent, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Following the decision of the shareholders of the Company on 9 April 2010 to transfer the registered office of the
Company to Luxembourg, ratification of the transfer of the place of the registered office and the principal place of business
(principal établissement) of the Company from Guernsey to Luxembourg and change of the nationality of the Company;
2. Adoption of the form of société anonyme for the purposes of Luxembourg law;
3. Change of the name of the Company into 3W Power Holdings S.A.;
4. Determination of the share capital of the Company by conversion of EUR 12,520,006.- share premium into the share
capital of the Company and conversion of the shares;
5. Confirmation of the valuation report of the independent auditor, all the assets and all the liabilities of the Company,
without limitation, remaining the ownership in their entirety of the Company by universal transfer of law (transfert
d'universalité) and acknowledgement of the share capital of the Company;
6. Adoption of the interim closing balance sheets of the Company;
7. Adoption of the opening balance sheet and the accounts of the Company;
8. Confirmation of the mandates of the members of the current board of directors;
9. Appointment of the independent auditor;
65976
L
U X E M B O U R G
10. Registered office and address of the Company;
11. Complete restatement of the Company's articles of incorporation;
12. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance
list, signed by the shareholders and by the board of the general meeting, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled
ne varietur by the persons appearing.
III. - That 31,127,752 shares, out of a total number of 50,236,024 shares are being present or represented at the present
general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowl-
edge of the agenda prior to this general meeting.
IV. - That all shares being registered shares, this extraordinary general meeting of shareholders has been convened by
registered letter sent to all shareholders on 13 April 2010.
V. - The convening notice has also been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in the
Tageblatt twice with an eight days interval at least and 8 days at least prior to the extraordinary general meeting of
shareholders i.e. on 15 April 2010 and 26 April 2010, in accordance with the provisions of article 70 of the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended.
VI. - That the convening notice has also been published in accordance with the rules of the stock exchange and the
provisions of directive 2004/109/EC as implemented in Luxembourg.
VII. - That the present general meeting, representing 61.96 % of the share capital, is regularly constituted and may
validly deliberate on the items of the agenda.
Then, after deliberation, the general meeting of shareholders takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to ratify the transfer of the registered office and the principal place of
business (principal établissement) of the Company from Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter Port, Guernsey
to Luxembourg and to adopt the Luxembourg nationality, in accordance with the decision of the shareholders of the
Company of 9 April 2010 by which it was resolved that the Company be deregistered in Guernsey and registered by way
of continuation under the laws of Luxembourg.
The general meeting of shareholders acknowledges that the Company will thus as of the date of the present meeting,
be subject to Luxembourg law, according to article 159 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies,
as amended, except, as the case may be, where Guernsey law remains applicable, until the Company has been fully de-
registered in Guernsey. As a consequence of the foregoing, the general meeting of shareholders further resolves to grant
special powers to Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg, acting with full power of
substitution, to sign, any documents, agreements, certificates and register inscriptions which may be deemed useful within
the scope of the present general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders acknowledges that as a result of the transfer of the registered office and the
principal place of business (principal établissement) of the Company from Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter
Port, Guernsey to Luxembourg and to adopt the Luxembourg nationality, the home member state of the Company for
the purpose of the law of 11 January 2008 on transparency requirements in relation to information about issuers whose
securities are admitted to trading on a regulated market shall be Luxembourg.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves that the Company adopts the legal form of a société anonyme in ac-
cordance with articles 23 sqq of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to change the name of the Company from "3W Power Holdings Limited"
into "3W Power Holdings S.A.".
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to set the share capital of the Company at EUR 12,520,006.- by con-
version of an amount of EUR 12,520,006.-from the share premium account to the share capital account of the Company.
The share capital of the Company will be fixed at twelve million five hundred twenty thousand and six euro (EUR
12,520,006) divided into thirty-nine million three hundred eighty-one thousand five hundred fifty-eight (39,381,558) shares
and ten million eight hundred fifty four thousand four hundred sixty-six (10,854,466) B shares (together being referred
to as "Shares") without indication of a nominal value.
65977
L
U X E M B O U R G
The general meeting further acknowledges the report established on 5 May 2010 by the board of directors in relation
to the creation of an authorised share capital and resolves to create an authorised share capital, including the issued share
capital, of thirty-seven million five hundred sixty thousand eighteen euro (EUR 37,560,018) consisting of one hundred and
fifty million two hundred forty thousand and seventy-two (150,240,072) shares without indication of a nominal value.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders approves the report dated 7 May 2010, established by Inter-Audit S.à r.l., a société
à responsabilité limitée, having its registered office in 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 29.501, in its function as independent auditor.
It results from the report established on 7 May 2010 by Inter-Audit S.à r.l., that the net value of the assets of the
Company is at least equal to the share capital.
The conclusion of this report is the following:
"Based on the verification carried out as described above, we express no observation on the value of the transferred
assets and liabilities which corresponds at least to the number and accounting value of the 39,381,558 shares and
10,854,466 B shares to be issued as consideration, representing a share capital of EUR 12.520.006.".
The report will remain attached to the present deed to be registered therewith.
The general meeting of shareholders acknowledges that the share capital of the Company amounts to twelve million
five hundred twenty thousand and six euro (EUR 12,520,006) represented by fifty million two hundred thirty-six thousand
twenty-four (50,236,024) Shares consisting of thirty-nine million three hundred eighty-one thousand five hundred fifty-
eight (39,381,558) shares and ten million eight hundred fifty-four thousand four hundred sixty-six (10,854,466) B shares,
without indication of a nominal value, as it has been justified to the undersigned notary by an opening balance sheet of
the Company.
The general meeting of shareholders acknowledges that thirty million eight hundred six thousand four hundred eighty-
seven (30,806,487) warrants have been issued by the Company.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to approve the interim closing balance sheets of the Company as pre-
pared by the board of directors of the Company. A copy will remain attached to the present deed to be registered
therewith.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders approves the opening balance sheet and the accounts of the Company as prepared
by the board of directors of the Company. A copy will remain attached to the present deed to be registered therewith.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to confirm and to appoint the 8 directors (administrateurs) of Company
who currently are:
Mr Keith Baden Corbin, Director, born on 18 August 1952 in Guernsey, Channel Islands, residing professionally in 19,
rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Roland Berger, Director, born on 22 November 1937 in Berlin - Koepenick, Germany, residing professionally in
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Bruce Alton Brock, Director, born on 26 April 1943 in Minneapolis, Minnesota, United States of America, residing
professionally in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Robert John Huljak, Director, born on 10 March 1947 in Milwaukee, Wisconsin, United States of America, residing
professionally in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Timothy Clark Collins, Director, born on 8 October 1956 in Frankfort, Kentucky, United States of America, residing
professionally in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Mark Matthias Wolfgang Wössner, Director, born on 14 October 1938 in Berlin-Charlottenburg, Germany, re-
siding professionally in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Leonhard Heinrich Fischer, Director, born on 6 January 1963 in Nordhorn, Germany, residing professionally in 19,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Mr Thomas Middelhoff, Director, born on 11 May 1963 in Düsseldorf, Germany, residing professionally in 19, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
for a period to expire at the annual general meeting of shareholders to be held on 1 June 2011.
65978
L
U X E M B O U R G
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to appoint KPMG Audit having its registered office at 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 103.590, as
independent auditor of the Company.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Tenth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to set the address of the Company at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg.
This resolution has been adopted by a majority of 31,124,960 votes in favour and 0 against, 2,792 votes abstained.
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to proceed to a complete restatement of the articles of incorporation
and decides that the articles of incorporation of the Company shall now read as follows:
"A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of "3W Power Holdings
S.A." (the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of incorporation.
Art. 3. Purpose. The Company's purpose is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, entering into leases, dealing
in commodities that are not securities, acquisition of assets generally, selling assets generally, giving security, giving and
receiving indemnities and security.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises, including trusts and unincorporated associations, and may render any assistance by way of loans, guarantees,
security or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or parent companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, preferred equity certificates, debentures,
notes, commercial paper, guarantees, and entering into of credit agreements, note purchase agreements, underwriting
agreements, indentures, trust agreements or any other type of financing instrument or document or any hedge, swap or
derivative related thereto.
In general, the Company may carry on any business or activity whatsoever, which it may consider expedient with a
view to rendering profitable or enhancing directly or indirectly the value of the Company's undertaking in any of its
properties or assets.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
directors.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of directors.
B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
5.1.1 The Company's issued share capital is set at twelve million five hundred twenty thousand and six euro (EUR
12,520,006), consisting of thirty-nine million three hundred eighty-one thousand five hundred fifty-eight (39,381,558)
shares and ten million eight hundred fifty-four thousand four hundred sixty-six (10,854,466) B shares (together being
referred to as "Shares") without indication of a nominal value.
5.1.2 Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the board of
directors in article 5.2 of these articles of incorporation ("Authorised share capital"), the Company's issued share capital
may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of incorporation.
65979
L
U X E M B O U R G
5.1.3 Any new Shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of
plurality of shareholders, such Shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of Shares held by
them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject to the
terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an increase
of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorisation to be granted to the board of directors to increase
the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder
(s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of incorporation.
5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of incorporation.
5.2 Authorised share capital
5.2.1 The Company's authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at thirty-seven million five
hundred sixty thousand eighteen euro (EUR 37,560,018) consisting of one hundred and fifty million two hundred forty
thousand and seventy-two (150,240,072) Shares without indication of a nominal value.
5.2.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of incorporation or, as the
case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article
5.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the
board of directors be and is hereby authorised (i) to issue Shares, (ii) to issue new Shares following, as the case may be,
the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the board of directors within the limits of the
authorised capital under the terms and conditions of the warrants as from time to time issued by the Company against
payment in cash or in kind, by conversion of claims against the Company or in any other manner, (iii) to grant options to
subscribe for Shares and to issue any other instruments convertible into Shares, within the limit of the authorised share
capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or
limiting the existing shareholder's/shareholders' preferential right to subscribe for the new Shares to be issued.
5.2.3 This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation, each time for a period not exceeding
five (5) years.
5.2.4 The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares and B shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders.
6.3 A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of Shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
6.5 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its
own Shares.
6.6 The Company's Shares are in registered form only.
6.7 The Company may issue warrants which shall entitle the holder (the "Warrantholder") to subscribe for the Shares
specified in it. The board of directors may determine and vary the conditions upon which the warrants shall be issued.
The Warrantholder shall be subject to the terms and conditions for the time being in force in respect of the warrants
whether made before or after the issue of such warrant.
Art. 7. Rights attaching to each class of shares.
7.1 Each class of Shares shall have the same rights save as provided for in this article 7.
7.2 The holders of the class B shares will automatically have the same rights as the holders of the shares as of 10
September 2010 (the "Expiry Date")
7.3 Before the Expiry Date stated in article 7.2, the holders of the class B shares shall have the following rights which
shall rank pari passu with the Company's shares in issue from time to time:
7.3.1 to vote at any meeting of the shareholders (or by written resolution) together with other shareholders as a single
class, save to the extent that any action to be taken at the meeting (or by a written resolution) entitles the holders of
the class B shares to rely upon and apply the provisions in article 7.4 of the articles of incorporation;
7.3.2 to share equally with the other shareholders in respect of any dividends or liquidation or other distributions
declared or made in respect of the Shares;
7.3.3 class B shares shall be subject to transfer restrictions to the effect that the Company shall not register any transfer
of any class B share, nor recognise any disposal of any beneficial interest in such share, nor give effect to any charge or
encumbrance created over such share, except (aa) that such share may be transferred by the holder thereof to its affiliates
65980
L
U X E M B O U R G
or their respective partners, members, shareholders, affiliates and beneficial owners, provided, however, that in any such
case, any such share held by such transferee is subject to the provisions of this paragraph, or (bb) with the consent of
the Company at the absolute discretion of the board of directors (excluding those directors who were directors of AEG
Power Solutions B.V. prior to the acquisition by the Company of AEG Power Solutions B.V.) and it is noted that this
restriction (to the extent not applicable to shares generally) shall cease to have any effect immediately on the Expiry Day;
7.3.4 if, prior to the Expiry Date the shares have been increased, decreased, changed into or exchanged for a different
number of Shares of different class, in each case, by reason of any reclassification, recapitalization, stock split, split-up,
combination or exchange of Shares, or any similar event occurs, and if, for any reason the number of class B shares has
not proportionately increased as a result of such event or action, the board of directors is entitled to authorise the
allotment and issue of such number of class B shares within the authorised share capital of the Company as shall be
necessary to maintain the relevant percentage interest in the Company; and
7.3.5 following the Expiry Date the class B shares shall be considered as freely transferable and listed on some exchange
where the Company's shares are listed.
7.4 Where the share capital of the Company is divided into shares and class B shares, resolutions of the shareholders
which would affect, alter, modify, commute, abrogate the rights, privileges or conditions for the time being attached to
any class or group, shall be validly adopted in the presence of two-thirds of the shareholders of each class of Shares at
such meeting of shareholders and by a majority of two-thirds of the votes for each class of Shares.
7.5 Following the expiry of the restrictions stated above on class B shares, the next ordinary or extraordinary general
meeting of shareholders shall be held in front of a notary for the purpose of amending the articles of incorporation of
the Company and to reflect the amendments to the classes of Shares which have occurred upon the Expiry Date.
Art. 8. Register of Shares and Warrants.
8.1 A register of Shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register of Shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or
registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, the indication of the payments made on
the Shares, any transfer of Shares and the dates thereof pursuant to article 9 of these articles of incorporation as well as
any security rights granted on Shares.
8.2 A register of warrants will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by
any Warrantholder. This register of warrants will in particular contain the name of each warrantholder, his/her/its resi-
dence or registered or principal office, the number of warrants held by such Warrantholder, the indication of the payments
made on the warrants, any transfer of warrants and the dates thereof as well as any security rights granted on warrants.
8.3 Shareholders and Warrantholders shall provide the Company with an address to which all notices and announce-
ments should be sent. Such address will also be entered into the register of Shares or the warrants register.
8.4 In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to
be entered into the register of Shares or the register of warrants and the shareholder's or Warrantholder's address will
be deemed to be at the registered office of the Company or at such other address as may be entered into the register
by the Company from time to time until another address shall be provided to the Company by such shareholder or
Warrantholder. A shareholder or Warrantholder may, at any time, change his address as entered into the register of
Shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be
determined by the Company from time to time.
Art. 9. Ownership and transfer of Shares.
9.1 Ownership of Shares will be established through the recording of a shareholder in the register of Shares. Certificates
of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, or by any two of its members
upon request and at the expense of the relevant shareholder.
9.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of such Share in relation to the Company. The Company
is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a Share held by several owners until one owner has been
designated.
9.3 The Shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law and to the provisions set out in
article 7 of these articles of incorporation.
9.4 Any transfer of registered Shares will become effective towards the Company and the parties either through the
recording of a declaration of transfer into the register of Shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company,
pursuant to which any member of the board of directors may record such transfer in the register of Shares.
9.5 The Company, through any of the members of the board of directors may also accept and enter into the register
of Shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's
and the transferee's consent.
65981
L
U X E M B O U R G
C. General meeting of shareholders
Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.
10.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one
of the Company's corporate bodies.
10.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of incorporation, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of incor-
poration is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".
10.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of incorporation.
Art. 11. Convening general meetings of shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors to
be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.
11.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors, as the case may be, upon
request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors, by one or several shareholders representing
in the aggregate at least three percent (3%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of
shareholders must be convened by the board of directors, in order to be held within a period of one (1) month from
receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.
11.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered
office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the fifteenth day of April at
12 a.m. noon. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following
business day. The board of directors, as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within
a period of four (4) months from the end of the Company's financial year.
11.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least fifteen (15)
days prior to the date scheduled for the meeting.
11.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least three per cent (3%) of the Company's issued
share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date
scheduled for the meeting.
11.6 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.
12.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
12.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
12.3 Quorum
No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise
required by law or by these articles of incorporation.
12.4 Vote
12.4.1 Each Share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of law.
12.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of
capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.
12.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication prior to the meeting, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may
represent several or even all shareholders.The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the
appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a company under its common seal or under
the hand of an officer or attorney duly authorised or in the case of shares held in a European central securities depository,
a statement of the relevant participant. In the case of shares registered in the name of a European central securities
depository or an affiliated institution, a shareholder may submit a written declaration via its participant or affiliated
institution which shall constitute an instruction appointing a proxy from the relevant registered shareholder confirming
that the number of shares mentioned in each written declaration form part of a collective deposit and that the person
65982
L
U X E M B O U R G
mentioned in the declaration is a participant for the mentioned number of shares in the collective deposit and shall be
entitled to exercise all rights attached to those shares and voting rights as a proxy in respect of such shares at the relevant
general meeting of shareholders of the Company provided further that such participant shall be entitled to delegate his
proxy to a third party by delivering such form of proxy executed in writing in accordance with the present articles of
incorporation.
12.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
12.7 Each shareholder may vote through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail, electronic voting
or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for
each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain
from voting thereon by marking the appropriate box with a cross or an electronic cross. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
12.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 13. Amendment of the articles of incorporation. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of
two-thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or
represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly
cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes
will not be taken into account.
Art. 14. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the law, the board of
directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened
in order to resolve on an amendment of the articles of incorporation, to four (4) weeks. The board of directors must
adjourn any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders repre-
senting in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of
a general meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.
Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.
15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
15.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
15.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two
of its members or by the person exercising solely the powers of the board of directors, as the case may be.
D. Management
Art. 16. Powers of the board of directors.
16.1 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the
Company's corporate purpose, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of incorporation
to the general meeting of shareholders.
16.2 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, the
Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be
delegated to an executive director or other committee or committees whether formed from among its own members
or not, or to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone
or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
16.3 The board of directors may create from time to time one or several committees composed of board members
and/or external persons and to which it may delegate powers and roles as appropriate. The committees shall operate in
accordance with the Regulations as defined in accordance with article 23.2 of these articles of incorporation. In any event,
the board of directors shall create a Compensation Committee and an Audit Committee.
Art. 17. Composition of the board of directors.
17.1 The board of directors is composed of four (4) members at least, their number being determined by the general
meeting of shareholders. Directors need not be shareholders.
17.2 The board of directors shall be composed of executive directors and non-executive directors to be determined
by the general meeting of shareholders. In any case, the director in charge of the daily management of the Company shall
65983
L
U X E M B O U R G
be an executive director and shall be appointed as chief executive officer ("CEO") of the Company by a decision of the
board of directors.
17.3 The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors which shall
be a non-executive director. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the
board of directors.
Art. 18. Election and removal of members of the board of directors and term of the office.
18.1 The members of the board of directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall
determine their remuneration and term of the office.
18.2 If a legal entity is elected member of the board of directors of the Company, such legal entity must designate an
individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity.
The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An
individual may only be a permanent representative of one (1) member of the board of directors and may not be a member
of the board of directors at the same time.
18.3 Any member of the board of directors may be removed at any time, without notice and without cause by the
general meeting of shareholders.
18.4 The term of the office of a member of the board of directors may not exceed six (6) years and any member of
the board of directors shall hold office until its/his/her successor is elected. Any member of the board of directors may
also be re-elected for successive terms.
Art. 19. Vacancy in the office of a member of the board of directors.
19.1 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,
retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by cooptation by the remaining board
members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed
suitable.
19.2 If, in case of plurality of shareholders or in case, the number of members of the board of directors falls below
four (4) or below such higher minimum set by these articles of incorporation, as the case may be, such vacancy must be
filled without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board
members until the next general meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment.
19.3 In case the vacancy occurs in the office of the person exercising solely the functions of the board of directors,
such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of directors.
20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to its members twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of commu-
nication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in
the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each member of the board of directors in writing
by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all
members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of
resolutions in writing pursuant to these articles of incorporation.
Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.
21.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meetings of the board of directors. In his/her/its absence,
the board of directors may appoint another member of the board of directors as chairman pro tempore.
21.2 Quorum
The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of directors.
21.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a simple majority of the members present or represented at a meeting
of the board of directors. The chairman shall not have a casting vote.
21.4 Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing any other
member as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication prior
to the meeting, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any member of the board of directors may
represent one or several of his/her/its colleagues.
21.5 Any member of the board of directors who participates in a meeting of the board of directors by conference-
call, video-conference or by any other means of communication which allows such member's identification and which
allows that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate
65984
L
U X E M B O U R G
in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors
held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
21.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all members of the board of directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature
sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document
showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving
evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
21.7 Save as otherwise provided by law, any member of the board of directors who has, directly or indirectly, a
proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Com-
pany's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration
recorded in the minutes of the board meeting. The relevant member of the board of directors may not take part in the
discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next
general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item.
Art. 22. Minutes of meetings of the board of directors.
22.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board
of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
22.2 The person exercising solely the powers of the board of directors, as the case may be, shall also draw and sign
minutes of his/her/its resolutions.
22.3 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the person
exercising solely the powers of the board of directors, as the case may be.
Art. 23. Dealings with third parties.
23.1 The Company will be bound towards third parties in all circumstances by by the joint signatures of any two
members of the board of directors. Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third
parties by the single signature of the duly appointed CEO of the Company or by the signature of any person(s) to whom
such power in relation to the daily management of the Company has been delegated in accordance with the rules of such
delegation.
23.2 The board of directors will operate in accordance with its internal regulations (the "Regulations") which shall be
binding upon all organs of the Company.
D. Supervision
Art. 24. Independent auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by an independent auditor. The
independent auditor shall be chose amongst the "réviseurs d'entreprises agréés" or "cabinets de revision agréés" ac-
credited by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) and shall be appointed by the general meeting
of shareholders, which determines the term of his/her/their office.
E. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 25. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 26. Profits.
26.1 From the Company's annual net profits at least five per cent (5%) shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.
26.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
26.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.
26.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general
meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of incorporation.
Art. 27. Interim dividends - Share premium.
27.1 Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim
dividends.
27.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)
or of the board of directors, subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal
reserve.
65985
L
U X E M B O U R G
F. Liquidation
Art. 28. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
G. Governing law
Art. 29. Governing law. These articles of incorporation shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended."
<i>Transitional provisionsi>
The first annual general meeting of shareholders shall be held on 1 June 2010.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in article 26 of
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, and expressly states that they have all been
complied with.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be eight thousand five hundred euro (EUR
8,500).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, 14, rue Erasme, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed, together with the notary,
this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzehn, den siebten Mai,
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wird eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der 3W Power Holdings Limited abgehalten, einer
Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Guernsey, mit Sitz in Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter Port,
Guernsey, eingetragen im Handelsregister von Guernsey unter der Nummer 48933.
Die Generalversammlung wurde um 11.00 Uhr eröffnet, unter dem Vorsitz von Herrn Michael Julian, General Counsel
AEG Power Solutions, geschäftsansässig in Paris,
welcher Herrn Max Kremer, licencié en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer berufen hat.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Jeanne Laurent, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg.
Sodann die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeich-
neten Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:
I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung zu befinden hat über folgende
<i>Tagesordnung:i>
1. Aufgrund der Entscheidung der Aktionäre der Gesellschaft vom 9. April 2010, den Sitz der Gesellschaft nach Lu-
xemburg zu verlegen, Ratifizierung der Verlegung des Gesellschaftssitzes und des Hauptgeschäftssitzes (principal établis-
sement) der Gesellschaft von Guernsey nach Luxemburg und Änderung der Nationalität der Gesellschaft;
2. Annahme der Gesellschaftsform einer Aktiengesellschaft (société anonyme) aus Gründen des Luxemburger Rechts;
3. Änderung des Gesellschaftsnamens in 3W Power Holdings S.A.;
4. Festsetzung des Gesellschaftskapitals durch Umwandlung von zwölf Millionen fünfhundertzwanzigtausendundsechs
Euro (EUR 12.520.006,-) Ausgabeaufgeld (share premium) in Gesellschaftskapital und Umwandlung der Aktien;
5. Bestätigung des Wertgutachtens des unabhängigen Wirtschaftsprüfers, dass alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft
im Falle eines universellen (transfert d'universalité) Rechtstransfers ohne Ausnahme im Eigentum der Gesellschaft ver-
bleiben und Bestätigung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft;
6. Annahme der Zwischenbilanzzahlen der Gesellschaft;
7. Annahme der Eröffnungsbilanz und der Konten der Gesellschaft;
8. Bestätigung des Mandats der Mitglieder des gegenwärtigen Verwaltungsrats;
65986
L
U X E M B O U R G
9. Ernennung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers;
10. Sitz und Adresse der Gesellschaft;
11. Vollständige Neufassung der Gesellschaftssatzung;
12. Verschiedenes.
II. Dass die anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheits-
liste eingetragen sind; diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären sowie vom Versammlungsvorstand
unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur unterschrieben wurden bleiben ebenfalls gegenwärtiger
Urkunde beigefügt.
III. Dass 31.127.752 Aktien von insgesamt 50.236.024 Aktien in der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend
oder vertreten sind und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie rechtzeitig benachrichtigt
wurden und vorab Kenntnis von der Tagesordnung der Generalversammlung erlangt haben.
IV. Dass, da alle Aktien Namensaktien sind, die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre per Einschrei-
bebrief vom 13. April 2010 an alle Aktionäre einberufen worden ist.
V. Die Einberufungsnachricht wurde auch im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und im Tageblatt zwei-
mal mit einem Zeitabstand von mindestens acht Tagen und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung der
Aktionäre d.h. am 15. April 2010 und am 26. April 2010, gemäß Artikel 70 des Gesetzes vom 10 August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, veröffentlicht.
VI. Dass das Einberufungsschreiben auch in Einklang mit den Rechtsvorschriften über den Aktientausch und den Vor-
gaben der Richtlinie 2004/109/EC, wie sie in Luxemburger Recht Umsetzung gefunden haben, veröffentlicht wurde.
VII. Dass die gegenwärtige Generalversammlung 61,96% des Gesellschaftskapitals vertritt, ordnungsgemäß gebildet und
damit in Bezug auf die Punkte der Tagesordnung beschlussfähig ist.
Nach Beratung hat die Generalversammlung der Aktionäre daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes und des Hauptgeschäftssitzes
(principal établissement) der Gesellschaft von Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter Port, Guernsey nach Lu-
xemburg zu ratifizieren, und die Luxemburger Nationalität anzunehmen im Einklang mit dem Beschluss der Aktionäre der
Gesellschaft vom 9. April 2010 über die Löschung der Registereintragung der Gesellschaft auf Guernsey zwecks Eintragung
und Weiterführung im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg.
Die Generalversammlung der Aktionäre nimmt zur Kenntnis, dass die Gesellschaft demzufolge ab dem Datum von
gegenwärtger Versammlung, dem Luxemburger Recht unterliegen wird, gem. Artikel 159 des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, ausgenommen, ggf. dort wo das Guernsey Recht anwendbar bleibt,
solange die Gesellschaft nicht vollkommen im Handelsregister von Guernsey gelöscht wurde. In diesem Zusammenhang
erteilt die Generalversammlung der Aktionäre Herrn Max Kremer, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Voll-
macht, mit dem umfassenden Recht Untervollmachten zu erteilen, jedwede Dokumente, Verträge, Zertifikate oder
Registereintragungen zu unterzeichnen welche im Zusammenhang mit den oben genannten Beschlüssen dienlich sind.
Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass als Folge der Verlegung des Gesellschaftssitzes und des Hauptge-
schäftssitzes von Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter Port, Guernsey nach Luxemburg und der Annahme der
Luxemburger Nationalität, Heimatland der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 11. Januar 2008 über Transparen-
zerfordernisse bezüglich Emittenten, deren Wertpapiere an einem geregelten Markt gehandelt werden können, Luxem-
burg sein wird.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt, dass die Gesellschaft die Form einer Aktiengesellschaft (société
anonyme) annimmt, gemäß Artikel 23 ff. des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von „3W Power Holdings Limited" in „3W Power
Holdings S.A." abzuändern.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
65987
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft auf zwölf Millionen fünfhundertzwan-
zigtausendundsechs Euro (EUR 12.520.006) festzusetzen, durch Umwandlung eines Betrages von zwölf Millionen fünf-
hundertzwanzigtausendundsechs Euro (EUR 12.520.006) vom Ausgabeaufgeldkonto auf das Konto des Gesellschaftska-
pitals der Gesellschaft.
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird auf zwölf Millionen fünfhundertzwanzigtausendundsechs Euro (EUR
12.520.006) festgelegt, aufgeteilt in neununddreißig Millionen dreihunderteinundachtzigtausendfünfhundertachtundfünfzig
Euro (39.381.558) Aktien und zehn Millionen achthundertvierundfünfzigtausendvierhundertsechsundsechzig Euro
(10.854.466) Aktien der Klasse B (gemeinsam als die „Aktien" bezeichnet) ohne Nennwert.
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsrats vom 5 Mai 2010 im Zusammenhang mit
der Schaffung eines genehmigten Kapitals und beschließt, ein genehmigtes Gesellschaftskapital, einschließlich des bereits
ausgegebenen Gesellschaftskapitals, von siebenunddreißig Millionen fünfhundertsechzigtausendundachtzehn Euro (EUR
37.560.018), aufgeteilt in einhundertfünfzig Millionen zweihundertvierzigtausendundzweiundsiebzig (150.240.072) Aktien
ohne Nennwert zu schaffen.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre bestätigt das Wertgutachten vom 7. Mai 2010, ausgestellt durch Inter-Audit
S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 119, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 29.501, in ihrer Funktion als unab-
hängiger Wirtschaftsprüfer.
Es folgt aus dem am 7. Mai 2010 von Inter-Audit S.à r.l. ausgeteilten Wertgutachten, dass die Netto-Vermögenswerte
der Gesellschaft mindestens dem Gesellschaftskapital entsprechen.
Die Schlussfolgerung des Berichts lautet:
"Auf der Grundlage unserer oben beschriebenen Prüfungshandlungen haben wir keine Anmerkungen zum Wert der
übertragenen Aktiva und Passiva, die mindestens der Anzahl und dem Buchwert der 39.381.558 Stück auszugebenden
Aktien und 10.854.466 Stück auszugebenden B Aktien, und somit einem Gesellschaftskapital von EUR 12.520.006, ent-
sprechen."
Der Bericht ist dieser Urkunde angehängt und wird zusammen mit ihr einregistriert.
Die Generalversammlung der Aktionäre nimmt zur Kenntnis, dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft zwölf Mil-
lionen fünfhundertzwanzigtausend und sechs Euro (EUR 12.520.006,-) beträgt, vertreten durch fünfzig Millionen zwei-
hundertsechsunddreißigtausendvierundzwanzig (50.236.024) Aktien aufgeteilt in neununddreißig Millionen dreihunder-
teinundachtzigtausendfünfhundertachtundfünfzig (39.381.558) Aktien und zehn Millionen achthundertvierundfünfzigtau-
sendvierhundertsechsundsechzig (10.854.466) Aktien der Klasse B ohne Nennwert, wie es dem unterzeichneten Notar
durch eine Eröffnungsbilanz der Gesellschaft unterbreitet wurde.
Die Generalversammlung der Aktionäre nimmt zu Kenntnis, dass dreißig Millionen achthundertsechstausendvierhun-
dertsiebenundachtzig (30.806.487) Optionsscheine durch die Gesellschaft ausgegeben wurden, wie es dem unterzeich-
neten Notar durch eine Bilanz der Gesellschaft unterbreitet wurde.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Zwischenbilanz der Gesellschaft anzunehmen, wie sie durch
den Verwaltungsrat der Gesellschaft erstellt wurde. Eine Kopie wird dieser Urkunde angehängt, um mit ihr einregistriert
zu werden.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre nimmt die Eröffnungsbilanz und die Gesellschaftskonten an, wie sie durch den
Verwaltungsrat der Gesellschaft erstellt wurden. Eine Kopie wird dieser Urkunde angehängt, um mit ihr eingetragen zu
werden.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt die nachfolgenden acht derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder zu
bestätigen und zu ernennen:
65988
L
U X E M B O U R G
Herr Keith Baden Corbin, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 18. August 1952 in Guernsey, Channel Islands, ge-
schäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg;
Herr Roland Berger, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 22. November 1937 in Berlin - Koepenick, Deutschland,
geschäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg;
Herr Bruce Alton Brock, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 26. April 1943 in Minneapolis, Minnesota, Vereinigte
Staaten von Amerika, geschäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Herr Robert John Huljak, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 10. März 1947 in Milwaukee, Wisconsin, Vereinigte
Staaten von Amerika, geschäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg;
Herr Timothy Clark Collins, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 8. Oktober 1956 in Frankfort, Kentucky, Vereinigte
Staaten von Amerika, geschäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg;
Herr Mark Matthias Wolfgang Wossner, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 14. Oktober 1938 in Berlin-Charlot-
tenburg, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg;
Herr Leonhard Heinrich Fischer, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 6. Januar 1963 in Nordhorn, Deutschland,
geschäftsansässig in 19, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg;
Herr Thomas Middelhoff, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 11. Mai 1963 in Düsseldorf, Deutschland, geschäfts-
ansässig in 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg;
bis zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 1. Juni 2011 zu bestätigen.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt KPMG Audit mit Sitz in 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen beim
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 103.590, als unabhängigen Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft zu bestellen.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, dass die Adresse der Gesellschaft auf 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
festgelegt wird.
Dieser Beschluss wurde angenommen durch einer Mehrheit von 31.124.960 Stimmen für und 0 gegen, bei 2.792
Stimmenthaltungen.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, eine völlige Neufassung der Satzung vorzunehmen und dass die Gesellschafts-
satzung nunmehr die wie folgt lautet:
"A. Name - Dauer - Zweck - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeich-
nung „3W Power Holdings S.A." (die „Gesellschaft").
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit durch Beschluss der General-
versammlung der Aktionäre aufgelöst werden, in der für eine Änderung dieser Satzung vorgeschriebenen Weise.
Art. 3. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen, in jeder denkbaren Form, an luxemburgischen
oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder anderen Art und Weise, genauso wie
die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder anders, von Aktien, Anleihen, Renten, Schuldverschreibungen und anderen
Sicherheiten jedweder Art; das Eingehen von Leasingvereinbarungen; das Handeln mit Gütern die keine Sicherheiten
darstellen; der Erwerb von Vermögenswerten im Allgemeinen, der Verkauf von Vermögenswerten im Allgemeinen; das
Leisten von Sicherheiten; die Ausstellung und Annahme von Entschädigungen und Sicherheiten.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und dem Aufbau jegliches Finanz-, Industrie oder Handelsunternehmen,
einschließlich Konzerne sowie nichteingetragenen Vereinigungen, beteiligen und kann Unterstützung leisten durch die
Vergabe von Krediten, die Übernahme von Garantien oder sonst an ihre Tochter-, verbundenen oder Mutterunterneh-
men.
Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen ausgeben, Vorzugsrechte, Renten, Schuldver-
schreibungen, Handelspapiere ausgeben, Garantien geben und Kreditvereinbarungen, Wertpapierkauf-, Emissions-, An-
leihen- und Treuhandverträge eingehen und kann in diesem Zusammenhang jedes andere Finanzinstrument oder -
dokument oder jede Absicherung, Wechsel oder Derivategeschäft abschließen.
Grundsätzlich kann die Gesellschaft jede Art von Handels- und Geschäftsaktivität ausüben, die sie für sinnvoll erachtet
im Hinblick auf ihre Profitabilität oder die direkte bzw. indirekte Wertsteigerung des Unternehmens bezüglich ihres
Eigentums oder Vermögens.
65989
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Gesellschaftssitz.
4.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt
werden.
4.3 In jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg kann der Gesellschaftssitz nur durch einen Beschluss
der Generalversammlung der Aktionäre verlegt werden, mit der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Mehr-
heit.
4.4 Filialen oder Zweigstellen können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates gegründet werden.
B. Aktienkapital - Aktien - Aktienregister -
Eigentum und Übertragung von Aktien
Art. 5. Aktienkapital.
5.1 Ausgegebenes Gesellschaftskapital
5.1.1 Das durch die Gesellschaft ausgegebene Gesellschaftskapital wird auf zwölf Millionen fünfhundertzwanzigtausen-
dundsechs Euro (EUR 12.520.006) festgesetzt, aufgeteilt in neununddreißig Millionen dreihunderteinundachtzigtausend-
funfhundertachtundfünfzig (39.381.558) Aktien und zehn Millionen achthundertvierundfunfzigtausendvierhundertsech-
sundsechzig (10.854.466) Aktien der Klasse B (gemeinsam als die „Aktien" bezeichnet) ohne Nennwert.
5.1.2 Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und ungeachtet der dem Verwaltungsrat in Art. 5.2. dieser
Satzung erteilten Genehmigung ("genehmigtes Gesellschaftskapital"), kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft durch
einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre mit der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Mehr-
heit erhöht werden.
5.1.3 Jede neu auszugebende Aktie, die in bar bezahlt wird, wird vorrangig dem (n) vorhandenen Aktionär (en) zum
Kauf angeboten. Bei einer Vielzahl von Aktionären, werden ihnen diese Aktien im Verhältnis zu der von ihnen gehaltenen
Aktienanzahl im Gesellschaftskapital der Gesellschaft angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt die Zeitspanne, während
der ein solches Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann. Sie darf nicht weniger als dreißig (30) Tage ab Versendung des
Einschreibebriefs an den (ie) Aktionär (e) betragen, worin der (ie) Aktionär(e) über die Ausgabe informiert werden. Die
Generalversammlung der Aktionäre kann aber vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen, für den Fall, dass (i) sie
entweder selbst zusammengerufen wurde, um über eine Erhöhung des durch die Gesellschaft ausgegebenen Gesell-
schaftskapitals zu beschließen oder, (ii) dass dem Verwaltungsrat die Erlaubnis zur Erhöhung des ausgegebenen Gesell-
schaftskapital gewährt wird, kann die Ausübung des Vorzugsrechts der (s) bestehenden Aktionärs (e) beschränken oder
unterbinden bzw. den Verwaltungsrat ermächtigen, eine entsprechende Maßnahme anzuordnen. Dieser Beschluss wird
mit der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Mehrheit erfasst.
5.1.4 Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft durch Beschluss
der Generalversammlung reduziert werden, mit der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Mehrheit.
5.2 Genehmigtes Gesellschaftskapital
5.2.1 Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt, einschließlich des bereits ausgegebenen Gesellschaftskapitals, sie-
benunddreißig Millionen fünfhundertsechzigtausendundachtzehn Euro (EUR 37.560.018), aufgeteilt in einhundertfünfzig
Millionen zweihundertvierzigtausendundzweiundsiebzig (150.240.072) Aktien ohne Nennwert.
5.2.2 Während fünf (5) Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung oder, falls dies der Fall sein sollte, ab dem Beschluss
das genehmigte Gesellschaftskapital zu erneuern, zu erhöhen oder zu verringern im Sinne des Art. 5.2, im Amtsblatt des
Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), ist der Verwaltungsrat hiermit befugt,
(i) Aktien auszugeben; (ii) neue Aktien auszugeben nachdem, je nach Fallgestaltung, Zeichnungs- und / oder Umwand-
lungsrechte ausgeübt wurden, wie sie durch den Verwaltungsrat innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals und
gemäß der Bestimmungen der von Zeit zur Zeit ausgegebenen Optionsscheine, gegen Bareinlage oder Sacheinlage gegen
Umwandlung von Forderungen gegen die Gesellschaft oder in jeder anderen Weise, ausgestellt wurden; (iii) Optionen
einzuräumen auf Aktienzeichnungen und jede andere in Aktien umwandelbare Wertpapiere auszugeben an solche Per-
sonen und zu solchen Bedingungen wie sie es für angebracht halten, insbesondere diese Aktienausgabe durchzuführen
unter Abstellung oder Begrenzung der Vorzugsechte des (r) bestehenden Aktionärs (e) neue zu emittierende Aktien zu
zeichnen.
5.2.3 Diese Genehmigung kann ein oder mehrmals durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, in
der für eine Änderung dieser Satzung vorgeschriebenen Weise, jeweils für einen Zeitraum von höchstens fünf (5) Jahren
verlängert werden.
5.2.4 Das genehmigte Gesellschaftskapital kann erhöht oder verringert werden durch einen Beschluss der General-
versammlung der Aktionäre, mit der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Mehrheit.
Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital ist aufgeteilt in Aktien und Aktien der Klasse B, jede von ihnen mit demselben Nennwert.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
65990
L
U X E M B O U R G
6.3 Die Rechte eines Aktionärs am Vermögen und an den Profiten der Gesellschaft sind proportional zu der von ihm
gehaltenen Anzahl an Aktien am Gesellschaftskapital.
6.5 Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, ihre eigenen Aktien zurücknehmen oder
zurückkaufen.
6.6 Die Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich Namensaktien.
6.7 Die Gesellschaft kann Optionen ausgeben, die dem Halter (der „Optionsinhaber") ein Recht einräumen, die darin
bezeichneten Aktien zu zeichnen. Der Verwaltungsrat kann die Konditionen bestimmen und abändern, zu denen diese
Optionen ausgegeben werden. Der Optionsinhaber ist diesen Konditionen während der Dauer ihrer Gültigkeit unter-
worfen, unabhängig davon, ob sie bei der Ausgabe bereits in Kraft waren oder erst nach Ausgabe bestimmt wurden.
Art. 7. Rechte der verschiedenen Klassen von Aktien.
7.1 Jeder Klasse von Aktien sind dieselben Rechte zugeordnet, sofern in diesem Artikel 7 nichts anderes bestimmt ist.
7.2 Am 10. September 2010 werden die Inhaber von Aktien der Klasse B automatisch die gleichen Rechte als die
Inhaber von Aktien haben (der "Stichtag").
7.3 Bis zu dem in Artikel 7.2 genannten Stichtag haben Halter von Aktien der Klasse B die folgenden Rechte, gleichrangig
neben den von Zeit zu Zeit herausgegebenen Aktie der Gesellschaft:
7.3.1 Ein gleichberechtigtes Wahlrecht bei allen Versammlungen (oder durch einen schriftlichen Beschluss) der Akti-
onäre, zusammen mit anderen Aktionären, vorausgesetzt, daß jeder Beschluss bei der Versammlung (oder durch einen
schriftlichen Beschluss) die Inhaber von Aktien der Klasse B dazu berechtigt, sich auf die Bestimmungen in Artikel 7.4 der
Satzung zu berufen und anzuwenden;
7.3.2 eine gleichberechtigte Teilhabe mit den anderen Aktionären an Dividende oder Liquidation oder anderen Aus-
schüttungen, die angemeldet oder gemacht wurden in Bezug auf die Aktien;
7.3.3 Aktien der Klasse B unterliegen Übertragungsbeschränkungen besagend dass die Gesellschaft weder eine Über-
tragung der Aktien der Klasse B einträgt, noch eine Verfügung eines Nießbrauchrechts bei dieser Aktie anerkennt noch
eine auf dieser Aktie enstandene Belastung verursacht, es sei denn, daß diese Aktie (aa) durch den Inhaber an Tochter-
gesellschaften oder deren Geschäftspartner, Teilhaber oder Nutznießer übertragen wird, vorausgesetzt jedoch, daß in
jedem Fall, jede Aktie, die durch diesen Zessionar gehalten wird, den Bestimmungen dieses Absatzes unterliegt, oder (bb)
mit der Zustimmung der Gesellschaft nach freiem Ermessen des Verwaltungsrates der Gesellschaft (Verwaltungsrats-
mitglieder, die bereits vor dem Erwerb der Gesellschaft durch die AEG Power Solutions B.V. ein entsprechendes Amt
bei letzterer innehatten, ausgeschlossen) und es ist vermekt, daß diese Beschränkung (in dem Maß nicht allgemein an-
wendbar bei Aktien) sofort ab dem Stichtag nicht mehr besteht;
7.3.4 sollten vor Eintritt des Stichtages die Anzahl der Aktien erhöht, verringert, ein Umgruppierung der Aktienklassen
oder eine Aktienteilung oder jede andere vergleichbare Veränderung vorgenommen worden sein und sollte die Anzahl
der Aktien der Klasse B im Falle des Eintrittes eines solchen Falles nicht proportional verändert oder ihre Aufteilung
entsprechend geändert worden sein, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Ausgabe und Aufteilung von Aktien der Klasse
B im Rahmen des autorisierten Gesellschaftskapitals zu genehmigen, um hierdurch das vor der Änderung bestehende
ursprüngliche Verhältnis von Aktien zu Aktien der Klasse B wiederherzstellen; und
7.3.5 Ab Eintritt des Stichtages entfallen die Übertragungsbeschränkungen und eine Eintragung von Eigentümerwech-
seln in das Aktienregister findet statt.
7.4 Für den Fall einer Aufteilung der Gesellschaftsanteile in Aktien und Aktien der Klasse B, können Beschlüsse der
Aktionäre, die diese Aufteilung ändern oder einen Einfluss auf die an sie geknüpften Sonderrechte haben, nur mit der
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der auf der einberufenen Generalversammlung anwesenden Aktionäre insgesamt,
einschließlich jeweils mindestens zwei Drittel der Aktionäre jeder Aktienklasse, beschlossen werden.
7.5 Nach Wegfall der Beschränkungen der Rechte von Aktien der Klasse B, ist die nächste ordentliche oder außer-
ordentliche Generalversammlung der Aktionäre vor einem Notar zum Zwecke der Änderung der Satzung der Gesellschaft
abzuhalten, um die zum Stichtag eintretenden Änderungen der Aktienklassen widerzuspiegeln.
Art. 8. Aktien- und Optionsregister.
8.1 Ein Aktienregister wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es zur Einsicht durch die Aktionäre frei zugänglich ist. Es
enthält insbesondere die Namen jedes Aktionärs, ihren Wohn- oder Gesellschaftssitz, die Anzahl der jeweils gehaltenen
Aktien, die Höhe der bereits getätigten Einzahlungen, jeden Übertrag mit Datum gemäß Artikel 9 dieser Satzung sowie
jede auf die Aktien getätigte Pfändung.
8.2 Ein Optionsregister wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es zur Einsicht durch jeden Optionsinhaber frei zugänglich
ist. Es enthält insbesondere die Namen der Optionsinhaber, ihren Wohn- oder Gesellschaftssitz, die Anzahl der jeweils
gehaltenen Optionen, die bereits getätigten Zahlungen auf die Optionen, jede Optionsübertragung mit Datum sowie die
auf die Optionen gegebenen Sicherheiten.
8.3 Aktien- und Optionsinhaber geben der Gesellschaft eine Zustellungsadresse an, an die alle Benachrichtigungen und
Ankündigungen geschickt werden. Diese Adresse findet ebenfalls Eintragung in das Aktien- oder Optionsregister.
8.4 Für den Fall, dass ein Aktionär oder Optionsinhaber seine Zustellungsadresse nicht mitteilt, kann die Gesellschaft
einen Eintrag in das Aktien- oder Optionsregister dergestalt vornehmen, dass als Zustellungsadresse der Sitz de Gesell-
65991
L
U X E M B O U R G
schaft gilt oder man kann diese Adresse im Register vermerken, bis der Aktionär oder Optionsinhaber der Gesellschaft
eine andere Adresse mitteilt. Aktionäre oder Optionsinhaber können ihre Zustellungsadresse jederzeit durch schriftliche
Mitteilung an die Gesellschaft nachreichen oder ändern.
Art. 9. Eigentum und Übertragung von Aktien.
9.1 Eigentum an den Aktien wird durch Eintragung des jeweiligen Aktionärs im Aktienregister erbracht. Auszüge solche
Registereintragungen werden auf Antrag und auf Kosten des Aktionärs ausgestellt und sind entweder durch den Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates oder jeweils zwei Verwaltungsratsmitglieder zu unterschreiben.
9.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Im Falle mehrerer Eigner einer Aktie müssen diese
gegenüber der Gesellschaft eine einzelne Person benennen, die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer auftritt. Die
Gesellschaft ist berechtigt, im Falle des Mehrfacheigentums an einer Aktie, sämtliche mit dieser Aktie verbundenen Rechte
einzustellen, bis einer der Eigentümer als alleiniger Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde.
9.3 Die Aktien sind frei übertragbar, dem Gesetz und den Vorgaben von Artikel 7 dieser Satzung unterworfen.
9.4 Jede Aktienübertragung erlangt gegenüber der Gesellschaft und dem Parteien Wirksamkeit durch Eintragung in
das Aktienregister, entweder durch datierte und seitens des Zessionars sowie des Zedenten bzw. deren Bevollmächtigten
unterschriebenen Eintragung oder, im Falle der Mitteilung der Übertragung zur oder auf die Genehmigung durch die
Gesellschaft, durch Eintragung eines Verwaltungsratsmitglieds.
9.5 Die Gesellschaft kann, durch ein Verwaltungsratsmitglied, auch dann einen entsprechenden Übertragungseintrag
genehmigen und die Eintragung in das Aktienregister vornehmen, wenn sich eine solche Übertragungsvereinbarung des
Zedenten an dem Zessionar aus Korrespondenz oder jedem anderen Dokument ergibt.
C. Generalversammlung der Aktionäre
Art. 10. Befugnisse der Generalversammlung.
10.1 Die Aktionäre üben ihre kollektiven Rechte durch die Generalversammlung aus. Sie ist eines der Organe der
Gesellschaft.
10.2 Für den Fall, dass ein Aktionär alle Anteile an der Gesellschaft alleine hält, übt er die Befugnisse der Generalver-
sammlung aus. In diesem Fall finden die Vorschriften der Satzung die auf die „Generalversammlung der Aktionäre" Bezug
nehmen Anwendung, selbst wenn der Begriff "alleiniger Aktionär" nicht ausdrücklich genannt wird.
10.3 Die Generalversammlung ist mit den ihr durch das Gesetz und diese Satzung zugesprochenen Rechte ausgestattet.
Art. 11. Einberufung der Generalversammlung.
11.1 Die Generalversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat zu einer bestimmten Zeit und
an einem bestimmten Ort einberufen werden, die in der Benachrichtigung benannt werden.
11.2 Die Generalversammlung der Aktionäre muss durch den Verwaltungsrat nach Eingang eines an ihn adressierten,
schriftlichen und einen Vorschlag einer Tagesordnung enthaltenden Ersuchens durch einen oder mehrere Aktionäre, die
zusammen mindestens drei Prozent (3%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals halten, einberufen werden. Der Ver-
waltungsrat muss die Generalversammlung in einem solchen Fall innerhalb von einem (1) Monat an einem in der
Einberufungsbenachrichtigung bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit abhalten.
11.3 Eine ordentliche Generalversammlung muss am fünfzehnten. April um zwölf (12.00) Uhr mittags eines jeden Jahres
entweder in der Gemeinde abgehalten werden, in der die Gesellschaft ihren eingetragenen Sitz hat, oder an jedem anderen
Ort, solange dieser in der Einberufungsbenachrichtigung hinreichend benannt ist. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag
ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächsten Werktag abgehalten. Auf jeden Fall muss der Verwaltungsrat die
jährliche Generalversammlung spätestens vier (4) Monate nach Ende des Haushaltsjahres der Gesellschaft einberufen.
11.4 Die Einberufungsbenachrichtigung zur Generalversammlung muss mindestens fünfzehn (15) Tage vorher per Ein-
schreibebrief an jeden Aktionär abgesandt werden und die Tagesordnung, den Ort, das Datum sowie die die Uhrzeit der
Versammlung enthalten.
11.5 Ein Aktionär oder mehrere Aktionäre, die alleine oder gemeinsam wenigstens drei Prozent (3%) des ausgegebenen
Gesellschaftskapitals halten, können die Hinzufügung von einem oder mehreren Punkten auf die Tagesordnung verlangen.
Ein solcher Antrag muss per Einschreiben wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung an den Gesellschaftssitz der
Gesellschaft abgeschickt werden.
11.6 Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind bei der Genraiversammlung der Aktionäre und erklären, dass
sie über der Tagesordnung informiert wurden, kann die Generalversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einla-
dung durchgeführt werden.
Art. 12. Ablauf der Generalversammlung.
12.1 Ein Vorstand ist bei jeder Generalversammlung der Aktionäre zu bilden, zusammengesetzt aus Vorsitzendem,
Sekretär und Schriftführer, jeder von ihnen wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestellt, muss aber weder
Aktionär noch Mitglied des Verwaltungsrates sein. Der Vorstand stellt sicher, dass die Versammlung im Einklang mit den
anwendbaren Regeln, insbesondere im Hinblick auf die Einberufung, Mehrheitserfordernisse, Stimmzählung und Vertre-
tung der Aktionäre, stattfindet.
12.2 Bei jeder Generalversammlung der Aktionäre ist eine Anwesenheitsliste zu führen.
65992
L
U X E M B O U R G
12.3 Quorum
Soweit durch Gesetz oder diese Satzung nichts anderes gefordert wird, wird kein Quorum für die gültige Abhaltung
der Generalversammlung der Aktionäre benötigt.
12.4 Abstimmung
12.4.1 Jede Aktie verleiht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine (1) Stimme.
12.4.2 Soweit durch Gesetz oder diese Satzung nichts anderes vorgeschrieben, werden Beschlüsse der Generalver-
sammlung mit einfacher Mehrheit gefasst, unabhängig des hierdurch vertretenen Aktienkapitals. Enthaltungen und
ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt.
12.5 Ein Aktionär kann sich auf jeder Generalversammlung durch eine Person, die nicht selbst auch Aktionär zu sein
braucht, vertreten lassen, wobei eine vorab an die Generalversammlung mittels Brief, Fax, Email oder in jeder anderen
Kommunikationsform, geschickte Kopie der schriftlichen und unterschriebener Vollmacht als Nachweis ausreicht. Eine
Person kann zugleich mehrere Aktionäre vertreten. Das zur Vollmacht verwendete Dokument muss durch den Voll-
machtgeber oder durch seinen Anwalt handschriftlich erstellt werden, oder wenn es sich bei dem Vollmachtgeber um
eine Gesellschaft handelt, mit Firmensiegel versehen sein oder handschriftlich durch einen dazu befugten leitenden An-
gestellten oder Anwalt erstellt oder wenn es sich um Aktien handelt, die an einer europäischen Hinterlegungsstelle für
Sicherheiten gehalten sind, eine Ausstellung des betreffenden Beteiligten aufweisen. Im Falle von Aktien, die im Namen
einer europäischen Hinterlegungsstelle für Sicherheiten oder einer angegliederten Institution registriert sind, kann der
Aktionär eine schriftliche Erklärung mittels seines Beteiligten oder seiner angegliederten Institution einreichen, die eine
Anweisung darstellt zur Erteilung einer Vollmacht des betreffenden eingetragenen Aktionärs und die bestätigt, daß die
Anzahl der Aktien, die auf jeder schriftlichen Erklärung aufgeführt sind, Teil einer Gesamthinterlegung sind und daß, die
in der Erklärung aufgeführte Person eine Beteiligter ist für die aufgeführte Anzahl von Aktien in der Gesamthinterlegung
und die Vollmacht erhält, alle Rechte bei der betreffenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft auszuüben,
die mit diesen Aktien und deren Wahlrechte verbunden sind, vorausgesetzt daß dieser Beteiligte, dazu befugt ist, seine
Vollmacht an Dritte zu übertragen, durch handschriftliche Ausstellung dieser Vollmacht gemäß der gegenwärtigen Satzung.
12.6 Jeder Aktionär, der an einer Generalversammlung via Telefon, Video oder jedem anderen Kommunikationsmittel
zugeschaltet ist, das die zweifelsfreie Identifikation des Aktionärs erlaubt und dass alle Teilnehmer der Generalversamm-
lung einander ununterbrochen hören und effektiv an der Versammlung teilhaben können, gilt als anwesend für die
Bestimmung des Quorums und kann an den Abstimmungen teilnehmen.
12.7 Jeder Aktionär kann durch mittels Post, Fax, Email, elektronischer Abstimmung, oder jeder anderen geeigneten
Kommunikationsform an den Gesellschaftssitz oder jeden anderen in der Einberufungsbenachrichtigung hierfür benannten
Ort übermittelten unterschriebenen Stimmzettel an der Abstimmung teilnehmen. Die Aktionäre dürfen nur durch die
Gesellschaft zur Verfügung gestellte Stimmzettel verwenden, die mindestens Angaben hinsichtlich des Ortes, des Datums,
der Zeit sowie die Tagesordnung der Generalversammlung enthalten, genauso wie Vorschläge betreffend die Tagesord-
nung, denen jeweils drei Abstimmungskästchen angefügt sind und es den Aktionären so ermöglicht, durch Ankreuzen
oder elektronisches Ankreuzen, für oder gegen die vorgeschlagenen Beschlüsse zu stimmen, bzw. sich der Stimme zu
enthalten. Es finden nur solche Stimmzettel Berücksichtigung, die vor Beginn der Generalversammlung eingehen.
12.8 Der Verwaltungsrat kann weitere zu erfüllende Voraussetzungen für die Durchführung einer Generalversammlung
aufstellen, die von den Aktionären zu erfüllen sind.
Art. 13. Satzungsänderungen. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen kann diese Satzung durch einen Be-
schluss der mindestens durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Stimmen angenommen werden muss, geändert
werden bei einer Generalversammlung bei der in einer ersten Abstimmung mindestens die Hälfte des ausgegebenen
Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls eine solche doppelte Mehrheit in einer ersten Abstimmung nicht
erreicht wird, findet eine zweite Abstimmung statt, bei der der Beschluss mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgege-
benen Stimmen angenommen werden kann, unabhängig des hierdurch repräsentierten Aktienkapitals. Stimmenthaltungen
und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt.
Art. 14. Vertagung der Generalversammlung. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben kann der Verwaltungsrat
jede Generalversammlung um bis zu vier (4) Wochen auch dann vertagen, wenn diese bereits begonnen oder eine Sat-
zungsänderung zum Gegenstand hat. Der Verwaltungsrat muss eine bereits begonnene Generalversammlung vertagen,
falls dies von Aktionären, die mindestens zwanzig Prozent (20%) der durch die Gesellschaft ausgegebenen Aktien reprä-
sentieren, verlangt wird. Für den Fall einer solchen Vertagung werden alle bis zu diesem Zeitpunkt getroffenen Beschlüsse
annulliert.
Art. 15. Protokolle der Generalversammlungen.
15.1 Der Vorstand der Generalversammlung hat ein Protokoll der Versammlung anzufertigen, das von seinen Mitglie-
dern und jedem anderen Aktionär, der dies wünscht zu tun, zu unterschreiben ist.
15.2 Für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, muss dieser ebenfalls ein zu unterschreibendes
Protokoll der von ihr/ ihm getroffenen Beschlüsse anfertigen.
15.3 Jede Vervielfältigung oder Auszug, außer dem Originalprotokoll, die für Gerichtsverfahren oder für Dritte aus-
gestellt wird, ist durch den das Original aufbewahrenden Notar zu beglaubigen, falls die Generalversammlung vor einem
Notar stattgefunden hat, bzw. durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder.
65993
L
U X E M B O U R G
D. Management
Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrats.
16.1 Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, alle für die Erfüllung des Gesellschafts-
zweck nützlichen Handlungen vorzunehmen, mit Ausnahme von solchen Maßnahmen, die durch Gesetz oder diese Satzung
der Generalversammlung vorbehalten sind.
16.2 In Einklang mit Art. 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, kann die
tägliche Geschäftsführung und ihre Vertretung in Zusammenhang hiermit an einen Geschäftsführer oder jedes andere
Komitee delegiert werden, unabhängig ob es sich dabei um Verwaltungsratsmitglieder, Aktionäre oder nicht oder andere
Personen, jeweils alleine oder gemeinsam zu Handeln befugt, handelt. Ihre Ernennung, Abberufung und Befugnisse kann
durch einen Beschluss des Verwaltungsrats erfolgen.
16.3 Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Ausschüsse bestehend aus Verwaltungsratsmit-
gliedern und/ oder externen Personen einrichten, und diesem Befugnisse und Aufgaben delegieren, wie er dies für
angebracht hält. Ein solcher Ausschuss hat in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Art. 23.2 dieser Satzung zu
handeln. Der Verwaltungsrat hat auf jeden Fall einen Entschädigungsausschuss sowie einen Revisionsausschuss zu gründen.
Art. 17. Zusammensetzung des Verwaltungsrats.
17.1 Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens vier (4) Mitgliedern zusammen, wobei die genaue Zahl durch die
Generalversammlung festgelegt wird. Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht zugleich auch Aktionäre sein.
17.2 Der Verwaltungsrat besteht aus executiven und nicht executiven directors, die durch die Generalversammlung
der Aktionäre bestimmt werden. Auf jeden Fall ist das mit der täglichen Geschäftsführung beauftragte Verwaltungsrats-
mitglied ein executive director und wird als „chief executive officer (CEO)" der Gesellschaft durch Beschluss des
Verwaltungsrates bestellt.
17.3 Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte. Er kann auch einen Sekretär wählen, der weder
Aktionär noch Verwaltungsratsmitglied sein muss.
Art. 18. Wahl und Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und Ende des Mandates.
18.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung gewählt, die zugleich ihre Entlohnung
und die Dauer ihres Mandates bestimmt.
18.2 Falls eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied gewählt wird, muss diese eine natürliche Person als
permanente Vertretung benennen, die für sie in ihrem Namen und mit Wirkung für sie handelt. Die betreffende juristische
Person kann ihren permanenten Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zugleich einen Nachfolger ernennt. Jede natür-
liche Person kann nur durch ein (1) Verwaltungsratsmitglied zugleich vertreten werden und darf nicht selbst Verwal-
tungsratsmitglied sein.
18.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Generalversammlung der Akti-
onäre abberufen werden.
18.4 Die Amtsdauer eines Verwaltungsratsmitglieds darf nicht länger als sechs (6) Jahre betragen und jedes Verwal-
tungsratsmitglied muss sein Amt bis zur Wahl seines Nachfolgers weiter ausüben. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann
auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 19. Vakanz eines Verwaltungsratssitzes.
19.1 Wenn das Amt eines Verwaltungsratsmitgliedes wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Ausscheidens oder
aus einem anderen Grund unbesetzt ist, kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorü-
bergehend besetzt werden und zwar bis zur nächsten Generalversammlung, die über eine dauerhafte Besetzung bestimmt.
19.2 Für den Fall, dass die Gesellschaft mehr als nur einen Aktionär hat und die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder
unter vier (4) oder unter ein höheres in dieser Satzung getroffene Minimum fällt, muss eine solche Vakanz unverzüglich
entweder durch die Generalversammlung oder, auf befristeter Basis, durch den verbleibenden Verwaltungsrat bis zu
nächsten Generalversammlung, die dann über eine dauerhafte Bestellung entscheidet, gefüllt werden.
19.3 Im Falle der Vakanz des alleinigen geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes, muss diese unverzüglich durch
die Generalversammlung der Aktionäre neu besetzt werden.
Art. 20. Einberufene Sitzungen des Verwaltungsrats.
20.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Ver-
waltungsratsmitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Absatz beschrieben.
20.2 Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorher-
gesehenen Datum zu jeder Verwaltungsratssitzung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunika-
tionsmittel schriftlich geladen Werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung
zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes
Verwaltungsratsmitglieds per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine
Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu
Verwaltungsratssitzungen nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden sollen wie dies in einem
vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats bestimmt wurde. Eine Ladung soll femer dann nicht erforderlich sein,
65994
L
U X E M B O U R G
wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen
gemäß dieser Satzung.
Art. 21. Leitung der Verwaltungsratssitzung.
21.1 Der Vorsitzende des Verwaltungsrates leitet die Verwaltungsratssitzung. Im Falle seiner Abwesenheit kann der
Verwaltungsrat ein anderes Mitglied als Vorsitzenden pro tempore wählen.
21.2 Quorum
Der Verwaltungsrat kann nur wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder bei der
Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist.
21.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der bei der Verwaltungsratssitzung anwesenden oder ordnungsgemäß
vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen. Der Vorsitzende hat keine entscheidende Stimme.
21.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich unter Zusendung einer schriftlichen Vollmacht mittels Brief, Fax, Email
oder jedem anderen geeigneten Kommunikationsmittel auf der Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Verwaltungs-
ratsmitglied vertreten lassen, solange diese Vollmacht vor Beginn der Sitzung eingeht, wobei eine Fotokopie der
Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehre Verwaltungs-
ratsmitglieder gleichzeitig vertreten.
21.5 Jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass
sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen
können, gilt für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit als anwesend. Eine solche mittels Kommunikations-
mitteln geführte Verwaltungsratssitzung gilt als am Gesellschaftsitz abgehalten.
21.6 Der Verwaltungsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer
ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Vorstandsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und
unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch
jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unter-
schriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das
Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
21.7 Falls nicht durch das Gesetz anders vorgesehen, muss jedes Verwaltungsratsmitglied, dass ein direktes oder
indirektes vermögensrechtliches Interesse an einem Vorgang hat, der durch den Verwaltungsrat angenommen wird, und
dieses Interesse im Konflikt mit den Interessen der Gesellschaft steht, den Verwaltungsrat von einem solchen Interes-
senkonflikt informieren und diese Erklärung in das Protokoll der Verwaltungsratssitzung aufnehmen. Das betreffende
Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber
abstimmen. Alle Interessenkonflikte müssen bei der nächsten Generalversammlung mitgeteilt werden bevor diese ir-
gendeine Entscheidung trifft.
Art. 22. Protokoll der Verwaltungsratssitzung.
22.1 Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Vorsitzende, soll ein Protokoll über jede
Verwaltungsratssitzung aufnehmen, welches vom Vorsitzenden und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
22.2 Genauso hat, für den Fall, dass eine Person alleine die Befugnisse des Verwaltungsrates innehat, diese ihre Be-
schlüsse in ein Protokoll aufzunehmen.
22.3 Jede Kopie oder jeder Auszug solcher urschriftlichen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet oder
die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen vom Verwaltungsratsvorsitzenden, von zwei beliebigen Verwal-
tungsratsmitgliedern oder von der Person, die allein die Befugnisse des Verwaltungsrats ausübt, wenn dies der Fall ist,
unterzeichnet werden.
Art. 23. Geschäfte mit Dritten.
23.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Bedingungen durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils
zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern gebunden. Im Rahmen des Tagesgeschäftes wird die Gesellschaft gegenüber Dritten
durch die alleinige Unterschrift des ordnungsgemäß bestellten CEO der Gesellschaft oder die alleinige Unterschrift jed-
weder Person (en) gebunden, der/denen diese Befugnis in Verbindung mit dem Tagesgeschäft der Gesellschaft gemäß den
Regeln dieser Übertragung übertragen wurde.
23.2 Der Verwaltungsrat handelt im Einklang mit der internen Geschäftsordnung (die „Geschäftsordnung"), an welche
jedes Organ der Gesellschaft gebunden ist.
D. Überwachung
Art. 24. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere
unabhängige Wirtschaftsprüfer überwacht. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird aus den von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) akkreditierten „reviseur d'entreprises agréé" beziehungsweise „cabinet de ré-
vision agréé" gewählt und durch die Generalversammlung bestellt, die auch die Dauer seines Mandates bestimmt.
65995
L
U X E M B O U R G
E. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jeden Jahres und endet am ein-
unddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 26. Gewinne.
26.1 Von den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rück-
lage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die
Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.
26.2 Beträge, die der Gesellschaft durch einen Aktionär zugeführt werden, können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn dieser einer solchen Zuführung zugestimmt hat.
26.3 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals, kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis
herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals nicht übersteigt.
26.4 Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Verwaltungsrat wird die Generalversammlung
der Aktionäre beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft verwendet werden
soll, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung.
Art. 27. Zwischendividenden - Ausgabeaufgeld.
27.1 Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen kann der Verwaltungsrat Zwischendividende zahlen.
27.2 Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Unauszahlbarkeit des Aktienkapitals sowie der ge-
setzlichen Rücklage kann ein Ausgabeaufgeld aufgrund Beschlusses der Generalversammlung oder des Verwaltungsrats
frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
F. Liquidation
Art. 28. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt
werden, die die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
G. Anwendbares Recht
Art. 29. Anwendbares Recht. Diese Satzung und ihre Auslegung und Interpretation unterliegen luxemburgischem
Recht. Alle in dieser Satzung nicht geregelte Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, bestimmt werden."
<i>Übergangsbestimmungeni>
Die erste ordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird am 1. Juni 2010 abgehalten.
<i>Erklärungi>
Der vinterzeichnete Notar erklärt hiermit das er die Erfüllung der in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, genannten Voraussetzungen geprüft hat und erklärt ausdrücklich, dass sie
alle erfüllt sind.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Komparenten schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass ge-
genwärtiger Generalversammlung entstehen, auf ungefähr achttausendfünfhundert Euro (EUR 8.500).
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt, dass auf Anfrage der erschienenen Personen,
folgende Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Im Fall von Abweichungen zwischen dem
englischen und dem deutschen Text wird die englische Fassung maßgebend sein.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 14, rue Erasme, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. JULIAN, M. KREMER, J. LAURENT und J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A. C., le 14 mai 2010. LAC/2010/21430. Reçu soixante-quize euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 27. Mai 2010.
Joëlle BADEN.
Référence de publication: 2010071571/1143.
(100079679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2010.
65996
L
U X E M B O U R G
Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 4.367.
Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2010077672/13.
(100070207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Murex International Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 75.043.
Les comptes consolidés au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2010.
Signature.
Référence de publication: 2010077684/11.
(100070146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
De Wending S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 58.890.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
De Wending S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2010078320/15.
(100070179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 41.153.
<i>Rectificatif du dépôt du 22 décembre 2009 (No L090196770)i>
Les comptes annuels modifiés au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2010077690/14.
(100070323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65997
L
U X E M B O U R G
Conseil Transaction Négoce (en abrégé: CTN) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3419 Dudelange, 22, rue Alphonse Benoît.
R.C.S. Luxembourg B 141.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077689/10.
(100070168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Fagus Multimanager, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 64.333.
Le bilan de la Société au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour FAGUS MULTIMANAGER
i>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Signature / Luc Biever
Référence de publication: 2010077691/13.
(100070399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Holteide Investissement S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 68.676.
L'actionnaire unique a pris en date du 27 avril 2010 les résolutions suivantes:
1- Il révoque Monsieur Gontran STIERNON de sa fonction d'administrateur unique;
2- Il nomme en remplacement Monsieur Paolo PANICO, administrateur de société, demeurant professionnellement
à L-1260, Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie. Son mandat expirera à l'assemblée statutaire de 2015;
3- Il renouvelle le mandat de la société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA de sa fonction de commissaire aux
comptes, dont le siège social est établit à L-1371, Luxembourg, 31, Val Sainte Croix. Son mandat expirera lors de l'as-
semblée statutaire de 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Paolo PANICO
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2010078412/17.
(100070383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Lagomar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 101.868.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
FIDUPAR
10, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2010078304/14.
(100070392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65998
L
U X E M B O U R G
Compagnia Atlantica Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 86.712.
Le Bilan au 11 Février 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077692/10.
(100070522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Rakis Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.542.
Le Bilan au 11 Février 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077693/10.
(100070521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Karsira Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 78.535.
Le Bilan au 11 Février 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077694/10.
(100070519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Centocinquantacinque S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.770.
Le Bilan au 11 Février 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077695/10.
(100070517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
I.T. Türk, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 134.249.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
10, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2010077707/13.
(100070374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
65999
L
U X E M B O U R G
Watercreek Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 80.616.
Le bilan et annexes au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077696/10.
(100070551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
C.F. Marazzi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 72.587.
Le bilan et annexes au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010077697/10.
(100070549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
BNL International Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 40.924.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinairei>
<i>qui s'est tenue le 9 avril 2010 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>10, boulevard Royali>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Yvan JUCHEM,
Noël DIDIER, Fabio DI VINCENZO et Alessandro PASSARO et du Président Daniel ASTRAUD pour une période d'un
an.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. au poste de
Commissaire aux Comptes de la société pour une période d'un an.
Les mandats des Administrateurs, du Président et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31/12/2010.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010078394/21.
(100070363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Monjoint L.L.C. - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.031.
Le Bilan consolidé au 31 Décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/05/2010.
Jorge Pérez Lozano
<i>Branch mangeri>
Référence de publication: 2010078319/12.
(100070193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
66000
3W Power Holdings S.A.
Arten
Becker & Zaccagnini
Blamar S.A.
BNL International Investments
Business Investor S.A.
Caravaggio Sicav
Centocinquantacinque S.A.
C.F. Marazzi S.A.
Compagnia Atlantica Holding S.A.
Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés
Conseil Transaction Négoce (en abrégé: CTN) Sàrl
Daulby S.A.
Dero S.A.
De Wending S.A.
Dockland Development S.A., SICAR
Donatello Sicav
EAVF S.à r.l.
ESCO Interamerica Ltd S.à r.l.
EuroRidge Solar Holding S.à r.l.
Fagus Multimanager
Finagra S.A.
Finantel S.A.
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles
Green Cross Equity S.àr.l.
Harsco Interamerica Limited S.à r.l.
Holteide Investissement S.A.
I.T. Türk
Karsira Holding S.A.
Lagomar S.A.
Marc Lefèbvre, S.à r.l.
Marwil Luxembourg S.à r.l.
MezzVest Luxembourg II S. à r.l .
MezzVest Luxembourg I S.à.r.l.
Monjoint L.L.C. - Luxembourg Branch
Murex International Luxembourg S.A.
NATIXIS Luxembourg Investissements
Phoenix Holdco I S.à r.l.
Rakis Holding S.A.
Sabone
SBRE Capmark Holdco
SBRE Neighbourhood Centre
SBRE Waren
SBRE West German Portfolio Luxco
Sogestaf S.à r.l.
Solum Parc Rischard S.A.
Trade-Match.com S.à.r.l.
Vertex Commodities Sàrl
Watercreek Investments S.à r.l.