logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1374

5 juillet 2010

SOMMAIRE

AMC Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65949

Anglona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65949

Anglona S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65952

Banque Transatlantique Luxembourg . . . .

65927

Blamar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65948

Caufort Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

65924

Coogee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65916

Creola S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65948

Dome GP, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65938

Dome S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65927

EAVF S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65928

European Logistics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65937

European Office Income Venture . . . . . . . .

65937

European Office Income Venture . . . . . . . .

65952

Exzentric S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65919

Fintinvest A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65952

Fi Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65918

Fountainhead S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65948

Fountainhead S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65949

Fountainhead S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65949

General Electric International Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65918

IFF (GIBRALTAR) Holdings (Luxem-

bourg) S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65938

Internationale Forêt Noire S.A.  . . . . . . . . .

65909

International Flavors & Fragrances Gibral-

tar Holdings (Luxembourg) S.C.S.  . . . . . .

65928

International Flavors & Fragrances Gibral-

tar Holdings (Luxembourg) S.C.S.  . . . . . .

65938

International Flavors & Fragrances Global

Holding S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65928

Joya-Coiffure S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65909

Kirchberg Services, S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

65928

Ksar Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65924

Lancelot Ector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65919

Lavanco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65949

Ligabue Immobiliare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

65924

Lux-Protect Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65912

Manly S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65919

Maxpama S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65923

M&L Global SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65923

Nord Europe Patrimonium  . . . . . . . . . . . . .

65910

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65907

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65910

Orco Property Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65913

Pliniana International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

65947

Redblack Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65906

Russian Investment Company  . . . . . . . . . . .

65906

SEB Optimix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65915

SES Digital Distribution Services S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65928

Stanley Invest Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

65915

Tinfos Nizi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65924

Tower Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65915

Wampum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65938

Wampum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65919

65905

L

U X E M B O U R G

Redblack Limited, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 95.369.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social le <i>20 juillet 2010 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2009
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2009 et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2009
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux administrateurs pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009
5. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2009
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010084195/17.

Russian Investment Company, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 55.168.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders, to be followed by an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of Russian Investment Company (the "Company"), will be held at 11.00 a.m. (local time) on <i>July 22,

<i>2010 at the registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg with the following agenda:

<i>Agenda of the Annual General Meeting:

1. To approve the annual report comprising the audited accounts of the Company for the financial year ended March

31, 2010 and to approve the Auditors' report thereon;

2. To approve the balance sheet, profit and loss accounts as of March 31, 2010 and the allocation of the net profits

(if applicable);

3. To grant discharge to the Directors for the performance of their duties during the financial year ended March 31,

2010;

4. To acknowledge the resignations of Allegra van Hövell as of August 31, 2009 and Antonio Thomas as of June 8,

2010;

5. To acknowledge the co-optation of Dominic Sheridan as a member of the Board of Directors of the Company as

from September 8, 2009 in replacement of Allegra van Hövell;

6. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next annual general meeting of shareholders

and until his or her successor is duly elected: Laurence Llewellyn, Jacques Elvinger, John Karachalios, João Santos
and Dominic Sheridan;

7. To elect PricewaterhouseCoopers S.àr.l. as Auditor of the Company until the annual general meeting to be held

in 2011;

8. Any other business which may be properly brought before the meeting.
Shareholders are advised that the resolutions are not subject to specific quorum or majority requirements.
The annual general meeting will be immediately followed by an extraordinary general meeting of shareholders with

the following agenda:

<i>Agenda of the Extraordinary General Meeting:

Amendment of the Company's name from "Russian Investment Company" to "F&amp;C Russian Investment Company" and

consequent amendment of article 1 of the Company's articles of association so as to read as follows:

"There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the form of a

"société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "F&amp;C RUSSIAN IN-
VESTMENT COMPANY" (the "Corporation")."

A quorum of 50% of the Company issued share capital is required to validly deliberate on the amendment to the

articles of association and the passing of this resolution requires the consent of two-thirds of the votes cast by the

65906

L

U X E M B O U R G

shareholders present or represented at the extraordinary general meeting. Votes cast do not include votes attaching to
shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or
invalid vote.

If the quorum is not reached, the extraordinary general meeting will be reconvened with the same agenda. There is

no quorum required for this reconvened extraordinary general meeting and the resolution will be passed by a majority
of two-thirds of the votes of the shareholders present or represented at reconvened extraordinary general meeting.
Proxies received at the first extraordinary general meeting will be held and be valid for the adjourned extraordinary
general meeting.

A draft of the restated Articles is available upon request at the registered office of the Company (Tel.: (+352) 47 40

66 6536 / Fax: (+352) 47 40 66 6503).

Shareholders may vote at both meetings in person or by proxy.
Shareholders, who do not expect to attend the meetings in person, are required to sign and date the proxy forms

available at the registered office and return them as soon as possible by fax to the following number: +(00) 352 47 40 66
707 and subsequently by airmail to: F&amp;C, B.P. 403, L-2014 Luxembourg. In order to be valid for this meeting, proxy forms
should be received by NOON on July 21, 2010 and only shareholders on record at NOON on July 21, 2010 are entitled
to vote at the annual general meeting of shareholders and at the extraordinary general meeting and at any adjournments
thereof.

<i>By Order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2010085381/755/58.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

FR0010333302

On May 19, 2010, the Paris Commercial court approved the safeguard plan presented by the Company (the "Safeguard

Plan"). This plan had been rejected by the majority of all the Bond issues on April 28, 2010 considering that the Safeguard
Plan underestimates the maximum liability due to bondholders by € 145,063,500.69 and due to the bondholders of this
issue by € 51,291,480.50 and that, based on the amount estimated by bondholders of the maximum liability due do them,
the cash flow projections of the Safeguard Plan show that, for a number of years during the Safeguard Plan, the Company
will not have enough resources to repay the amounts due to bondholders. Consistent with his duty to act in order to
protect the interests of the bondholders, the Bondholder Representative thus lodged a preventive third party claim
("tierce opposition") against the Safeguard Plan on May 28, 2010. The Bondholder Representative now wishes to convene
a general meeting of bondholders to resolve upon the third party claim ("tierce opposition") against the Safeguard Plan.
As of today, the decision of the court is still not available; the Bondholder Representative thus decides to cancel the
General Meeting initially convened on June 29, 2010, and decides to convene a new

GENERAL MEETING

<i>July 15, 2010 at 11.30 CET.
A general meeting of the holders of the bonds registered under ISIN code: FR0010333302 (the "Bonds 2013") as

described in the Prospectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on June 1, 2006 of €
149.999.928, 1 per cent convertible bonds due May 31, 2013 at an issue price: € 138, represented by 1.086.956 convertible
bonds with a par value of € 145, for which the visa on the prospectus was delivered by the CSSF on May 17, 2006 (the
"Prospectus"), will thus be held at 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, on July 15, 2010 at 11.30 Central European
time ("CET") (the "Meeting"). The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the third party claim ("tierce opposition") of the Bondholder Representative against the Safeguard Plan

and of his powers in this respect and assumption of the costs in connection with challenging the Safeguard Plan.

2. Miscellaneous.
The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the  disposal  of  the  holders  of  Bonds  2013  from  June  25,  2010  on  request  either  with  the  Company  on
www.orcogroup.com or with the Bondholders Representative by email at lleroi@pt.lu.

Copies of the Prospectus, the Safeguard Plan and the articles of association of the Company are available on the

Company's website at http://www.orcogroup.com and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2013 of the Company; the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2013 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent CACEIS Corporate Trust can attend and vote at any meeting.

65907

L

U X E M B O U R G

The Company and its legal advisors, as well as its respective financial advisors and such other persons as may be accepted
by the meeting, may attend and speak at the meeting. Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy
given by a Beneficial Owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting. Beneficial Owner who took no action
in respect of the Meeting can give instructions for the adjourned Meeting by following the same procedure.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended, the

quorum at the General Meeting for passing the above resolutions is a simple majority of the votes cast by the represented
Bondholders. No quorum is required for the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that a simple majority of the Bondholders represented

at the Meeting can take valid resolutions that will validly bind all the Bondholders (even those not represented at the
meeting). Notably, Article 94-5 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended provides that
when a Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the law of 10th August, 1915
on commercial companies as amended, Bondholders may no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2013, the Bonds 2013 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream
Luxembourg"), through which transactions in the Bonds 2013 are effected.

All of the Bonds 2013 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2013, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Voting instructions may be delivered only through direct Accountholders with the type of vote: in favour of / against /

abstain from the proposed resolution mentioned in the Agenda and by stating the Principal Amount of Bonds 2013. A
splitting of the resolutions is not accepted.

In order to obtain a voting certificate or instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting

(or any adjourned Meeting, as the case may be) in accordance with a Bondholder's instructions, an Accountholder must
procure delivery of an electronic voting instruction, in accordance with the procedures of Euroclear or Clearstream
Luxembourg, to the relevant Paying Agent prior to the Expiration Time on the Expiration Date all of them as defined
below.

If a Bondholder is not wishing to attend and vote at the Meeting or any adjourned such Meeting in person, he can

instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the meeting or any adjourned such Meeting on his
behalf with the type of vote: in favour of / against / abstain from the proposed resolution. A splitting of the resolutions is
not accepted.

Bondholders may also allow their voting right in the Bondholders meeting to be exercised by an authorized repre-

sentative, e.g. allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2013 in order
to procure delivery of their voting instructions via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying Agent
prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be 14h30 CET (the "Expiration Time") of July 12, 2010 (the "Expiration Date"). The Company

has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2013, it shall not release the

Bond 2013 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial Owners
are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2013 will be blocked until the conclusion of the Meeting or the adjourned Meeting. This means that it may
not be possible to sell such Bonds 2013 until the conclusion of the Meeting or any adjourned Meeting.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and

effective for the adjourned Meeting. Beneficial Owners who took no action in respect of the Meeting can give instructions
for the adjourned Meeting by following the same procedure set forth above.

For the purposes of this Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours, respectively,

including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant meeting is to

65908

L

U X E M B O U R G

be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this purpose the
day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the extent necessary,
more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which banks are open
for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from June 25, 2010 to July 12, 2010.
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is July 12, 2010.
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is July 12, 2010.
3. Contact

The Bondholder representative
Mr Luc Leroi
13A, rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen
Email: lleroi@pt.lu

The Paying Agent
CACEIS Corporate Trust
Service assemblées
14, rue du Rouget de Lisle, F-92889 Issy les Moulineaux
Fax : +33 1.49.08.05.82
Email: gisele.gresle@caceis.com

The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. M. Ralf Limburg
Tel: +352 26 47 67 1
Fax: +352 26 47 67 67
Email: rlimburg@orcogroup.com

Eischen June 24, 2010.

Luc Leroi
<i>Bondholder representative

Référence de publication: 2010077608/1273/127.

Joya-Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 12, rue de Hesperange.

R.C.S. Luxembourg B 137.785.

Le Bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010060900/9.
(100075674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2010.

Internationale Forêt Noire S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 21.728.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu mercredi <i>21 juillet 2010 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société en «INTERNATIONALE FORET NOIRE S.A. S.P.F.» et modification

de l'article premier des statuts.

2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social comme

suit: «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que
définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial
(«SPF»).»

65909

L

U X E M B O U R G

3. Modification de l'article 5.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010085382/1267/19.

Nord Europe Patrimonium, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.785.

L'Assemblée du 16 juin 2010 n'ayant pas obtenu le quorum de présence requis, le Conseil d'Administration a l'honneur

de convoquer les Actionnaires de la Sicav NORD EUROPE PATRIMONIUM, à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>  2 1 juillet 2010   à 10.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Modification de la dénomination sociale de la Sicav en UFG-LFP FUNDS

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Des procurations sont disponibles au siège
social de la Sicav. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins
cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501) de leur intention
d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2010073855/755/17.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

ISIN: XS0291838992
ISIN: XS0291840626

On May 19, 2010, the Paris Commercial court approved the safeguard plan presented by the Company (the "Safeguard

Plan"). This plan had been rejected by the majority of all the Bond issues on April 28, 2010 considering that the Safeguard
Plan underestimates the maximum liability due to bondholders by € 145,063,500.69 and due to the bondholders of this
issue by € 58,976,984.36 and that, based on the amount estimated by bondholders of the maximum liability due do them,
the cash flow projections of the Safeguard Plan show that, for a number of years during the Safeguard Plan, the Company
will not have enough resources to repay the amounts due to bondholders. Consistent with his duty to act in order to
protect the interests of the bondholders, the Bondholder Representative thus lodged a preventive third party claim
("tierce opposition") against the Safeguard Plan on May 28, 2010. The Bondholder Representative now wishes to convene
a general meeting of bondholders to resolve upon the third party claim ("tierce opposition") against the Safeguard Plan.
As of today, the decision of the court is still not available; the Bondholder Representative thus decides to cancel the
General Meeting initially convened on June 29, 2010, and decides to convene a new

GENERAL MEETING

<i>July 15, 2010 at 12.00 CET.
A general meeting of the holders of the bonds registered under ISIN code: XS0291838992 and XS0291840626 (the

"Bonds 2014") as described in the Prospectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on March
28, 2007 of € 175.000.461,60, 2.5 per cent bonds with redeemable warrants attached due March 28, 2014 at an issue
price: 97,10 per cent, represented by 119.544 bonds of € 1421,45 each, for which a visa on the prospectus was delivered
by the CSSF (the "Prospectus"), will thus be held at 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, on July 15, 2010 at 12.00
Central European time ("CET") (the "Meeting"). The Meeting will be held in order to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the third party claim ("tierce opposition") of the Bondholder Representative against the Safeguard Plan

and of his powers in this respect and assumption of the costs in connection with challenging the Safeguard Plan.

2. Miscellaneous.
The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the  disposal  of  the  holders  of  Bonds  2014  from  June  25,  2010  on  request  either  with  the  Company  on
www.orcogroup.com or with the Bondholders Representative by email at lleroi@pt.lu.

Copies of the Prospectus, the Safeguard Plan and the articles of association of the Company are available on the

Company's website at http://www.orcogroup.com and at the registered office of the Company upon request.

65910

L

U X E M B O U R G

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2014 of the Company; the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2014 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent (Bank of New York, Brussels Branch, Avenue des Arts, 35, B-1040
Brussels (Belgium)) can attend and vote at any meeting. The Company and its legal advisors, as well as its respective
financial advisors and such other persons as may be accepted by the meeting, may attend and speak at the meeting. Any
instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and effective
for an adjourned Meeting. Beneficial Owner who took no action in respect of the Meeting can give instructions for the
adjourned Meeting by following the same procedure.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended, the

quorum at the General Meeting for passing the above resolutions is a simple majority of the votes cast by the represented
Bondholders. No quorum is required for the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that a simple majority of the Bondholders represented

at the Meeting can take valid resolutions that will validly bind all the Bondholders (even those not represented at the
meeting). Notably, Article 94-5 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended provides that
when a Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the law of 10th August, 1915
on commercial companies as amended, Bondholders may no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2014, the Bonds 2014 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream
Luxembourg"), through which transactions in the Bonds 2014 are effected.

All of the Bonds 2014 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2014, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Bondholders may also allow their voting right in the Bondholders meeting to be exercised by an authorized repre-

sentative, e.g. allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2014 in order
to procure delivery of their voting instructions if any via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying
Agent prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be 14h30 CET (the "Expiration Time") of July 12 (the "Expiration Date"). The Company has

the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2014, it shall not release the

Bond 2014 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions if any to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial
Owners are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2014 will be blocked until the conclusion of the Meeting or the adjourned Meeting. This means that it may
not be possible to sell such Bonds 2014 until the conclusion of the Meeting or any adjourned Meeting.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and

effective for the adjourned Meeting. Beneficial Owners who took no action in respect of the Meeting can give instructions
for the adjourned Meeting by following the same procedure set forth above.

For the purposes of this Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours, respectively,

including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant meeting is to
be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this purpose the
day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the extent necessary,
more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which banks are open
for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from June 25, 2010 to July 12, 2010.
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is July 12, 2010.

65911

L

U X E M B O U R G

Last deadline for revocation, for cancellation or changes is July 12, 2010.
3. Contact

The Bondholder representative
Luc Leroi
13A, rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen
Email: lleroi@pt.lu

The Paying Agent
Bank of New York, Brussels Branch,
Avenue des Arts, 35, B-1040 Brussel
Tel: +32 2 326 12 11
Email: latoya.austin@bnymellon.com

The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. M. Ralf Limburg
Tel: +352 26 47 67 1
Fax: +352 26 47 67 67
Email: rlimburg@orcogroup.com

Eischen June 11, 2010.

Luc Leroi.

Référence de publication: 2010077609/1273/114.

Lux-Protect Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 110.989.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le

jeudi <i>15 juillet 2010 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31

mars 2010.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2010; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010078458/755/29.

65912

L

U X E M B O U R G

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 40, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

FR0010249599

On May 19, 2010, the Paris Commercial court approved the safeguard plan presented by the Company (the "Safeguard

Plan"). This plan had been rejected by the majority of all the Bond issues on April 28, 2010 considering that the Safeguard
Plan underestimates the maximum liability due to bondholders by € 145,063,500.69 and due to the bondholders of this
issue by € 34,795,035.83 and that, based on the amount estimated by bondholders of the maximum liability due do them,
the cash flow projections of the Safeguard Plan show that, for a number of years during the Safeguard Plan, the Company
will not have enough resources to repay the amounts due to bondholders. Consistent with his duty to act in order to
protect the interests of the bondholders, the Bondholder Representative thus lodged a preventive third party claim
("tierce opposition") against the Safeguard Plan on May 28, 2010. The Bondholder Representative now wishes to convene
a general meeting of bondholders to resolve upon the third party claim ("tierce opposition") against the Safeguard Plan.
As of today, the decision of the court is still not available; the Bondholder Representative thus decides to cancel the
General Meeting initially convened on June 29, 2010, and decides to convene a new

GENERAL MEETING

<i>July 15, 2010

 at 11.00 CET.

A general meeting of the holders of the bonds registered under ISIN code: FR0010249599 (the "Bonds 2010") as

described in the Prospectus (as defined below) issued by the Company in relation to the issue on March 28, 2007 of €
50,272,605.30, 4.5 per cent bonds with redeemable share subscription warrants attached due November 18, 2005 at an
issue price: € 686.10, represented by 73,273 bonds with a par value of € 686.10, for which the visa on the prospectus
was delivered by the CSSF on November 14, 2005 (the "Prospectus"), will thus be held at 24, rue Saint Mathieu, L-2138
Luxembourg, on July 15, 2010 at 11.00 Central European time ("CET") (the "Meeting"). The Meeting will be held in order
to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the third party claim ("tierce opposition") of the Bondholder Representative against the Safeguard Plan

and of his powers in this respect and assumption of the costs in connection with challenging the Safeguard Plan.

2. Bondholders representative remuneration.
3. Miscellaneous.
The voting certificate, hereinafter mentioned, necessary to be represented and participate at the Meeting shall be at

the disposal of the holders of Bonds 2010 from June 25, 2010 on request with the Company on www.orcogroup.com or
with the Bondholder's representative (contact lleroi@pt.lu).

Copies of the Prospectus, the Safeguard Plan and the articles of association of the Company are available on the

Company's website at http://www.orcogroup.com and at the registered office of the Company upon request.

The Bondholder's representative would like to point out that for holders of Bonds 2010 of the Company; the conditions

for attendance or representation at the Meeting are as follows:

1. Authorization to participate
As mentioned in the Prospectus, holders of Bonds 2010 ("Bondholders"), and proxies showing a voting certificate and

register of voting certificates issued by the Paying Agent CACEIS Corporate Trust can attend and vote at any meeting.
The Company and its legal advisors, as well as its respective financial advisors and such other persons as may be accepted
by the meeting, may attend and speak at the meeting. Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy
given by a Beneficial Owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting. Beneficial Owner who took no action
in respect of the Meeting can give instructions for the adjourned Meeting by following the same procedure.

2. Participation in and Voting at the Meeting
In accordance with Article 94-2 and 94-3 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended, the

quorum at the General Meeting for passing the above resolutions is a simple majority of the votes cast by the represented
Bondholders. No quorum is required for the Meeting.

The attention of Bondholders is particularly drawn to the fact that a simple majority of the Bondholders represented

at the Meeting can take valid resolutions that will validly bind all the Bondholders (even those not represented at the
meeting). Notably, Article 94-5 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended provides that
when a Bondholder representative has been appointed in accordance with the provisions of the law of 10th August, 1915
on commercial companies as amended, Bondholders may no longer exercise their rights individually.

As is customary for securities such as the Bonds 2010, the Bonds 2010 are generally held through banks or other

financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, Euroclear Bank
S.A./N.V., as operator of the Euroclear System ("Euroclear") and Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream
Luxembourg"), through which transactions in the Bonds 2010 are effected.

65913

L

U X E M B O U R G

All of the Bonds 2010 are represented by a bearer global bond (the "Global Bond"). The Global Bond is presently held

by a common depositary for Euroclear and Clearstream Luxembourg.

Each person (a "Beneficial Owner") who is the owner of a particular principal amount of the Bonds 2010, through

Euroclear, Clearstream Luxembourg or their respective account holders with Euroclear or Clearstream Luxembourg
(the "Accountholders"), should be entitled to attend and vote at the Meeting in accordance with the procedures set out
below.

Voting instructions may be delivered only through direct Accountholders with the type of vote: in favour of / against /

abstain from the proposed resolution mentioned in the Agenda and by stating the Principal Amount of Bonds 2010. A
splitting of the resolutions is not accepted.

In order to obtain a voting certificate or instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting

(or any adjourned Meeting, as the case may be) in accordance with a Bondholder's instructions, an Accountholder must
procure delivery of an electronic voting instruction, in accordance with the procedures of Euroclear or Clearstream
Luxembourg, to the relevant Paying Agent prior to the Expiration Time on the Expiration Date all of them as defined
below.

If a Bondholder is not wishing to attend and vote at the Meeting or any adjourned such Meeting in person, he can

instruct the Paying Agent to appoint a proxy to attend and vote at the meeting or any adjourned such Meeting on his
behalf with the type of vote: in favour of / against / abstain from the proposed resolution. A splitting of the resolutions is
not accepted.

Bondholders may also allow their voting right in the Bondholders meeting to be exercised by an authorized repre-

sentative, e.g. allow another person of their choice to act as proxy. The authorizations must be issued in writing.

Beneficial Owners who are not Accountholders must arrange through their broker, dealer, commercial bank, custo-

dian, trust company or other nominee to contact the Accountholder through which they hold their Bond(s) 2010 in order
to procure delivery of their voting instructions via Euroclear or Clearstream, Luxembourg to the relevant Paying Agent
prior to the Expiration Time on the Expiration Date.

The expiration time shall be 14h30 CET (the "Expiration Time") of July 12, 2010 (the "Expiration Date"). The Company

has the right to postpone the Expiration Date; in that case, notice of such postponement shall be given to the Bondholders.

Once the Paying Agent has issued a voting certificate for a meeting in respect of a Bonds 2010, it shall not release the

Bond 2010 until either (i) the meeting has been concluded or (ii) the voting certificate has been surrendered to the Paying
Agent. A vote cast in accordance with a block voting instruction may not be revoked or altered during the 48 hours
before the time fixed for the meeting.

Beneficial Owners should note that they must allow sufficient time for compliance with the standard operating pro-

cedures of Euroclear and Clearstream Luxembourg and, if applicable, such Accountholder in order to ensure delivery of
their voting instructions to the Paying Agent in accordance with the time-frame set out in this Notice. Beneficial Owners
are urged to contact any such person promptly to ensure timely delivery of such voting instructions.

Once instructions to participate in the Meeting or to vote by proxy have been given, the Beneficial Owner's interest

in the Bonds 2010 will be blocked until the conclusion of the Meeting or the adjourned Meeting. This means that it may
not be possible to sell such Bonds 2010 until the conclusion of the Meeting or any adjourned Meeting.

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and

effective for the adjourned Meeting. Beneficial Owners who took no action in respect of the Meeting can give instructions
for the adjourned Meeting by following the same procedure set forth above.

For the purposes of this Notice, "48 hours" and "24 hours" shall mean a period of 48 hours or 24 hours, respectively,

including all or part of a day upon which banks are open for business in both the place where the relevant meeting is to
be held and in each of the places where the Paying Agent have their specified offices (disregarding for this purpose the
day upon which such meeting is to be held) and such period shall be extended by one period or, to the extent necessary,
more periods of 24 hours or 48 hours until there is included as aforesaid all or part of a day upon which banks are open
for business as aforesaid.

The period to give instructions is scheduled from June 25, 2010 to July 12, 2010.
Last deadline to receive the Electronic Voting Instruction is July 12, 2010.
Last deadline for revocation, for cancellation or changes is July 12, 2010.
3. Contact

The Bondholder representative
Mr Luc Leroi
13A, rue de Clairefontaine
L-8460 Eischen
Email: lleroi@pt.lu

The Paying Agent
CACEIS Corporate Trust

65914

L

U X E M B O U R G

Service assemblées
14, rue du Rouget de Lisle, F-92889 Issy les Moulineaux
Fax: +33 1.49.08.05.82
Email: gisele.gresle@caceis.com

The Company
ORCO PROPERTY GROUP, 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Att. M. Ralf Limburg
Tel: +352 26 47 67 1
Fax: +352 26 47 67 67
Email: rlimburg@orcogroup.com

Eischen June 24, 2010.

Luc Leroi
<i>Bondholder representative

Référence de publication: 2010077610/1273/129.

Stanley Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 88.828.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mardi <i>13 juillet 2010 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2009.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
Référence de publication: 2010078459/1267/15.

Tower Fund, Fonds Commun de Placement.

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS DU

FONDS COMMUN DE PLACEMENT TOWER FUND

Il est porté à la connaissance des porteurs de parts que le Conseil d'Administration de la Société de Gestion de TOWER

FUND à décidé de fusionner le compartiment TOWER FUND - GLOBAL VALUE EQUITY dans le compartiment TO-
WER FUND - GLOBAL EQUITY avec effet au 12 août 2010. Les parts seront échangées sur la base du rapport d'échange
des valeurs nettes d'inventaire des compartiments concernés au dernier jour d'évaluation précédant immédiatement la
fusion.

Cette fusion se justifie principalement par le fait que les actifs du compartiment TOWER FUND - GLOBAL VALUE

EQUITY sont en-dessous d'un seuil jugé adéquat par la Société de Gestion pour le fonctionnement et la gestion efficace
de ce compartiment dans l'intérêt des investisseurs.

Du 6 juillet 2010 au 6 août 2010, il sera permis de demander le rachat de leurs parts sans frais aux porteurs de parts

qui manifestent leur propre volonté d'être remboursés à cause de la fusion envisagée. En outre, à partir du 6 août 2010,
plus aucune nouvelle souscription ni conversion ne sera acceptée dans TOWER FUND - GLOBAL VALUE EQUITY.

Luxembourg, le 5 juillet 2010.

TOWER MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>La Société de Gestion

Référence de publication: 2010082641/275/20.

SEB Optimix, Fonds Commun de Placement.

Sondervermögen, verwaltet von der SEB Asset Management S.A., mit Sitz in 6A, Circuit de la Foire Internationale,

L-1347 Luxembourg, eingetragen in Handelsregister unter der Nummer B 28.468.

Das Verwaltungsreglement des SEB Optimix (Stand: Juni 2010) wurde im Juli 2010 beim Handelsregister hinterlegt.

65915

L

U X E M B O U R G

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Asset Management S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft

Référence de publication: 2010083839/11.
(100093711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2010.

Coogee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 153.824.

In the year two thousand ten, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Manly S.A., a société anonyme, with registered office at 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered

with the Luxembourg trade and Commerce Register (R.C.S Luxembourg) under number B 153.777,

here represented by Mr John PENNING, employee, residing at 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel,
by virtue of a proxy given on the 24 

th

 day of June, 2010.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of COOGEE S.à.r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée),

registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 153.824, constituted by a deed of the
undersigned notary on the 18 

th

 day of June, 2010, not yet published;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of FOUR HUNDRED EIGHTY SEVEN

THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (487,500.- EUR) in order to bring it from its present amount of TWELVE THOU-
SAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) to FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (500,000.- EUR) by the issuance
of FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY-FIVE (4,875) new shares with a par value of ONE HUNDRED
EURO (100.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder, represented as stated hereabove, declares to subscribe for the FOUR THOUSAND EIGHT

HUNDRED SEVENTY-FIVE (4,875) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount
of FOUR HUNDRED EIGHTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (487,500.- EUR) is from now on at the
disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of

incorporation, which will henceforth have the following wording:

“ Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (500,000.-EUR), repre-

sented by FIVE THOUSAND (5,000) shares of ONE HUNDRED EURO (100.-EUR) each.”

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to fix the number of managers at five and to appoint two new managers for an unlimited

period:

1) Mr Claude MACK, administrateur de sociétés, born on the 29 

th

 day of July 1968 in Luxembourg, residingat L-8123

Bridel, 13, bei den 5 Buchen;

2) Mr Marc SMIT, employee, born on the 20 

th

 day ofJune 1972 in Düsseldorf (Germany), residing at GroteBickersstraat,

27, 1013 KN Amsterdam (The Netherlands).

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately ONE THOUSAND EIGHT
HUNDRED EURO (1,800.- EUR).

65916

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Manly S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri, imma-

triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S Luxembourg) sous le numéro B 153.777,

ici représentée par Monsieur John PENNING, employé, demeurant à L-8131 Bridel, 53, rue des Genêts,
en vertu d'une procuration datée du 24 juin 2010.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée COOGEE S.à.r.l., une société, enregistrée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153.824, constituée suivant acte du notaire instrumentant
en date du 18 juin 2010, encore non publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT SEPT

MILLE CINQ CENTS EUROS (487,500.- EUR) pour porter son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12.500.- EUR) à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.- EUR) par l'émission de QUATRE MILLE HUIT CENTS SOIXAN-
TEQUINZE (4.875) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associée unique déclare souscrire les QUATRE MILLE HUIT CENTS SOIXANTE-QUINZE (4.875) parts sociales

nouvelles et les libérer moyennant apport en espèces de sorte que le montant de QUATRE CENT QUATRE-VINGT
SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (487.500.- EUR) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été
donnée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000.- EUR), représenté par CINQ MILLE (5.000)

parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide d’augmenter le nombre de gérants à cinq et de nommer deux gérants nouveaux pour une

durée indéterminée:

1) Monsieur Claude MACK, administrateur de sociétés, né le 29 juillet 1968 à Luxembourg, demeurant à L-8123 Bridel,

13, bei den 5 Buchen;

2) Monsieur Marc SMIT, employé, né le 20 juin 1972 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Grote Bickersstraat, 27,

1013 KN Amsterdam (Pays-Bas).

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

65917

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. PENNING, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 juin 2010. Relation: LAC/2010/28311. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 28 juin 2010.

Référence de publication: 2010080929/109.
(100091702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

Fi Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 29.479.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le jeudi 6 mai 2010 au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

L’Assemblée décide de nommer en qualité d'Administrateurs:
- M. Vincenzo Montano, Président du Conseil d'Administration et Administrateur, demeurant professionnellement au

25A, Boulevard Royal, 1 

er

 étage, L-2449 Luxembourg.

- M. Thierry Hubert, Administrateur, demeurant professionnellement au 25A, Boulevard Royal, 1 

er

 étage, L-2449

Luxembourg.

- M. Claude Weber, Administrateur, demeurant professionellement au 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance à l’expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2011 qui aura à statuer sur les

comptes de l’exercice social de 2010.

L’Assemblée décide de nommer comme réviseur indépendant: Deloitte S.A 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance à l’expiration à l’issue de l’Assemblée Générale de 2011 qui aura à statuer sur les comptes
de l’exercice social de 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010060401/23.
(100075279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

General Electric International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.439.480,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 62.841.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 31 mai 2010 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de M. Roeland Pels, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 21 janvier 2010.
- Mme Marjoleine Van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élue nouveau

gérant B de la société avec effet au 21 janvier 2010 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 31 mai 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010060407/15.
(100075326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

65918

L

U X E M B O U R G

Lancelot Ector, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 54.040.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 avril 2010

L'assemblée générale ordinaire a décidé de:
- renouveler les mandats d'administrateurs de tous les membres actuels du conseil d'administration pour une période

prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011, de sorte que le conseil d'administration de la Société
se compose des personnes suivantes:

Monsieur Tobias Järnblad avec adresse professionnelle à S-103 23 Stockholm, Nybrokajen 7, président du conseil

d'administration

Monsieur Per Ljungberg avec adresse professionnelle à S-103 23 Stockholm, Nybrokajen 7,
Monsieur Jean-Claude Wolter avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 35 avenue J-F Kennedy
-  nommer  PricewaterhouseCoopers  S.à  r.l.,  400  route  d'Esch,  L-1471  Luxembourg,  comme  réviseur  indépendant

d'entreprises. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010060425/20.
(100075272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Wampum, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.131.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 avril 2010 à 11.30 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de M. Koen LOZIE, 61, Grand-Rue, L-8510

Redange-sur-Attert et COSAFIN S.A., représentée par M. Jacques BORDET, Administrateurs et de M. Pierre SCHILL,
Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer M. Joseph WINANDY, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig, en

qualité d'Administrateur en remplacement de M. Jean QUINTUS.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.

Pour copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010076756/19.
(100070282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Exzentric S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.469.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010060874/10.
(100075673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2010.

Manly S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 153.777.

In the year two thousand ten, on the twenty-fifth day of June.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

65919

L

U X E M B O U R G

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Manly S.A.", a société anonyme, having its registered

office in Luxembourg, constituted by a notarial deed of the undersigned notary, on June 9, 2010, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mr Carlo NOEL, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Ms Romina LEIBOFF, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr John PENNING, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of SIX HUNDRED FIVE THOUSAND THREE HUNDRED EURO

(605,300.-  EUR)  to  bring  it  from  its  present  amount  of  THIRTY  TWO  THOUSAND  EURO  (32,000.-  EUR)  to  SIX
HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED EURO (637,300.- EUR) by the issuance of SIX THOU-
SAND FIFTYTHREE (6.053) new shares with a par value of EUR 100.- each, having the same rights and obligations as the
existing shares.

2. Subscription of this capital increase and payment by contribution in cash together with a share premium of two

hundred fifty seven euros and seventy-three cents (257,73.- EUR) per share for a total amount of TWO MILLION ONE
HUNDRED  SIXTY-FIVE  THOUSAND  THREE  HUNDRED  THIRTY-NINE  EUROS  AND  SIXTY-NINE  CENTS
(2,165,339,69.- EUR) by

- Saphir S.A.: 3840 shares
- CM Participation: 1515 shares
- Mr Schneider: 698 shares.
3. Amendment of article 5, first paragraph, of the articles of association.
4. Appointment of two new directors.
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting has decided to increase the subscribed capital by an amount of SIX HUNDRED FIVE THOUSAND

THREE HUNDRED EURO (605,300.- EUR) to bring it from its present amount of THIRTY TWO THOUSAND EURO
(32,000.- EUR) to SIX HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED EURO (637,300.- EUR) by the
issuance of 6053 new shares with a par value of EUR 100.- each, having the same rights and obligations as the existing
shares together with a share premium of two hundred fifty seven euros and seventy-three cents (257,73.- EUR) per share
for a total amount of TWO MILLION ONE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-NINE
EUROS AND SIXTY-NINE CENTS (2,165,339,69.-EUR).

<i>Second resolution

This increase of capital has been fully paid up by payment in cash by the actual sole shareholder as well as by the new

shareholders.

<i>Intervention-Subscription - Payment

Thereupon intervenes:
A) Saphir Capital Partners S.A., a “Société Anonyme”, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard

Prince Henri, R.C.S. Luxembourg B 150.152,

here represented by Mr John PENNING, prenamed, by virtue of proxy given on 24 

th

 June, 2010,

declares to subscribe to three thousand eight hundred forty (3,840) new shares.
B) CM Participations SA, a company existing under the laws of Luxembourg under RCSL number B 94.724, having its

registered office at L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame,

here represented by Mr John PENNING, prenamed,
by virtue of proxy given on 22 

nd

 June 2010,

declares to subscribe to one thousand five hundred fifteen (1,515) new shares.

65920

L

U X E M B O U R G

C) Mr Pierre SCHNEIDER, born on the 14 

th

 day of June 1937 in Luxembourg, residing at 21, Gaston Diederich, L-1420

Luxembourg,

Here represented by Mr John PENNING, prenamed,
by virtue of proxy given on 22 

nd

 June, 2010,

declares to subscribe to six hundred ninety eight (698) new shares.
The shares have been fully paid up in cash, together with the share premium, so that the amount of TWO MILLION

ONE  HUNDRED  SIXTYFIVE  THOUSAND  THREE  HUNDRED  THIRTY-NINE  EUROS  AND  SIXTY-NINE  CENTS
(2,165,339,69.- EUR) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned
notary, by a bank certificate.

The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the appearing parties, the board of the meeting and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 5, first paragraph of the articles of incorporation, which will henceforth

have the following wording:

Art. 5. par 1. The corporate capital is set at SIX HUNDRED THIRTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED

EURO (637,300.- EUR) represented by SIX THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY THREE (6,373) shares with a
par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) each.”

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to appoint two new directors:
1) Mr Claude MACK, administrateur de sociétés, born on the 29 

th

 day of July 1968 in Luxembourg , residing at L-8123

Bridel, 13, bei den 5 Buchen;

2) Mr Marc SMIT, employee, born on the 20 

th

 day of June 1972 in Düsseldorf (Germany), residing at Grote Bickerstraat,

27, 1013 KN Amsterdam (The Netherlands).

Their terms of office will expire, together with the other three directors already in place, after the annual meeting of

shareholders of the year 2014.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand
six hundred EURO (2,600.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil dix, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Manly S.A.", avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte notarié en date du 9 juin 2010,encore non publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo NOEL, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Romina LEIBOFF, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John PENNING, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de SIX CENT CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS (605.300.-EUR) pour le porter

de son montant actuel de TRENTE DEUX MILLE EURO (32.000.- EUR) au montant de SIX CENT TRENTE -SEPT MILLE

65921

L

U X E M B O U R G

TROIS CENTS (637.300.- EUR) par l’émission de SIX MILLE CINQUANTE-TROIS (6.053) nouvelles actions d’une valeur
nominale de CENT EURO (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions existantes.

2. Souscription et contribution en numéraire de cette augmentation de capital , ensemble avec une prime d’émission

de deux cent cinquante-sept euros et soixante-treize centimes par action, soit une montant total de DEUX MILLIONS
CENT SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTENEUF CENTIMES (2.165.339,
69.- EUR) par:

- Saphir S.A.: 3.840 actions
- CM Participation: 1.515 actions
- M. Schneider: 698 actions

3. Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1 

er

 des statuts.

4. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de SIX CENT CINQ MILLE TROIS CENTS EUROS (605.300.- EUR)

pour le porter de son montant actuel de TRENTE DEUX MILLE EURO (32.000.- EUR) au montant de SIX CENT TRENTE
-SEPT MILLE TROIS CENTS (637.300.- EUR) par l’émission de SIX MILLE CINQUANTETROIS (6.053) nouvelles actions
d’une valeur nominale de CENT EURO (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les
actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'augmentation de capital a été entièrement libérée en espèces par l’unique actionnaire actuel, ainsi que les nouveux

actionnaires.

<i>Intervention-Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
A) Saphir Capital Partners SA, une société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, enregistrée au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.152

ici représentée par Monsieur John PENNING, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24

juin 2010,

laquelle déclare souscrire trois mille huit cent quarante (3.840) actions nouvelles.
B) CM Participations SA, une société anonyme enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B 94.724, ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame,

ici représentée par Monsieur John PENNING, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22

juin 2010,

laquelle déclare souscrire soixante mille (1.515) actions nouvelles.
C) Monsieur Pierre SCHNEIDER, né le 14 juin 1937 à Luxembourg, demeurant à L-1420 Luxembourg, 21, Gaston

Diederich,

lequel déclare souscrire six cent quatre-vingt dix-huit (698) actions nouvelles.
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de DEUX MILLIONS

CENT SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTENEUF CENTIMES (2.165.339,
69.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant
au moyen d’un certificat bancaire.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, par les membres du bureau ainsi que

par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

65922

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. par 1. Le capital social est fixé à SIX CENT TRENTE -SEPT MILLE TROIS CENTS (637.300.- EUR) représenté

par SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE (6.373) actions d’une valeur nominale de CENT EURO (100.- EUR)
chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nominer deux nouveaux administrateurs:
1) Monsieur Claude MACK, administrateur de sociétés, né le 29 juillet 1968 à Luxembourg, demeurant à L-8123 Bridel,

13, bei den 5 Buchen;

2) Monsieur Marc SMIT, employé, né le 20 juin 1972 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Grote Bickerstraat, 27,

1013 KN Amsterdam (Pays-Bas).

Leur mandat expirera, ensemble avec trois autres administrateurs déjà en place, après l’assemblée générale annuelle

de 2014.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ DEUX MILLE SIX CENTS EURO
(2.600.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: C. NOEL, R. LEIBOFF, J. PENNING, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 juin 2010. Relation: LAC/2010/28309. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé) F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 28 juin 2010.

Référence de publication: 2010081081/198.
(100091703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2010.

Maxpama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 123.850.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 28/05/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010060913/10.
(100075660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juin 2010.

M&amp;L Global SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 149.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010078316/9.
(100070246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

65923

L

U X E M B O U R G

Ksar Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 137.190.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 18 décembre 2009

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Charles CHURET comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010076751/14.
(100070265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Caufort Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 89.552.

Au Gérant et aux actionnaires de la société CAUFORT LUXEMBOURG S à R L, RCS B 89.552
Je tiens par la présente à vous faire part de ma décision de dénoncer avec effet à la date de la présente le contrat de

domiciliation conclu.

Luxembourg, le 19 mai 2010.

Maître Joë LEMMER.

Référence de publication: 2010076669/10.
(100070499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Ligabue Immobiliare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 135.922.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 5 mai 2010 à 13.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Joseph WINANDY et de COSAFIN S.A.

administrateurs pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Koen LOZIE né le 24 juin 1965 et demeurant 61, Grand-Rue L-8510 Redange

sur Attert pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2010.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer la société The Clover avec siège social à 8, rue haute L-4963 Clemency,

immatriculée au RCS Luxembourg n° B 149.293 au poste de Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance
lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2010

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010076752/18.
(100070268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Tinfos Nizi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 69.587.

In the year two thousand and ten, on the seventeenth day of the month of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

«TINFOS LUXEMBOURG S.A.», a société anonyme, incorporated and existing under Luxembourg Law, registered in

the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 48.213, established and having its registered office
at 89E, rue Pafebruch, L-8308 Capellen,

here represented by:
Mr Gjermund RØYNESTAD, company director, with professionnal address at 89E, rue Pafebruch, Capellen,

65924

L

U X E M B O U R G

by virtue of a proxy given in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg,
on 11 June 2010,
which proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of “TINFOS NIZI S.A.” (the “Company”), a “société anonyme”, registered

in the Luxembourg Company Register under section B number 69.587 and having its registered office at 89E, rue Pafe-
bruch, L-8308 Capellen.

The Company was incorporated by a notarial deed of 27 April 1999, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, number 516 of 7 July 1999. The articles of Incorporation of the Company have been amended for the
last time pursuant a notarial deed of the undersigned notary on 3 June 2010, its publication in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, pending, in which notarial deed it has been decided to change, as per 21 June 2010, the
corporate name of the Company from “TINFOS NIZI S.A.” to “NIZI INTERNATIONAL S.A.”.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Com-

pany fixed currently at TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (2’500’000.- EUR), required the under-
signed notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder RESOLVES to increase the subscribed share capital of the Company by an aggregate amount of

TWENTY-FIVE MILLION EURO (25’000’000.- EUR) in order to increase the share capital from its current amount of
TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (2’500’000.- EUR) divided into one hundred thousand (100’000)
shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each up to an amount of TWENTY-SEVEN MILLION FIVE
HUNDRED THOUSAND EURO (27’500’000.- EUR) to be divided into one million one hundred thousand (1’100’000)
shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) per share.

<i>Second resolution

The sole shareholder RESOLVES to issue one million (1’000’000) new fully paid-up shares with a par value of TWENTY-

FIVE EURO (25.- EUR) per share, each share having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to
dividends as from the day of the acknowledgment of present shareholder’s resolutions.

<i>Third resolution

The sole shareholder RESOLVES to subscribe, in his own name, the one million (1’000’000) newly issued shares by

the Company, with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each and to fully pay up the same shares by means
of a contribution in kind consisting in part of a subordinated loan (25’000’000.- EUR) in a aggregate amount of THIRTY-
ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND EURO (31’200’000.- EUR) arising from the sole shareholder’s loan
agreement for a subordinated loan granted previously to the Company.

In conformity with article 32-1 (5) of the Law of August 10, 1915, as amended, said claim has been dealt with a report

established by “MAZARS”, a company (société anonyme) with registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg, and signed by Mr Joseph HOBSCHEID, réviseur d’entreprises, on 17 June 2010, which concludes as follows:

«Based on our work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of

the contribution in kind is not a least equal to the number and nominal value of shares to be issued in return.”

Said report, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder RESOLVES to amend Article five (5) first paragraph of the Articles of Incorporation of the

Company, to give such first paragraph henceforth the following new wording:

Art. 5. (First paragraph). “The subscribed corporate capital of the company is fixed at TWENTYSEVEN MILLION FIVE

HUNDRED THOUSAND EURO (27’500’000.- EUR) represented by one million one hundred thousand (1’100’000)
shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each.”

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

the present deed are estimated at approximately at six thousand three hundred euro.

Whereof the present deed is drawn up in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

65925

L

U X E M B O U R G

This deed having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, said proxy holder signed together with the Notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille dix, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«TINFOS LUXEMBOURG S.A.», une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, enregistrée

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section B numéro 48.213, établie et ayant son siège
social au 89E, rue Pafebruch, L-8308 Capellen,

ici représentée par:
Monsieur Gjermund RØYNESTAD, directeur de société, avec adresse professionnelle au 89E, rue Pafebruch, Capellen,
en vertu d'une procuration donnée à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 juin 2010,
laquelle procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’actionnaire unique de «TINFOS NIZI S.A.» (la «Société»), enregistrée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 69.587 et ayant son siège social au 89E, rue Pafebruch, L-8308
Capellen.

La  Société  a  été  constituée  suivant  acte  notarié  du  27  avril  1999,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations, numéro 516 du 7 juillet 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié
dressé par le notaire soussigné en date du 3 juin 2010, sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
étant en cours et dans lequel acte il fut décidé de changer, avec effet au 21 juin 2010, la dénomination sociale de la Société
de «TINFOS NIZI S.A.» en celle de «NIZI INTERNATIONAL S.A.».

Laquelle partie comparante, représentée comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social

de la Société fixé actuellement à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2'500'000.- EUR), a requis le notaire
instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique a DECIDÉ d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant total

de VINGT-CINQ MILLIONS D’EUROS (25'000'000.- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel
de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2'500'000.- EUR) divisé en cent mille (100'000) actions d’une valeur
nominale de VINGTCINQ EUROS (25.- EUR) chacune, à un montant de VINGT-SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE
EUROS (27'500'000.- EUR) qui sera divisé en un million cent mille (1'100'000) actions d’une valeur nominale de VINGT-
CINQ EUROS (25.- EUR) par action.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique a DECIDÉ d’émettre un million (1'000'000) d’actions nouvelles intégralement libérées d’une valeur

nominale de VINGTCINQ EUROS (25.- EUR) par action, chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la constatation des présentes résolutions de l’actionnaire
unique.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique a DECIDÉ de souscrire, pour son propre compte, les un million (1'000'000) actions nouvelles

d’une valeur nominale de VINGTCINQ EUROS (25.- EUR) chacune et de libérer entièrement ces mêmes actions nou-
vellement  émises  par  la  Société  au  moyen  d’un  apport  en  nature  consistant  en  partie  (25'000'000.-  EUR)  d’un  prêt
subordonné à hauteur d'un montant total de TRENTE ET UN MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (31'200'000.-
EUR) provenant d’un prêt accordé par l’actionnaire unique pour un prêt subordonné octroyée antérieurement en faveur
de la Société.

En conformité avec l’article 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, la dite créance a fait l’objet d’un

rapport, établi par la société «MAZARS», une société anonyme établie et ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt,
L-2530 Luxembourg et signé par Monsieur Joseph HOBSCHEID, réviseur d’entreprises, en date du 17 juin 2010, dont la
conclusion rédigée en langue anglaise est la suivante:

«Based on our work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of

the contribution in kind is not a least equal to the number and nominal value of shares to be issued in return.”

Le susdit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire unique a DECIDÉ de modifier consécutivement l’article cinq (5) premier alinéa des statuts de la Société

afin de donner à ce premier alinéa la nouvelle teneur suivante:

65926

L

U X E M B O U R G

Art.  5.  (Premier  alinéa).  «Le  capital  souscrit  est  fixé  à  VINGT-SEPT  MILLIONS  CINQ  CENT  MILLE  EUROS

(27'500'000.- EUR) représenté par un million cent mille (1'100'000) actions d’une valeur nominale de VINGT-CINQ
EUROS (25.- EUR) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge, en raison des présentes, sont estimés à approximativement six mille trois cents euros.

DONT ACTE, fait et passé à Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même parties comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. RØYNESTAD, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 juin 2010. Relation: EAC/2010/7476. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010079563/138.
(100090754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2010.

Dome S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 112.653.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2010 à 10.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide de nommer en tant que Membres du Conseil de Surveillance:
Monsieur Batcha Noordin, 39, rue Camille Pelletan, F-95190 Goussainville
Monsieur Stéphane Teyssier, La Navarre 52, allée Granados, F-13008 Marseille.
Monsieur Bruno Canihac, 6, impasse du Stade, F-13080 Luynes.
pour une période venant à échéance lors de l'approbation des comptes au 31.12.2010.

Pour copie conforme
Dome GP, Sàrl
<i>Gérant Commandité
Représentée par O. GASCHE
<i>Gérant

Référence de publication: 2010076753/18.
(100070273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Banque Transatlantique Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 31.730.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 avril 2010, acte n° 130 pardevant

Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320
L-2013 Luxembourg
<i>Notaire

Référence de publication: 2010077639/16.
(100070260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

65927

L

U X E M B O U R G

Kirchberg Services, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 55.034.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2010077641/12.
(100070319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

SES Digital Distribution Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 86.167.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2010077643/12.
(100070329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

EAVF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EAVF S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010077647/11.
(100070096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S., Société en Commandite

simple,

(anc. International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S. à r.l.).

Capital social: EUR 330.426.950,00.

Siège social: L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 79.233.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third day of December.
Before Maître Wersandt, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S.à

r.l.” (the “Company”), a private company with limited liability, having its registered office at 6, rue de Mamer, L-8081
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 79.233, incorporated by a notarial deed enacted by Me Joseph Elvinger, on the 30 

th

 November 2000, published

in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 458, page number 21056, lastly amended by a
notarial deed enacted on the 16 

th

 November 2009 by Me Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Receuil

Spécial des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs. Carole Soudier, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Jérémy Muszkatblit, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Sabine Belair, with professional address in Luxembourg.

65928

L

U X E M B O U R G

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. The list and

the proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain hereto annexed to be registered with this deed.

II.- As appears from the attendance list which has been checked by the scrutineer, who has confirmed the capacities

and the qualities of the shareholders of the Company and the validity of the power of attorney given by them under
private seal, the 13,217,078 (thirteen million two hundred seventeen thousand seventy-eight) shares, representing the
whole issued capital of the Company, are represented at this meeting so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>“Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgement of the resignation of the managers of the Company;
3. Waiving of the application to the Company of (i) the Holding 1929 company tax regime based on the law of the 31

st

 July 1929 and of (ii) the Billionaire Holding company tax regime based on the law of the 31 

st

 July 1929 and Arrêté

Grand-Ducal of the 17 

th

 December 1938;

4. Approval of the change of the legal form of the Company from a private limited company (“Société à responsabilité

limitée”) into a limited corporate partnership (“Société en commandite simple”) in accordance with the applicable legal
provisions with effective date as of 31 December 2009;

5. Approval of the change of name of the Company with effective date as of 31 December 2009;
6. Approval of the change of address of the registered office of the Company with effective date as of 31 December

2009;

7. Approval of the subsequent amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to

reflect the new legal form of the Company with effective date as of 31 December 2009;

8. Appointments of Mr. Kevin Berryman and Mr. Beth Ford as managers of the Company with effective date as of 31

December 2009; and

9. Miscellaneous.”
After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting, acknow-

ledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

It is unanimously resolved to acknowledge on their terms the resignations submitted by Mr. Rob Edelman, Mr. Robert

Anderson, Mr. Roger Blanken and Mr. Emilio Perez Carrilllo from their position of managers of the Company which shall
only take effect upon the effective date of the conversion of the Company by the shareholders, from a private limited
liability company (“Société à responsabilité limitée”) into a limited corporate partnership (“Société en commandite sim-
ple”) (the “Conversion”), releasing them from any responsibility that they have incurred during the performance of their
duties.

<i>Third resolution:

It is unanimously resolved to approve the waiving of the application to the Company of (i) the Holding 1929 company

tax regime based on the law of the 31 

st

 July 1929 and of (ii) the Billionaire Holding company tax regime based on the

law of the 31 

st

 July 1929 and Arrêté Grand-Ducal of the 17 

th

 December 1938.

<i>Fourth resolution:

It is unanimously resolved to change the legal form of the Company from a private limited liability company (“Société

à responsabilité limitée”) into a limited corporate partnership (“Société en commandite simple”) with effective date as of
31 December 2009. It is further unanimously resolved that International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings will be
the unlimited shareholder of the Company holding the 2,720,000 (two million seven hundred twenty thousand) unlimited
shares and that International Flavors &amp; Fragrances Worldwide (Gibraltar) Limited will be the limited shareholder of the
Company holding the 10,497,078 (ten million four hundred ninety-seven thousand seventy-eight) limited shares.

65929

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution:

It is unanimously resolved to change the name of the Company into International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar

Holdings (Luxembourg) S.C.S. with effective date as of 31 December 2009.

<i>Sixth resolution:

It is unanimously resolved, further to the change of legal form, mentioned above to amend and restate the articles of

association of the Company in order to make them complying with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable
to a Luxembourg “société en commandite simple” and to approve the current version of the articles of association of
the Company, the terms of which are reproduced hereafter with effective date as of 31 December 2009:

Amended and restated articles of association

of International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S.à r.l.

as at 31 December 2009

“Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a “société en commandite simple”, which will be governed by the laws pertaining to such entity

(hereafter the “Company”), and by current Luxembourg laws, in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

Art. 2. The Company has the following corporate object:
The Company’s purpose is to carry on a business together with a view to a profit. This business could involve to take

participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or
foreign companies or enterprises and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, liquidation, bankruptcy or

insolvency of any shareholder or manager.

The dissolution of the Company will require the unanimous consent of the shareholders of the Company.

Art. 4. The Company will have the name International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating unanimously.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by simple

decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares - Share premium

Art. 6. The share capital is fixed at EUR 330,426,950 (three hundred thirty million four hundred twenty-six thousand

nine hundred fifty Euros) represented by 13,217,078 (thirteen million two hundred seventeen thousand seventy-eight)
shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, divided into (i) 2,720,000 (two million seven hundred
twenty thousand) unlimited shares for International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings, the unlimited shareholder
(“commandité”) and (ii) 10,497,078 (ten million four hundred ninety-seven thousand sevety-eight) limited shares for
International Flavors &amp; Fragrances Worldwide (Gibraltar) Limited, a limited shareholder (“commanditaire”).

The capital may be changed at any time by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 15 of

the Articles.

Art. 7. Each unlimited and limited share confers identical voting rights in shareholders’ meetings.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. A shareholder may only hold
one class of shares, either limited or unlimited.

Art. 9. Unlimited shares are non transferable unless such transfer is agreed by all the unlimited shareholders and by

the majority of the limited shareholders by way of a resolution of the general meeting.

Limited shares are freely transferable among the limited shareholders.
Limited shares are non transferable to third parties unless such transfer is agreed by all the unlimited shareholders

and by the majority of the limited shareholders by way of a resolution of the general meeting.

Any transfer of unlimited or limited shares will be made performed under the conditions of article 21 of the Law.

65930

L

U X E M B O U R G

Liability of the shareholders

Art. 10. Subject to articles 16 and 152 of the Law, the unlimited shareholders are jointly and severally liable towards

third parties for all and any liabilities of the Company.

The limited shareholders are liable up to the amount of their capital contribution.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. The managers are appointed and dismissed by the general

meeting of shareholders upon the proposal made by the unlimited partner. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers.

The managers need not to be shareholders. They may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

Powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence

of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers to

one several ad hoc agents, which shall never be a limited partner of the Company.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Any manager does not contract in its or his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by such manager in the name of the Company; as a representative of the Company a manager is only responsible
for the execution of its or his mandate.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

members present or represented.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 1 (one) day in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of manager shall require the presence of two managers,

either present in person, by proxy or by representative, which shall form a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 14. The limited shareholders shall take no part in the management of the Company in the meaning of article 11

of the Articles, and shall have no right or authority to act for the Company or to take any part in or in anyway to interfere
in the management of the Company.

65931

L

U X E M B O U R G

General meetings of shareholders

Art. 15. Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Col-

lective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unanimous vote of the shareholders (limited and
unlimited), all present or represented.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year starts on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of each year.

Art. 17. At the end of each financial year, the Company's accounts are prepared and the manager, or in case of plurality

of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities. The inventory, balance sheet and the profit and loss account will be submitted to the approval of the
shareholders.

Art. 18. Each shareholder may inspect the above inventory, balance sheet and profit and loss account at the Company's

registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses, represent the net profit.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-

pany.

Art. 20. The shareholders, upon proposal of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers,

may decide to make interim distributions before the end of the current financial year on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the unlimited shareholder.
When the liquidation of the Company is closed, the proceeds of the Company will be attributed to the shareholders,

in proportion to their respective shareholdings.

Applicable Law

Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.”

<i>Seventh resolution:

It is unanimously resolved to approve the change of the address of the registered office of the Company from 6, rue

de Mamer, L-8081 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg to 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg as of 31 December 2009.

<i>Eighth resolution:

It is unanimously resolved to appoint as managers with effective date as of 31 December 2009:
- Mr. Kevin Berryman, with private or professional address at 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York,

the United States of America; and

- Mr. Beth Ford, with private or professional address at 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York, the

United States of America.

The managers shall serve for an undetermined duration. Mr. Kevin Berryman and Mr. Beth Ford, who having received

previous notice of their appointment, have accepted through a letter of acceptance, their position and assumed the
obligation to faithfully and properly carry out their duties for an undetermined duration.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which shall be charged to the Company in connection with

its conversion from a société anonyme into a société à responsabilité limitée, have been estimated at about EUR 3,500
(three thousand five hundred Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

65932

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-troisième jour de décembre.
Par-devant Maître Wersandt, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «International Flavors &amp; Fragrances Global Holding

S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 6, rue de Mamer, L-8081 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 79.233, constituée par acte pris par Me Joseph Elvinger, en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 458, page 21056, dernièrement modifié par acte pris par Me Joseph Elvinger
le 16 novembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Melle Carole Soudier, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire M. Jérémy Muszkatblit, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Melle Sabine Belair, avocate, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Rup-

pert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires de la Société et le nombre de parts sociales détenues par eux sont reflétés dans la liste de présence.

La liste et les procurations, signées par les personnes comparantes et le notaire, resteront ci-annexées afin d’être enre-
gistrées avec cet acte.

II.- Tel qu’il ressort de la liste de présence qui a été vérifiée par le scrutateur, qui a confirmé les capacités et les qualités

des associés de la Société et la validité de la procuration donnée par eux sous seing privé, les 13.217.078 (treize millions
deux cent dix-sept mille soixante-dix-huit) parts sociales, représentant la totalité du capital social émis de la Société, sont
représentés à cette assemblée de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du
jour dont les associés reconnaissent avoir été dûment informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>«Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Prise d’acte de la démission des gérants de la Société;
3. Renonciation à l’application à la Société du (i) régime fiscal des sociétés Holding 1929 basé sur la loi du 31 juillet

1929 et du (ii) régime fiscal des sociétés Milliardaires basé sur la loi du 31 juillet 1929 et le règlement grand-ducal du 17
décembre 1938;

4. Approbation du changement de forme juridique de la Société d’une société à responsabilité limitée à une société

en commandite simple conformément aux dispositions légales applicables avec effet au 31 décembre 2009;

5. Approbation du changement de dénomination de la Société avec effet au 31 décembre 2009;
6. Approbation du changement d’adresse du siège social de la Société avec effet au 31 décembre 2009;
7. Approbation de la modification subséquente et de la refonte des statuts de la Société afin de refléter la nouvelle

forme juridique de la Société avec effet au 31 décembre 2009;

8. Nominations de M. Kevin Berryman et M. Beth Ford en tant que gérants de la Société avec effet au 31 décembre

2009; et

9. Divers.»
Suite à l’approbation de ce qui précède par les associés de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à

cette assemblée générale, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour, considèrent être valablement
convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. De plus, il
a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition des associés dans un délai suffisant afin de leur
permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est unanimement décidé de prendre acte à leurs termes les démissions soumises par M. Rob Edelman, M. Robert

Anderson, M. Roger Blanken et M. Emilio Perez Carillo de leur poste de gérants de la Société qui prendront effet uni-
quement à compter de la date effective de la conversion de la Société par les associés, d’une société à responsabilité

65933

L

U X E M B O U R G

limitée en une société en commandite simple (la «Conversion»), les dégageant de leur responsabilité qu’ils ont encourue
durant l’exécution de leurs fonctions.

<i>Troisième résolution:

Il est unanimement décidé d’approuver la renonciation à l’application à la Société du (i) régime fiscal des sociétés

Holding 1929 basé sur la loi du 31 juillet 1929 et du (ii) régime fiscal des sociétés Milliardaires basé sur la loi du 31 juillet
1929 et le règlement grand-ducal du 17 décembre 1938.

<i>Quatrième résolution:

Il est unanimement décidé de changer la forme juridique de la Société d’une société à responsabilité limitée à une

société en commandite simple conformément aux dispositions légales applicables avec effet au 31 décembre 2009. Il est
encore unanimement décidé que International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings sera l’associé commandité de la
Société détenant 2.720.000 (deux millions sept cent vingt mille) parts sociales de commandité et que International Flavors
&amp; Fragrances Worldwide (Gibraltar) Limited sera l’associé commanditaire de la Société détenant 10.497.078 (dix millions
quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-dix-huit) parts sociales de commanditaire.

<i>Cinquième résolution:

Il est unanimement décidé de changer la dénomination sociale de la Société en International Flavors &amp; Fragrances

Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S. avec effet au 31 décembre 2009.

<i>Sixième résolution:

Il est unanimement décidé, suite au changement de forme juridique mentionné ci-dessus, de modifier et refondre les

statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables aux
sociétés en commandite simple et d’approuver la version actuelle des statuts de la Société dont les termes ont été
reproduits ci-après avec effet au 31 décembre 2009:

Statuts modifiés et refondus

d’International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S.à r.l.

à la date du 31 décembre 2009

«Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué une société en commandite simple régie par les lois concernant ce type d’entité (ci-après

la "Société"), et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), aussi bien que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. La Société a l’objet social suivant:
L'objet de la Société est de poursuivre une affaire en vue de faire du profit. Cette affaire pourrait impliquer de détenir

des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, indus-
trielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères,

d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et

de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts,
comme la Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en
tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute Société
les acquérant,

de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute

société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; finalement d’accomplir toute opération
qui est directement ou indirectement en relation avec son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de tout associé ou gérant ne mettent pas fin à la Société.
La dissolution de la Société requerra le consentement unanime des associés de la Société.

Art. 4. La Société aura pour dénomination International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré à toute autre place au Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant unanimement.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu dans la municipalité de la commune de Luxembourg

par simple décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

65934

L

U X E M B O U R G

Capital - Parts sociales - Prime d’émission

Art. 6. Le capital social est fixé à 330.426.950 EUR (trois cent trente millions quatre cent vingt-six mille neuf cent

cinquante Euros) représenté par 13.217.078 (treize millions deux cent dix-sept mille soixante-dix-huit) parts sociales
d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, divisé en (i) 2.720.000 (deux millions sept cent vingt mille)
parts sociales de commandité pour International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings, l’associé commandité et (ii)
10.497.078 (dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-dix-huit) parts de sociales de commanditaire
pour International Flavors &amp; Fragrances Worldwide (Gibraltar) Limited, un associé commanditaire.

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée des associés, conformément à l’article

15 des Statuts.

Art. 7. Chaque part sociale de commandité et de commanditaire confère des droits de vote identiques aux assemblées

des associés.

Art. 8. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, sachant qu’un seul détenteur est admis par

part sociale. Les co-détenteurs doivent nommer une seule personne en tant que représentant envers la Société. Un
associé peut uniquement détenir une classe de parts sociales, de commandité ou de commanditaire.

Art. 9. Les parts sociales de commandité sont non transmissibles à moins que ce transfert ne soit consenti par tous

les associés commandités et par la majorité des associés commanditaires par voie de résolution de l’assemblée générale.

Les parts sociales de commanditaire sont librement transmissibles parmi les associés commanditaires.
Les parts sociales de commanditaire sont non transmissibles aux tiers à moins que ce transfert ne soit consenti par

tous les associés commandités et par la majorité des associés commanditaires par voie de résolution de l’assemblée
générale.

Tout transfert de parts sociales de commandité ou de commanditaire sera fait sous les conditions de l’article 21 de la

Loi.

Responsabilité des associés

Art. 10. Sous réserve des articles 16 et 152 de la Loi, les associés commandités sont conjointement et solidairement

responsables envers les tiers pour toute dette de la Société.

Les associés commanditaires sont responsables jusqu’au montant de leur apport.

Gestion

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants sonr nommés et révoqués par l’assemblée générale

des associés sur proposition de l’associé commandité. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de
gérance.

Les gérants ne doivent pas forcément être associés. Ils peuvent être révoqués ad nutum.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de cet article auront été respectés.

Les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés tombent sous la

compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer tout ou partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc, qui ne sera jamais un associé commanditaire de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu)

de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements réguliè-

rement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des membres présents

ou représentés.

Une convocation à un conseil de gérance sera adressée à tous les gérants moins 1 (un) jour avant la réunion, sauf en

cas d’urgence, dont la nature sera relatée dans le procès-verbal de l’assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale et la nature du sujet traité.
Convocation peut être donnée oralement, par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyen électronique ou tout

autre moyen de communication à chaque gérant.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyen élec-

tronique ou tout autre moyen de communication de chaque gérant.

La réunion sera dûment tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

65935

L

U X E M B O U R G

Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux spécifiés dans un calendrier

préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Chaque réunion du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants, doit requérir une présence de deux gérants,

présents ou représentés, par procuration ou par représentant, qui devront former un quorum.

Chaque gérant peut agir à chaque réunion en nommant par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyen élec-

tronique un autre gérant en tant que son mandataire.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

réunion du conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions ou décisions seront prises expressément, soit formulées par résolutions circulaires,

transmises par lettre ordinaire, lettre électronique ou télécopieur, ou par téléphone ou téléconférence ou tout autre
moyen de communication.

Une résolution écrite peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance seront enregistrées dans un procès-verbal, qui sera signé par le président ou

deux gérants. Toute transcription ou extrait de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Chacun et tous les gérants peuvent participer à chaque réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo confé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à tous les gérants faisant partie de la réunion de
s’entendre. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 14. Les associés commanditaires prendront part à la gestion de la Société conformément à l’article 11 des Statuts,

et n’auront aucun droit ni autorité pour agir pour la Société ou prendre part ou en aucune façon d’interférer dans la
gestion de la Société.

Assemblée générale des associés

Art. 15. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales

qu’il détient. Les décisions collectives sont uniquement valablement prises à partir du moment où elles sont adoptées par
vote unanime des associés (commandité ou commanditaire), tour présents ou représentés.

Exercice social - Bilan

Art. 16. L’exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont préparés et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et des passifs de
la Société. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes seront soumis à l’approbation des associés.

Art. 18. Chaque associé peut inspecter l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes mentionnés ci-dessus au

siège social de la Société.

Art. 19. Les profits bruts de la Société déclarés dans les comptes annuels, après déduction de dépenses générales,

amortissements et dépenses, représentent le profit net.

Le solde du profit net peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans la Société.

Art. 20. Les associés, sur proposition du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peuvent décider

de faire des distributions intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours sur la base d’une déclaration des comptes
préparés par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), et démontrant que des fonds suffisants sont dispo-
nibles pour la distribution, étant entendu que le montant à être distribué ne peut pas excéder les profits réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés ainsi que les réserves disponibles et diminué des pertes
reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu de la Loi ou des Statuts.

Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera poursuivie par l’associé commandité.
Quand la liquidation de la Société est clôturée, les recettes de la Société seront attribuées aux associés, en proportion

de leur participations respectives.

Loi applicable

Art. 22. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toute question pour laquelle il n’existe aucune disposition

spécifique dans ces Statuts.»

<i>Septième résolution:

Il est unanimement décidé d’approuver le changement d’adresse du siège social de la Société du 6, rue de Mamer,

L-8081 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg à la date du 31 décembre 2009.

65936

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution:

Il est unanimement décidé de nommer en tant que gérants avec effet au 31 décembre 2009:

M. Kevin Berryman, avec adresse privée ou professionnelle au 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York,

Etats-Unis d’Amérique, et

M. Beth Ford, avec adresse privée ou professionnelle au 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York, Etats-

Unis d’Amérique.

Les gérants devront servir pour une durée indéterminée. M. Kevin Berryman et M. Beth Ford, ayant reçu préavis de

leur nomination, ont accepté par lettre d’acceptation leur mandat et assumé leur obligation de mener leurs devoirs
fidèlement et correctement pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 3.500,- (trois mille cinq cents Euros).

Aucun autre point n’ayant été soulevé, l’assemblée a été ajournée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu’en tête.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Carole Soudier, Jérémy Muszkatblit, Sabine Belair, Carlo Wersandt.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2009. LAC/2009/57533. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 9 juin 2010.

Référence de publication: 2010072185/469.
(100084700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

European Logistics, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.727.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Logistics
Signature

Référence de publication: 2010077649/12.
(100070093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

European Office Income Venture, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.347.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Office Income Venture
Signature

Référence de publication: 2010077650/12.
(100070092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

65937

L

U X E M B O U R G

Dome GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 112.642.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2010 à 10.30 heures à Luxembourg.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de gérant de Mr Bruno Dujon pour une période venant

à échéance lors de l'approbation des comptes au 31.12.2010.

Pour copie conforme
O. GASCHE
<i>Président

Référence de publication: 2010076754/13.
(100070276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Wampum, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.131.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 21 avril 2010.

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
J. WINANDY / K. LOZIE
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2010076755/13.
(100070278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

IFF (GIBRALTAR) Holdings (Luxembourg) S.C.S., Société en Commandite simple,

(anc. International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 79.233.

RECTIFICATIF

L'an deux mille dix, le dix-neuf février.
Par-devant Nous, Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg , Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Torsten SCHMITT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant sur base de deux pro-

curations qui sont restées annexées un acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2009, enregistré à
Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2009, Relation: LAC/2009/57533.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

- Que la Société a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 30 novembre 2000, lequel acte de constitution

fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 458 du 19 juin 2001, page 21056, et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 79.233;

- Qu’une assemblée générale extraordinaire de la Société s’est tenue devant le notaire instrumentant, en date du 23

décembre 2009, ayant entre autres pour objet la transformation de la Société en société en commandite simple, lequel
procès-verbal a été enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009, Relation: LAC/2009/57533, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- Que suite à des informations incorrectes les noms des associés commandité et commanditaire, ainsi que la nouvelle

dénomination de la société ont été indiqués de façon incorrecte;

- Que la dénomination correcte de l’associé commandité est «IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS» au lieu de «International

Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings»;

- Que la dénomination correcte de l’associé commanditaire est «IFF WORLWIDE (GIBRALTAR) LIMITED» au lieu

de «International Flavors &amp; Fragrances Worldwide (Gibraltar) Limited»;

65938

L

U X E M B O U R G

- Que finalement la nouvelle dénomination correcte de la Société est «IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS (Luxembourg)

S.C.S.» au lieu de «International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S.»;

- Que la référence à M. Beth Ford doit être remplacée par la référence à Mme Beth Ford,

de sorte qu’il y a lieu de rectifier et de modifier avec effet rétroactif l’acte en question comme suit:

English version:

“In the year two thousand and nine, on the twenty-third day of December.
Before Maître Wersandt, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of “International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S.à

r.l.” (the “Company”), a private company with limited liability, having its registered office at 6, rue de Mamer, L-8081
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 79.233, incorporated by a notarial deed enacted by Me Joseph Elvinger, on the 30 

th

 November 2000, published

in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 458, page number 21056, lastly amended by a
notarial deed enacted on the 16 

th

 November 2009 by Me Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, Receuil

Spécial des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs. Carole Soudier, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Jérémy Muszkatblit, with professional address in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Sabine Belair, with professional address in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. The list and

the proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain hereto annexed to be registered with this deed.

II.- As appears from the attendance list which has been checked by the scrutineer, who has confirmed the capacities

and the qualities of the shareholders of the Company and the validity of the power of attorney given by them under
private seal, the 13,217,078 (thirteen million two hundred seventeen thousand seventy-eight) shares, representing the
whole issued capital of the Company, are represented at this meeting so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>“Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Acknowledgement of the resignation of the managers of the Company;
3. Waiving of the application to the Company of (i) the Holding 1929 company tax regime based on the law of the 31

st

 July 1929 and of (ii) the Billionaire Holding company tax regime based on the law of the 31 

st

 July 1929 and Arrêté

Grand-Ducal of the 17 

th

 December 1938;

4. Approval of the change of the legal form of the Company from a private limited company (“Société à responsabilité

limitée”) into a limited corporate partnership (“Société en commandite simple”) in accordance with the applicable legal
provisions with effective date as of 31 December 2009;

5. Approval of the change of name of the Company with effective date as of 31 December 2009;
6. Approval of the change of address of the registered office of the Company with effective date as of 31 December

2009;

7. Approval of the subsequent amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to

reflect the new legal form of the Company with effective date as of 31 December 2009;

8. Appointments of Mr. Kevin Berryman and Mrs. Beth Ford as managers of the Company with effective date as of 31

December 2009; and

9. Miscellaneous.”

After the foregoing was approved by the shareholders of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowl-

edge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and
vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been
put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

It is unanimously resolved to acknowledge on their terms the resignations submitted by Mr. Rob Edelman, Mr. Robert

Anderson, Mr. Roger Blanken and Mr. Emilio Perez Carrilllo from their position of managers of the Company which shall

65939

L

U X E M B O U R G

only take effect upon the effective date of the conversion of the Company by the shareholders, from a private limited
liability company (“Société à responsabilité limitée”) into a limited corporate partnership (“Société en commandite sim-
ple”) (the “Conversion”), releasing them from any responsibility that they have incurred during the performance of their
duties.

<i>Third resolution:

It is unanimously resolved to approve the waiving of the application to the Company of (i) the Holding 1929 company

tax regime based on the law of the 31 

st

 July 1929 and of (ii) the Billionaire Holding company tax regime based on the

law of the 31 

st

 July 1929 and Arrêté Grand-Ducal of the17 

th

 December 1938.

<i>Fourth resolution:

It is unanimously resolved to change the legal form of the Company from a private limited liability company (“Société

à responsabilité limitée”) into a limited corporate partnership (“Société en commandite simple”) with effective date as of
31 December 2009. It is further unanimously resolved that IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS will be the unlimited share-
holder of the Company holding the 2,720,000 (two million seven hundred twenty thousand) unlimited shares and that
IFF WORLWIDE (GIBRALTAR) LIMITED will be the limited shareholder of the Company holding the 10,497,078 (ten
million four hundred ninety-seven thousand seventy-eight) limited shares.

<i>Fifth resolution:

It is unanimously resolved to change the name of the Company into IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS (Luxembourg)

S.C.S. with effective date as of 31 December 2009.

<i>Sixth resolution:

It is unanimously resolved to approve the change of the address of the registered office of the Company from 6, rue

de Mamer, L-8081 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg to 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg as of 31 December 2009.

<i>Seventh resolution:

It is unanimously resolved, further to the change of legal form, mentioned above to amend and restate the articles of

association of the Company in order to make them complying with the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable
to a Luxembourg “société en commandite simple” and to approve the current version of the articles of association of
the Company, the terms of which are reproduced hereafter with effective date as of 31 December 2009:

Amended and restated articles of association

of International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S.à r.l.

as at 31 December 2009

“Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a “société en commandite simple”, which will be governed by the laws pertaining to such entity

(hereafter the “Company”), and by current Luxembourg laws, in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

Art. 2. The Company has the following corporate object:
The Company’s purpose is to carry on a business together with a view to a profit. This business could involve to take

participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or
foreign companies or enterprises and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, liquidation, bankruptcy or

insolvency of any shareholder or manager.

The dissolution of the Company will require the unanimous consent of the shareholders of the Company.

Art. 4. The Company will have the name IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS (Luxembourg) S.C.S.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating unanimously.

The address of the registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by simple

decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

65940

L

U X E M B O U R G

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares - Share premium

Art. 6. The share capital is fixed at EUR 330,426,950 (three hundred thirty million four hundred twenty-six thousand

nine hundred fifty Euros) represented by 13,217,078 (thirteen million two hundred seventeen thousand seventy-eight)
shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euros) each, divided into (i) 2,720,000 (two million seven hundred
twenty thousand) unlimited shares for IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS, the unlimited shareholder (“commandité”) and
(ii) 10,497,078 (ten million four hundred ninety-seven thousand seventy-eight) limited shares for IFF WORLWIDE (GI-
BRALTAR) LIMITED, a limited shareholder (“commanditaire”).

The capital may be changed at any time by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 15 of

the Articles.

Art. 7. Each unlimited and limited share confers identical voting rights in shareholders’ meetings.

Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. A shareholder may only hold
one class of shares, either limited or unlimited.

Art. 9. Unlimited shares are non transferable unless such transfer is agreed by all the unlimited shareholders and by

the majority of the limited shareholders by way of a resolution of the general meeting.

Limited shares are freely transferable among the limited shareholders.
Limited shares are non transferable to third parties unless such transfer is agreed by all the unlimited shareholders

and by the majority of the limited shareholders by way of a resolution of the general meeting.

Any transfer of unlimited or limited shares will be made performed under the conditions of article 21 of the Law.

Liability of the shareholders

Art. 10. Subject to articles 16 and 152 of the Law, the unlimited shareholders are jointly and severally liable towards

third parties for all and any liabilities of the Company.

The limited shareholders are liable up to the amount of their capital contribution.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. The managers are appointed and dismissed by the general

meeting of shareholders upon the proposal made by the unlimited partner. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers.

The managers need not to be shareholders. They may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

Powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence

of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may sub-delegate all or part of his powers to

one several ad hoc agents, which shall never be a limited partner of the Company.

The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Any manager does not contract in its or his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by such manager in the name of the Company; as a representative of the Company a manager is only responsible
for the execution of its or his mandate.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

members present or represented.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 1 (one) day in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

65941

L

U X E M B O U R G

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any meeting of the board of managers, in the case of plurality of manager shall require the presence of two managers,

either present in person, by proxy or by representative, which shall form a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 12. The limited shareholders shall take no part in the management of the Company in the meaning of article 11

of the Articles, and shall have no right or authority to act for the Company or to take any part in or in anyway to interfere
in the management of the Company.

General meetings of shareholders

Art. 13. Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Col-

lective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unanimous vote of the shareholders (limited and
unlimited), all present or represented.

Financial year - Balance sheet

Art. 14. The Company's financial year starts on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of each year.

Art. 15. At the end of each financial year, the Company's accounts are prepared and the manager, or in case of plurality

of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities. The inventory, balance sheet and the profit and loss account will be submitted to the approval of the
shareholders.

Art. 16. Each shareholder may inspect the above inventory, balance sheet and profit and loss account at the Company's

registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses, represent the net profit.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Com-

pany.

Art. 18. The shareholders, upon proposal of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers,

may decide to make interim distributions before the end of the current financial year on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the unlimited shareholder.
When the liquidation of the Company is closed, the proceeds of the Company will be attributed to the shareholders,

in proportion to their respective shareholdings.

Applicable Law

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.”

<i>Eighth resolution:

It is unanimously resolved to appoint as managers with effective date as of 31 December 2009:

65942

L

U X E M B O U R G

- Mr. Kevin Berryman, with private or professional address at 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York,

the United States of America; and

- Mrs. Beth Ford, with private or professional address at 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York, the

United States of America.

The managers shall serve for an undetermined duration. Mr. Kevin Berryman and Mrs. Beth Ford, who having received

previous notice of their appointment, have accepted through a letter of acceptance, their position and assumed the
obligation to faithfully and properly carry out their duties for an undetermined duration.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which shall be charged to the Company in connection with

its conversion from a société anonyme into a société à responsabilité limitée, have been estimated at about EUR 3,500
(three thousand five hundred Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.”

Version française:

«L'an deux mille neuf, le vingt-troisième jour de décembre.
Par-devant Maître Wersandt, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «International Flavors &amp; Fragrances Global Holding

S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 6, rue de Mamer, L-8081 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 79.233, constituée par acte pris par Me Joseph Elvinger, en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 458, page 21056, dernièrement modifié par acte pris par Me Joseph Elvinger
le 16 novembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Melle Carole Soudier, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire M. Jérémy Muszkatblit, juriste, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Melle Sabine Belair, avocate, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Rup-

pert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires de la Société et le nombre de parts sociales détenues par eux sont reflétés dans la liste de présence.

La liste et les procurations, signées par les personnes comparantes et le notaire, resteront ci-annexées afin d’être enre-
gistrées avec cet acte.

II.- Tel qu’il ressort de la liste de présence qui a été vérifiée par le scrutateur, qui a confirmé les capacités et les qualités

des associés de la Société et la validité de la procuration donnée par eux sous seing privé, les 13.217.078 (treize millions
deux cent dix-sept mille soixante-dix-huit) parts sociales, représentant la totalité du capital social émis de la Société, sont
représentés à cette assemblée de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du
jour dont les associés reconnaissent avoir été dûment informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>«Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Prise d’acte de la démission des gérants de la Société;
3. Renonciation à l’application à la Société du (i) régime fiscal des sociétés Holding 1929 basé sur la loi du 31 juillet

1929 et du (ii) régime fiscal des sociétés Milliardaires basé sur la loi du 31 juillet 1929 et le règlement grand-ducal du 17
décembre 1938;

4. Approbation du changement de forme juridique de la Société d’une société à responsabilité limitée à une société

en commandite simple conformément aux dispositions légales applicables avec effet au 31 décembre 2009;

5. Approbation du changement de dénomination de la Société avec effet au 31 décembre 2009;
6. Approbation du changement d’adresse du siège social de la Société avec effet au 31 décembre 2009;

65943

L

U X E M B O U R G

7. Approbation de la modification subséquente et de la refonte des statuts de la Société afin de refléter la nouvelle

forme juridique de la Société avec effet au 31 décembre 2009;

8. Nominations de M. Kevin Berryman et Mme Beth Ford en tant que gérants de la Société avec effet au 31 décembre

2009; et

9. Divers.»

Suite à l’approbation de ce qui précède par les associés de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à

cette assemblée générale, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour, considèrent être valablement
convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. De plus, il
a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition des associés dans un délai suffisant afin de leur
permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est unanimement décidé de prendre acte à leurs termes les démissions soumises par M. Rob Edelman, M. Robert

Anderson, M. Roger Blanken et M. Emilio Perez Carillo de leur poste de gérants de la Société qui prendront effet uni-
quement à compter de la date effective de la conversion de la Société par les associés, d’une société à responsabilité
limitée en une société en commandite simple (la «Conversion»), les dégageant de leur responsabilité qu’ils ont encourue
durant l’exécution de leurs fonctions.

<i>Troisième résolution:

Il est unanimement décidé d’approuver la renonciation à l’application à la Société du (i) régime fiscal des sociétés

Holding 1929 basé sur la loi du 31 juillet 1929 et du (ii) régime fiscal des sociétés Milliardaires basé sur la loi du 31 juillet
1929 et le règlement grand-ducal du 17 décembre 1938.

<i>Quatrième résolution:

Il est unanimement décidé de changer la forme juridique de la Société d’une société à responsabilité limitée à une

société en commandite simple conformément aux dispositions légales applicables avec effet au 31 décembre 2009. Il est
encore  unanimement  décidé  que  IFF  (GIBRALTAR)  HOLDINGS  sera  l’associé  commandité  de  la  Société  détenant
2.720.000 (deux millions sept cent vingt mille) parts sociales de commandité et que IFF WORLWIDE (GIBRALTAR)
LIMITED sera l’associé commanditaire de la Société détenant 10.497.078 (dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept
mille soixante-dix-huit) parts sociales de commanditaire.

<i>Cinquième résolution:

Il est unanimement décidé de changer la dénomination sociale de la Société en IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS (Lu-

xembourg) S.C.S. avec effet au 31 décembre 2009.

<i>Sixième résolution:

Il est unanimement décidé, suite au changement de forme juridique mentionné ci-dessus, de modifier et refondre les

statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables aux
sociétés en commandite simple et d’approuver la version actuelle des statuts de la Société dont les termes ont été
reproduits ci-après avec effet au 31 décembre 2009:

Statuts modifiés et refondus

d’International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S.à r.l.

à la date du 31 décembre 2009

«Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué une société en commandite simple régie par les lois concernant ce type d’entité (ci-après

la "Société"), et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), aussi bien que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. La Société a l’objet social suivant:
L'objet de la Société est de poursuivre une affaire en vue de faire du profit. Cette affaire pourrait impliquer de détenir

des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, indus-
trielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et

de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts,
comme la Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en
tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute Société
les acquérant;

65944

L

U X E M B O U R G

de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute

société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; finalement d’accomplir toute opération
qui est directement ou indirectement en relation avec son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de tout associé ou gérant ne mettent pas fin à la Société.
La dissolution de la Société requerra le consentement unanime des associés de la Société.

Art. 4. La Société aura pour dénomination IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS (Luxembourg) S.C.S..

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré à toute autre place au Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant unanimement.

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu dans la municipalité de la commune de Luxembourg

par simple décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales - Prime d’émission

Art. 6. Le capital social est fixé à 330.426.950 EUR (trois cent trente millions quatre cent vingt-six mille neuf cent

cinquante Euros) représenté par 13.217.078 (treize millions deux cent dix-sept mille soixante-dix-huit) parts sociales
d’une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, divisé en (i) 2.720.000 (deux millions sept cent vingt mille)
parts sociales de commandité pour IFF (GIBRALTAR) HOLDINGS, l’associé commandité et (ii) 10.497.078 (dix millions
quatre  cent  quatre-vingt-dix-sept  mille  soixante-dix-huit)  parts  de  sociales  de  commanditaire  pour  IFF  WORLWIDE
(GIBRALTAR) LIMITED, un associé commanditaire.

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée des associés, conformément à l’article

15 des Statuts.

Art. 7. Chaque part sociale de commandité et de commanditaire confère des droits de vote identiques aux assemblées

des associés.

Art. 8. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, sachant qu’un seul détenteur est admis par

part sociale. Les co-détenteurs doivent nommer une seule personne en tant que représentant envers la Société. Un
associé peut uniquement détenir une classe de parts sociales, de commandité ou de commanditaire.

Art. 9. Les parts sociales de commandité sont non transmissibles à moins que ce transfert ne soit consenti par tous

les associés commandités et par la majorité des associés commanditaires par voie de résolution de l’assemblée générale.

Les parts sociales de commanditaire sont librement transmissibles parmi les associés commanditaires.
Les parts sociales de commanditaire sont non transmissibles aux tiers à moins que ce transfert ne soit consenti par

tous les associés commandités et par la majorité des associés commanditaires par voie de résolution de l’assemblée
générale.

Tout transfert de parts sociales de commandité ou de commanditaire sera fait sous les conditions de l’article 21 de la

Loi.

Responsabilité des associés

Art. 10. Sous réserve des articles 16 et 152 de la Loi, les associés commandités sont conjointement et solidairement

responsables envers les tiers pour toute dette de la Société.

Les associés commanditaires sont responsables jusqu’au montant de leur apport.

Gestion

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale

des associés sur proposition de l’associé commandité. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de
gérance.

Les gérants ne doivent pas forcément être associés. Ils peuvent être révoqués ad nutum.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour

agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de cet article auront été respectés.

Les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés tombent sous la

compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

65945

L

U X E M B O U R G

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer tout ou partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc, qui ne sera jamais un associé commanditaire de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu)

de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements réguliè-

rement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des membres présents

ou représentés.

Une convocation à un conseil de gérance sera adressée à tous les gérants moins 1 (un) jour avant la réunion, sauf en

cas d’urgence, dont la nature sera relatée dans le procès-verbal de l’assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale et la nature du sujet traité.
Convocation peut être donnée oralement, par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyen électronique ou tout

autre moyen de communication à chaque gérant.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyen élec-

tronique ou tout autre moyen de communication de chaque gérant.

La réunion sera dûment tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux spécifiés dans un calendrier

préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Chaque réunion du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants, doit requérir une présence de deux gérants,

présents ou représentés, par procuration ou par représentant, qui devront former un quorum.

Chaque gérant peut agir à chaque réunion en nommant par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex, moyen élec-

tronique un autre gérant en tant que son mandataire.

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

réunion du conseil de gérance.

Dans de tels cas, les résolutions ou décisions seront prises expressément, soit formulées par résolutions circulaires,

transmises par lettre ordinaire, lettre électronique ou télécopieur, ou par téléphone ou téléconférence ou tout autre
moyen de communication.

Une résolution écrite peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance seront enregistrées dans un procès-verbal, qui sera signé par le président ou

deux gérants. Toute transcription ou extrait de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Chacun et tous les gérants peuvent participer à chaque réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo confé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à tous les gérants faisant partie de la réunion de
s’entendre. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 12. Les associés commanditaires prendront part à la gestion de la Société conformément à l’article 11 des Statuts,

et n’auront aucun droit ni autorité pour agir pour la Société ou prendre part ou en aucune façon d’interférer dans la
gestion de la Société.

Assemblée générale des associés

Art. 13. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales

qu’il détient. Les décisions collectives sont uniquement valablement prises à partir du moment où elles sont adoptées par
vote unanime des associés (commandité ou commanditaire), tour présents ou représentés.

Exercice social - Bilan

Art. 14. L’exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont préparés et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et des passifs de
la Société. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes seront soumis à l’approbation des associés.

Art. 16. Chaque associé peut inspecter l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes mentionnés ci-dessus au

siège social de la Société.

Art. 17. Les profits bruts de la Société déclarés dans les comptes annuels, après déduction de dépenses générales,

amortissements et dépenses, représentent le profit net.

Le solde du profit net peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans la Société.

Art. 18. Les associés, sur proposition du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peuvent décider

de faire des distributions intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours sur la base d’une déclaration des comptes

65946

L

U X E M B O U R G

préparés par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), et démontrant que des fonds suffisants sont dispo-
nibles pour la distribution, étant entendu que le montant à être distribué ne peut pas excéder les profits réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés ainsi que les réserves disponibles et diminué des pertes
reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu de la Loi ou des Statuts.

Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera poursuivie par l’associé commandité.
Quand la liquidation de la Société est clôturée, les recettes de la Société seront attribuées aux associés, en proportion

de leurs participations respectives.

Loi applicable

Art. 20. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toute question pour laquelle il n’existe aucune disposition

spécifique dans ces Statuts.»

<i>Septième résolution:

Il est unanimement décidé d’approuver le changement d’adresse du siège social de la Société du 6, rue de Mamer,

L-8081 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg à la date du 31 décembre 2009.

<i>Huitième résolution:

Il est unanimement décidé de nommer en tant que gérants avec effet au 31 décembre 2009:
M. Kevin Berryman, avec adresse privée ou professionnelle au 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York,

Etats-unis d’Amérique, et

Mme Beth Ford, avec adresse privée ou professionnelle au 521 West 57 

th

 Street, New York, 10019 New York, Etats-

unis d’Amérique.

Les gérants devront servir pour une durée indéterminée. M. Kevin Berryman et Mme Beth Ford, ayant reçu préavis

de leur nomination, ont accepté par lettre d’acceptation leur mandat et assumé leur obligation de mener leurs devoirs
fidèlement et correctement pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 3.500,- (trois mille cinq cents Euros).

Aucun autre point n’ayant été soulevé, l’assemblée a été ajournée.
A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu’en tête.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Torsten SCHMITT, Carlo WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 février 2010. LAC/2010/7897. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la société.

Luxembourg, le 9 juin 2010.

Référence de publication: 2010072186/496.
(100084700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2010.

Pliniana International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 71.822.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 avril 2010 à 11.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs Monsieur Koen

LOZIE demeurant 61, Grand-Rue L-8510 Redange sur Attert et de COSAFIN S.A. L'Assemblée Générale décide de
nommer Monsieur Joseph Winandy né le 16 février 1946 à Ettelbruck et demeurant 92, rue de l'horizon L-5960 Itzig

65947

L

U X E M B O U R G

Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2010.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Fiduciaire Glacis S.à.r.l., en tant que Commissaire aux Comptes. Le

mandat du Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2010.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010076757/19.
(100070325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Creola S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 65.349.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 20 avril 2010

<i>Résolutions:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,
- de nommer Monsieur Joseph WINANDY comme Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010076758/14.
(100070344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Blamar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 62.980.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 23 avril 2010

<i>Résolution:

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Joseph WINANDY en tant que Président du

Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
J. WINANDY / COSAFIN S.A.
<i>Président / Administrateur

Référence de publication: 2010076759/14.
(100070348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Fountainhead S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010077674/12.
(100070189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

65948

L

U X E M B O U R G

Fountainhead S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010077676/12.
(100070187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Fountainhead S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 74.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Halsey Group S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2010077678/12.
(100070183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Anglona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 124.247.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kristel Segers / Christophe Gammal
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010077680/12.
(100070173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

AMC Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 117.309.

Les comptes annuels au 30 juin 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010077686/10.
(100070176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Lavanco Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.368.

DISSOLUTION

L'an deux mille dix, le vingt-huit mai.
Par-devant  Nous  Maître  Léonie  GRETHEN,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussignée.

A COMPARU:

65949

L

U X E M B O U R G

La société anonyme holding AGIV HOLDING, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 18669,

ici représentée par Monsieur Jérôme ADAM, employé privé, demeurant professionnellement à L-1527 Luxembourg,

10, rue du Maréchal Foch, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée par Monsieur Jérôme ADAM, pré-nommé, déclare et requiert le notaire

instrumentaire d'acter:

1) Que la société anonyme holding “LAVANCO HOLDING S.A.” établie et ayant son siège social à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B et le numéro 105368 (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire
de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro
318 du 11 avril 2005.

2) Que le capital de la Société est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille Euros) représenté par 700 (sept cents) actions

d’une valeur nominale de EUR 1000,- (mille Euros) chacune.

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les actions de la

Société.

4) Que la partie comparante, agissant comme actionnaire unique ("l’Actionnaire Unique"), siégeant en assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société
avec effet immédiat et la mise en liquidation.

5) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, signer,

exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que l'Actionnaire Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l’article

151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

7) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la Société.

8) Que de l’accord de la Société et des créanciers, toutes les dettes ont été reprises par l'Actionnaire Unique.
9) Que l'Actionnaire Unique présente le rapport de liquidation et déclare qu’elle reprend tout l’actif de la Société et

qu’elle garantira le paiement de toutes les dettes de la Société même inconnues à ce jour.

Le rapport sur la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

10) Que l'Actionnaire Unique nomme en qualité de commissaire à la liquidation, la société à responsabilité limitée

COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte, et lui confie la mission de faire le rapport sur la gestion de la liquidation.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'Actionnaire Unique en adopte les conclu-

sions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à COMCOLUX
S.à r.l., pré-nommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour.

Le rapport du commissaire à la liquidation est annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
11) Que l'Actionnaire Unique, lors de la troisième assemblée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et

que tous les registres de la Société relatifs à l’émission d’actions ou de tous autres titres seront annulés. Elle constate
que la Société a définitivement cessé d’exister.

12) Que décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuels de la Société pour l’exécution

de leurs mandats.

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de mille cent euros
(1.100.- EUR).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français et l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie

comparante, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise; à la requête de la même partie comparante
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

65950

L

U X E M B O U R G

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par son nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise / Follows the English translation

In the year two thousand and ten, on the twenty-eight day of May
Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned,

APPEARED:

The public limited holding company AGIV HOLDING, with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 18669,

here represented by Mr. Jérôme ADAM, private employee, residing professionally at L-1527 Luxembourg, 10, rue du

Maréchal Foch, by virtue of a proxy given under private seal. Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary
and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented by Mr. Jérôme ADAM, pre-named, declared and requested the notary to act:
1) That the public limited holding company “LAVANCO HOLDING S.A.”, established and having its registered office

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered at the Trade and Companies' Register of
Luxembourg, under section B and number 105368 (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Maî-
treJean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on December 17, 2004, published at the
Memorial C number 318 of April 11, 2005.

2) That the capital of the company is fixed at EUR 700,000.- (seven hundred thousand Euro), represented by 700 (seven

hundred) shares with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each.

3) That the appearing party, represented as said before, is the sole owner of all the shares of the Company.
4) That the appearing party, acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder") at an extraordinary shareholders’

meeting amending the articles of the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the
commencement of the liquidation process.

5) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and in its capacity as liquidator of the

Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of the present deed.

6) That the Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders

in accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold
these meetings one after the other.

7) That in its capacity as liquidator of the Company, the Sole Shareholder declares having thorough knowledge of the

articles of association and of the financial situation of the Company.

8) That with the approval of the Company and the creditors, all debts have been taken over by the Sole Shareholder.
9) That the Sole Shareholder presents its liquidation report and declares that it takes over all the assets of the Company,

and that it will guarantee the payment of any debts of the Company even if unknown at present.

The liquidation report, after having been signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, shall stay

affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

10) That the Sole Shareholder appoints as auditor to the liquidation, the private limited company COMCOLUX S.à

r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, and asks it to establish a report on the liquidation.

Having reviewed the report of the auditor to the liquidation, the Sole Shareholder accepts its findings, approves the

liquidation accounts and grants a total and entire discharge, without reserve or restriction to COMCOLUX S.à r.l.,
prenamed, in relation to the verifications carried out as of the date hereof.

The report of the auditor to the liquidation shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration

authorities.

11) That the Sole Shareholder, in the third general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the Com-

pany is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be
cancelled. It confirms that the Company has definitely ceased to exist.

12) That discharge is given to the incumbent directors and statutory auditor of the Company for the performance of

their mandates.

13) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at

the former registered office of the Company at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred euro
(1.100.- EUR).

65951

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks French and English, states herewith that on request of the above

appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the French and the English text, the French version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by his name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Signé: Adam, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2010. Relation: LAC/2010/24379. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2010.

Référence de publication: 2010063681/134.
(100079444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2010.

Anglona S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 124.247.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kristel Segers / Christophe Gammal
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010077682/12.
(100070169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

European Office Income Venture, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 97.347.

Les comptes consolidés audités au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Office Income Venture
Signature

Référence de publication: 2010077654/12.
(100070088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2010.

Fintinvest A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.446.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 mars 2010

Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (B), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.

Monsieur Michel DI BENEDETTO, né le 16 septembre 1969 à Mont Saint Martin (F), adresse professionnelle au 3,

avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est nommé représentant permanent de la société FMS SERVICES S.A.

<i>Pour la société
FINTINVEST A.G.

Référence de publication: 2010060405/14.
(100075330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

65952


Document Outline

AMC Management S.A.

Anglona S.A.

Anglona S.A.

Banque Transatlantique Luxembourg

Blamar S.A.

Caufort Luxembourg S.à r.l.

Coogee S.à r.l.

Creola S.A.

Dome GP, S.à r.l.

Dome S.C.A.

EAVF S.à r.l.

European Logistics

European Office Income Venture

European Office Income Venture

Exzentric S.A.

Fintinvest A.G.

Fi Reinsurance S.A.

Fountainhead S.à r.l.

Fountainhead S.à r.l.

Fountainhead S.à r.l.

General Electric International Holdings S.à r.l.

IFF (GIBRALTAR) Holdings (Luxembourg) S.C.S.

Internationale Forêt Noire S.A.

International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S.

International Flavors &amp; Fragrances Gibraltar Holdings (Luxembourg) S.C.S.

International Flavors &amp; Fragrances Global Holding S. à r.l.

Joya-Coiffure S.à r.l.

Kirchberg Services, S.àr.l.

Ksar Invest S.A.

Lancelot Ector

Lavanco Holding S.A.

Ligabue Immobiliare S.A.

Lux-Protect Fund

Manly S.A.

Maxpama S.A.

M&amp;L Global SPF S.A.

Nord Europe Patrimonium

Orco Property Group

Orco Property Group

Orco Property Group

Pliniana International S.A.

Redblack Limited

Russian Investment Company

SEB Optimix

SES Digital Distribution Services S.à r.l.

Stanley Invest Holding S.A.

Tinfos Nizi S.A.

Tower Fund

Wampum

Wampum