This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1272
17 juin 2010
SOMMAIRE
Adams Rayner Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . .
61053
AMBD SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61010
Arts et Nature S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61010
Athena Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61020
Brasserie Kirchberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
61020
Colombo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61042
Compagnie d'Investissement des Arden-
nes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61054
Controlinveste International Finance . . . .
61056
DTZ Consulting Luxembourg S.A. . . . . . . .
61051
Euro Immo Invest & Conseil S.A. . . . . . . . .
61048
Euro Real Estate Britain I S.à r.l. . . . . . . . .
61020
Euro Real Estate Germany I S.à r.l. . . . . . .
61010
Forgital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61051
GSFG Financing Luxembourg S.à r.l. . . . .
61056
Hammond International Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61044
ING Investment Management Multi Mana-
ger S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61046
Marine International Operations S.A. . . . .
61052
Marine International Operations S.A. . . . .
61053
Morghy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61031
Morghy Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61031
Neptune International Investment Funds
(SICAV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61050
Omnium Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
61053
One Park Lane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61030
Pétrusse Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61030
Piccioli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61031
Représentations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61031
ROV Diving International S.A. . . . . . . . . . . .
61055
ROV Diving International S.A. . . . . . . . . . . .
61054
SCG STE Maurice 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
61041
SCG STE Maurice 4 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
61041
Schimmelpenningh International S.A. . . . .
61055
Schimmelpenningh International S.A. . . . .
61056
SEB Sicav 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61042
SF Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61042
Sicily Investments S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
61043
Société Financière Anigh Spf S.A. . . . . . . .
61044
Sofeco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61046
SOF European Hotel Co-Invest Holdings II,
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61044
SOFI Asia Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
61047
SOF-VI Global Holdings Lux S.à r.l. . . . . . .
61045
SOF-VII European Holdings I, S.à r.l. . . . . .
61045
SOF-VI International Holdings Lux, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61045
Starwood Capital Group European S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61041
Starwood Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
61041
Unical Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61047
Unicapital Investments (Management)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61052
UTI Investment Luxembourg S.à r.l. . . . . .
61049
Vandersanden Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
61049
Voltige Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61050
Voltige Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61049
Vratislavia Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
61030
61009
L
U X E M B O U R G
AMBD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.419.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009 que:
1. L’assemblée a décidé de renommer aux fonctions d’administrateurs
Monsieur Jacques Delen, demeurant professionnellement à B-2020 Antwerpen, J. Van Rijswijklaan, 184
Monsieur Thierry Maertens de Noordhout, demeurant professionnellement à B-4000 Liège, boulevard d’Avroy, 4
Monsieur Philippe Havaux, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287
Monsieur Serge Cammaert, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287.
2. L’assemblée a décidé de renommer comme réviseur d’entreprises la société Deloitte S.A., ayant son siège social à
L-2220 Luxembourg, rue de Neudorf, 560
Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Pour copie certifiée conforme
Référence de publication: 2010056828/19.
(100071452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Arts et Nature S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3348 Leudelange, 3, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 54.496.
L’assemblée générale des associés prend note:
- de la nomination de Monsieur Fernand GUELF, demeurant à 3, rue des Champs L-3348 Leudelange comme gérant
technique avec effet immédiat pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/05/2010.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire Weber Bontemps & Mouwannes S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscauxi>
Référence de publication: 2010056830/15.
(100071499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Euro Real Estate Germany I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.832.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Euro Real Estate Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, which
registration with the Luxembourg Trade and Companies register is pending,
here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 27 April 2010.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
61010
L
U X E M B O U R G
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Euro Real Estate Germany I S.àr.l." (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The purpose of the Company is further the aquisition, development and management as well as the sale of real
estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500)
shares in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
61011
L
U X E M B O U R G
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by several managers including at least one class A and one class B manager appointed
by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound with respect to decisions involving amounts of up to ten thousand euro (10,000 Euro) by
the single signature of any one manager.
The Company is bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of at least one class A manager
and one class B manager or by the single signature of any one class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
61012
L
U X E M B O U R G
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions only by
a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
61013
L
U X E M B O U R G
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
1.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
1.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2010.
<i>Subscription and Paymenti>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for five hundred
(500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr. Gerd Schneider, Tax Adviser, born on 17 November 1965 in Kaiserslautern, Germany, residing at 25, Montée
de Clausen; L-1343 Luxembourg, as class A manager;
(b) Mr. Leander Scherer, Accountant, born on 17 December 1961 in Rodenbach, Germany, residing at Bergstrasse 6
in D-67688 Rodenbach, as class A manager; and
(c) Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, born on 25 May 1978 in Coburg, Germany, residing at Keferloh 1B in
D-85630 Grasbrunn, as class B manager.
2. The registered office of the Company is established at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
61014
L
U X E M B O U R G
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am siebenundzwanzigsten Tag des Monats April im Jahre zweitausendzehn,
ist vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
ERSCHIENEN:
die Euro Real Estate Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Lu-
xemburg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister anhängig ist,
hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht welche am 27. April 2010 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen:
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Euro Real Estate Germany I S.àr.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft
ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-
schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (der Rat) an einen anderen Ort innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Sollte der Rat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereig-
nisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesell-
schaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschafts-
sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung sowie der Verkauf von Immobilien
sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die
erforderliche Genehmigung, reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft, ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
61015
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus fünfhundert
(500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25); die Gesellschaftsanteile wurden
gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
zu.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an
Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art.7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem Klasse A und einem Klasse
B Geschäftsführer, verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat.
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
61016
L
U X E M B O U R G
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten bis zu einem Betrag in Höhe von zehntausend Euro (10.000 Euro) durch
die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.
In allen übrigen Angelegenheiten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens eines Klasse A Geschäftsführers sowie mindestens eines Klasse B Geschäftsführers oder durch die alleinige
Unterschrift mindestens eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der mit Spezialvollmachten ausgestat-
teten Personen gebunden.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen,
welche für den Rat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den alleinigen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.
9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten
Personen gebunden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für
Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder den ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
61017
L
U X E M B O U R G
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann nur aufgrund der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art.12. Alleingesellschafter.
12.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
14.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
14.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um
die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der ge-
setzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)
Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbe-
schlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
61018
L
U X E M B O U R G
16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschaftsanteile in
Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).
Die Aktien wurden vollständig in Bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr EUR 1.500.- betragen.
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten
Gesellschaftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
(a) Herr Gerd Schneider, Steuerberater, geboren am 17. November 1965 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäfts-
ansässig in der 25, Montée de Clausen, L-1343 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer;
(b) Herr Leander Scherer, Buchhalter, geboren am 17. Dezember 1961 in Rodenbach, Deutschland, wohnhaft in der
Bergstrasse 6 in D-67688 Rodenbach, als Klasse A Geschäftsführer; und
(c) Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geboren am 25. Mai 1978 in Coburg, Deutschland, geschäftsansässig in
Keferloh 1B in D-85630 Grasbrunn, als Klasse B Geschäftsführer.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. STADLER-TJAN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2010. Relation: LAC/2010/19757. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 6. Mai 2010.
Référence de publication: 2010066382/506.
(100063233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
61019
L
U X E M B O U R G
Athena Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 47.027.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2009 que:
1. L’assemblée a décidé de renommer aux fonctions d’administrateurs
Monsieur Jacques Delen, demeurant professionnellement à B-2020 Antwerpen, J. Van Rijswijklaan, 184
Monsieur Thierry Maertens de Noordhout, demeurant professionnellement à B-4000 Liège, boulevard d’Avroy, 4
Monsieur Philippe Havaux, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287
Monsieur Serge Cammaert, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, route d’Arlon, 287.
2. L’assemblée a décidé de renommer comme réviseur d’entreprises la société Deloitte S.A., ayant son siège social à
L-2220 Luxembourg, rue de Neudorf, 560.
Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
Luxembourg, le 30 septembre 2009.
Pour copie certifiée conforme
Référence de publication: 2010056832/19.
(100071459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Brasserie Kirchberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 193, rue de Kirchberg.
R.C.S. Luxembourg B 51.804.
L’assemblée générale des associés prend note:
- de la nomination de Madame Josée FRITZ, demeurant à 3, rue des Champs L-3348 Leudelange comme gérante
technique avec effet immédiat pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18/05/2010.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire Weber Bontemps & Mouwannes S.à r.l.
<i>Experts Comptables et Fiscauxi>
Référence de publication: 2010056836/15.
(100071472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Euro Real Estate Britain I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.830.
STATUTES
In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Euro Real Estate Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Luxembourg, which
registration with the Luxembourg Trade and Companies register is pending,
here represented by Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, with professional address at 18-20, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxemburg, by virtue of a power of attorney dated 27 April 2010.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
61020
L
U X E M B O U R G
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Euro Real Estate Britain I S.àr.l." (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The purpose of the Company is further the acquisition, development and management as well as the sale of real
estate in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500)
shares in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
61021
L
U X E M B O U R G
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by several managers including at least one class A and one class B manager appointed
by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound with respect to decisions involving amounts of up to ten thousand euro (10,000 Euro) by
the single signature of any one manager.
The Company is bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of at least one class A manager
and one class B manager or by the single signature of any one class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
61022
L
U X E M B O U R G
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions only by
a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
61023
L
U X E M B O U R G
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
1.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
1.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2010.
<i>Subscription and Paymenti>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for five hundred
(500) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr. Gerd Schneider, Tax Adviser, born on 17 November 1965 in Kaiserslautern, Germany, residing at 25, Montée
de Clausen; L-1343 Luxembourg, as class A manager;
(b) Mr. Leander Scherer, Accountant, born on 17 December 1961 in Rodenbach, Germany, residing at Bergstrasse 6
in D-67688 Rodenbach, as class A manager; and
(c) Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, born on 25 May 1978 in Coburg, Germany, residing at Keferloh 1B in
D-85630 Grasbrunn, as class B manager.
2. The registered office of the Company is established at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
61024
L
U X E M B O U R G
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am siebenundzwanzigsten Tag des Monats April im Jahre zweitausendzehn,
ist vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
ERSCHIENEN:
die Euro Real Estate Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Lu-
xemburg, deren Registrierung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister anhängig ist,
hier vertreten durch Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, mit Geschäftsadresse in 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht welche am 27. April 2010 erteilt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (soc/été à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen:
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Euro Real Estate Britain I S.àr.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft
ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-
schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (der Rat) an einen anderen Ort innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Sollte der Rat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereig-
nisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesell-
schaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschafts-
sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung sowie der Verkauf von Immobilien
sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die
erforderliche Genehmigung, reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft, ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
61025
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus fünfhundert
(500) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25); die Gesellschaftsanteile wurden
gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
zu.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an
Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem Klasse A und einem Klasse
B Geschäftsführer, verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat.
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
61026
L
U X E M B O U R G
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten bis zu einem Betrag in Höhe von zehntausend Euro (10.000 Euro) durch
die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.
In allen übrigen Angelegenheiten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von
mindestens eines Klasse A Geschäftsführers sowie mindestens eines Klasse B Geschäftsführers oder durch die alleinige
Unterschrift mindestens eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der mit Spezialvollmachten ausgestat-
teten Personen gebunden.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen,
welche für den Rat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den alleinigen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.
9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten
Personen gebunden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für
Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder den ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
61027
L
U X E M B O U R G
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann nur aufgrund der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art. 12. Alleingesellschafter.
12.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
14.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
14.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um
die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der ge-
setzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)
Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbe-
schlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
61028
L
U X E M B O U R G
16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2010.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschaftsanteile in
Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500).
Die Aktien wurden vollständig in Bar eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr EUR 1.500,- betragen.
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten
Gesellschaftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
(a) Herr Gerd Schneider, Steuerberater, geboren am 17. November 1965 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäfts-
ansässig in der 25, Montée de Clausen, L-1343 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer;
(b) Herr Leander Scherer, Buchhalter, geboren am 17. Dezember 1961 in Rodenbach, Deutschland, wohnhaft in der
Bergstrasse 6 in D-67688 Rodenbach, als Klasse A Geschäftsführer; und
(c) Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geboren am 25. Mai 1978 in Coburg, Deutschland, geschäftsansässig in
Keferloh 1B in D-85630 Grasbrunn, als Klasse B Geschäftsführer.
2. Sitz der Gesellschaft ist in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. STADLER-TJAN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mai 2010. Relation: LAC/2010/19756. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 6. Mai 2010.
Référence de publication: 2010066383/506.
(100063227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
61029
L
U X E M B O U R G
One Park Lane S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 113.618.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Bertrange en date du 7 avril 2010i>
"...
II résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Gabriel JEAN, demeurant au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément à
l'Article 7 des Statuts de la Société.
En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Gabriel JEAN aura tous les pouvoirs réservés à cette
fonction dans les Statuts de la Société.
..."
Bertrange, le 7 avril 2010.
Référence de publication: 2010056888/16.
(100071445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Pétrusse Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 97.151.
<i>Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 avril 2010i>
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale du 15 avril 2010 que:
- L'assemblée accepte la démission de Madame Caria Machado-Leite Oliveira, Monsieur Gilles Apel et Monsieur René
Moris en tant qu'administrateurs de la société avec effet au 1
er
janvier 2010.
L'assemblée accepte également la démission de Monsieur René Moris en tant qu'administrateur-délégué de la société
avec effet au 1
er
janvier 2010.
- L'assemblée décide de pourvoir au remplacement des administrateurs sortant en appelant:
* La société à responsabilité limitée Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS sous le no
B142674, ayant son siège social au 63, rue de Merl à L-2146 Luxembourg;
* Madame Florence Bastin, née le 02.07.1975 à Haine St Paul (Belgique), demeurant professionnellement au 63, rue
de Merl à L-2146 Luxembourg.
Les 2 nouveaux administrateurs sont élus avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2010 et reprennent la durée du mandat
de leurs prédécesseurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
- Le siège social de la société est transféré au 63, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2010.
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Référence de publication: 2010056891/24.
(100070867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Vratislavia Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 101.882.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la Société en date du 5 mai 2010i>
- Efstratios HATZIPANAGIOTIDIS a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société avec effet au 28 avril
2010.
Luxembourg, le 21 mai 2010.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010056922/14.
(100071429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
61030
L
U X E M B O U R G
Piccioli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 133.075.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010 que les mandats des administrateurs suivants sont renou-
velés jusqu'à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012:
- Monsieur Riccardo MORALDI, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40 Avenue de la
Faïencerie L-1510;
- Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40 Avenue de
la Faïencerie L-1510;
- Monsieur Michele CANEPA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 40 Avenue de la Faïen-
cerie L-1510
Luxembourg, le 21 mai 2010.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2010056892/18.
(100071182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Représentations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 57.784.
Changement des adresses des administrateurs comme suit:
Monsieur Michel GLAESENER , administrateur et administrateur-délégué, demeurant à L- 8715 Everlange, 23, rue
Hiehl
Monsieur Christian MAROLDT, administrateur, demeurant à L-5828 Fentange, 17, rue Gewaennchen
Alzingen, le 19 mai 2010.
Référence de publication: 2010056894/12.
(100070783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Morghy Spa, Société Anonyme,
(anc. Morghy S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 128.414.
L'an deux mille dix, le neuf avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
la société "WEALTH-ASSURANCE AG, une société constituée et existant sous le droit du Liechtenstein, établie et
ayant son siège social à Pflugstrasse 28, 9490 VADUZ (Liechtenstein), ("l'Associé Unique"),
ici représentée par Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée le 1
er
avril 2010,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter le fait que l'Associé Unique est l'associé unique de
"Morghy S.A.", une société anonyme constituée sous les lois de Luxembourg (i) ayant son siège social à 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, (ii) constituée suivant acte dressé par le ministère du notaire soussigné en date du 1
er
juin 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1463 du 16 juillet 2007, et page 70190 et
dont les statuts ne furent jamais modifiés depuis son acte de constitution, (iii) immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 128 414 et (iv) dont le capital social est actuellement fixé à TRENTE-DEUX
MILLE EUROS (32'000.- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions ordinaires ayant une valeur nominale de CENT
EUROS (100.- EUR) chacune (la "Société").
L'Associé Unique, représenté tel que mentionné auparavant, ayant reconnu être pleinement informé des résolutions
devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:
61031
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination de la Société en "Morghy S.p.A.";
2) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050.
3) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société;
4) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et
adoption par la Société de la nationalité italienne; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à
l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
5) Fixation du nouveau siège social de la Société à Carpi, et plus précisément Via Abetone, 20, I-41012 Carpi (Italie);
6) Soumission de la Société constituée au Luxembourg sous forme d'une société anonyme en celle d'une société par
actions de droit italien;
7) Modification de l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant
défini par l'article trois (3) [Oggetto] des statuts refondus de la Société en langue italienne;
8) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne;
9) Nomination d'un administrateur unique et d'un college des commissaries composé de cinq (5) membres tous de
nationalité italienne et tous inscrits au Registre des "Revisori contabili" et fixation de la durée de leurs mandates;
10) Délégation de pouvoirs;
a demandé au notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de changer la raison sociale de la Société en "Morghy Spa".
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2050.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Alexis DE BERNARDI, de Mon-
sieur Régis DONATI et de Monsieur Louis VEGAS-PIERONI de leurs mandats d'administrateurs et également de
Monsieur Mohammed KARA, en tant que commissaire aux comptes actuel de la Société et DECIDE de leur accorder
pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'au jour de la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du
Grand-Duché de Luxembourg à Carpi (Modena) [Italie], de fixer sa nouvelle adresse à Via Abetone 20, I-41012 Carpi et
de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de
siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive
de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de soumettre la Société, constituée auparavant au Grand-Duché de Luxembourg sous forme
d'une société anonyme, en celle d'une société par actions (SPA) régie par le droit italien.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau
libellé est maintenant défini par l'article trois (3) [Oggetto] des statuts refondus de la Société en langue italienne établis
ci-après.
<i>Septième résolutioni>
Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, l'Associé Unique DECIDE de procéder à une refonte com-
plète des statuts de la Société nouvellement dénommée "Morghy Spa" pour les mettre en concordance avec la législation
italienne et de les arrêter comme suit:
Nouvelle version des statuts en langue italienne:
"STATUTO
Denominazione.
1) È costituita una società per azioni denominata: "Morghy Spa".
Sede.
2) La società ha sede legale nel Comune di Carpi (MO) all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese.
61032
L
U X E M B O U R G
Per deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse succursali, agenzie,
rappresentanze sia in Italia che all'estero.
Oggetto.
3) La società ha per oggetto, in via principale, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione,
la conduzione e l'affitto di beni immobili e beni mobili in genere, in essi comprese anche azioni, obbligazioni e quote
societarie in genere, nonchè qualsiasi attività di intermediazione relativa ai vari settori indicati.
In via secondaria ha per oggetto:
a) la produzione, il commercio in conto proprio e per conto terzi, anche in qualità di agente, rappresentante e com-
missionario di articoli di maglieria, di confezioni e di abbigliamento in genere;
b) l'attività di consulenza tecnico-commerciale nel settore sopra indicato;
c) l'acquisizione, la vendita, la gestione e/o la concessione in licenza - attiva e passiva - di diritti su marchi e brevetti
relativi ai settori sopra indicati;
d) la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione, la conduzione, l'affitto e l'amministrazione
di beni immobili.
La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie
ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'ac-
quisto, la vendita, la permuta e la locazione-conduzione di beni mobili, anche registrati, immobili, diritti immobiliari e di
aziende; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche e Società, concedendo le opportune
garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi.
La società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi
oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi di legge e di ogni operazione nei
confronti del pubblico.
Durata.
4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050.
Capitale.
5) Il capitale della società è di euro 32.000,00 (trentaduemila/00 Euro).
Azioni.
6) Il capitale è diviso in numero 320 (trecentoventi) azioni, tutte del valore nominale di euro 100,00 (cento/00). Il
capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
nonché attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni a mente dell'articolo 2420 bis del Codice Civile.
7) Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Dititto di voto delle azioni.
8) Ogni azione dà diritto ad un voto.
Indivisibilità delle azioni.
9) Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.
Trasferibilità delle azioni.
10) Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte; sono, altresì, liberamente trasferibili, per
atto tra vivi a favore delle persone di cui all'articolo 536 Codice Civile e cioè i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli
naturali, il coniuge, i figli legittimati ed adottivi ed i discendenti dei figli legittimi, legittimati naturali ed adottivi del socio
cedente. In ogni altro caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione secondo
le disposizioni che seguono:
a) per trasferimento di azioni si intende compreso qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine,
a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni, o di diritti di
opzione ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento, la costituzione di
rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, la
fusione e la scissione; ove indicato azioni deve comunque intendersi "azioni e diritti di opzione";
b) qualora taluno dei soci intenda comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne notizia agli altri
soci, tramite l'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) qualora siano in circolazione categorie diverse di azioni, il diritto di prelazione sulle azioni offerte in vendita delle
singole categorie, spetterà agli azionisti delle categorie rispettive;
d) l'organo amministrativo, ricevuta l'offerta, la parteciperà, entro il termine di giorni venti dal ricevimento, a tutti i
soci, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, assegnando agli stessi un termine, non superiore a giorni trenta per l'esercizio
del diritto di prelazione; entro detto termine assegnato, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'offerente ed
all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione;
61033
L
U X E M B O U R G
e) l'offerta di vendita dovrà essere irrevocabile (salvo quanto previsto al successivo punto i) e contenere tutti gli
elementi necessari al perfezionamento del contratto (prezzo richiesto, modalità e condizioni di pagamento) nonché il
nominativo e le generalità del terzo potenziale acquirente;
f) il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente ma deve essere esercitato per tutte le azioni contenute
nell'offerta; nel caso di offerta congiunta (proposta da parte di più soci), il diritto di prelazione degli altri soci non dovrà
avere necessariamente ad oggetto il complesso delle azioni offerte, potendo riguardare anche solo le azioni di uno o alcuni
degli offerenti;
g) nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, il riparto delle azioni sarà effettuato in proporzione
alle partecipazioni dagli stessi detenute ovvero di comune accordo tra gli stessi;
h) qualora i soci che ricevono l'offerta ritengano eccessivo il prezzo richiesto avranno singolarmente la facoltà, nel
medesimo termine di cui sopra assegnato per l'esercizio del diritto di prelazione, di depositare presso un primario istituto
di credito, a nome del socio offerente, la somma ritenuta adeguata al valore delle azioni e di richiedere contemporanea-
mente la valutazione delle azioni medesime da parte di un arbitratore in conformità di quanto disposto in appresso; la
nomina dell'arbitratore dovrà essere richiesta al Presidente del Tribunale nel cui circondario la società ha la sede legale
e ne dovrà essere data comunicazione, entro venti giorni, all'offerente ed all'organo amministrativo; l'arbitratore, entro
novanta giorni dalla sua nomina, procederà alla determinazione del valore delle azioni offerte in vendita dandone immediata
comunicazione alle parti interessate; fatto salvo quanto previsto al successivo punto i), il socio o i soci che avranno richiesto
la predetta valutazione dovranno procedere, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle decisioni dell'anzidetto
arbitratore, all'eventuale conguaglio tra la somma depositata e l'importo corrispondente alla valutazione come sopra
eseguita; qualora, invece, il deposito eccedesse la cifra risultante dalla valutazione dell'arbitratore, il depositante avrà
diritto di ottenere la immediata restituzione della maggiore somma versata senza alcuna responsabilità dell'istituto de-
positario;
i) qualora il valore stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo richiesto, il socio
proponente l'offerta di vendita avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia, a mezzo di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento, all'organo amministrativo ed ai soci che hanno richiesto la valutazione, nel termine di
giorni venti dal ricevimento della comunicazione da parte dell'arbitratore; ove il socio proponente l'offerta non si avvalga
di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci, che hanno richiesto la valutazione, avverrà al valore determinato dall'ar-
bitratore; ove il socio proponente l'offerta si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della
prelazione si intenderanno prive di effetto ed il depositante avrà diritto di ottenere la immediata restituzione della somma
versata senza alcuna responsabilità dell'istituto depositario;
j) ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso, ma la natura del negozio non preveda
un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, per la determinazione del valore delle azioni offerte si
dovrà ricorrere alla valutazione fatta secondo le modalità di cui al punto h) precedente;
k) nei casi sopra previsti, il trasferimento delle azioni a favore dei soci che hanno esercitato la prelazione ed il pagamento
del corrispettivo dovrà avvenire nei termini previsti nell'offerta; nel caso di termini scaduti, a seguito dell'espletamento
delle procedure sopra descritte, il trasferimento delle azioni ed il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire nei
trenta giorni successivi a quello di comunicazione della valutazione fatta dall'arbitratore;
l) nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, l'offerente può liberamente
procedere all'alienazione delle azioni nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte riportate nell'offerta; in caso contrario
dovrà ripetersi l'offerta.
Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione ed al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso è libero per quanto
previsto al primo comma del presente articolo, il trasferimento di azioni per atto tra vivi è, comunque, subordinato al
gradimento, che dovrà essere espresso dall'assemblea ordinaria dei soci.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta fatta dal socio che intende effettuare il trasferimento, l'assemblea
ordinaria dei soci delibera sul gradimento e, con deliberazione motivata, può rifiutare il gradimento, dichiarando inefficace
il trasferimento nei confronti della società.
In caso di rifiuto del gradimento l'assemblea ordinaria dei soci avrà l'obbligo di presentare, entro sessanta giorni dalla
richiesta, altro acquirente che si renda cessionario delle azioni, in mancanza di cui, spetta all'offerente il diritto di recedere
dalla società; il corrispettivo dell'acquisto ovvero il valore di liquidazione in caso di recesso sono determinati secondo le
modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del codice civile.
Nel caso in cui l'assemblea ordinaria dei soci non si riunisca ovvero non deliberi in merito entro sessanta giorni dalla
richiesta, il trasferimento delle azioni a terzi diviene efficace nei confronti della società.
La richiesta di gradimento dovrà contenere tutti gli elementi come sopra richiesti per l'offerta di vendita in caso di
esercizio della prelazione e dovrà essere inviata all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
I titoli azionari che verranno emessi a cura della società dovranno recare la seguente stampigliatura:
"Il trasferimento delle azioni di cui al presente titolo è soggetta all'osservanza delle disposizioni e limitazioni elencate
nell'articolo 11 dello statuto sociale; alle stesse disposizioni e limitazioni sono obbligati gli eredi o aventi causa comunque
dei soci".
61034
L
U X E M B O U R G
Assemblea
Convocazione - Luogo - Modalità.
11) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
12) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo
stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente
stabiliti per le convocazioni successive.
Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.
Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo, alternativamente alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:
a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od
equiparati forniti di avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per
ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.
Assemblea totalitaria.
13) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero
capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti
degli organi amministrativo e di controllo.
Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese
quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.
Convocazione su richiesta dei soci.
14) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno
il decimo di capitale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli
argomenti da trattare.
Convocazione annuale.
15) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora
la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della società.
Intervento all'assemblea.
16) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui - per legge o in forza
del presente statuto - è riservato il diritto di intervento.
Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione; tuttavia, i
soci, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2370, terzo comma, del codice civile, devono esibire i propri titoli
o certificati, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea, prima dell'inizio dell'assemblea.
Intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
17) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per
audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di
parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
= sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione
predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
= sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
= sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno;
= vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati
a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Rappresentanza in assemblea.
18) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega,
nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere semplicemente scritta sul biglietto
di ammissione o su altro documento separato.
61035
L
U X E M B O U R G
Presidenza.
19) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di
assenza o impedimento di quest'ultimo, dal vice presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del vice presi-
dente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole
sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da un socio designato da tanti soci rappresentanti la
maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, da lui
designato.
Verbale dell'assemblea.
20) Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è
redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.
Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di
verbalizzazione delle stesse.
Competenza dell'assemblea ordinaria.
21) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni com-
portanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
Competenza dell'assemblea straordinaria.
22) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Quorum.
23) L'assemblea ordinaria è costituita validamente con la presenza, personale o per delega, di tanti azionisti che rap-
presentino almeno la metà del capitale sociale.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata.
Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale
intervenuto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono prese con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
24) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
Impugnazione delle deliberazioni.
25) L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con
riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale
prevista dall'art. 2377 C.C.
Disposizioni generali.
26) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.
Organo di vigilanza è il collegio sindacale.
Amministratori.
27) Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito
all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-
cizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
61036
L
U X E M B O U R G
Consiglio di amministrazione.
28) Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un
vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
29) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte
che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri qualora il
consiglio sia composto da più di due membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera a mezzo posta raccomandata, telefax o telegramma da spedire
almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma,
telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
30) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In
caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
31) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente, se
nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'amministratore designato dalla maggioranza dei consiglieri intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
32) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione
che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare
documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il
segretario.
33) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio si applica il disposto dell'art. 2386 C.C.; gli ammi-
nistratori nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare dureranno in carica fino alla prossima assemblea.
34) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amminis-
trazione, si intenderà decaduto l'intero consiglio con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori nominati
dall'assemblea di cui al seguente capoverso.
L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica od anche da uno solo di essi.
In caso di cessazione dell'intero organo amministrativo, la convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata d'ur-
genza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Poteri di gestione.
35) All'organo amministrativo, sia esso costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione,
competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.
Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art.2381 codice civile, ad un
comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti o ad un Consigliere Delegato, determinando il contenuto, i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega e, sentito il parere del collegio sindacale, la relativa remunerazione.
Ove si addivenga alla costituzione di un comitato esecutivo, questo sarà composto da alcuni componenti del consiglio
di amministrazione. Per il funzionamento del comitato esecutivo, salvo quanto previsto dal consiglio all'atto della costi-
tuzione, valgono, in quanto applicabili, le norme concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione potrà, comunque, impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni
rientranti nella delega.
Rappresentanza.
36) La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del
Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdi-
zione; agli stessi spetta la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento del presidente la rappresentanza stessa sarà esercitata dal vice presidente, se no-
minato; nei confronti dei terzi la firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
La rappresentanza spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega dal consiglio di amministrazione e nei limiti della delega
medesima.
37) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art. 36 del presente statuto è generale.
L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di
rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.
61037
L
U X E M B O U R G
Compensi agli amministratori.
38) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
Per i compensi degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2389 C.C.
Agli amministratori potrà - inoltre - essere attribuita una indennità di fine mandato nella misura in cui verrà definita
dal competente organo deliberante.
Disposizione particolare.
39) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche
nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a
violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa
quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.
È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della contro-
versia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le
prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza
di elementari obblighi tributari.
Azione sociale di responsabilità.
40) Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea la società
può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinunzia o transazione siano approvate con
deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.
Possono esercitare l'azione di responsabilità i soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.
Collegio sindacale.
41) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri effettivi e due
supplenti scelti secondo i criteri di cui all'articolo 2397 C.C.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea, comunque in misura non inferiore alle tariffe delle ris-
pettive categorie professionali. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal
precedente art. 32.
Controllo contabile.
42) Fino a quando la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile di cui all'art.
2409 bis C. C. è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito
presso il Ministero della Giustizia; con delibera dell'assemblea ordinaria, il controllo contabile potrà, tuttavia, essere
affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Obbligazioni
43) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.
La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.
Bilancio ed utili
44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa
non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno attribuiti ai soci proporzionalmente, salvo che l'assemblea
deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in
parte all'esercizio successivo.
Versamenti e finanziamenti soci.
46) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero
stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.
La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.
In caso di dubbio si presume che la somma sia versata a titolo di finanziamento infruttifero.
Recesso
47) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente, o che abbia manifestato
voto contrario o si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
61038
L
U X E M B O U R G
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Tale diritto di recesso potrà essere esercitato con preavviso di almeno un anno.
48) Sono escluse ulteriori cause di recesso, neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la
proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.
49) Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice
Civile.
Liquidazione del socio receduto.
50) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato
della revisione contabile, se esistente.
Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo
anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza
patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato - entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso
- attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
Patrimonio dedicato.
51) I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Scioglimento e liquidazione
52) La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 codice civile.
La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'organo
amministrativo. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le
maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono
il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:
(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante
avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori
si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i
componenti presenti alla riunione. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni
con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.
Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere
tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale,
stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.
Clausola compromissoria.
53) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori,
i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal presidente del collegio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta
su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà
essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la
società.
Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro novanta giorni dalla nomina.
La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio
è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori,
sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero.
Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il
collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia
della delibera stessa."
61039
L
U X E M B O U R G
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de confier l'administration de la Société à un administrateur unique, DECIDE à cet effet de
nommer administrateur unique de la société:
Monsieur Pederzoli Silvio, né a Carpi (Italie) le 15 mars 1943, resident à Carpi viale Carducci 33, CF.
PDRSLV43C15B819A,
qui restera en fonction, pour une durée indéterminée, jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés
par les statuts.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de désigner un collège de commissaires composé de CINQ (5) membres, tous ayant la
nationalité italienne et inscrits au Registre des "Revisori contabili". Les honoraires des commissaires sont établis d'après
les tarifs professionnels des Dottori Commercialisti.
CE COLLEGE DES COMMISSAIRES SERA COMPOSE DES CINQ (5) MEMBRES SUIVANTS:
(i) Dott. Mauro Cantaroni, né à Castelfranco Emilia (MO) le 7 février 1969, residente à Carpi (MO) Via F.Ili Rosselli
n. 30, C.F.: CNT MRA 69B07 C107I; Président;
(ii) Dott.ssa Francesca Pederzoli, née à Carpi (MO) le 14 mai 1972, résidente à Carpi (MO) Via Amendola n. 24, C.F.:
PDR FNC 72E54 B819V, commissaire effectif;
(iii) Dott. Diacci Massimo, né à Carpi (MO) le 8 septembre 1968, résident à Carpi (Mo) Via Tacito n. 5, C.F.: DCC
MSM 68P08 B819H; commissaire effectif;
(iv) Dott.ssa Maria Elena Pederzoli, née à Carpi (MO) le 6 août 1973, résident à Carpi (MO) Via F.Ili Rosselli n. 30,
C.F.: PDR MLN 73M46 B819M, commissaire suppléant;
(v) Dott.ssa Roberta Montanini, née à Modena le 5 juillet 1969 et résidente à MODENA, Via Nazionale per Carpi sud
118, CF: MNT RRT 69L45 F257K, commissaire suppléant,
lesquels resteront en fonction, pour une durée indéterminée, jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs
fixés par les statuts.
<i>Dixième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE en outre de conférer à cet administrateur unique, Monsieur Pederzoli Silvio, prénommé,
tous pouvoirs nécessaires en vue de l'exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat
de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et
munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités
compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite
inscription se fasse également en plusieurs actes.
<i>Onzième résolutioni>
L'Associé unique DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue de la
présente assemblée générale extraordinaire.
Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes:
I comparenti dichiarano:
di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società com-
merciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese e
l'acquisto della nazionalità italiana senza scioglimento e ricostituzione, ma con assoluta continuità della personalità giuridica
conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio 1995 n.
218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec Nous,
Notaire, la présente minute.
Signé: S. ERK, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 avril 2010. Relation: EAC/2010/4327. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2010066425/510.
(100063210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
61040
L
U X E M B O U R G
Starwood Capital Group European S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 83.810.
Par résolutions prises en date du 11 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 7 mai 2010.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet au 7 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2010.
Référence de publication: 2010056896/15.
(100071063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Starwood Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 84.214.
Par résolutions prises en date du 7 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Référence de publication: 2010056897/15.
(100071064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SCG STE Maurice 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 90.612.
Par résolutions prises en date du 11 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant A avec effet au 7 mai 2010.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant A, avec effet au 7 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2010.
Référence de publication: 2010056899/15.
(100071056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SCG STE Maurice 4 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 27.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 91.006.
Par résolutions prises en date du 11 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant A avec effet au 7 mai 2010.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
61041
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Référence de publication: 2010056900/15.
(100071057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SEB Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 35.166.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 avril 2010i>
Sont nommés administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des
actionnaires en 2011
Monsieur Kjell Norling avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen, président
Madame Barbro Lilieholm avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen,
Madame Marie Winberg avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen,
Monsieur Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.
Est nommé réviseur d’entreprises agréé pour la même période:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010056901/18.
(100070773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Colombo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 960.150,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 112.725.
<i>Extrait des résolutions des associés du 26 avril 2010i>
Les associés de Colombo S.à r.l. (la "Société") ont décidé comme suit:
d'accepter la démission des gérants suivants avec effet immédiat:
- Richard van 't Hof, gérant de catégorie B;
- Roberto Muroni, gérant de catégorie C.
de nommer les gérants suivants avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:
<i>- gérant de catégorie B:i>
* Joannes C. L. van de Sanden, né le 21 juin 1951 à Jutphaas, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20, rue de
la Poste, L-2346 Luxembourg.
<i>- gérant de catégorie C:i>
* Thomas Rivolta, né le 27 juillet 1979 à Gênes, Italie, demeurant professionnellement au Royal Damcenter - Dam 7F,
1012 JS Amsterdam, Pays-Bas.
Luxembourg, le 30 avril 2010.
Martijn Bosch.
Référence de publication: 2010066451/21.
(100062951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
SF Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 130.702.
L'an deux mille dix, le sept avril.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de "SF REAL ESTATE S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 130702 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 24 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 2069 du 22 septembre 2007.
61042
L
U X E M B O U R G
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L – 1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis GALIOTTO, juriste, demeurant à Luxembourg.
Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation la société LISOLUX SARL,
ayant son siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. ZIANVENI, R. GALIOTTO, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2010. Relation: LAC/2010/15434. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 22 avril 2010.
Référence de publication: 2010056903/48.
(100071077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Sicily Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 124.425.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 19 mai 2010i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de M. Thomas RIVOLTA de son poste de gérant catégorie B de la société avec effet
immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme M. Alessandro BARACHETTI, né le 17 mars 1973 à Milan (Italie), résidant professionnellement
au Royal Damcenter, Dam 7f, 1012 JS Amsterdam, au poste de gérant catégorie B de la société avec effet immédiat pour
une durée illimitée.
61043
L
U X E M B O U R G
Pour extrait
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2010056904/18.
(100071230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Société Financière Anigh Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 43.859.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14.05.2010 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs TORDOOR Jacques, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en
tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que
commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2016.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010056906/17.
(100071121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Hammond International Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 69, rue de la Semois.
R.C.S. Luxembourg B 141.950.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires lors de sa réunion du 3 mai 2010i>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Daniel KUFFER, né le 22 mars 1963 à Differdange (Luxembourg), demeurant
professionnellement 7, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur avec effet au 22 mars
2010 et celle de Monsieur Ferdinando CAVALLI, né le 26 juin 1963 à Rome (Italie), demeurant professionnellement 7,
rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 3 mai 2010.
- De nommer les administrateurs suivants en remplacement des administrateurs démissionnaires:
* M. Marco LAGONA, né le 18 avril 1972 à Milan, Italie, ayant comme adresse professionnelle 37/A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg,
* M. Giuliano BESSON, né le 1
er
janvier 1950 à Sauze d'Oulx, Italie, domicilié Piazza Assietta, 13, I-10050 Sauze d'Oulx,
Italie.
Leur mandat aura la même échéance que celui de leur prédécesseur et se terminera lors de l'assemblée générale des
actionnaires approuvant les comptes de l'exercice clôturés au 31.12.2011 qui se tiendra en 2012.
- De modifier l'adresse professionnelle de M. Carlo SANTOIEMMA qui sera dorénavant la suivante: 37/A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HAMMOND INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2010066465/25.
(100062987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
SOF European Hotel Co-Invest Holdings II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.013.
Par résolutions prises en date du 7 mai 2010, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat.
61044
L
U X E M B O U R G
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Référence de publication: 2010056907/15.
(100071058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SOF-VI Global Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 136.739.
Par résolutions prises en date du 11 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 7 mai 2010.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet au 7 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2010.
Référence de publication: 2010056908/15.
(100071059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SOF-VI International Holdings Lux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 136.738.
Par résolutions prises en date du 7 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Référence de publication: 2010056909/15.
(100071060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SOF-VII European Holdings I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 106.773.
Par résolutions prises en date du 11 mai 2010, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 7 mai 2010.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet au 7 mai 2010 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2010.
Référence de publication: 2010056910/15.
(100071061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
61045
L
U X E M B O U R G
ING Investment Management Multi Manager S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.363.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2010i>
<i>Conseil d'Administrationi>
- Nomination des administrateurs suivants:
* Madame Edith Magyarics, Chief Operating Officer, Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Confirmation du mandat des administrateurs suivants:
* Monsieur Michel Van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) bv, The
Hague, 15 Prinses Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands
* Madame Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,
2595 AK The Hague, The Netherlands
* Monsieur Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses
Beatrixlaan, 2595 AK The Hague, The Netherlands
* Monsieur David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,
2595 AK The Hague, The Netherlands
* Monsieur Jan Straatman, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Eusope) bv, 15 Prinses Beatrixlaan,
2595 AK The Hague, The Netherlands
* Monsieur Maurice Hannon, Head of Legal, ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
<i>Réviseur d'Entreprisesi>
Reconduction de mandat de la société Ernst & Young, 7, parc d'activités Syrdall à L-5365 Munsbach pour une période
d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2011.
Luxembourg, le 13 avril 2010.
ING Investment Management Luxembourg S.A.
<i>Par délégation
i>Signatures
Référence de publication: 2010066446/33.
(100063047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
Sofeco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 46.843.
L'an deux mille dix, le sept avril.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de "SOFECO S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 46843 ayant son siège social à Luxembourg au 54,
Avenue de la Liberté, constituée par acte de Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch en date du 7
février 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 227 du 9 juillet 1994.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L–1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis GALIOTTO, juriste, domicilié professionnellement
au 15, Côte d'Eich, L–1450 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich,
L–1450 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions
d'une valeur nominale de trente euros quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 30,99) chacune, représentant l'intégralité du
capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.
61046
L
U X E M B O U R G
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Jean HOFFMANN,
domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L–1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. ZIANVENI, R. GALIOTTO, R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 08 avril 2010. Relation: LAC/2010/15433. Reçu douze euros (12.- €)
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, le 22 avril 2010.
Référence de publication: 2010056911/49.
(100071087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
SOFI Asia Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 104.653.
Par résolutions prises en date du 7 mai 2010, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de Michael Murphy, avec adresse professionnelle au 7 A, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
- Nomination de Thierry Drinka, avec adresse professionnelle au 6, Rue Julien Vesque, L-2668 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Référence de publication: 2010056912/15.
(100071062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Unical Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 115.919.
<i>Extrait de Résolution prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2010i>
L’Assemblée a accepté la démission de M. Lennart STENKE de son poste d’administrateur et d’administrateur délégué.
L’Assemblée a nommé en remplacement au poste d’administrateur et administrateur délégué M. Nicolas KRUCHTEN,
né le 28/08/1957 à Luxembourg et résidant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
Son mandat arrivera à échéance lors de l’assemblée générale qui se réunira en 2011.
61047
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 19 mai 2010.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010056916/15.
(100071426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Euro Immo Invest & Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8365 Hagen, 48A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 45.694.
L'an deux mille dix, le six mai.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EURO IMMO INVEST &
CONSEIL S.A.", (la "Société"), avec siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 45 694, constituée suivant acte reçu par Maître
André Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 1993, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 27 du 24 janvier 1994, les statuts ayant été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1075 du 21 octobre 2005.
L'assemblée est présidée par Mademoiselle Catherine GIORDANO, résidant professionnellement à 67, rue Ermesinde,
L-1469 Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie STACCHINI, résidant professionnellement au 67, rue
Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1 Transfert du siège social de la Société.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé de transférer le siège social de la Société du 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 48A, rue Principale,
L-8365 Hagen avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EURO IMMO INVEST & CONSEIL S.A..
Le siège social est établi dans la commune de Steinfort.
Il pourra être transféré à toute autre adresse à l’intérieur de la même commune ou dans une autre commune par
simple décision du conseil d’administration ou par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires, tel que requis
par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»
61048
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. GIORDANO, S. STACCHINI, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 07 mai 2010. Relation: MER/2010/851. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): A.MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 25 mai 2010.
Référence de publication: 2010058083/59.
(100072211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2010.
UTI Investment Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 112.413.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du fait que la dénomination de l'associé de UTI INVESTMENT
LUXEMBOURG S.à r.l., AIG Global Emerging Markets Fund II, L.P., a été modifié, en date du 1
er
février 2010, en
PineBridge Global Emerging Markets Partners II, L.P.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2010.
UTI INVESTMENT LUXEMBOURG S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2010056917/15.
(100071262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
VDS Finance S.à.r.l., Vandersanden Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 175.770.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 82.430.
Il est porté à la connaissance de qui de droit que suite au contrat de cession signé en date du 7 décembre 2009, les
associés existants, à savoir:
- VANDERSANDEN BRICKS S.A. (anciennement VANSAN S.A.), ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg détentrice de 1.757.699 parts sociales;
- Monsieur Constant VANDERSANDEN, demeurant Riemsterweg 293/a à B-3740 Bilzen détenteur de 1 part sociale;
ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient respectivement à:
- VANSAN HOLDING S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2010056919/18.
(100070747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Voltige Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 56.599.
<i>Extrait de l’acte de cession de parts du 18 février 2005i>
Il résulte de l'acte de cession du 18 février 2005 entre
Monsieur MARIEN Fabien, associé de la société, demeurant au 73, rue Général Simmer F-57570 Rodemack (France).
et
Monsieur RAUGER Willy, associé de la société, demeurant au 8, rue Foch F-54135 MEXY (France).
que:
61049
L
U X E M B O U R G
20 parts sociales détenues par MARIEN Fabien dans le capital de la Société VOLTIGE LUXEMBOURG SARL, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B56599, sont entièrement cédées à RAUGER Willy pour un
montant total de 2.200€ (deux mille deux cents Euros).
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2010056920/17.
(100071224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Voltige Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 56.599.
<i>Extrait de l'acte de cession de parts du 22 février 2005i>
Il résulte de l'acte de cession du 22 février 2005 entre:
Monsieur MARIEN Fabien, associé de la société, demeurant au 73, rue Général Simmer, F-57570 Rodemack (France).
et
Madame ANSELMI Céline demeurant au 9, rue Victor Hugo, F-57365 ENNERY (France).
que:
10 parts sociales détenues par MARIEN Fabien dans le capital de la Société VOLTIGE LUXEMBOURG SARL, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 56599, sont entièrement cédées à ANSELMI Céline pour
un montant total de 1.100 € (mille cent Euros).
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2010056921/17.
(100071398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Neptune International Investment Funds (SICAV), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 134.929.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2009i>
Composition du Conseil d'administration:
- Il a été décidé de réélire Monsieur Charles Andrew McKinna, Monsieur Roger Charles Barker, Monsieur Richard
Howard Green ainsi que Monsieur Iain Macleod en date du 28 avril 2010, en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2010.
Au 28 avril 2010, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- M. Charles Andrew McKinna
- M. Roger Charles Barker
- M. Richard Howard Green
- M. Iain Macleod
- Il a été décidé de renouveler le mandat de Ernst & Young S.A., en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2010.
- Il a été noté le changement de domicile de Monsieur Richard Howard Green, désormais domicilié au 3 Shortlands,
London, W6 8DA, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2010.
<i>Pour Neptune International Investment Funds (SICAV)
i>Martina Graessler
<i>Au nom et pour le compte de JPMorgan Bank Luxembourg S.A. (en tant qu'Agent domiciliataire)i>
Référence de publication: 2010066434/26.
(100062891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
61050
L
U X E M B O U R G
DTZ Consulting Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 68.586.
DISSOLUTION
L’an deux mil dix, le vingt-huit avril,
s’est tenue pardevant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., ayant son
siège social à Howald, 37, rue des Scillas,
constituée sous la dénomination de AMADEUS Luxembourg SA aux termes d’un acte reçu par le notaire Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 février 1999, publié au Mémorial C numéro 344 du 14
mai 1999 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’une assemblée générale actée par le prédit
notaire ELVINGER en date du 19 mars 2004, publiée au Mémorial C numéro 546 du 26 mai 2004,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro
B 68.586.
A comparu:
Monsieur Jean-Pierre LEQUEUX, administrateur délégué de la société DTZ WINSSINGER TIE LEUNG (Luxembourg)
S.A., demeurant à L-1747 Luxembourg, 32, Op der Heed,
Agissant tant en sa qualité d’administrateur-délégué que comme mandataire d’un second administrateur de ladite
société DTZ WINSSINGER TIE LEUNG (Luxembourg) S.A., en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée,
Qui expose et prie le notaire d’acter au nom de sa mandante que:
1. La société DTZ WINSSINGER TIE LEUNG (Luxembourg) S.A., avec siège à L-2529 Howald, 37, rue des Scillas,
RCSL B 52.634, est devenue l'actionnaire unique de la Société;
2. que les comptes sociaux sont parfaitement connus de l’actionnaire unique;
3. que l’actionnaire reprend par la présente tous les actifs de la Société et qu'elle prendra en charge tout le passif de
la Société et en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;
4. que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre et de liquider la Société avec effet immédiat;
5. que décharge est donnée aux administrateurs en exercice à ce jour et au commissaire de la Société;
6. que pour autant que de besoin, Monsieur Jean-Pierre Lequeux, susvisé, prend la qualité de liquidateur de la Société;
7. que les livres, documents et pièces relatives à la Société seront conservés pendant un délai de 5 ans à l’adresse
suivante: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas;
8. que la société est partant liquidée et la liquidation est clôturée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 14.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.P. LEQUEUX, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 30 avril 2010. Relation: CAP/2010/1494. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€
<i>Le Receveuri> (signé): I. Neu.
POUR COPIE CONFORME.
Capellen, le 5 mai 2010.
Référence de publication: 2010056930/44.
(100071160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Forgital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 103.925.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2010066880/10.
(100063223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
61051
L
U X E M B O U R G
Unicapital Investments (Management) S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.249.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) S.A., décidée par acte du notaire Maître
Jean-Joseph Wagner en date du 10 décembre 2009, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing
privé tenue en date du 30 avril 2010.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 1, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Référence de publication: 2010056932/15.
(100071326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Marine International Operations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 76.762.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2010: -
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60
Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L- 1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Lu-
xembourg n° RCS Luxembourg B99 747.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary & Accounting Services S.A. ayant son
siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme
Commissaire aux Comptes jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 29 mars 2010.
<i>Pour Marine International Operations S.A.i>
Référence de publication: 2010056955/32.
(100070907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
61052
L
U X E M B O U R G
Marine International Operations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 76.762.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 29 mars 2010:-i>
<i>Résolution 1.i>
Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-
bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 29 mars 2010.
<i>Pour Marine International Operations S.A.i>
Référence de publication: 2010056956/14.
(100070907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Omnium Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 80.601.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2010: -
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60
Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Lu-
xembourg n° RCS Luxembourg B99 747.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary & Accounting Services S.A. ayant son
siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme
Commissaire aux Comptes jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 29 mars 2010.
<i>Pour Omnium Ventures S.A.i>
Référence de publication: 2010056957/32.
(100070904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Adams Rayner Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 152.147.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 4 mai 2010i>
- La démission de Mr Samuel Christopher Mellor en tant que gérant de la Société a été acceptée.
- Le nombre de gérants de la Société est passé de 3 à 2.
61053
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Adams Rayner Capital S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2010066441/15.
(100063314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
ROV Diving International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 83.781.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2010: -
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60
Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1er étage, L-1660 Lu-
xembourg n° RCS Luxembourg B99 747.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary & Accounting Services S.A. ayant son
siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme
Commissaire aux Comptes jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 25 mars 2010.
<i>Pour R.O.V. Diving International S.A.i>
Référence de publication: 2010056963/32.
(100071053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Compagnie d'Investissement des Ardennes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 107.824.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon anticipative en date du 13 avril 2010i>
<i>5 i>
<i>ei>
<i> Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,
l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe
BLONDEAU, Président du Conseil d'Administration, employé privé, né le 28 février 1954 à Anvers (Belgique), résidant
professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de Monsieur Romain THILLENS, Licencié en Sciences Eco-
nomiques Appliquées, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), résidant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg et de Monsieur Nour-Eddin NIJAR, employé privé, né le 10 septembre 1952 à Marrakech (Maroc), résidant
professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société anonyme HRT
REVISION S.A. (anciennement HRT Révision S.àr.l.), ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg pour
une nouvelle période de six ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
61054
L
U X E M B O U R G
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Compagnie d'Investissement des Ardennes S.A.
i>C. BLONDEAU / N.-E. NIJAR
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2010066458/22.
(100063549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
ROV Diving International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 83.781.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 25 mars 2010:-i>
<i>Résolution 1.i>
Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-
bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 25 mars 2010.
<i>Pour R.O.V. Diving International S.A.i>
Référence de publication: 2010056964/14.
(100071053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Schimmelpenningh International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 79.494.
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2010: -
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 746.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60
Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 747 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Lu-
xembourg n° RCS Luxembourg B99 747.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social
60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739 comme Administrateur jusqu'à l’assemblée
générale qui se tiendra en l’année 2016.
- Est acceptée la nomination de Rika Mamdy avec adresse professionnelle 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg en tant
que représentant permanent de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 60 Grand Rue, 1
er
étage, L-1660
Luxembourg n° RCS Luxembourg B99 739.
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Fiduciary & Accounting Services S.A. ayant son
siège social R.G. Hodge Plaza, 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, n° IBC 303554 comme
Commissaire aux Comptes jusqu'à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 29 mars 2010.
<i>Pour Schimmelpenningh International S.A.i>
Référence de publication: 2010056965/32.
(100071111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
61055
L
U X E M B O U R G
Controlinveste International Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 149.973.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises à Luxembourg en date du 20 mai 2010i>
La société Deloitte S.A., société anonyme, ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 67.895, a été nommée en qualité de commissaire
aux comptes de la Société avec effet rétroactif au 2 décembre 2009 pour une période se terminant lors de l'assemblée
générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010.
La société Deloitte S.A. remplace la société KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 9
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B
103.590.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2010.
Référence de publication: 2010058063/17.
(100071546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2010.
GSFG Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.599.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 23 avril 2010i>
1. M. Jonathan LEPAGE a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. M. Vincent TUCCI a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
3. M. Xavier SOULARD, administrateur de sociétés, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de
catégorie B pour une durée indéterminée.
4. M. Frank HODYJAS, administrateur de sociétés, né à Offenbach am Main (Allemagne), le 8 janvier 1966, demeurant
à CP-61462 Konigstein im Taunus (Allemagne), Am Neuenhainerwald, 39, a été nommé comme gérant de catégorie A
pour une durée indéterminée.
5. M. Paul Garrett WHITE, administrateur de sociétés, né à Wicklow (Irlande) le 14 juillet 1963, demeurant à 1015 BJ
Amsterdam (Pays-Bas), Herengracht 163, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 6 mai 2010.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GSFG Financing Luxembourg S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2010066466/22.
(100063497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2010.
Schimmelpenningh International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 79.494.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 29 mars 2010:-i>
<i>Résolution 1.i>
Nationwide Management S.A. ayant son siège social 60, Grand Rue, 1
er
étage, L-1660 Luxembourg, n° RCS Luxem-
bourg B99 746, a été confirmé avec effet immédiat comme Administrateur-Délégué jusqu'à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2016.
Luxembourg, le 29 mars 2010.
<i>Pour Schimmelpenningh International S.A.i>
Référence de publication: 2010056966/14.
(100071111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2010.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
61056
Adams Rayner Capital S.à r.l.
AMBD SICAV
Arts et Nature S.à r.l.
Athena Sicav
Brasserie Kirchberg S.à r.l.
Colombo S.à r.l.
Compagnie d'Investissement des Ardennes S.A.
Controlinveste International Finance
DTZ Consulting Luxembourg S.A.
Euro Immo Invest & Conseil S.A.
Euro Real Estate Britain I S.à r.l.
Euro Real Estate Germany I S.à r.l.
Forgital S.A.
GSFG Financing Luxembourg S.à r.l.
Hammond International Investments S.A.
ING Investment Management Multi Manager S.A.
Marine International Operations S.A.
Marine International Operations S.A.
Morghy S.A.
Morghy Spa
Neptune International Investment Funds (SICAV)
Omnium Ventures S.A.
One Park Lane S.A.
Pétrusse Invest S.A.
Piccioli S.A.
Représentations S.A.
ROV Diving International S.A.
ROV Diving International S.A.
SCG STE Maurice 2 S.àr.l.
SCG STE Maurice 4 S.àr.l.
Schimmelpenningh International S.A.
Schimmelpenningh International S.A.
SEB Sicav 1
SF Real Estate S.A.
Sicily Investments S.à.r.l.
Société Financière Anigh Spf S.A.
Sofeco S.A.
SOF European Hotel Co-Invest Holdings II, S.à r.l.
SOFI Asia Investments S.à r.l.
SOF-VI Global Holdings Lux S.à r.l.
SOF-VII European Holdings I, S.à r.l.
SOF-VI International Holdings Lux, S.à r.l.
Starwood Capital Group European S.à r.l.
Starwood Germany S.à r.l.
Unical Investments S.A.
Unicapital Investments (Management) S.A.
UTI Investment Luxembourg S.à r.l.
Vandersanden Finance S.à.r.l.
Voltige Luxembourg
Voltige Luxembourg
Vratislavia Holdings S.A.